logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3089

12 novembre 2015

SOMMAIRE

Alzheimer Europe Foundation . . . . . . . . . . . . .

148239

ATGM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148271

Bailiff S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148226

Beheer- en Beleggingsmaatschappij Radi B.V.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148235

BNP Paribas Investment Partners Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148227

Breba - Cars S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148226

Brookfield Properties (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148254

Capa S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148226

Chemtrade Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

148254

Compagnie de Saint Cyr S.A. . . . . . . . . . . . . . .

148264

Compagnie Francilienne d'Investissements

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148236

Corridor Topco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148242

Croq'Chalet Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148236

CVC European Credit Opportunities S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148236

Dachkin-Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148237

DF Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148239

DH Services Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .

148235

Dolpo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148264

Dover Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

148236

Dover Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

148237

D-R Luxembourg Partners 1 S.C.S.  . . . . . . . .

148236

Dynamic Materials Luxembourg 2 S.à r.l.  . . .

148237

Elburg Invest B.V. S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

148237

Entreprise de constructions Modeste BAATZ

et Fils S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148237

ERRV Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

148254

ETMF II C S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148226

Exclusive Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

148229

Finasset S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148235

Hikma Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . .

148265

Hindelang Logistics S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

148272

INTERTEL & CO, société de gestion de patri-

moine familial (SPF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148267

Invista European Real Estate Trust SICAF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148229

Justfin International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

148272

Key Care S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148272

Korbach Logistics (European RE Club) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148242

Le Nomade, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148238

Lithoma Property  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148250

Maint S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148239

MEIF4 Luxembourg B Holdings S.à. r.l.  . . . .

148242

Mylan Luxembourg 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

148234

New Form S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148238

OCM Luxembourg Wembley Finance S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148238

OCM Luxembourg Wembley Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148238

Plotin Holding SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148229

PPM Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148228

Schuler Romain S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148235

Sepik S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148235

Thesion Handelsgesellschaft S.à r.l. . . . . . . . . .

148270

Treetop PSF S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148238

Trucknology S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148227

UBS (Lux) Equity Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148228

Vedipar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148253

Viager Life Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148241

World Fuel Services Finance Company S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148227

148225

L

U X E M B O U R G

Breba - Cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 82, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 59.056.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159198/9.
(150175944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Bailiff S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel.

R.C.S. Luxembourg B 102.872.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015159179/11.
(150175852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Capa S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 191.512.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2015.

<i>Pour: CAPA S.A. SPF
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015159225/14.
(150175446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

ETMF II C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 78.988.

Les actionnaires de la société ETMF II C S.A. (la «Société») sont par la présente invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

de la Société qui sera tenue le <i>20 novembre 2015 à 14h00 au siège social de la société, afin de se prononcer sur l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Considérer la décision de prononcer la dissolution anticipée de la Société et de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination  de  la  société  Eurotime  S.A.,  société  anonyme  ayant  son  siège  social  au  163,  rue  du  Kiem,  L-8030

Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 56.177,
comme liquidateur de la Société;

3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Divers.

Il est rappelé aux actionnaires que pour des raisons techniques, ils ne peuvent assister à l'assemblée générale par visio-

conférence. Ils peuvent cependant donner procuration pour se faire représenter à l'assemblée générale.

<i>Le Conseil d'Administration .

Référence de publication: 2015176399/771/20.

148226

L

U X E M B O U R G

Trucknology S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 143.292.

Le Bilan du 1 

er

 Janvier au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159003/9.
(150175042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

World Fuel Services Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.020.000,00.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 95.561.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015159058/10.
(150175092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 27.605.

La Société de Gestion, agissant au nom et pour le compte du Fonds, informe les porteurs de parts du Fonds qu'une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

se tiendra le <i>23 novembre 2015 à 11:00 CET, dans les bureaux de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,

bâtiment H2O, bloc A, rez-de-chaussée, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, aux fins
de statuer sur l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Changement de forme juridique du Fonds : Transformation d'un fonds commun de placement (FCP) de type classique

en société d'investissement à capital variable (SICAV) sous la forme d'une société anonyme à compartiments mul-
tiples ;

2. Changement de dénomination sociale du Fonds en " BNP Paribas Easy " ;
3. Transfert de siège social ;
4. Changement de la langue officielle du Fonds ;
5. Nomination d'un conseil d'administration ;
6. Approbation des statuts du Fonds en remplacement du règlement de gestion ;
7. Reprise des divers engagements et contrats ;
8. Divers.

Les décisions prises par cette assemblée générale extraordinaire ne prendront effet qu'un mois après leur publication

dans les journaux officiels afin de permettre aux porteurs de parts ne les approuvant pas de demander le rachat sans frais
de leurs parts.

Les porteurs de parts souhaitant être présents doivent faire connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée au

moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de l'Assemblée. Ils seront admis à l'Assemblée sur justification de leur identité.

L'assemblée pourra délibérer quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées et les résolutions seront adoptées

aux deux-tiers (2/3) des parts présentes ou représentées, compte non tenu des abstentions. Chaque part, quelle que soit sa
valeur unitaire, donne droit à une voix. Les fractions de parts ne conféreront aucun droit de vote.

Tout porteur de parts ne pouvant se présenter à l'adresse et aux dates et heures mentionnées ci-dessous peut envoyer par

email puis par courrier postal une procuration dûment signée au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de l'Assemblée
(à l'attention de Mme Fabienne Veronese, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange - email : fs.lu.legal@bnpparibas-
ip.com).

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015177979/755/35.

148227

L

U X E M B O U R G

PPM Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 68.086.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015158908/10.
(150175242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

UBS (Lux) Equity Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 56.386.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Equity SICAV werden zur

HAUPTVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>24. November 2015 um 11.30 Uhr (Ortszeit Luxemburg) mit der folgenden Tages-

ordnung an ihrem Geschäftssitz abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Mai 2015
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Der Jahresbericht ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos

erhältlich. Jeder Aktionär kann beantragen, dass ihm der Jahresbericht zugesandt wird.

Die Mehrheit wird auf der Hauptversammlung nach den fünf Tage vor der Hauptversammlung um Mitternacht (Ortszeit

Luxemburg) ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien bestimmt (bezeichnet als "Stichtag"). Es besteht kein An-
wesenheitsquorum für die gültige Beratung und Beschlussfassung der Hauptversammlung in Bezug auf die Tagesord-
nungspunkte. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmmehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen
Aktien gefasst. Auf der Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme. Die Rechte eines Aktionärs
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der mit seinen Aktien verbundenen Stimmrechte richten sich
nach den von diesem Aktionär am Stichtag gehaltenen Aktien.

Falls Sie an dieser Versammlung nicht teilnehmen können und sich vom Vorsitzenden der Hauptversammlung vertreten

lassen möchten, übermitteln Sie bitte spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung (d. h. bis 19. November 2015) eine
datierte und unterzeichnete Vollmacht per Fax und/oder Post und/oder E-Mail zu Händen des Sekretariats der Gesellschaft
bei der Anschrift UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Faxnummer +352 441010 6248 (E-Mail: sh-ubsfsl-corporate-secretary@ubs.com). Die Vorlage für eine Standardvollmacht
kann unter derselben Adresse angefordert werden. Nach Eingang der Vollmacht werden die Aktien bis zu dem auf die
Hauptversammlung folgenden Tag gesperrt. Findet eine weitere Hauptversammlung der Gesellschaft mit derselben Ta-
gesordnung (bezeichnet als "vertagte Hauptversammlung") statt, bleiben die Aktien bis zu dem auf die vertagte Haupt-
versammlung folgenden Tag gesperrt, es sei denn, der Aktionär erteilt eine anderslautende Anweisung (dadurch wird die
für die vertagte Hauptversammlung erteilte Vollmacht ungültig).

Aktionäre oder ihre Vertreter, die an der Hauptversammlung persönlich teilnehmen möchten, werden gebeten, die Ge-

sellschaft spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung von ihrer Teilnahmeabsicht in Kenntnis zu setzen.

Das ausgefüllte Vollmachtsformular ist nur gültig, wenn es den Vor- und Nachnamen des Aktionärs sowie seines Ver-

treters und die Anzahl der zum Stichtag gehaltenen Aktien, die offizielle Adresse und die Unterschrift sowie Weisungen
für die Stimmabgabe enthält und rechtzeitig eingeht. Unvollständige oder fehlerhafte Vollmachtsformulare oder Voll-
machtsformulare, die nicht die darin beschriebenen Formvorgaben erfüllen, werden nicht berücksichtigt.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015177224/755/44.

148228

L

U X E M B O U R G

Plotin Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 146.108.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015158906/10.
(150174533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Exclusive Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 31, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 149.563.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour Exclusive Management S.à r.l.
Fideco S.A.

Référence de publication: 2015157887/12.
(150174322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Invista European Real Estate Trust SICAF, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital

Fixe.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.461.

<i>Recommended proposals for a voluntary winding-up of the Company

<i>Notice of Extraordinary General Meeting

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES SHAREHOLDERS' IMMEDIATE ATTENTION. IT CON-

TAINS PROPOSALS RELATING TO INVISTA EUROPEAN REAL ESTATE TRUST SICAF (THE “COMPANY”)
ON WHICH SHAREHOLDERS ARE BEING ASKED TO VOTE.

If you are in any doubt about the contents of this document or the action you should take, you should immediately consult

your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other appropriately qualified independent financial adviser, au-
thorised under the Financial Services and Markets Act 2000.

If you have sold or otherwise transferred all of your Shares in the Company, please send this circular (the “Circular”),

but not the accompanying form of proxy (the “Form of Proxy”), as soon as possible to the purchaser or transferee, or to
the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected, for delivery to the purchaser or
transferee. However, such documents should not be distributed, forwarded or transmitted in or into the United States,
Australia, Canada, Japan, New Zealand, South Africa and any other jurisdiction if to do so would constitute a violation of
the relevant laws and regulations in such other jurisdiction. If you have sold or transferred only part of your holding of
Shares please consult the bank, stockbroker or other agent through which the sale or transfer was effected.

The Proposals described in this Circular are conditional on Shareholder approval, which is being sought at an Extraor-

dinary General Meeting of the Company to be held at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, at 11.30 a.m. on 26 November
2015. Notice of the Extraordinary General Meeting is set out at the end of this Circular.

Shareholders are requested to complete, sign and return the Form of Proxy accompanying this Circular, in accordance

with the instructions printed thereon, so as to be received by post or by hand by Mr Jorrit Crompvoets, Citco REIF Services
(Luxembourg) S.A., 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (fax: +352 47 24 73) as soon as possible but in any event so
as to arrive not later than close of business on 23 November 2015. The lodging of a Form of Proxy will not prevent
Shareholders from attending, speaking and voting in person at the Extraordinary General Meeting if they so wish.

If you are a Depository Interest holder, you will find enclosed a Form of Direction, which should be completed and sent

to The Depository, Capita Asset Services, PXS, 34, Beckenham Road, Beckenham, Kent, United Kingdom BR3 4TU to
be received no later than 11.30 a.m. (CET) on 23 November 2015.

The Company is registered pursuant to part II of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective

investments.  Notification  of  the  Proposals  has  been  made  to  the  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier
(“CSSF”).

148229

L

U X E M B O U R G

This Circular should be read as a whole. Your attention is drawn to the letter from the Chairman of the Company set

out on pages 2 to 5 of this Circular and which recommends that you vote in favour of the Resolutions. Your attention is
drawn to the section entitled “Action to be Taken by Shareholders” on page 5 of this Circular.

Defined terms used in this Circular have the meanings given to them in the section headed “Definitions” on page [6] of

this Circular.

EXPECTED TIMETABLE OF EVENTS

The anticipated dates and sequence of events relating to the implementation of the Proposals are set out below:

Record date for participation and voting at the EGM

6 p.m. on 12 November 2015

Latest time and date for receipt of Form of Proxy for the EGM

close of business on 23 November 2015

Last time and date for receipt of the Form of Direction for the
EGM

11.30 a.m. on 23 November 2015

EGM

11.30 a.m. on 26 November 2015

Liquidator appointed

26 November 2015

Announcement of results of the EGM

26 November 2015

Closing of the Company's register and Record Date for par-
ticipation in liquidation distributions (if any)

6 p.m. on 26 November 2015

Cancellation of listings and admission of the Shares to trading
on the Main Market

7 a.m. on 1 December 2015

All references are to Central European Time (CET) unless otherwise stated.

LETTER FROM THE CHAIRMAN

Invista European Real Estate Trust SICAF

<i>Directors:

<i>Registered office:

Tom Chandos (Chairman)

11-13, boulevard de la Foire

Michael Chidiac

L-1528 Luxembourg

Robert DeNormandie

26 October 2015

<i>Voluntary Liquidation of the Company

<i>Notice of Extraordinary General Meeting

1. INTRODUCTION AND BACKGROUND
The Company announced on 14 September 2015 that, following the expiry of the standstill agreement in relation to

certain ongoing events of default with regard to the mezzanine loan facility provided by Islay Investment S.à r.l., an affiliate
of Blackstone Real Estate Debt Strategies, (“Islay” or the “Mezzanine Lender”) to Invista European Real Estate Holdings
S.à r.l. (“IEREH”), Islay had called for repayment of the mezzanine loans by IEREH.

IEREH was not able to repay the loans and Islay called on the guarantee of the loans by the Company. The Company,

in turn, was not able to pay the amounts guaranteed.

In accordance with its rights under the mezzanine loan facility documentation (including the related guarantee and

security documentation), on 14 September 2015 Islay enforced its security by way of a sale of the Company's entire interests
in IEREH, Invista European Real Estate Finance S.à r.l. and Invista European RE Pocking PropCo S.à r.l. (the “Subsidia-
ries”) and any other interests (including intra-group loans) to Artillery Investments S.à r.l., TTNYR Limited, TTNYR
Artillery LLP and DPK Artillery LLP (together, the “Purchasers”) (the “Enforcement”). The Enforcement involved the
transfer of the shares and all debt interests held by the Company in each Subsidiary to the Purchasers.

The Enforcement was conducted in such a way that, although the Company has been released from any further liability

under its guarantee and remains solvent, the Board expects that there will be no value for distribution to either the Ordinary
or Preference Shareholders. The Company therefore stated in its announcement of 14 September 2015 that it intended, in
due course, to publish a shareholder circular convening an extraordinary general meeting at which Shareholder approval
would be sought for the delisting and voluntary liquidation of the Company.

Furthermore, following the Enforcement, the Company has continued to meet its ongoing operating costs. On 30 Sep-

tember 2015, the net asset value of the Company was estimated to be less than €833,333. The Company's Articles and
applicable law provide that if the total net assets of the Company falls below two-thirds of the Company's prescribed
minimum capital (being €1.25 million), then the Board must submit the question of the Company's dissolution to a general
meeting of the Shareholders for which no quorum is prescribed and which shall pass resolutions by simple majority of the
Shares represented at the meeting.

Accordingly,  by  the  Notice  of  the  Extraordinary  General  Meeting  set  out  at  the  end  of  this  Circular,  the  Board  is

convening a general meeting of the Company at which the question of the Company's dissolution will be put to the Ordinary
and Preference Shareholders.

148230

L

U X E M B O U R G

In light of the Company's financial circumstances, the Board believes that it is in the best interests of the Company and

the Shareholders for the Company to be placed into voluntary liquidation and for the Company's Shares to be delisted from
the Official List and their admission to trading on the Main Market to be cancelled. I am therefore writing to you to outline
the Board's Proposals, which require the approval of the Shareholders, and further details of which are set out in section 2
below.

This Circular sets out details of, and seeks your approval for, the Proposals and explains why your Board is recom-

mending that you vote in favour of the Resolutions.

2. PROPOSALS
The purpose of this Circular is to convene an Extraordinary General Meeting of the Company to be held at 20, rue de

la Poste, L-2346 Luxembourg, at 11.30 a.m. on 26 November 2015, to seek approval from the Shareholders of the Proposals,
in accordance with applicable law.

The Board proposes to:
(i) put the Company into liquidation and dissolve it; and
(ii) appoint Fund Solutions SCA, a partnership limited by shares (société en commandite par actions), incorporated and

existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 154.626 and represented for the purposes of
the liquidation of the Company by Mr Christophe Cahuzac, residing professionally in Luxembourg and Mr Marek Doma-
gala, residing professionally in Luxembourg, as liquidator to the Company (the “Liquidator”) and grant to the Liquidator
the broadest powers to manage the Company for the purposes of its liquidation, including those powers contained in articles
144 et sequentia of the Law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended),

(together, the “Proposals”).
The Proposals set out in this Circular are subject to the approval of Shareholders. Notice of the Extraordinary General

Meeting at which the resolutions to approve the Proposals (the “Resolutions”) will be considered is set out at the end of
this Circular. The Resolutions will, if approved, result in the voluntary liquidation of the Company pursuant to which the
Shareholders will realise their Shareholdings in the Company in an orderly and efficient way.

As set out in further detail in section 3 below, only surplus funds (if any) remaining after the Liquidator has settled all

liabilities, costs and expenses (including the costs of the Company's liquidation) will be available for distribution to the
Shareholders at the conclusion of the liquidation. It should be noted, however, that, as stated in section 1 above, following
the Enforcement the Board expects that no value remains in the Company for distribution to the Shareholders and any such
surplus is therefore expected to be minimal.

In the event that the Resolutions are not passed at the Extraordinary General Meeting, the Board will consider and put

forward alternative proposals for the future of the Company. However, it is anticipated that if the Company continues to
subsist then its ongoing operating costs will result in the Company becoming insolvent in the near future. The Company
would then be highly likely to face mandatory liquidation proceedings, further reducing the prospect of any recovery for
the Shareholders.

3. APPOINTMENT OF LIQUIDATOR AND LIQUIDATION
Subject to Shareholder approval of the Resolutions, the Liquidator will be appointed as liquidator to the Company and

their remuneration shall be determined by the Company. The appointment of the Liquidator will take effect immediately
upon the passing of the Resolutions. Upon the appointment of the Liquidator, all powers of the Board will cease and the
Liquidator will be responsible for the affairs of the Company until it is wound up. The Liquidator will wind up the Company
in accordance with Luxembourg law, discharge the liabilities of the Company and, following satisfaction of all the creditors
of the Company, will divide the surplus assets (if any) of the Company among the Shareholders according to their respective
rights and interests in the Company.

After the liquidation of the Company and the distribution of surplus assets (if any) to Shareholders, existing certificates

in respect of the Shares will cease to be of value and any existing credit of the Shares in any stock account in CREST will
be redundant.

The Liquidator will establish a reserve of such amount as they consider appropriate to meet the Company's liabilities

and estimated costs and expenses whilst in liquidation (the “Retention”). The Liquidator estimates that the Retention will
amount to approximately €250,000. Any surplus funds remaining from the Retention after the Liquidator has settled all
liabilities, costs and expenses, will be distributed to Shareholders at the conclusion of the liquidation. Payment will be made
by cheque.

4. COSTS OF THE PROPOSALS
It is anticipated that the expenses incurred in relation to the Proposals (including professional advice and the Liquidator's

fees) will amount to approximately €100,000, which excludes the fees and expenses of service providers in the ordinary
course of business up to the date of the Liquidator's appointment in accordance with the terms of their engagement.

5. CANCELLATION OF LISTINGS AND THE ADMISSION OF THE SHARES TO TRADING ON THE MAIN

MARKET

148231

L

U X E M B O U R G

Subject to the passing of the Resolutions, the Board has made an application to the London Stock Exchange to cancel

the admission of the Shares to trading on the Main Market and application to the UKLA to cancel the listing of the Shares
on the Official List, with effect from 1 December 2015.

6. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
The Proposals are subject to Shareholder approval. Notice convening the Extraordinary General Meeting, to be held at

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg at 11.30 a.m. on 26 November 2015, is set out at the end of this Circular. The
Notice includes the full text of the Resolutions.

The Extraordinary General Meeting is required to be convened pursuant to Article 30 of the Articles because the total

net assets of the Company are below two-thirds (€833,333) of the minimum capital prescribed by the Luxembourg act
dated 20 December 2002 on undertakings for collecting investment, as amended (being €1,250,000).

In accordance with Article 30, no quorum is prescribed for the meeting and the meeting may pass the Resolutions by

simple majority.

For the avoidance of doubt, holders of both Ordinary and Preference Shares shall be entitled to attend, speak and vote

at the Extraordinary General Meeting on the Resolutions. All Shareholders shall have one vote per Ordinary or Preference
Share held.

7. LUXEMBOURG REGULATORY NOTIFICATIONS
Pursuant to the Luxembourg law of 11 January 2008 on transparency requirements in relation to information about

issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market as amended (the “Transparency Law”), this Circular
and any notices in connection with the Extraordinary General Meeting shall be filed with the Luxembourg Stock Exchange
in its capacity as officially appointed mechanism (“OAM”) under the Transparency Law and notified to the CSSF.

8. ACTION TO BE TAKEN BY SHAREHOLDERS
If you are a Shareholder, you will find enclosed with this Circular the Form of Proxy for use at the Extraordinary General

Meeting. Whether or not you intend to be present at the Extraordinary General Meeting, you are asked to complete the
Form of Proxy in accordance with the instructions printed thereon and to return the Form of Proxy to the Company's
Registrar, Mr Jorrit Crompvoets, Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, to
arrive by the time and date specified on the Form of Proxy.

The completion and return of the Form of Proxy will not preclude you from attending, speaking and voting at the

Extraordinary General Meeting if you wish to do so.

If you are a Depository Interest holder, you will find enclosed a Form of Direction, which should be completed and sent

to Capita Asset Services, PXS, 34, Beckenham Road, Beckenham, Kent, United Kingdom BR3 4TU to be received no later
than 11.30 a.m. (CET) on 23 November 2015.

9. RECOMMENDATION
The Board unanimously considers that the Proposals are in the best interests of Shareholders as a whole. The Board

recommends that Shareholders vote in favour of the Resolutions, as the Directors intend to do in respect of their own
beneficial holdings of Shares which, in aggregate, amount to 261,000 Shares, representing approximately 0.1 per cent. of
the issued Shares of the Company.

Tom Chandos
<i>Chairman

DEFINITIONS

“Articles”

the articles of the Company in force from time to time

“Board” or “Directors”

the board of directors of the Company whose names are set
out on page 2 of this Circular

“Circular”

this document

“Company”

Invista European Real Estate Trust SICAF

“CREST”

the system for paperless settlement of trades and the holding
of uncertificated securities administered by Euroclear

“Depository”

Capita IRG Trustees Limited

“Depository Interest Holder”

a holder of a Depository Interest

“Depository Interests”

interest in the Shares held through the Depository

“Extraordinary General Meeting” or “EGM”

the extraordinary general meeting of the Company convened
for [time] on [date] at the Company's registered office, 11-13,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (or any adjourn-
ment thereof), notice of which is set out at the end of this
Circular

“Form of Direction”

the form of direction for use at the Extraordinary General
Meeting

148232

L

U X E M B O U R G

“Form of Proxy”

the form of proxy for use at the Extraordinary General Meet-
ing

“HMRC”

HM Revenue &amp; Customs

“Liquidator”

Fund Solution SCA, a partnership limited by shares (société
en commandite par actions), incorporated and existing under
the laws of Luxembourg, having its registered office at 1,
Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Regis-
tre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under num-
ber B 154.626 and represented for the purposes of the
liquidation of the Company by Mr Christophe Cahuzac, re-
siding professionally in Luxembourg and Mr Marek Doma-
gala, residing professionally in Luxembourg

“London Stock Exchange” or “LSE”

London Stock Exchange plc

“Notice of Extraordinary General Meeting”

the notice convening the Extraordinary General Meeting, as
set out at the end of this Circular

“Main Market”

the Main Market of the London Stock Exchange

“Official List”

the official list of the UKLA

“Ordinary Shares”

all shares in the capital of the Company other than Preference
Shares

“Preference Shares”

the non-voting preference shares issued from time to time in
accordance with, and with such specific rights as set out in,
Article 8 of the Articles

“Registrar”

Citco REIF Services (Luxembourg) S.A.

“Resolutions”

the resolutions to be proposed at the EGM in relation to the
Proposals

“Retention”

has the meaning given on page 4 of this Circular

“Shareholders”

holders of Shares

“Shares”

the Ordinary and Preference Shares of no par value in the
capital of the Company

“UKLA”

the Financial Conduct Authority acting in its capacity as the
competent authority for the purposes of Part VI of the Finan-
cial Services and Markets Act 2000

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company will be held at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg at 11.30 a.m. on <i>26 November 2015 to consider

and, if thought fit, to pass the following Resolutions:

<i>RESOLUTIONS:

THAT:

1) The Company be put into liquidation and dissolved.

2) Fund Solutions SCA, a partnership limited by shares (société en commandite par actions), incorporated and existing

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 154.626 and represented for the purposes of the
liquidation of the Company by Mr Christophe Cahuzac, residing professionally in Luxembourg and Mr Marek Domagala,
residing professionally in Luxembourg, be appointed as liquidator to the Company and granted the broadest powers to
manage the Company for the purposes of its liquidation, including those powers contained in articles 144 <i>et sequentia of
the Law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended).

Save where the context requires otherwise, the definitions contained in the Circular shall have the same meanings where

used in the Resolution.

26 October 2015

<i>By order of the Board

<i>Registered office:

Citco REIF Services (Luxembourg) S.A.

11-13, boulevard de la Foire

<i>Secretary

L-1528 Luxembourg

148233

L

U X E M B O U R G

<i>Explanatory Notes:

1) The Resolutions require a simple majority of those Shareholders voting in person or by proxy at the EGM
to be passed.
2) The “Vote Withheld” option is provided to enable Shareholders to abstain on any particular Resolution.
However, it should be noted that a “Vote Withheld” is not a vote in law and will not be counted in the calculation
of the proportion of the votes 'For' and 'Against' a resolution.
3) A Shareholder entitled to attend and vote at the EGM is entitled to appoint one or more proxies to attend
and vote instead of him or her. A proxy need not be a Shareholder. Completion and return of the Form of Proxy
will not preclude Shareholders from attending, speaking or voting at the EGM, if they so wish.
4) More than one proxy may be appointed provided each proxy is appointed to exercise the rights attached to
different Shares.
5) To be valid the Form of Proxy, together with the original power of attorney or other authority, if any, under
which it is executed (or a notarially certified copy of such power of authority) must be returned by post or by
hand to the Company's Registrar, Mr Jorrit Crompvoets, Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., 20, rue de
la Poste, L-2346 Luxembourg, as soon as possible but in any event so as to arrive not later than close of business
on 23 November 2015. A Form of Proxy is enclosed with this Notice.
6) All persons recorded on the register of Shareholders as holding Shares in the Company as at 6 p.m. on 12
November 2015 or, if the EGM is adjourned, as at forty-eight hours before the time of the second EGM, shall
be entitled to attend, speak and vote (either in person or by proxy) at the EGM and shall be entitled to one vote
per Share held.
7)  Where  there  are  joint  registered  holders  of  any  Shares  such  persons  shall  not  have  the  right  of  voting
individually in respect of such Shares but shall elect one of their number to represent them and to vote whether
in person or by proxy in their name. In default of such election the person whose name stands first on the
register of Shareholders shall alone be entitled to vote. Where there are joint participants in respect of any
Share such persons shall not have the right of voting individually in respect of such Share but shall elect one
of their number to represent them and to vote whether in person or by proxy in their name. In default of such
election the participant whose interests are first notified to the Company shall alone be entitled to vote.
8) Where the Shareholder is a corporation, the Form of Proxy must be executed under its common seal or
under the hand of its duly authorised officer or attorney.
9) On a poll, votes may be given either personally or by proxy and a Shareholder entitled to more than one
vote need not use all his votes or cast all the votes he uses in the same way.
10) Any corporation which is a Shareholder may by resolution of its directors or other governing body authorise
such person as it thinks fit to act as its representative at this meeting. Any person so authorised shall be entitled
to exercise on behalf of the corporation which he represents the same powers (other than to appoint a proxy)
as that corporation could exercise if it were an individual Shareholder.
11) If you are a Depository Interest holder, please complete and send the enclosed Form of Direction to Capita
Asset Services, PXS, 34, Beckenham Road, Beckenham, Kent, United Kingdom BR3 4TU to be received no
later than 11.30 a.m. (CET) on 23 November 2015. Depository Interest holders wishing to attend the Extraor-
dinary General Meeting should request a Letter of Representation by contacting The Depository, Capita IRG
Trustees Limited, 34, Beckenham Road, Beckenham, Kent, United Kingdom BR3 4TU no later than 11.30
a.m. (CET) on 23 November 2015.

Référence de publication: 2015175735/755/309.

Mylan Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 133.517.

La Société a été constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 2877 du 11 décembre 2007.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mylan Luxembourg 3 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015159569/15.
(150175827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

148234

L

U X E M B O U R G

Beheer- en Beleggingsmaatschappij Radi B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 194.137.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015158380/9.
(150174566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Schuler Romain S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 48-52, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 84.969.

Les comptes annuels au 30 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015158973/10.
(150175125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Sepik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 163.877.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015158977/10.
(150174588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Finasset S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 128.961.

Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015159359/12.
(150175558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

DH Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 166.266.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 27 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 587 du 6 mars 2012.

Les comptes annuels de la Société au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DH Services Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2015159309/13.
(150176022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

148235

L

U X E M B O U R G

D-R Luxembourg Partners 1 S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 182.924.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159294/9.
(150176038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Croq'Chalet Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 51.638.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PINHEIRO Samantha.

Référence de publication: 2015159290/10.
(150175483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

CVC European Credit Opportunities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 158.090.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159293/10.
(150175547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Dover Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 89.408.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2013 de la maison mère, Dover Corporation, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DOVER LUXEMBOURG S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2015159318/12.
(150176057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Compagnie Francilienne d'Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 71.411.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2015159281/13.
(150176116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

148236

L

U X E M B O U R G

Dynamic Materials Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 140.050,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 134.213.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159297/10.
(150175451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Dachkin-Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 69.330.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2015159298/10.
(150176052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Elburg Invest B.V. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 174.104.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Elburg Invest B.V., S. à r.l.

Référence de publication: 2015159329/11.
(150175712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Entreprise de constructions Modeste BAATZ et Fils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Luxembourg, 1, Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 22.520.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MODESTE BAATZ ET FILS S.A R.L.
FIDUCIAIRE ATTEN, SADIKU &amp; ASSOCIES S.A R.L.

Référence de publication: 2015159332/11.
(150176164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Dover Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 89.408.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2014 de la maison mère, Dover Corporation, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DOVER LUXEMBOURG S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2015159319/12.
(150176065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

148237

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg Wembley Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 175.269.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Référence de publication: 2015158865/10.
(150174939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

OCM Luxembourg Wembley Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 175.449.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Référence de publication: 2015158866/10.
(150174938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Treetop PSF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 175.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg.

Fernand ZANEN.

Référence de publication: 2015159001/10.
(150174469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Le Nomade, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 26, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 103.597.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015158768/11.
(150174863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

New Form S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 77.356.

Le bilan de clôture au 15 septembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2015.

<i>POUR LE LIQUIDATEUR
Signature

Référence de publication: 2015158844/12.
(150174545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

148238

L

U X E M B O U R G

DF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 111.398.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28. septembre 2015.

Référence de publication: 2015159308/10.
(150175755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Maint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 55.568.

REMPLACE BILAN ET COMPTES DE RESULTAT DEPOSE LE 04.09.2015 NUMERO L150163120
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015159571/11.
(150174633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Alzheimer Europe Foundation, Fondation.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 145, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg G 229.

<i>Multi-annual Budget

<i>Alzheimer Europe Foundation G229

Income

2015

2016

2017

2018

01. Set-up grant by AE
02 Donations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,000

40,000

70,000

100,000

03. EU-Subsidies
04. Corporate sponsorship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000

10,000

20,000

40,000

05. Other sponsorship/subsidies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,000

50,000

75,000

100.000

06. Pub. Sales and royalties

500

1,000

07. Meeting registration fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000

7,500

10,000

08. Bank interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

1,000

2,000

2,000

09. Other revenue
Total Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,500

106,000

175,000

253,000

Expenses
01. Personnel costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,000

50,000

02. Travel and Accommodation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000

25,000

35,000

40,000

03. Stationery and supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

500

500

500

04. Communication costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,000

4,500

4,500

4,500

05. Publications/Info, Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,500

5,000

5,000

5,000

06. Rent and office costs
07. Equipment and leasing
08. Grants to associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,000

25,000

50,000

80,000

09. Awards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,000

10,000

20,000

10. Bank charges
11. Legal fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,500

12. Other costs
Total Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27,500

70,000

130,000

200,000

Final Surplus/deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,000

36,000

45,000

53,000

End-of year Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,500

150,500

195,500

248,500

Report of the Réviseur d'entreprises agréé

148239

L

U X E M B O U R G

and
annual accounts as at December 31, 2014

<i>Report of the réviseur d'entreprises agréé

Following our appointment by the Board, we have audited the accompanying annual accounts of ALZHEIMER EU-

ROPE FOUNDATION, which comprise the balance sheet as at December 31, 2014 and the profit and loss account for the
year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of the Board of Directors' for the annual accounts
The Board of Directors Is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance

with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts, and for such internal
control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.

Responsibility of the réviseur d'entreprises agréé
Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in

accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier, Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance about whether the annual accounts are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual

accounts. The procedures selected depend on the réviseur d'entreprises agréé's judgement, including the assessment of the
risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the
réviseur d'entreprises agréé considers Internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the annual
accounts in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors, as well as eva-
luating the overall presentation of the annual accounts.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In  our  opinion,  the  annual  accounts  give  a  true  and  fair  view  of  the  financial  position  of  ALZHEIMER  EUROPE

FOUNDATION as of December 31, 2014, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts,

Luxembourg, September 2 

nd

 , 2015.

<i>For auditeurs associés, Cabinet de révision agréé
32, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Philippe SLENDZAK
<i>Partner

Appendix:

<i>Annual accounts as at December 31 

<i>st

<i> , 2014

<i>Balance sheet as of December 31, 2014

2014

(Euro)

ASSETS
Current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 421,98

Other debtors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 792,65

Cash at bank and on deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 214,63

115 214,63

LIABILITIES
Capital and reserves
Results brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 000,00
Result of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4 785,37

115 214,63

Creditors
Other liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00
0,00

115 214,63

148240

L

U X E M B O U R G

<i>Profit and loss account

<i>Year ended December 31, 2014

2014

(Euro)

Grants received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 516,33

Grants given . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -68 260,00
Bank charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-41,70

-4 785,37

<i>Notes to the annual accounts as at 31 December 31 2014

Note 1. General. Alzheimer Europe Foundation, hereafter «the Foundation)), was set up on November 22, 2013 within

the definition of a non-profit making association as defined by Luxembourg law for an unlimited period of time.

The Foundation's registered office is established in L-2611 Luxembourg at 145, route de Thionville. The financial year

of the Foundation runs from January 1 to December 31 of each year.

The aim of the Foundation is to support networking activities of national Alzheimer's associations in the framework of

Alzheimer Europe a.s.b.l., to encourage the involvement of people with dementia in European conferences, meetings and
projects, to promote European dialogue on legal and ethical issues in dementia, and to support the exchange of information
and good practices on national dementia strategies and Alzheimer's plans.

Note 2. Summary of significant accounting policies. The annual accounts as at 31 December 2014 have been prepared

in accordance with generally accepted accounting principles and in accordance with the laws and regulations in force in
the Grand-Duchy of Luxembourg.

Debtors and creditors are recorded at nominal value.
Grants received by the Foundation but which have not been paid as at the year end are included in other debtors and are

recorded as income in the profit and loss account.

Grants given by the Foundation but which have not been paid as at the year end are included in other liabilities and are

recorded as expense in the profit and loss account.

During the period under review, the Foundation did not receive grants from or give grants to third parties other than

Alzheimer Europe a.s.b.l.

Note 3. Capital and Reserves. The Foundation was set up with an initial grant of 120,000 EUR paid to the Foundation

by Alzheimer Europe a.s.b.l.

Note 4. Staff. The Foundation did not employ any staff in the period under review.

Note 5. Remuneration of the Board of Directors.
No compensation was paid to members of the Board in respect of their functions within the Foundation in the period

under review.

Note 6. Off balance sheet commitments. There are no off balance sheet commitments of the Foundation as at 31 De-

cember 2014.

Référence de publication: 2015157760/126.
(150174066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Viager Life Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 157.957.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

<i>Pour: Viager Life Holding
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015159788/14.
(150175701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

148241

L

U X E M B O U R G

MEIF4 Luxembourg B Holdings S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 166.170.

Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159580/10.
(150176074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Korbach Logistics (European RE Club) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 187.749.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015159491/11.
(150175943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Corridor Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 200.221.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of the month of September.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Logicor Europe Holdings II S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated

under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  2-4,  rue  Eugène  Ruppert,  L-2453
Luxembourg, being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 181.528
and having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 25,000),

represented by Mr François-Xavier Joyeux, juriste, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated

17 

th

 September 2015 which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company “Corridor Topco S.à r.l.” (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Corridor Topco S.à

r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

148242

L

U X E M B O U R G

The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream guarantees), grant security interests,

grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the
same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance

money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case

may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500)

represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business

of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to

act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

148243

L

U X E M B O U R G

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,

by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the

board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal

to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

148244

L

U X E M B O U R G

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in

the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in  the  register  of  shareholders  held  by  the  Company  at  least  eight  (8)  days  before  the  proposed  effective  date  of  the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions  (or  subject  to  the  satisfaction  of  the  majority  requirements,  on  the  date  set  out  therein).  Unanimous  written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year, save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December

2015.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies;

in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December 2015.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:

Subscriber

Number

of shares

Subscription

price (EUR)

Logicor Europe Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12,500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12,500

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

148245

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles

of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:

- BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at

35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under number B 180.304.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,

the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English
language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn am achtzehnten Tag des Monats September,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen,

Logicor Europe Holdings II S.à r.l.., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) lu-

xemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausend-
fünfhundert Euro (EUR 25.000) beträgt, und die im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der nummer
B 181.528 eingetragen ist,

hier vertreten durch Herrn François-Xavier Joyeux, juriste, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 17. September 2015, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei
der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Corridor Topco S.à r.l." wie folgt zu beur-
kunden.

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

"Corridor Topco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebe-
nenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die
entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,

Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream als auch sidestream Bürgschaften), Sicherheiten

leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt
oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-

geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder - Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und

148246

L

U X E M B O U R G

alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-

denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,

durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölf tausend fünf

hundert euros (EUR 12.500), eingeteilt in fünf hundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig euro (EUR 25).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung

vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht

anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die

keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-

gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse

um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und

abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der

Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten

148247

L

U X E M B O U R G

werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,

von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen

Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder

leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-

schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die  Rechte  zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

148248

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage

vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens  acht  (8)  Tage  bevor  der  Beschluss  wirksam  werden  soll,  an  alle  Gesellschafter  an  ihre  im  Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember

eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember
2015 enden.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die  Gesellschafter  können  auf  der  Grundlage  eines  von  dem  alleinigen  Geschäftsführer,  beziehungsweise  der  Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet

werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179

(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich

nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2015 enden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt

in bar eingezahlt und gezeichnet:

148249

L

U X E M B O U R G

Einzahler

Zahl der

Geschäftsanteile

Einzahlungspreis

(EUR)

Logicor Europe Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12.500

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12.500

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.

<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der

Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:

- BRE/Management 7 S.A. eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue

Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer
B 180.304.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen

Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-

schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach

Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: F.- X. JOYEUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30208. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 25. September 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015157825/453.
(150174667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Lithoma Property, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5969 Itzig, 57, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 200.217.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le seizième jour de septembre.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Mario Derikx, juriste, né à Lommel (B) le 5 juillet 1967 demeurant professionnellement à L-5324 Contern,

4, rue des Chaux; et

2) Madame Lieve Nuyts, informaticienne, née à Lommel (B) le 18 décembre 1969 demeurant professionnellement

L-5324 Contern, 4, rue des Chaux.

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  La société est une société commerciale. Elle a la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est régie

par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de „LITHOMA PROPERTY.“

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune du siège social par décision de la gérance.

148250

L

U X E M B O U R G

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale extraor-

dinaire des associés prise dans les conditions requises prévue pour les modifications statutaires.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se

rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente-six mille euros (EUR 36.000,00) représenté par trois mille six cents (3.600)

parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/trois mille six centième (1/3600 

ème

 ) du capital

social, toutes intégralement libérées.

Art. 7. En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont

libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne pourront être cédées ou transmises que dans les conditions du présent

article et les règles suivantes sont d'application:

L'associé cédant doit informer le gérant au moyen d'une lettre recommandée à la poste en indiquant le nombre des parts

dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés, ainsi que le prix de
vente des parts et les conditions de la cession.

Le gérant convoquera une assemblée générale dans les trente jours de la notification de cession en vue de l'application

de la procédure d'agrément.

Agrément
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant plus de la moitié (au moins 50% + 1 (une) part) du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Toutefois, le consentement
n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

L'assemblée générale n'est pas tenue d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.
La décision d'agrément ou de refus de l'assemblée générale est notifiée par le gérant à l'associé cédant dans les huit jours

de la décision de l'assemblée.

La demande d'agrément sera faite par les héritiers ou bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles de

l'associé décédé.

En cas de non-agrément, les héritiers, légataires ou institués contractuels peuvent, à défaut d'avoir trouvé un cessionnaire

réunissant les conditions requises du présent article pour l'ensemble des parts sociales de leur auteur, provoquer la disso-
lution de la société trois mois après mise en demeure signifiée au gérant par exploit d'huissier et notifiée aux associés par
pli recommandé à la poste. Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales de l'associé défunt peuvent être
acquises, soit par les associés, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même si elle remplit les conditions
exigées pour l'acquisition par une société de ses titres, sur base d'un prix de rachat calculé sur la base du bilan moyen des
trois dernières années, ou à défaut de trois exercices, sur base du bilan de la dernière ou des deux dernières années.

Les autres associés ont un droit de préemption sur les parts proposées à la cession.
L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société. Toute opération de cession ou de transmission n'est opposable à la société comme aux tiers qu'à la
condition d'avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du
Code civil, et qu'après qu'elle soit dûment inscrite au registre des parts.

Art. 8. Les attributs du droit de propriété se répartissent, en cas de démembrement du droit de propriété en usufruit et

nue-propriété comme suit:

a) le droit de vote aux assemblées générales est exercé par l'usufruitier;

148251

L

U X E M B O U R G

b) Pour ce qui n'est pas réglé par le point a) ci-dessus, les droits respectifs des nus propriétaires et usufruitiers sont réglés

par les dispositions du code civil luxembourgeois applicables en la matière.

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un

seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Le démembrement du droit de propriété des
parts sociales en usufruit et en nue-propriété ne tombe pas sous la clause prévisée, les droits y relatifs étant exercés par
l'usufruitier.

Art. 9. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir

l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées géné-

rales.

Art. 10. La société est gérée par Monsieur Mario Derikx, né à Lommel (B) le 5 juillet 1967 pour un terme indéterminé.
La révocation ou la nomination du gérant statutaire ne pourra être décidée que moyennant modification des statuts et

par résolution prise à l'unanimité des associés comme stipulé à l'article 12 ci-après.

Le gérant a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
A l'égard des tiers, la société ne se trouve valablement engagée que par la signature du gérant qui peut conférer à toutes

personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Sous réserve de dispositions contraires de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou de textes légaux applicables en

la matière, Madame Lieve Nuyts, née à Lommel (B) le 18 décembre 1969 est désignée en qualité de gérant suppléant qui
entrera en fonction dès l'instant où le gérant titulaire vient à décéder ou n'est plus à même d'exercer son mandat dûment
justifié par deux certificats médicaux délivrés par des médecins spécialistes.

Art. 11. Ni le décès, ni l'interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture du gérant ou d'un ou de

plusieurs associés n'entraînent la dissolution de la Société.

Art. 12. Les décisions des associés sont prises soit en assemblée générale, soit par écrit conformément à l'article 193 de

la loi régissant les sociétés commerciale.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de démembrement de

l'usufruit et de la nue-propriété d'une part, l'usufruitier exerce seul le droit de vote aux assemblées générales des associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées

par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de
la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés

représentant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. En outre, la nomination

ou la révocation d'un gérant statutaire ne pourra être décidée que moyennant modification des statuts et par résolution prise
à l'unanimité des associés.

Aussi longtemps que la société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des

associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un

bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière
reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est
à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Le gérant est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, la gérance soit en

possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de fonds suffisants à la distribution
de ces acomptes sur dividendes. La distribution de dividendes intérimaires est soumise aux dispositions des articles 167 et
201 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du
capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

148252

L

U X E M B O U R G

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois
modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se clôturera le 31

décembre 2016.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis, les trois mille six cents (3.600) parts sociales ont été souscrites et libérées

par un apport en espèces comme suit par:

1) Monsieur Mario Derikx, précité et ici présent qui déclare souscrire et libérer intégralement en espèces mille huit cent

trente-six (1.836) parts sociales.

2) Madame Lieve Nuyts, précitée et ici présente qui déclare souscrire et libérer intégralement en espèces mille sept cent

soixante-quatre (1.764) parts sociales.

Toutes les 3.600 parts sociales ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de

TRENTE-SIX MILLE EUROS (EUR 36.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en est justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.100,00).

La société s'engage solidairement ensemble avec les comparants, au paiement desdits frais.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, les associés, exerçant les pouvoirs de l‘assemblée générale, ont pris la

résolution suivante:

Le siège social est établi à L - 5969 Itzig, 57 rue de la Libération.

<i>Pouvoirs

Les comparants, dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné,

chacun pouvant agir séparément à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs (faute(s) de frappe) éventuels des
présentes.

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Mario Deriks, Lieve Nuyts, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 17 septembre 2015. 1LAC / 2015 / 29627. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 septembre 2015.

Référence de publication: 2015158052/170.
(150174559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Vedipar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 131.813.

Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159038/9.
(150174998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

148253

L

U X E M B O U R G

Chemtrade Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.766.570,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 183.212.

<i>Rectificatif au dépôt numéro L150140287 déposé en date du 31 juillet 2015.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159208/10.
(150176163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Brookfield Properties (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 100.464.

Veuillez prendre note que le gérant, M. Luc LEROI a changé d'adresse et se situe désormais au 13a, rue de Clairefontaine,

L-8460 Eischen, Luxembourg.

Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Brookfield Properties (Luxembourg) S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015157782/13.
(150174111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

ERRV Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 2.093.256,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 198.351.

In the year two thousand and fifteen, on the fourteenth day of September,
Before the undersigned, Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg (the

"Notary"),

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Shareholders") of ERRV Luxembourg Holdings S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered address at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500.- and registered with the Luxembourg register of commerce and
companies (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 198.351 (the "Company"), incorporated pursuant to
a deed of the undersigned notary dated 29 June 2015 and whose articles of association (the "Articles") were published in
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C") number 2316, page 111151, on 29 August 2015. The
Articles have not been amended since its incorporation.

Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, whose professional address is in Pétange, acted as chairman of

the meeting with the consent of the meeting (the "Chairman"). The Chairman appointed Mrs Marisa GOMES, private
employee, whose professional address is in Pétange, to act as secretary. The meeting elected Mrs Laetitia ZUANEL, whose
professional address is in Luxembourg, to act as scrutineer.

These appointments having been made, the Chairman declared that:
I. The names of the shareholders present or represented at the meeting by proxies (the "Shareholders") and the number

of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list, signed by or on behalf of the Shareholders,
the Notary, the Chairman, scrutineer and secretary, together with the proxy forms, signed ne varietur by the Shareholders
represented at the meeting by proxyholders, the Notary and the Chairman, scrutineer and secretary, shall remain annexed
to the present deed and shall be registered with it.

II. The attendance list shows that Shareholders holding 12,500 shares, representing the whole share capital of the Com-

pany, are represented at the meeting by proxies. All the Shareholders have declared that they have been sufficiently informed
of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The meeting is
therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

148254

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. To remove the nominal value of the shares issued by the Company.
2. To convert the share capital of the Company from Euro (EUR) into Danish Krone (DKK) using the exchange currency

rate applicable as of 14 September 2015 being 1 EUR for 7.4605 DKK, so that the share capital of the Company shall
henceforth amount to DKK 93,256.25 represented by 12,500 shares without designation of a nominal value.

3. To reduce the share capital of the Company in the amount of DKK 0.25 in order to bring the current share capital to

DKK 93,256.-, by reducing the accounting value of each share and allocating the amount of the capital reduction to a freely
distributable reserve in the accounts of the Company.

4. To exchange the 12,500 shares without designation of a nominal value against 93,256 shares with a nominal value

of DKK 1.- each, all subscribed by the Shareholders, the amount of the share capital remaining unchanged.

5. To create 10 new classes of preferred shares having the rights set out below and each share having a nominal value

of DKK 1.-, hereinafter referred to as:

- class A shares (the "Class A Preferred Shares");
- class B shares (the "Class B Preferred Shares");
- class C shares (the "Class C Preferred Shares");
- class D shares (the "Class D Preferred Shares");
- class E shares (the "Class E Preferred Shares");
- class F shares (the "Class F Preferred Shares");
- class G shares (the "Class G Preferred Shares");
- class H shares (the "Class H Preferred Shares");
- class I shares (the "Class I Preferred Shares"); and
- class J shares (the "Class J Preferred Shares").
6. To reclassify the existing 93,256 shares in the Company as the "Initial Ordinary Shares".
7. To increase the share capital of the Company by an amount of DKK 2,000,000.-, in order to raise it from its current

amount of DKK 93,256.- to DKK 2,093,256.-, through the creation and issuance of 200,000 Class A Preferred Shares,
200,000 Class B Preferred Shares, 200,000 Class C Preferred Shares, 200,000 Class D Preferred Shares, 200,000 Class E
Preferred Shares, 200,000 Class F Preferred Shares, 200,000 Class G Preferred Shares, 200,000 Class H Preferred Shares,
200,000 Class I Preferred Shares and 200,000 Class J Preferred Shares, with a nominal value of DKK 1.- each (together,
the "New Shares"), having the rights set out below.

8. To amend articles 5.1, 5.5, 14.2 and 14.3 of the articles of association of the Company.
After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to remove the nominal value of the shares issued by the Company.

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to convert the share capital of the Company from Euro (EUR) into Danish Krone (DKK)

using the exchange currency rate applicable as of 14 September 2015 being 1 EUR for 7.4605 DKK, so that the share
capital of the Company shall henceforth amount to DKK 93,256.25 represented by 12,500 shares without designation of a
nominal value.

<i>Third resolution

The Shareholders resolved to reduce the share capital of the Company in the amount of DKK 0.25 in order to bring the

current share capital to DKK 93,256.-, by reducing the accounting value of each share and allocating the amount of the
capital reduction to a freely distributable reserve in the accounts of the Company.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolved to exchange the 12,500 shares without designation of a nominal value against 93,256 shares

with a nominal value of DKK 1.- each, all subscribed by the Shareholders, the amount of the share capital remaining
unchanged.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolved to create 10 new classes of preferred shares having the rights set out below and each share

having a nominal value of DKK 1.-, hereinafter referred to as:

- class A shares (the "Class A Preferred Shares");
- class B shares (the "Class B Preferred Shares");
- class C shares (the "Class C Preferred Shares");
- class D shares (the "Class D Preferred Shares");

148255

L

U X E M B O U R G

- class E shares (the "Class E Preferred Shares");
- class F shares (the "Class F Preferred Shares");
- class G shares (the "Class G Preferred Shares");
- class H shares (the "Class H Preferred Shares");
- class I shares (the "Class I Preferred Shares"); and
- class J shares (the "Class J Preferred Shares").

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolved that pursuant to the resolutions above, the existing 93,256 shares in the Company shall be

referred to as the "Initial Ordinary Shares".

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of DKK 2,000,000.-, in order to

raise it from its current amount of DKK 93,256.- to DKK 2,093,256.-, through the creation and issuance of 200,000 Class
A Preferred Shares, 200,000 Class B Preferred Shares, 200,000 Class C Preferred Shares, 200,000 Class D Preferred Shares,
200,000 Class E Preferred Shares, 200,000 Class F Preferred Shares, 200,000 Class G Preferred Shares, 200,000 Class H
Preferred Shares, 200,000 Class I Preferred Shares and 200,000 Class J Preferred Shares, with a nominal value of DKK
1.- each (together, the "New Shares"), having the rights set out below.

<i>Subscription and payment

3i ERRV Denmark Limited, a Jersey law governed private company incorporated under the Companies (Jersey) Law

1991, registered with the Jersey Financial Services Commission Companies Registry under number 118811 and having its
registered office at 12 Castle Street, St Helier, Jersey, JE2 3RT, represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
notary clerk, residing professionally in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, here annexed, declared
to subscribe for the ownership of 100,000 Class A Preferred Shares, 100,000 Class B Preferred Shares, 100,000 Class C
Preferred Shares, 100,000 Class D Preferred Shares, 100,000 Class E Preferred Shares, 100,000 Class F Preferred Shares,
100,000 Class G Preferred Shares, 100,000 Class H Preferred Shares, 100,000 Class I Preferred Shares and 100,000 Class
J Preferred Shares of the New Shares, fully paid up by a contribution in cash in a total amount of DKK 133,474,941.60,
which shall be allocated as follows: DKK 1,000,000.- shall be allocated to the share capital of the Company and DKK
132,474,941.60 shall be allocated to the Company's share premium account.

AMP Capital Investors (European Infrastructure Lux) S.à r.l. (previously AMP Capital Investor (Angel Trains UK No.

3) S.à r.l.), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of GBP 20,000.- and registered with the Luxembourg register of commerce
and companies (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 197.824, represented by Mrs Sofia AFONSO-DA
CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, here
annexed, declared to subscribe for the ownership of 100,000 Class A Preferred Shares, 100,000 Class B Preferred Shares,
100,000 Class C Preferred Shares, 100,000 Class D Preferred Shares, 100,000 Class E Preferred Shares, 100,000 Class F
Preferred Shares, 100,000 Class G Preferred Shares, 100,000 Class H Preferred Shares, 100,000 Class I Preferred Shares
and 100,000 Class J Preferred Shares of the New Shares, fully paid up by a contribution in cash in a total amount of DKK
133,474,941.60, which shall be allocated as follows: DKK 1,000,000.- shall be allocated to the share capital of the Company
and DKK 132,474,941.60 shall be allocated to the Company's share premium account.

Proof that the amount of DKK 266,949,833.20 is at the disposition of the Company has been shown to the Company.

<i>Eighth resolution

The Shareholders resolved to amend articles 5.1, 5.5, 14.2 and 14.3 of the articles of association of the Company as

follows.

The Shareholders resolved to amend article 5.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

5.1. The Company's share capital is set at two million ninety-three thousand two hundred and fifty-six Danish Kroner

(DKK 2,093,256.-) divided into:

- ninety-three thousand two hundred and fifty-six (93,256) initial ordinary shares (the "Initial Ordinary Shares"),
- two hundred thousand (200,000) class A preferred shares (the "Class A Preferred Shares"),
- two hundred thousand (200,000) class B preferred shares (the "Class B Preferred Shares"),
- two hundred thousand (200,000) class C preferred shares (the "Class C Preferred Shares"),
- two hundred thousand (200,000) class D preferred shares (the "Class D Preferred Shares"),
- two hundred thousand (200,000) class E preferred shares (the "Class E Preferred Shares"),
- two hundred thousand (200,000) class F preferred shares (the "Class F Preferred Shares"),
- two hundred thousand (200,000) class G preferred shares (the "Class G Preferred Shares"),

148256

L

U X E M B O U R G

- two hundred thousand (200,000) class H preferred shares (the "Class H Preferred Shares"),
- two hundred thousand (200,000) class I preferred shares (the "Class I Preferred Shares"), and
- two hundred thousand (200,000) class J preferred shares (the "Class J Preferred Shares"),
each a "Share" and together referred to as the "Shares", having a nominal value of one Danish Kroner (DKK 1.-) each

and the rights and obligations set out in these Articles. The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders"
and individually a "Shareholder".

Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."
The Shareholders resolved to amend article 5.5 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

5.5. The share capital of the Company may be reduced exclusively through the repurchase and subsequent cancellation

of all the issued shares of one or more Classes (a "Share Redemption") in respect of the following periods, provided however
that the Company may not at any time purchase and cancel the Initial Ordinary Shares. A reduction of share capital through
the repurchase of a class of Preferred Shares may only be made within the respective Class Periods:

- The period for the Class A Preferred Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 14 September 2015

and ending no later than on 31 December 2016 (the "Class A Period").

- The period for the Class B Preferred Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending no

later than on 31 December 2017 (the "Class B Period").

- The period for the Class C Preferred Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no

later than on 31 December 2018 (the "Class C Period").

- The period for the Class D Preferred Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending on

no later than on 31 December 2019 (the "Class D Period").

- The period for the Class E Preferred Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no

later than on 31 December 2020 (the "Class E Period").

- The period for the Class F Preferred Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no

later than on 31 December 2021 (the "Class F Period").

- The period for the Class G Preferred Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending no

later than on 31 December 2022 (the "Class G Period").

- The period for the Class H Preferred Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no

later than on 31 December 2023 (the "Class H Period").

- The period for the Class I Preferred Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no

later than on 31 December 2024 (the "Class I Period").

- The period for the Class J Preferred Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later

than on 31 December 2025 (the "Class J Period").

Where a Class has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and cancellation

of that Class may be made within a new period (the "New Period"), which shall start on the date after the last Class Period
(or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another class) and end no later
than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class J Period.

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a Class shall take place prior to the last

day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case may be,
New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such Class and shall continue to end on the day
initially defined in the Articles above.

Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant Class(es), the Cancellation Amount will become due and

payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such Class(es). For the avoidance of doubt the
Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the Sole Manager or,

in case of plurality of managers the Board of Managers (as both terms defined below) in its reasonable discretion and within
the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the Sole Manager or, in case of plurality the Board
of Managers can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount
the freely distributable reserves either in part or in totality.

For the purposes of these Articles, the following words shall have the following definitions:
- "Available Amount" shall mean for each Class Period the total amount of net profits of the Company (including carried

forward profits), increased by (i) any freely distributable reserves and share premium attributable to the Preferred Shares
(ii) as the case may be, by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of
Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums
to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each time as set out in the relevant
Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, and double counting), (iii) any dividend to which the holder(s) of
the Initial Ordinary Shares are entitled pursuant to the Articles and (iv) any Profit Entitlement so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + OD + PE)

148257

L

U X E M B O U R G

Whereby:
AA= Available Amount;
NP= net profits (including carried forward profits);
P= any freely distributable reserves;
CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preferred Shares to be

cancelled;

L= losses (including carried forward losses) expressed as a positive;
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the 1915 Law or of the Articles;
OD = any dividend to which the holder(s) of the Initial Ordinary Shares are entitled pursuant to the Articles;
PE = Profit Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by

the Sole Manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers of the Company in good faith with the view
to the Company's ability to continue as a going concern.

- "Available Liquidities" shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a

remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds, and notes
and any receivable which in the opinion of the Sole Manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers
will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six
(6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the
case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company.

- "Cancellation Amount" shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period

(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities
relating to the relevant Class Period (or New Period).

- "Class" refers to a particular class or classes of Preferred Shares.
- "Class Period" shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the

Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

- "Interim Accounts" shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
- "Interim Account Date" shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the

date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preferred Shares.

- "Preferred Shares" means the Class A Preferred Shares, Class B Preferred Shares, Class C Preferred Shares, Class D

Preferred Shares, Class E Preferred Shares, Class F Preferred Shares, Class G Preferred Shares, Class H Preferred Shares,
Class I Preferred Shares and Class J Preferred Shares.

- "Profit Entitlement" shall mean the dividends allocated to the Preferred Shares."
The Shareholders resolved to amend article 14.2 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

14.2. Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholder

declare dividends. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken
by the Shareholders and such dividend shall be allocated and paid in the following sequential order:

- first to the holder(s) of the Initial Ordinary Shares who shall be entitled to a dividend equal to 11% of the nominal

value of the Initial Ordinary Share held by them, then,

- to the holder(s) of the Class A Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 1% of the nominal value

of the Class A Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class B Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 2% of the nominal value

of the Class B Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class C Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 3% of the nominal value

of the Class C Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class D Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 4% of the nominal value

of the Class D Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class E Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 5% of the nominal value

of the Class E Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class F Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 6% of the nominal value

of the Class F Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class G Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 7% of the nominal value

of the Class G Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class H Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 8% of the nominal value

of the Class H Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class I Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 9% of the nominal value of

the Class I Preferred Shares held by them, then,

148258

L

U X E M B O U R G

- to the holder(s) of the Class J Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 10% of the nominal value

of the Class J Preferred Shares held by them, the balance shall be allocated to the holder(s) of the Preferred Shares pursuant
to a decision taken by the general meeting of Shareholders."

The Shareholders resolved to amend article 14.3 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

14.3. The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder

(s) before the end of the financial year in accordance with the distribution provisions described in the preceding Article
15.2 of these Articles on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of
the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward
losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any
such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder
(s)."

Whereof, the present deed is drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by her name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le quatorze septembre,
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg (le "Notaire"),

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des associés (les "Associés") de ERRV Luxembourg Holdings S.à r.l., une société

à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6,
rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,- et immatriculée auprès du Registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.351 (la "Société") et constituée par un acte du notaire
soussigné en date du 29 juin 2015 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le "Mémorial C") numéro 2316, page 111151, en date du 29 août 2015. Les Statuts n'ont pas encore été
modifiés depuis sa constitution.

Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle est à Pétange, a agi en

tant que président de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée (le "Président"). Le Président a nommé Madame Marisa
GOMES, employée privée, dont l'adresse professionnelle est à Pétange, pour agir en tant que secrétaire. L'assemblée a élu
Madame Laetitia ZUANEL, employée privée, dont l'adresse professionnelle est à Pétange, pour agir en tant que scrutateur.

Ces nominations ayant été effectuées, le Président a déclaré que:
I. Les noms des Associés représentés à l'assemblée en vertu des procurations et le nombre de parts sociales détenues par

eux sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par ou au nom des Associés, le Notaire, le
Président, le scrutateur et le secrétaire, ensemble avec les procurations, signés ne varietur par les Associés représentés à
l'assemblée par des mandataires, le Notaire et le Président, le scrutateur et le secrétaire, devront rester annexées au présent
acte et devront être enregistrées avec lui.

II. Il ressort de la liste de présence que les Associés détenant 12,500 parts sociales représentant l'intégralité du capital

social de la Société sont représentés à l'assemblée par des mandataires. Tous les Associés ont déclaré avoir été suffisamment
informés de l'ordre du jour de l'assemblée en avance et ont renoncé aux exigences et formalités de convocation. L'assemblée
est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Supprimer la valeur nominale des parts sociales.
2. Convertir le devis du capital social de la Société de Euro (EUR) en Couronne Danoise (DKK) au taux de change

applicable au 14 septembre 2015 comme suit: 1 EUR pour 7,4605 DKK, de sorte que le capital social de la société s'élève
dorénavant à DKK 93.256,25 représenté par 12.500 parts sociales sans désignation de valeur nominale chacune.

3. Réduire le capital social de la Société à concurrence de DKK 0,25 afin de le ramener de son montant actuel au montant

de DKK 93.256,-, moyennant la réduction du pair comptable de chaque part et allocation du montant de réduction au poste
de réserve disponible dans les comptes de la Société.

4. Echanger les 12.500 parts sociales sans désignation de valeur nominale chacune contre 93.256 parts sociales d'une

valeur nominale de DKK 1,- chacune, toutes entièrement souscrites par les Associés, le montant du capital social restant
sans modification.

148259

L

U X E M B O U R G

5. Créer 10 nouvelles catégories de parts sociales préférentielles ayant les droits décrits ci-dessous et chaque part sociale

ayant une valeur nominale de DKK 1,-, ci-après dénommées:

- parts sociales préférentielles de catégorie A (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A");
- parts sociales préférentielles de catégorie B (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B");
- parts sociales préférentielles de catégorie C (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C");
- parts sociales préférentielles de catégorie D (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D");
- parts sociales préférentielles de catégorie E (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E");
- parts sociales préférentielles de catégorie F (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F");
- parts sociales préférentielles de catégorie G (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G");
- parts sociales préférentielles de catégorie H (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H");
- parts sociales préférentielles de catégorie I (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I"); et
- parts sociales préférentielles de catégorie J (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J").
6. Reclassifier les 93.256 parts sociales existantes dans la Société comme les "Parts Sociales Ordinaires Initiales".
7. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de DKK 2.000.000,- afin de le porter de son montant actuel

de DKK 93.256,-à DKK 2.093.256,-, par la création et l'émission de 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie
A, 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B, 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C, 200.000
Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E, 200.000 Parts Sociales
Préférentielles de Catégorie F, 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G, 200.000 Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie H, 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I et 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie
J, avec une valeur nominale de DKK 1,- chacune (ensemble, les "Nouvelles Parts Sociales"), ayant les droits décrits ci-
dessous.

8. Modifier les articles 5.1, 5.5, 14.2 et 14.3 des statuts de la Société.
Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les Associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de convertir le devis du capital social de la Société de Euro (EUR) en Couronne Danoise (DKK)

au taux de change applicable au 14 septembre 2015 comme suit: 1 EUR pour 7,4605 DKK, de sorte que le capital social
de la société s'élève dorénavant à DKK 93.256,25 représenté par 12.500 parts sociales sans désignation de valeur nominale
chacune.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société à concurrence de DKK 0,25 afin de le ramener de son

montant actuel au montant de DKK 93.256,-, moyennant la réduction du pair comptable de chaque part et allocation du
montant de réduction au poste de réserve disponible dans les comptes de la Société.

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident d'échanger les 12.500 parts sociales sans désignation de valeur nominale chacune contre 93.256

parts sociales d'une valeur nominale de DKK 1,- chacune, toutes entièrement souscrites par les Associés, le montant du
capital social restant sans modification.

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de créer 10 nouvelles catégories de parts sociales préférentielles ayant les droits décrits ci-dessous

et chaque part sociale ayant une valeur nominale de DKK 1,-, ci-après dénommées:

- parts sociales préférentielles de catégorie A (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A");
- parts sociales préférentielles de catégorie B (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B");
- parts sociales préférentielles de catégorie C (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C");
- parts sociales préférentielles de catégorie D (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D");
- parts sociales préférentielles de catégorie E (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E");
- parts sociales préférentielles de catégorie F (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F");
- parts sociales préférentielles de catégorie G (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G");
- parts sociales préférentielles de catégorie H (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H");
- parts sociales préférentielles de catégorie I (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I"); et
- parts sociales préférentielles de catégorie J (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J").

148260

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

Les Associés décident que suivant les résolutions ci-dessus, les 93,256 parts sociales existantes dans la Société seront

dénommées comme les "Parts Sociales Ordinaires Initiales".

<i>Septième résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de DKK 2.000.000,- afin de le porter de

son montant actuel de DKK 93.256,- à DKK 2.093.256,-, par la création et l'émission de 200.000 Parts Sociales Préféren-
tielles de Catégorie A, 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B, 200.000 Parts Sociales Préférentielles de
Catégorie C, 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E,
200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F, 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G, 200.000 Parts
Sociales Préférentielles de Catégorie H, 200.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I et 200.000 Parts Sociales
Préférentielles de Catégorie J, avec une valeur nominale de DKK 1,- chacune (ensemble, les "Nouvelles Parts Sociales"),
ayant les droits décrits ci-dessous.

<i>Souscription et paiement

3i ERRV Denmark Limited, une société régie par les lois de Jersey, constituée en vertu de la Companies (Jersey) Law

1991, enregistrée auprès du registre des sociétés (Companies Registry) de la Jersey Financial Services Commission sous
le numéro 118811 et ayant son siège social au 12 Castle Street, St Helier, Jersey, JE2 3RT, représentée par Madame Sofia
AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, Grand Duché de Luxembourg,
agissant en vertu d'une procuration, ci-annexée, déclare souscrire à la propriété de 100.000 Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie A, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie
C, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E, 100.000
Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G, 100.000 Parts Sociales
Préférentielles de Catégorie H, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I et 100.000 Parts Sociales Préféren-
tielles de Catégorie J des Nouvelles Parts Sociales, payées intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de
DKK 133.474.941,60, qui sera attribué comme suit: DKK 1.000.000,- sont alloués au capital social de la Société et DKK
132.474.941,60 sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

AMP Capital Investors (European Infrastructure Lux) S.àr.l. (antérieurement AMP Capital Investors (Angel Trains UK

No. 3) S.à r.l.), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg ("RCS") sous le numéro B197824 et ayant un capital social de GBP 20.000,-,
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange,
Grand Duché de Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration, ci-annexée, déclare souscrire à la propriété de 100.000
Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B, 100.000 Parts Sociales
Préférentielles de Catégorie C, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, 100.000 Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie E, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie
G, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H, 100.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I et 100.000
Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J des Nouvelles Parts Sociales, payées intégralement par un apport en numéraire
d'un montant total de DKK 133.474.941,60, qui sera attribué comme suit: DKK 1.000.000,- sont alloués au capital social
de la Société et DKK 132.474.941,60 sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve que la somme de DKK 266.949.833,20 est à la disposition de la Société a été montrée à la Société.

<i>Huitième résolution

Les Associés décident de modifier les articles 5.1, 5.5, 14.2 et 14.3 des statuts de la Société comme suit.
Les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:

5.1. Le capital souscrit est fixé à deux millions quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante-six Couronnes Danoises

(DKK 2.093.256,-) représenté par:

- quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante-six (93,256) parts sociales ordinaires initiales (les "Parts Sociales Ordi-

naires Initiales"),

- deux cents mille (200.000) parts sociales préférentielles de catégorie A (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

A"),

- deux cents mille (200.000) parts sociales préférentielles de catégorie B (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

B"),

- deux cents mille (200.000) parts sociales préférentielles de catégorie C (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

C"),

- deux cents mille (200.000) parts sociales préférentielles de catégorie D (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

D"),

- deux cents mille (200.000) parts sociales préférentielles de catégorie E (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

E"),

148261

L

U X E M B O U R G

- deux cents mille (200.000) parts sociales préférentielles de catégorie F (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

F"),

- deux cents mille (200.000) parts sociales préférentielles de catégorie G (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

G"),

- deux cents mille (200.000) parts sociales préférentielles de catégorie H (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

H"),

- deux cents mille (200.000) parts sociales préférentielles de catégorie I (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

I"), et

- deux cents mille (200.000) parts sociales préférentielles de catégorie J (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

J"), chaque "Part Sociale" et ensemble ci-après désignées comme les "Parts Sociales", ayant une valeur nominale d'une
Couronne Danoise (DKK 1,-) chacune, et ayant les droits et obligations décrits dans les présents Statuts. Les détenteurs de
Parts Sociales sont désignés tous ensemble comme les "Associés", et individuellement comme "Associé".

Chaque Part Sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."
Les Associés décident de modifier l'article 5.5 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:

5.5. Le capital social de la Société peut être réduit exclusivement par le rachat et l'annulation subséquente des Parts

Sociales émises d'une ou plusieurs Catégorie(s) (un "Remboursement de Part Sociale") à l'égard des périodes suivantes,
sous réserve cependant, que la Société ne rachète et n'annule à tout moment les Parts Sociales Ordinaires Initiales. Une
réduction du capital social par le biais d'un rachat d'une catégorie de Parts Sociales Préférentielles peut se faire seulement
endéans les Périodes de Catégorie respectives:

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A est la période qui commence à la date de l'acte notarié

du 14 septembre 2015 et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2016 (la "Période de Catégorie A").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie A et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2017 (la "Période de Catégorie B").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie B et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2018 (la "Période de Catégorie C").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie C et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2019 (la "Période de Catégorie D").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie D et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2020 (la "Période de Catégorie E").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie E et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2021 (la "Période de Catégorie F").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie F et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2022 (la "Période de Catégorie G").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie G et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2023 (la "Période de Catégorie H").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie H et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2024 (la "Période de Catégorie I").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie I et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2025 (la "Période de Catégorie J").

Lorsqu'une Catégorie n'aura pas été rachetée et annulée endéans la Période de Catégorie concernée, le remboursement

et l'annulation de cette Catégorie peut se faire endéans une nouvelle période (la "Nouvelle Période"), laquelle devra com-
mencer à la date après la dernière Période de Catégorie (ou selon le cas, la date après la fin immédiate de la Nouvelle
Période précédente d'une autre catégorie) et se terminer pas plus tard qu'un an après la date de début de cette Nouvelle
Période. La première Nouvelle Période devra commencer le jour après la Période de Catégorie J.

Afin d'éviter tout doute, dans le cas où un rachat et une annulation d'une Catégorie aurait lieu avant le dernier jour de

sa Période de Catégorie respective (ou selon le cas, Nouvelle Période), la Période de Catégorie suivante (ou selon le cas,
Nouvelle Période) devra commencer la jour après la rachat et l'annulation de cette Catégorie et devra continuer pour se
terminer le jour comme initialement défini dans les Statuts ci-dessus.

Sur le rachat et l'annulation de la(des) Catégorie(s) entière(s) concernée(s), le Montant d'Annulation deviendra dû et

exigible par la Société à l'(aux) Associé(s) au pro rata de leur détention dans cette(ces) Catégorie(s). Afin d'éviter tout doute
la Société peut s'acquitter de ses obligations de paiement en numéraire, en nature ou par voie de compensation.

Le Montant d'Annulation mentionné dans le paragraphe ci-dessus devant être retenu devra être déterminé par le Gérant

Unique ou, en cas de pluralité de gérants le Conseil de Gérance (les deux termes définis ci-dessous) à sa discrétion rai-
sonnable et dans le meilleur intérêt de la Société. Afin d'éviter tout doute, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité le Conseil
de Gérance peut choisir à sa seule discrétion d'inclure ou d'exclure dans sa détermination du Montant d'Annulation les
réserves librement distribuables soit en partie soit en totalité.

Pour les besoins de cet Article, les mots suivants auront les définitions suivantes:
- "Catégorie" désigne une ou plusieurs catégories spécifiques de Parts Sociales.

148262

L

U X E M B O U R G

- "Comptes Intérimaires" signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés.
- "Date des Comptes Intérimaires" signifie la date pas plus tôt que trente (30) jours mais pas plus de dix (10) jours avant

la date de rachat et d'annulation de la catégorie de Parts Sociales Préférentielles concernée.

- "Droit au bénéfice" signifie les dividendes préférentiels des Parts Sociales Préférentielles.
- "Liquidités Disponibles" signifie (i) tout l'argent détenu par la Société (sauf l'argent sur des dépôts à terme avec une

maturité restante excédant six (6) mois, (ii) tous instruments financiers facilement négociables, obligations et notes et toutes
créances qui selon l'opinion du Conseil de Gérance sera payées à la Société à court terme moins tout endettement ou autre
dette de la Société payable dans les six (6) mois déterminé sur la base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de
Catégorie concernée (ou Nouvelle Période, selon le cas) et (iii) tous actifs tels que des parts sociales, actions ou titres
d'autres sortes détenus par la Société.

- "Montant d'Annulation" signifie un montant n'excédant pas le Montant Disponible relatif à la Période de Catégorie

concernée (ou Nouvelle Période, selon le cas) à condition que le Montant d'Annulation ne peut être plus élevé que les
Liquidités Disponibles relatives à la Période de Catégorie concernée (ou Nouvelle Période).

- "Montant Disponible" signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant les bénéfices reportés) aug-

menté par (i) toutes réserves librement distribuables et (ii) selon le cas, par le montant de la réduction de capital et la
réduction de la réserve légale relative à la catégorie de Parts Sociales Préférentielles devant annulée mais réduite par (i)
toutes pertes (incluant les pertes reportées) exprimées comme positive, (ii) toutes sommes devant être placées dans la(les)
réserve(s) en application aux exigences de la Loi de 1915 ou des Statuts, chaque fois comme établi dans les Comptes
Intérimaires concernés (sans, afin d'éviter tout doute, tout double comptage), (iii) tous dividendes auxquels le(s) détenteur
(s) de Parts Sociales Ordinaires Initiales a(ont) droit en vertu des Statuts et (iv) tout Droit au Bénéfice de manière que:

AA = (NP + P+ CR) - (L+LR+OD+PE)
Dont:
AA = Montant Disponible;
NP = bénéfices nets (incluant les bénéfices reportés);
P = toutes réserves librement distribuables;
CR = le montant de la réduction de capital et la réduction de la réserve légale relative à la catégorie de Parts Sociales

Préférentielles devant être annulée;

L= pertes (incluant les pertes reportées) exprimées comme positive;
LR = toutes sommes devant être placées dans la(les) réserve(s) en vertu des dispositions de la Loi de 1915 ou des Statuts;
OD = tous dividendes auxquels le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires a droit en vertu des Statuts
PE = Bénéfice Autorisé.
Le Montant Disponible doit être établi dans les Comptes Intérimaires de la Période de Catégorie respective et devra être

évalué par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants le Conseil de Gérance de la Société de bonne foi et avec la
vue des capacités de la Société pour qu'elle puisse continuer.

- "Parts Sociales Préférentielles" signifie les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A, Parts Sociales Préférentielles

de Catégorie B Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, Parts Sociales
Préférentielles de Catégorie E, Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F, Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G,
Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H, Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I et Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie J.

- "Période de Catégorie" signifie chacune de la Période de Catégorie A, la Période de Catégorie B, la Période de Catégorie

C, la Période de Catégorie D, la Période de Catégorie E, la Période de Catégorie F, la Période de Catégorie G, la Période
de Catégorie H, la Période de Catégorie I et la Période de Catégorie J."

Les Associés décident de modifier l'article 14.2 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:

14.2. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par résolutions des

Associés déclarer des dividendes. La décision de distribuer des fonds et la détermination du montant d'une telle distribution
seront prises par les Associés et ledit dividende sera alloué et payé dans l'ordre suivant:

- d'abord, le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires Initiales a(ont) droit à un dividende égal à 11 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Ordinaires Initiales détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A a(ont) droit à un dividende égal à 1 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B a(ont) droit à un dividende égal à 2 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C a(ont) droit à un dividende égal à 3 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D a(ont) droit à un dividende égal à 4 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, détenues par lui/eux, puis,

148263

L

U X E M B O U R G

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E a(ont) droit à un dividende égal à 5 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F a(ont) droit à un dividende égal à 6 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G a(ont) droit à un dividende égal à 7 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H a(ont) droit à un dividende égal à 8 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I a(ont) droit à un dividende égal à 9 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J a(ont) droit à un dividende égal à 10 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J, détenues par lui/eux, puis,

la différence sera allouée au(x) détenteur(s) de Parts Sociales Préférentielles conformément à une décision prise par

l'assemblée générale des Associés."

Les Associés décident de modifier l'article 14.3 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:

14.3. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut, le cas échéant, décider de payer des acomptes sur dividendes

au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social conformément aux dispositions relatives à la distribution décrites dans
l'Article 14.2 précédent sur base d'une situation comptable montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la
distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis
la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes
reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi de 1915 ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes
distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés peuvent devoir être remboursés par le(s) Associé
(s)."

Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte a été lu au mandataire des comparants connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le mandataire

des comparants a signé l'acte avec le notaire.

Signé: Conde, Gomes, Zuanel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21192. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015157897/565.
(150173968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Compagnie de Saint Cyr S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 169.051.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159280/9.
(150175644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Dolpo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 149.766.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2015159317/10.
(150176139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

148264

L

U X E M B O U R G

Hikma Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.161.931,00.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 191.163.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of September,
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Hikma Pharmaceuticals PLC, a company incorporated and governed by the laws of England and Wales, having its

registered office address at 13 Hanover Square, London W1S 1HW, United Kingdom, and registered with the Companies
House of England and Wales under number 5557934 (the “Appearing Company”),

here represented by Peggy Simon, employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy

of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the Appearing Company and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such Appearing Company, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The Appearing Company is the sole shareholder of the private limited liability company (“société à responsabilité

limitée”) established in Luxembourg under the name of “Hikma Finance (Luxembourg) S.à r.l.”, having its registered office
at 20 rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 191163 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,
Maître Henri Beck, dated October 15 

th

 , 2014, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number

3485 on November 20, 2014, and whose articles have been lastly amended pursuant to a deed by the undersigned notary
dated March 17, 2015, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, number 1236 on May 12, 2015.

II. The share capital is set at thirty one million two hundred fifty-seven thousand four hundred and seventy-three US

dollars (USD 31,257,473), represented by thirty-one million two hundred fifty-seven thousand four hundred and seventy-
three (31,257,473) shares, having a par value of one US dollar (USD 1) each.

III. The sole shareholder, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of one million ninety five

thousand five hundred and forty-two US dollars (USD 1,095,542), from its present amount of thirty one million two hundred
fifty-seven thousand four hundred and seventy-three US dollars (USD 31,257,473), represented by thirty-one million two
hundred fifty-seven thousand four hundred and seventy-three (31,257,473) shares, having a par value of one US dollar
(USD 1) each, to thirty million one hundred sixty-one thousand nine hundred and thirty-one US dollars (USD 30,161,931),
represented by thirty million one hundred sixty-one thousand nine hundred and thirty-one (30,161,931) shares, having a
par value of one US dollar (USD 1) each, by way of redemption and cancellation of one million ninety five thousand five
hundred forty-two (1,095,542) shares having a nominal value of one US dollar (USD 1) each and to repay a portion of the
share premium by an amount of nine million seven hundred forty four thousand nine hundred and four US dollars (USD
9,744,904).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to reduce the amount currently allocated to the legal reserve to the legally required amount

of three million sixteen thousand one hundred and ninety-three US dollars and ten Cents (USD 3,016,193.10), representing
10 % of the new share capital amount.

<i>Third resolution

Pursuant to the above resolution, the article 6, first paragraph, of the Company's articles of association is amended and

shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at thirty million one hundred sixty-one thousand nine hundred and

thirty-one US dollars (USD 30,161,931), represented by thirty million one hundred sixty-one thousand nine hundred and
thirty-one (30,161,931) shares, having a par value of one US dollar (USD 1) each.”;

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empowered and authorized any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the cancellation
of the shares in the share register of the Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

148265

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the Appearing Company,

the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the Appearing Company and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, the Grand Duchy of Luxembourg, on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the Appearing Company, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-et-un septembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Hikma Pharmaceuticals PLC, une société constituée et soumise aux lois de l'Angleterre et du Pays de Galle, ayant son

siège social au 13 Hanover Square, London W1S 1HW, Royaume-Uni, et enregistrée au «Companies House» de l'Angle-
terre et du Pays de Galle sous le numéro 5557934 (la «Comparante»),

représentée par Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la Comparante et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle Comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La Comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de «Hikma Finance (Luxembourg) S.à r.l.», ayant son siège social au 20 rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
191163 (ci-après la «Société»), constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, Maître Henri Beck, notaire de
résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 15 octobre 2014, publié au Mémorial C - Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 3485 en date du 20 novembre 2014, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 mars 2015, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1236 du 12 mai 2015.

II. Le capital social de la Société est fixé à trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille quatre cent soixante-

treize Dollars américains (31,257,473,-USD) représenté par trente-et-un millions deux cent cinquante-sept mille quatre
cent soixante-treize (31,257,473) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune.

III. L'associée unique, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de un million quatre-vingt-quinze mille

cinq  cent  quarante-deux  Dollars  américains  (1.095.542,-  USD)  de  son  montant  actuel  trente-et-un  millions  deux  cent
cinquante-sept mille quatre cent soixante-treize Dollars américains (31.257.473,- USD) représenté par trente-et-un millions
deux cent cinquante-sept mille quatre cent soixante-treize (31.257.473) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar
américain  (1,-  USD)  chacune  à  trente  millions  cent  soixante-et-un  mille  neuf  cent  trente-et-un  Dollars  américains
(30.161.931,- USD), représenté par trente millions cent soixante-et-un mille neuf centre trente-et-un (30.161.931) parts
sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune, par le rachat et l'annulation de un million
quatre-vingt-quinze mille cinq cent quarante-deux (1.095.542) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar amé-
ricain (1,- USD) chacune, et moyennant remboursement d'une partie de la prime d'émission d'un montant de neuf millions
sept cent quarante-quatre mille neuf cent quatre Dollars américains (9.744.904,- USD).

<i>Deuxième résolution

L'associée unique a décidé de réduire le montant actuellement alloué à la réserve légale au montant légalement requis

de trois millions seize mille centre quatre-vingt-treize Dollars américains et dix Cents (3.016.193,10 USD), représentant
10% du nouveau capital social.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions susmentionnées, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à trente millions cent soixante-et-un mille neuf cent trente-et-un

Dollars américains (30.161.931,- USD), représenté par trente millions cent soixante-et-un mille neuf cent trente-et-un
(30.161.931) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD)».

148266

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui

précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription
de l'annulation des parts sociales dans le registre des parts sociales de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la Comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la Comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera

foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des pré-

sentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la Comparante, connue du notaire soussigné par son nom et

prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 septembre 2015. Relation: GAC/2015/8068. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. DIEDERICH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 24 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157974/129.
(150174638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

INTERTEL &amp; CO, société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société en Commandite par Actions - Société

de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 74.638.

In the year two thousand and fifteen,
on the sixteenth day of the month of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, acting in

replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed,

was held

the extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “INTERTEL &amp; CO”, société de gestion de

patrimoine familial, (the Company), a “société de gestion de patrimoine familial (SPF) established under the legal form of
a “société en commandite par actions”, having its registered office at 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg,
incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 24 February 2000, published in the Memorial, Journal Officiel du
Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations (the “Memorial”), n° 442 dated 21 June 2000, on page
21191, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 74 638.

The Articles of Incorporation of the Company were amended for the last time by a notarial deed enacted by notary Jean-

Joseph WAGNER, prenamed, dated 30 November 2010, which deed has been published in the Memorial, n° 485 of 15
March 2011, on page 23275.

The Meeting is opened at 10.00 a.m. and chaired over by Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address

in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, who appointed Mr Jean-Marc DEBATY, employee, with professional address
in Luxembourg, as secretary and as scrutineer of the Meeting.

The Chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Members of the Board or as

the Board.

The Board having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I) The agenda of the Meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation.
2. Appointment of “Van Cauter-Snauwaert &amp; Co S.à r.l.” with registered office at 80, rue des Romains L-8041 Strassen

as liquidator of the company and Determination of the powers to be given to the liquidator and of the liquidator’s remu-
neration.

3. Full discharge is to be granted to the directors and to the auditor (commissaire).
4. Miscellaneous.

148267

L

U X E M B O U R G

II) This Meeting was convened by registered mail to the registered shareholders dated 25 August 2015 (all shares issued

exclusively in registered form).

The justifying publications are deposited with the board of the General Meeting for inspection.
III) The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in

an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed by the holders of powers of attorney
who represent the shareholders who are not present and the Members of the Board. Said list as well as the powers of attorney
will remain attached to these minutes.

IV) The Chairman informed the Meeting that the present Meeting will validly deliberate only if at least fifty percent

(50%) of the issued share capital is present or represented and that the resolutions will be validly adopted if approved by
at least two thirds (2/3) of the votes cast at the Meeting.

V) As it appears from the attendance list, that out of nine thousand five hundred and one (9’501) shares in registered

form [comprising one (1) participating management share held by the unlimited partner (actionnaire commandité) and nine
thousand five hundred (9’500) ordinary shares held by the limited partners (actionnaires commanditaires)] representing
the entire subscribed share capital of the Company amounting to NINE HUNDRED FIFTY THOUSAND ONE HUNDRED
EURO (950’100.- EUR), in circulation, six thousand five hundred (6’500) ordinary shares (actions de commanditaires)
and one (1) participating management share (action de commandité) are present or represented at the Meeting.

VI) A first General Meeting with the same agenda, held in front of notary Jean-Joseph WAGNER, prenamed, on 19

August 2015, was not able to validly deliberate on the items on the agenda, as the requested proportion of the capital was
then not reached.

In accordance with the article 67-1 of the Law of 10 August 1915 concerning commercial companies, this Meeting shall

validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented.

The Chairman has commented on the items on the agenda and the shareholders have approved the following resolutions

with more than twothirds (2/3) of the votes as mentioned on the attendance list:

<i>First resolution

The Meeting RESOLVES to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The Meeting RESOLVES to appoint “Van Cauter - Snauwaert &amp; Co S.à r.l.” a Luxembourg private limited liability

company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 80, rue des Romains L-8041 Strassen and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 52610, as sole liquidator of the Company (the
“Liquidator”).

<i>Third resolution

The Meeting RESOLVES that, in performing his duties, the Liquidator shall have the broadest powers to carry out any

act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The Liquidator shall have the social signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties,

including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The Liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The Liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxyholders such

part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the

Liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The Shareholders resolved to approve the Liquidator’s remuneration as agreed among the parties concerned.

<i>Fourth resolution

The Meeting RESOLVES to grant full discharge to the directors and statutory auditor of the Company for the accom-

plishment of their respective duties up to this date.

There being no further business before the Meeting and no one else wished to speak, the Chairman adjourned then the

Meeting at 10.15 a.m.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appearing

persons, these minutes are worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing
persons, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.

Whereas these minutes were drawn up in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, on the date stated at the

beginning of this document.

The document having been read to the members of the Board, said persons signed together with Us, notary these minutes.

148268

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze,
le seize septembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxem-

bourg,  agissant  en  remplacement  de  Maître  Jean-Joseph  WAGNER,  notaire  de  résidence  à  Sanem,  Grand-Duché  de
Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute,

a été tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires ci-après, l'Assemblée) de la société «INTERTEL &amp; CO, société

de gestion de patrimoine familial», une société de gestion de patrimoine familial (SPF) établie sous la forme juridique d’une
société en commandite par actions (SCA), (ci-après, la Société), ayant son siège social au 11, avenue de la Porte Neuve,
L-2227 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B.
74 638, constituée suivant acte notarié dressé en date du 24 février 2000, publié au Mémorial, Journal Officiel du Grand-
Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 442 du 21 juin 2000 à la page 21
191.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte dressé par le notaire Jean-Joseph WAGNER,

prénommé, en date du 30 novembre 2010, lequel acte fut publié au Mémorial, le 15 mars 2011, sous le numéro 485 et page
23275.

La séance est déclarée ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec

adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg,

qui désigne Monsieur Jean-Marc DEBATY, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg comme secré-

taire et scrutateur de l'Assemblée.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau.
Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I) La présente Assemblée a pour ordre du jour:
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation.
2. Nomination de «Van Cauter-Snauwert &amp; Co S.à r.l.», avec siège social au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen, aux

fonctions de liquidateur de la Société et détermination des pouvoirs à conférer au liquidateur ainsi que sa rémunération.

3. Décharge pleine et entière à accorder aux administrateurs et au commissaire de la Société.
4. Divers.
II) La présente Assemblée a été convoquée par des lettres recommandées adressées aux actionnaires nominatifs datées

du 25 août 2015 (toutes les actions étant des actions émises sous forme nominative).

Les justificatifs de ces publications sont déposés auprès du bureau de l'Assemblée pour inspection.
III) Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont

inscrits sur une liste de présence qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregis-
trement  et  qui  sera  signée  par  les  mandataires  des  actionnaires  et  des  membres  du  Bureau.  Ladite  liste,  ainsi  que  les
procurations des actionnaires représentés resteront annexées aux présentes.

IV) Le Président informe l'Assemblée que la présente Assemblée ne délibérera valablement que si au moins cinquante

pour cent (50%) du capital social émis est présent ou représenté et que les résolutions ne seront valablement adoptées que
si elles sont approuvées par au moins deux tiers (2/3) des votes émis à l'Assemblée.

V) Il résulte de la liste de présence que sur les neuf mille cinq cent et une (9'501) actions nominatives [comprenant une

(1) action de commandité détenue par l'actionnaire commandité et neuf mille cinq cents (9'500) actions de commanditaire
détenues par les actionnaires commanditaires], représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société qui est de
NEUF CENT CINQUANTE MILLE ET CENT EUROS (950'100.- EUR) en circulation, six mille cinq cents (6'500) actions
de commanditaire et une (1) action de commandité sont dûment présentes ou représentées à la présente Assemblée.

VI) Une première Assemblée ayant le même ordre du jour, tenue devant le notaire Jean-Joseph WAGNER, prénommé,

en date du 19 août 2015, n'a pu délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour, pour défaut de quorum de
présence.

En conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente Assemblée

peut donc délibérer valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Le Président de l'assemblée a commenté les points proposés se trouvant à l'ordre du jour et les actionnaires ont approuvé

les résolutions suivantes à plus de deux tiers (2/3) des voix, comme le montre la liste de présence:

<i>Première résolution

L’Assemblée DECIDE la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

148269

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée DECIDE de nommer «Van Cauter - Snauwaert &amp; Co S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés - Luxembourg sous le numéro B 52.610, comme seul liquidateur (le «Liquidateur»).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée DECIDE que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour

effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou
l'importance des opérations en question.

Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il

peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des

pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du Liquidateur,

pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

Les Associés décident d’approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée DECIDE d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de la présente Assemblée et personne d’autre ne demandant la parole, le Président

clôture la séance à 10.15 heures.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, ceux-ci ont signé ensemble avec Nous notaire

le présent procès-verbal.

Signé: B. D. KLAPP, J.M. DEBATY, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21708. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015158001/173.
(150174360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Thesion Handelsgesellschaft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 158.044.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am zweiten September.
Vor Uns Roger ARRENSDORFF, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Frau Sigrid BURGHARDT, geb. ABEL, Diätassistentin, geboren am 1. November 1962 in D-Hünfeld, wohnhaft in Am

Taunengraben 33, Bad Homburg v.d.H.,

hier rechtsgültig vertreten durch Herrn Marc KERNEL, Buchhalter, beruflich wohnhaft in L-5532 Remich, 6, rue Enz,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 7. August 2015,
welche Vollmacht nach gehöriger «ne varietur» Unterzeichnung durch die Komparentin und den amtierenden Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden,

handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Anteilinhaber der Gesellschaft «Thesion Handelsgesellschaft S.à r.l.», mit

Sitz  zu  L-8017  Strassen,  18,  rue  de  la  Chapelle,  eingetragen  im  Handelsregister  in  Luxemburg,  unter  der  Nummer  B
158.044,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notarin Martine SCHAEFFER, im Amtssitz in Luxemburg, am 20.

Dezember 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, unter der Nummer 613 vom
1. April 2011, welche Statuten seither nicht abgeändert wurden.

148270

L

U X E M B O U R G

Sodann hat die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, den Notar ersucht um ihre Erklärungen und Feststellungen

wie folgt zu beurkunden:

1) Dass die Gesellschaft "Thesion Handelsgesellschaft S.à r.l." gegründet wurde wie hiervor erwähnt.
2) Dass Frau Sigrid BURGHARDT, geb. ABEL, vorgenannt, zur Liquidatorin der Gesellschaft ernannt wird.
3) Dass das Gesellschaftskapital vorgenannter Gesellschaft ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (12.500.-

EUR) beträgt und in FÜNF HUNDERT (500) Anteile von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (25.-EUR) eingeteilt ist, welche
vollends eingezahlt sind.

4) Dass die Komparentin als alleinige Eigentümerin der genannten Gesellschaft dementsprechend den ausdrücklichen

Wunsch äussert die Gesellschaft aufzulösen und sich bereit erklärt alle Aktiva und Passiva der Gesellschaft zu übernehmen
und für sämtliche Schulden aufzukommen und dass somit dieselbe als vollständig liquidiert zu betrachten ist.

5) Dass die Komparentin dem Geschäftsführer der aufgelösten Gesellschaft vollends Entlastung erteilt.
6) Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft werden für die Dauer von fünf (5) Jahren am ehemaligen Gesell-

schaftssitz der aufgelösten Gesellschaft hinterlegt.

7) Dass die alleinige Anteilinhaberin die wirklich Berechtigte des Gesellschaftskapitals ist, welche Gelder aus keiner

Straftat entstammen.

Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Luxemburg, in der Amtsstube.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, welcher dem Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: KERNEL, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/28228. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157672/47.
(150174072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

ATGM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.943,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 181.782.

EXTRAIT

Le transfert des actions suivantes de M. Johathan Grisdale à Appleby Trust (Jersey) Limited est accepté avec effet au 1

er

 Septembre 2015:

- 1,239 parts sociales de classe C
- 12,730 parts sociales de classe D
- 177 parts sociales de classe E2
- 177 parts sociales de classe F2
- 177 parts sociales de classe G2
Le transfert des actions suivantes de M. David Blyth à Appleby Trust (Jersey) Limited est accepté avec effet au 1 

er

Septembre 2015:

- 14,030 parts sociales de classe D
Par conséquent, les associés de la société sont les suivants:
- M. Howard Panter
- Mrs, Helen Enright
- M. Peter Kavanagh
- M. Nicholas Potter
- M. Michael Lynas
- M. Timothy McFarlane
- M. Gregory Dyke
- M.David Lazar
- Appleby Trust (Jersey) Limited
- Mrs. Rosemary Squire

148271

L

U X E M B O U R G

Il résulte de la résolution des associés tenue en date du 10 Septembre 2015 que M. Ralf Kokemüller ayant son adresse

résidentielle au 14 Collinistrasse, 68161 Mannheim, Allemagne est élu nouveau gérant avec effet au 10 Septembre 2015.

Par conséquent, le Conseil de Gérance de la société est compose comme suit:
- M. Michael Kidd (gérant de catégorie B)
- M. Claude Larbière (gérant de catégorie B)
- M. Gregory Dyke (gérant de catégorie A)
- Mrs. Helen Enright (gérant de catégorie A)
- M. Peter Kavanagh (gérant de catégorie A)
- M. Michael Lynas (gérant de catégorie A)
- M. Timothy McFarlane (gérant de catégorie A)
- M. Howard Panter (gérant de catégorie A)
- M. Nicholas Potter (gérant de catégorie A)
- Mrs. Rosemary Squire (gérant de catégorie A)
- M. David Lazar (gérant de catégorie A)
- M. Ralf Kokemüller (gérant de catégorie A)

Luxembourg, le 22 Septembre 2015.

Alicia Rassatti.

Référence de publication: 2015157769/46.
(150174030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Hindelang Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 69.492.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015159424/10.
(150175374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Key Care S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9711 Clervaux, 80A, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 171.377.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015159496/10.
(150175377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Justfin International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 113.139.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2015.

<i>Pour: JUSTFIN INTERNATIONAL S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015159484/14.
(150175431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

148272


Document Outline

Alzheimer Europe Foundation

ATGM S.à r.l.

Bailiff S.A.

Beheer- en Beleggingsmaatschappij Radi B.V.

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Breba - Cars S.à r.l.

Brookfield Properties (Luxembourg) S.à r.l.

Capa S.A. SPF

Chemtrade Luxembourg S.à r.l.

Compagnie de Saint Cyr S.A.

Compagnie Francilienne d'Investissements S.A.

Corridor Topco S.à r.l.

Croq'Chalet Sàrl

CVC European Credit Opportunities S.à r.l.

Dachkin-Lux S.A.

DF Luxembourg S.à r.l.

DH Services Luxembourg S.à r.l.

Dolpo S.A.

Dover Luxembourg S.à r.l.

Dover Luxembourg S.à r.l.

D-R Luxembourg Partners 1 S.C.S.

Dynamic Materials Luxembourg 2 S.à r.l.

Elburg Invest B.V. S.à.r.l.

Entreprise de constructions Modeste BAATZ et Fils S.à r.l.

ERRV Luxembourg Holdings S.à r.l.

ETMF II C S.A.

Exclusive Management S.à r.l.

Finasset S.A.

Hikma Finance (Luxembourg) S.à r.l.

Hindelang Logistics S.à r.l.

INTERTEL &amp; CO, société de gestion de patrimoine familial (SPF)

Invista European Real Estate Trust SICAF

Justfin International S.A.

Key Care S.à r.l.

Korbach Logistics (European RE Club) S.à r.l.

Le Nomade, s.à r.l.

Lithoma Property

Maint S.A.

MEIF4 Luxembourg B Holdings S.à. r.l.

Mylan Luxembourg 3 S.à r.l.

New Form S.A.

OCM Luxembourg Wembley Finance S.à r.l.

OCM Luxembourg Wembley Holdings S.à r.l.

Plotin Holding SPF S.A.

PPM Participations S.A.

Schuler Romain S.à.r.l.

Sepik S.A.

Thesion Handelsgesellschaft S.à r.l.

Treetop PSF S.à r.l.

Trucknology S.A.

UBS (Lux) Equity Sicav

Vedipar S.A.

Viager Life Holding

World Fuel Services Finance Company S.à r.l.