logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3053

9 novembre 2015

SOMMAIRE

2 boulevard Konrad Adenauer S.à r.l.  . . . . . .

146515

ACMBernstein SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146498

Advanced Communication Technologies Con-

sulting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146544

AIH-IP (Luxembourg) S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

146509

amandea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146514

ARC Global II DB Lux S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

146515

Carmel Capital VI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

146530

Cellyant Global SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . .

146502

Cemex Global Funding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

146526

ComStage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146498

Edelveys Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146524

Ergan International SARL  . . . . . . . . . . . . . . . .

146538

Ergan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146538

Groupe Figueira S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146500

Guidance Immobilière s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

146542

HA Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146523

Herald, the Henderson European Retail Pro-

perty Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146523

Investprojet Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146527

IV Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146530

Jack RIBEIRO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146530

Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . .

146531

JPMorgan Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146514

Juler Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146531

King's Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146544

Kisifrott S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146544

KPI Residential Property 14 S.à r.l.  . . . . . . . .

146531

Lennon J1 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146544

Leudelange S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146527

Maestro SICAV (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146501

Market Access II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146529

McLaren S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146515

MI-FONDS (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146499

MUGC/WA Asian USD Bond Fund  . . . . . . . .

146515

MUGC/WA U.S. High Yield Credit Fund  . . .

146515

MWD - Marc Weiler Design S.à r.l.  . . . . . . . .

146531

Oerlikon Balzers Coating Luxembourg, S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146535

Office Portfolio Minerva I Sàrl  . . . . . . . . . . . .

146535

Offset Moselle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146535

Paddock S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146512

PALLINGHURST INVESTOR CONSOR-

TIUM II (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146537

PAN European Value Added Venture Feeder

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146536

Pan European Value Added Venture German

Feeder S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146537

Parc Belair S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146537

Participations A & F S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

146536

Partners Group Search S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

146535

Partners of Excellence S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

146536

PEH Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146513

Pharma Investors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146536

PineBridge S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146534

Place Ovale Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

146534

Plumeau S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146538

Prima Private Equity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

146537

Prodilux Diffusion s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

146538

Property Leasing S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146537

Quoniam Funds Selection SICAV  . . . . . . . . . .

146500

SOP I SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146501

146497

L

U X E M B O U R G

ComStage, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 140.772.

Hiermit laden wir die Anteilsinhaber der ComStage (die "Gesellschaft") zu der

AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Anteilsinhaber der Gesellschaft (die "Außerordentliche Hauptversammlung") ein, welche am <i>30. November 2015 ,

9.30 Uhr MEZ am Geschäftssitz der Gesellschaft abgehalten wird. Die Außerordentliche Hauptversammlung wird über
folgende Tagesordnung beraten und beschließen:

<i>Tagesordnung:

1. Wahl des Vorsitzenden der Außerordentliche Hauptversammlung;
2. Wahl von Herrn Peter Corner zum Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft für einen Zeitraum bis zur or-

dentlichen Hauptversammlung in 2019;

3. Sonstiges.

BESCHLUSSFÄHIGKEIT

Bitte beachten Sie, dass für Beschlüsse über die oben genannten Tagesordnungspunkte keine besonderen Anforderungen

an die Beschlussfähigkeit gestellt werden und dass die Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der bei der Außerordentlichen
Hauptversammlung abgegebenen Stimmen gefasst werden.

TEILNAHME

Wenn Sie bei der Außerordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich anwesend sein können und vertreten werden

möchten, sind Sie berechtigt, einen für Sie stimmberechtigten Vertreter zu ernennen. Ein Vertreter muss nicht Anteilsin-
haber der Gesellschaft sein.

Die Teilnahme an der Außerordentlichen Hauptversammlung steht den Anteilsinhabern offen, die entweder ihre Teil-

nahme schriftlich bestätigt haben oder eine ausgefüllte Vollmacht eingereicht haben. Bestätigungen der Teilnahme und
ausgefüllte Vollmachten sind bis zum 27. November 2015, 17:00 Uhr MEZ per Fax an die Faxnummer +352 2708 2650
oder per Post an den Sitz der Gesellschaft zu übermitteln. Vollmachten, welche nach diesem Zeitpunkt eingehen, können
nicht berücksichtigt werden. Vollmachtsformulare können ebenfalls unter der vorgenannten Anschrift angefordert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015176400/30.

ACMBernstein SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 117.021.

Following the first Extraordinary General Meeting held on 29 October 2015 which did not reach the required quorum,

notice is hereby given that the reconvened

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Reconvened Extraordinary General Meeting") of ACMBernstein SICAV (the "Company") will

be held on <i>10 December 2015 , at 2:30 PM (Luxembourg time), at the registered office of the Company, with the following
Agenda, which is the same Agenda as proposed during the first Extraordinary General Meeting held on 29 October 2015:

<i>Agenda:

FIRST RESOLUTION

Change of name of the Company into "AB SICAV I" and consequent amendment of Article 1 of the articles of association

of the Company so as to read as follows:

"There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares a company in the

form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of
"AB SICAV I" (the "Company")."

being specified that such amendment will be effective as of 5 February 2016.

SECOND RESOLUTION

Amendment of paragraph (7) of section A. of Article 23 of the articles of association of the Company so as to read as

follows:

"(7) U.S. Government securities and other debt instruments having 60 days or less remaining until maturity

are generally valued at market by an independent pricing vendor, if a market price is available. If a market
price is not available, the securities are valued at amortized cost. This methodology pertains to short term

146498

L

U X E M B O U R G

securities that have an original maturity of 60 days or less, as well as short term securities that had an original
term to maturity that exceeded 60 days. In instances where amortized cost is utilized, the Board must reasonably
conclude that the utilization of amortized cost is approximatively the same as the fair value of the security.
Such factors the Board will consider include, but are not limited to, an impairment of the creditworthiness of
the issuer or material changes in interest rates."

being specified that such amendment will be effective as of 11 December 2015.

THIRD RESOLUTION

Amendment of Article 23 of the articles of association of the Company in order to add the following paragraph:

"E. For the purpose of determination of the Net Asset Value per share, the net assets attributable to each

class of shares shall be divided by the number of shares of the relevant class issued and outstanding on the
relevant Valuation Day. The Net Asset Value may be adjusted as the Board or its delegate may deem appro-
priate to reflect, among other considerations, any dealing charges including any dealing spreads, fiscal charges
and potential market impact resulting from shareholders transactions."

being specified that such amendment will be effective as of 11 December 2015.

VOTING

The resolutions on the Agenda of the Reconvened Extraordinary General Meeting will not be subject to any quorum

requirement and will be passed by a majority of two-thirds of the votes cast.

Only shareholders of record at the close of business on 4 December 2015 are entitled to vote at the Reconvened Ex-

traordinary General Meeting and at any adjournments thereof.

Shareholders are advised to consult the amended version of the articles of association of the Company which is available

free of charge, in English, at the registered office of the Company and which is also available to be downloaded from the
internet site www.abglobal.com.

VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders who cannot personally attend the Reconvened Extraordinary General Meeting are requested to use the

attached proxy. Completed proxy must be received no later than 48 hours before the time appointed for the Reconvened
Extraordinary General Meeting at the registered office of the Company.

By order of the Board of Directors
Référence de publication: 2015180240/755/53.

MI-FONDS (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.264.

Die Aktionäre der MI-FONDS (Lux) werden zur

HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT

eingeladen, die am <i>2. Dezember 2015 um 14.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) mit der folgenden Tagesordnung an ihrem

Geschäftssitz abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2015
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Der Jahresbericht ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos

erhältlich. Jeder Aktionär kann beantragen, dass ihm der Jahresbericht zugesandt wird.

Die Mehrheit wird auf der Hauptversammlung nach den fünf Tage vor der Hauptversammlung um Mitternacht (Ortszeit

Luxemburg) ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien bestimmt (bezeichnet als "Stichtag"). Es besteht kein An-
wesenheitsquorum für die gültige Beratung und Beschlussfassung der Hauptversammlung in Bezug auf die Tagesord-
nungspunkte. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien
gefasst.  Auf  der  Hauptversammlung  berechtigt  jede  Aktie  zur  Abgabe  einer  Stimme.  Die  Rechte  eines  Aktionärs  zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der mit seinen Aktien verbundenen Stimmrechte richten sich nach
den von diesem Aktionär am Stichtag gehaltenen Aktien.

146499

L

U X E M B O U R G

Falls Sie an dieser Versammlung nicht teilnehmen können und sich vom Vorsitzenden der Hauptversammlung vertreten

lassen möchten, übermitteln Sie bitte spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung (d. h. bis 27. November 2015) eine
datierte und unterzeichnete Vollmacht per Fax und/oder Post und/oder E-Mail zu Händen des Sekretariats der Gesellschaft
bei der Anschrift UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Faxnummer +352 441010 6248 (E-Mail: sh-ubsfsl-corporate-secretary@ubs.com). Die Vorlage für eine Standardvollmacht
kann unter derselben Adresse angefordert werden. Nach Eingang der Vollmacht werden die Aktien bis zu dem auf die
Hauptversammlung folgenden Tag gesperrt. Findet eine weitere Hauptversammlung der Gesellschaft mit derselben Ta-
gesordnung (bezeichnet als "vertagte Hauptversammlung") statt, bleiben die Aktien bis zu dem auf die vertagte Haupt-
versammlung folgenden Tag gesperrt, es sei denn, der Aktionär erteilt eine anderslautende Anweisung (dadurch wird die
für die vertagte Hauptversammlung erteilte Vollmacht ungültig).

Aktionäre oder ihre Vertreter, die an der Hauptversammlung persönlich teilnehmen möchten, werden gebeten, die Ge-

sellschaft spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung von ihrer Teilnahmeabsicht in Kenntnis zu setzen.

Das ausgefüllte Vollmachtsformular ist nur gültig, wenn es den Vor- und Nachnamen des Aktionärs sowie seines Ver-

treters und die Anzahl der zum Stichtag gehaltenen Aktien, die offizielle Adresse und die Unterschrift sowie Weisungen
für die Stimmabgabe enthält und rechtzeitig eingeht. Unvollständige oder fehlerhafte Vollmachtsformulare oder Voll-
machtsformulare, die nicht die darin beschriebenen Formvorgaben erfüllen, werden nicht berücksichtigt.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015180241/755/44.

Groupe Figueira S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 190, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 156.283.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015156739/9.
(150173023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Quoniam Funds Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.455.

Einberufung zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

welche am <i>27. November 2015 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet und folgende Tagesordnung hat:

<i>Tagesordnung:

1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates
2. Entgegennahme des Berichtes des Abschlussprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2015
4. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses des am 30. September 2015 endenden Geschäftsjahres
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Bestellung des Abschlussprüfers
7. Wahl des Verwaltungsrates
8. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Verwahrstelle mit

der Übersendung einer Depotbestands-bescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestands-bescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können am Sitz der Gesellschaft unter der Telefonnummer 00352-2640-3009

oder unter der Faxnummer 00352-2640-2818 angefordert werden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der

Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft unter den zuvor genannten Kontaktdaten anzumelden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015180242/755/29.

146500

L

U X E M B O U R G

SOP I SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 168.325.

The Shareholders, the Liquidator herewith invites you, in accordance with article 24 of the Company's articles of asso-

ciation to the

ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to take place on <i>27 November 2015 at 11.00 a.m. at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and the Auditor on the financial statements for the financial year as per 30 April

2015.

2. Approval of the balance sheet as per 30 April 2015 and the profit and loss statement as well as the notes.
3. Discharge of the Board of Directors from their function executed for the financial year that elapsed.
4. Remuneration for the Members of the Board of Directors.
5. Re-Election of the Members of the Board of Directors.
6. Re-Election of the Auditor.
7. Miscellaneous.

For the proper execution of the voting rights at the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders, the Shareholders

will have to deposit their shares at least one day before this meeting and submit written notice of the deposit to the Company.

Each Shareholder may be represented by a person who is duly authorized by proxy. A proxy need not be a Shareholder.

If you wish to vote at the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders, would you please sign the proxy form and
return it to us on or before the 26th of November 2015. Please send it by post to Oppenheim Asset Management Services
S.à r.l., regulatory set-up department, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, and in advance either by e-
mail to d_FundSetUpOPAM@oppenheim.lu or by fax to (00352) 22 15 22 9471. Proxy forms can be obtained upon request.

Luxembourg, November 2015

By order of the Liquidator
Référence de publication: 2015180243/755/28.

Maestro SICAV (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 127.905.

Im Einklang mit den Artikeln 10 und 14 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'In-

vestissement à capital variable) Maestro SICAV (Lux) wurde die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

auf Beschluss des Verwaltungsrates vertagt und findet nunmehr am <i>27. November 2015 um 11.00 Uhr am Sitz der

Gesellschaft, 9A, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach statt.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Juni 2014 bis zum 31. Mai 2015.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Bestätigung des neuen Verwaltungsrates.
6. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres

2016.

7. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2016.
8. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberaktien vorgelegt werden

oder die Aktien bis spätestens zum 19. November 2015 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über
die Sperrung der Aktien genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im November 2015

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015180244/2501/27.

146501

L

U X E M B O U R G

Cellyant Global SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 201.152.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth of October.
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

THERE APPEARED:

- Nicolas HAMAR, born on 21 January 1974, in Paris (France), having his professional address at 5, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, having his professional address in Pétange,

by virtue of a proxy given under private seal, dated 15 October 2015.

The above-mentioned proxy, being initialed ne varietur by the appearing party, and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has, in the capacity of which it acts, requested the notary to draw up the following articles of

Association (the Articles of Association) of a public limited company (“société anonyme”) (the “Company”), the incor-
poration of which such party has approved.

Art. 1. Form. There is hereby formed among the subscriber(s) and all persons who may become holder of shares hereafter

issued, a company in the form of a public limited company (“société anonyme”), formed as an investment company with
variable capital (“SICAV”) and Specialized Investment Fund, governed by the present articles of association (the “Articles”
or “Articles of Association”) and by current Luxembourg laws, and notably by the Law on Commercial Companies of 10
August 1915 (the “1915 Law”) and the law on Specialized Investment Funds of 13 February 2007 (the “2007 Law”).

Art. 2. Name. The Company’s name is Cellyant Global SICAV-SIF.

Art. 3. Purpose. The Company’s exclusive object is the collective investment of its funds in assets in order to spread the

investment risks and to ensure for the investors the benefit of the results of the management of these assets according to
its investment objectives and policies in accordance with the provisions of the 2007 Law and applicable Luxembourg
Supervisory Authority’s (the “CSSF”) circulars.

The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Company’s private placement

memorandum.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and in

particular, without limitation, grant any assistance, loans, advances or guarantees and raise money in any manner and secure
the repayment of any money borrowed from third parties or from its shareholders.

In addition, the Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly

to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the
2007 Law.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, in the Grand

Duchy of Luxembourg. If and to extent permitted by law, the board of directors of the Company (the “Board”) may decide
to transfer the registered office of the Company within the municipality by a resolution of the Board. The Board shall further
have the right to set up branches, offices, administrative centers and agencies wherever it shall deem fit, either within or
outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

Where the Board determines that extraordinary political, economical or social developments or events have occurred

or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. Duration. The Company is constituted for an unlimited duration.
The Company may be terminated at any time by a decision of the general meeting of shareholders in the manner required

for the amendment of these Articles of Association.

The life of the Company does not come to an end upon the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any of its shareholders or members of the Board of Directors.

Art. 6. Share Capital. The initial share capital of the Company is set at thirty one thousand Euros (EUR 31,000) divided

into thirty-one (31) fully paid up Shares, with no par value. The Company’s share capital shall at any time be equal to its
net asset value, as determined in accordance with Article twelve (12) hereafter.

146502

L

U X E M B O U R G

The minimum subscribed capital of the Company, which must be achieved within 12 (twelve) months as from the date

on which the Company has been authorized as a Specialized Investment Fund by the CSSF, shall be one million two hundred
fifty thousand Euros (EUR 1,250,000.-) as required by the 2007 Law.

Art. 7. The sub-funds and classes of shares. The Company is a multi-compartment structure consisting of one or several

sub-funds, each one representing a specific portfolio of assets and liabilities. There is no cross liability between sub-funds.
Each sub-fund is invested in accordance with the investment objective and policy applicable to it. The investment objective
and policy as well as other specific features of each sub-fund will be set forth in the Company’s private placement memo-
randum. The Board of Directors may decide to create at any time additional sub-funds or to close an existing sub-fund.

The Board of Directors may decide to issue, within each sub-fund, separate classes of shares, which may carry different

rights and obligations, inter alia with regard to their distribution policy and right to revenues, their fee structure, their
minimum initial subscription and holding amounts or their target investors. The specific features of the classes within each
sub-fund will be set forth in the Company’s private placement memorandum. The Board of Directors may create at any
time additional classes or close an existing class.

Art. 8. Form of shares / Register of shareholders. Shares will only be issued in registered form. All issued shares of the

Company shall be registered in the register of shareholders. Such register shall contain the name and address of each
shareholder, the number of shares held by it and, if applicable, their date of transfer.

The registration of the shareholder’s name in the register of shares evidences its right of ownership over such registered

shares. The shareholder shall receive a written confirmation of its shareholding. The shareholder may, at any time, change
its address as entered in the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered
office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

Fractions of shares may be issued, up to three decimal places.

Art. 9. Shareholders. The holding of shares is exclusively restricted to “Well-Informed Investors” as defined in the 2007

Law.

The Board of Directors shall have the power to impose such restrictions as it may think necessary for the purpose notably

of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person in breach of these Articles of Association,
the private placement memorandum of the Company, the law or requirement of any country or governmental authority, or
(b) any person in circumstances which in the opinion of the Board of Directors might result in the Company incurring any
liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred
or suffered. For such purposes the Board of Directors may:

a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share where it appears to it that such registration

or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such share being held by a person who is precluded
from holding shares of the Company;

b) at any time require any person whose name is entered in the register of shareholders to furnish it with any information,

supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not legal or beneficial
ownership of such shareholder’s shares rests or will rest in a person who is precluded from holding shares of the Company;

c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares of the Company is a legal or

beneficial owner of shares or holds shares, cause the Company compulsorily to repurchase from any such shareholder all
shares held by such shareholder; and

d) the Company may decide from time to time the grant preferential treatments to certain shareholders as regards,

amongst others, the fees to be paid, the various reports and information to be received, the right to be consulted and/or
represented in advisory and/or any other Fund's committees, the co-investment opportunities, etc. Details on any such
preferential treatment, including the type of investors who may obtain such preferential treatment will be disclosed in the
relevant Sub-Fund information sheet.

Art. 10. Issue of shares. Whenever shares of the Company shall be offered by the Company for subscription, the price

per share at which such shares shall be issued shall be the net asset value thereof as determined in accordance with the
provisions of Article 12 hereof on the basis of the fair value principle. The Board of Directors may also decide that an issue
commission has to be paid. The allotment of Shares is conditional upon payment and if timely payment has not been received
within the settlement period, the subscription may lapse and be cancelled at the cost of the investor or the investor’s financial
intermediary. If payment is not received in full, the relevant allotment of Shares may be reduced accordingly. The Board
of Directors may in its discretion determine the minimum amount of any subscription in any Class of share of any sub-
fund.

Subscriptions received before a certain hour (“cut-off time”) on a specific date (which does not need to be the valuation

date) as determined by the Board of Directors from time to time shall be processed at the net asset value determined for
the applicable valuation date. If subscriptions are received after that cut-off time as determined by the Board of Directors
from time to time, they shall be processed at the net asset value determined for the following valuation date. The investor
will bear any taxes or other expenses attaching to the application.

The Board of Directors may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities to any share-

holder who agrees to comply with any conditions set forth by the Board of Directors from time to time including, but not

146503

L

U X E M B O U R G

limited to, the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company which shall be available for ins-
pection, and provided that such securities comply with the investment restrictions and policies of the relevant sub-fund, as
set forth in the Company’s private placement memorandum. Any costs incurred in connection with a contribution in kind
of securities, including the auditor’s costs for preparing any valuation report required, shall be borne by the shareholder
making such contribution.

The Board of Directors reserves the right to accept or refuse any application of subscription for shares in whole or in

part.

Art. 11. Transfer and conversion of shares. Any transfer of shares to the existing shareholders or to any third party shall

require the prior written approval of the Board of Directors and the Board of Directors may in its discretion and without
indicating any reason decline to approve or register such transfer.

The Board shall not accept any transfer of shares to any transferee who may not be considered as an eligible investor

within the meaning of the Law.

The shareholder wishing to transfer its shares in the Company will be responsible for all costs associated with any

attempted or realized transfer.

Shareholders are not allowed to pledge or grant a security interest in any of their shares without the prior consent of the

Board of Directors.

Unless otherwise provided for within the Company’s private placement memorandum, (i) shares of a sub-fund may not

be converted for shares in another sub-fund and (ii) shares of a sub-fund may be converted for shares in another class of
shares of the same sub-fund, subject to the prior written approval of the Board of Directors.

Art. 12. Net asset value. The net asset value of the Company shall be determined as often as the Board of Directors may

think useful, but in no event less than once a year.

The net asset value will be expressed in Euro and shall be determined by the Board of Directors on the basis of the fair

valuation of the underlying assets of the Company as provided by the AIFM or any external valuer appointed by the AIFM
pursuant to the provision of the AIFM Law on each valuation date by aggregating the value of all assets of the Company
and deducting all liabilities of the Company.

If needed, the net asset value may be calculated by using swing-pricing methodology to ensure a fair treatment between

investors.

Art. 13. Suspension. The Board of Directors may temporarily suspend the calculation of the net asset value during:
a) any period when, in the reasonable opinion of the Board of Directors, a fair valuation of the assets of the Company

is not practicable for reasons beyond the control of the Company; or

b) any period when any of the principal markets (where applicable) on which a substantial proportion of the investments

of the Company are quoted are closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are restricted
or suspended; or

c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned by

the Company would be impractical; or

d) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the

price or value of any of the investments or the currency price or values on any such stock exchange; or

e) when, following redemption requests, it has not proved possible to dispose of the assets of the concerned sub-fund

(s) as necessary as a consequence of the markets’ liquidity; or

f) in any other case where deemed necessary by the Board of Directors in the exclusive interest of the Company or of

its shareholders.

Art. 14. Redemption of shares. The Company is an open-ended Specialized Investment Fund. However, the Board of

Directors may decide, depending on the investment strategy and objectives of each sub-fund, to launch closed-ended sub-
funds.

Redemptions will be made in accordance with the principles set forth in the private placement memorandum of the

Company for each sub-fund.

The payment of the redemption price shall be made for cash or consideration in kind at the discretion of the Board of

Directors. The allotment of Company’s assets in respect of redemption for consideration in kind shall be fair and not
detrimental to the interests of the other shareholders of the Company. In compliance with the provisions of the 2007 and
1915 Laws, any redemption for consideration in kind shall be subject to the confirmation by an auditor’s special report of
the valuation of the Company of the Company’s assets to be allocated, the costs of which shall be borne by the Company.

Redemption of shares shall be made at a price, which is determined by the Board of Directors to be the fair value for

the shares to be redeemed by applying the principles described in the Company’s private placement memorandum. The
rules relating to distributions as set forth in the Company’s private placement memorandum of the Company are furthermore
applicable.

The Company may decide to compulsorily redeem at its sole discretion the shares wholly or in part in particular in the

following circumstances:

146504

L

U X E M B O U R G

a) the shares are held by shareholders not authorized to buy or own shares in the Company, e.g. a shareholder that no

longer qualifies as “Well-Informed Investor” as defined in the 2007 Law or such shareholder (or an affiliate of the same)
that becomes a U.S. person as referred to in the Company’s private placement memorandum;

b) in the event that a shareholder is declared bankrupt, enters into an arrangement for the benefit of its creditors or goes

into liquidation;

c) in case of liquidation or merger of sub-funds or classes of shares;
d) the shares that are held in breach of any law or regulation or otherwise in circumstances having, or which may have,

adverse regulatory, tax or fiscal consequences for the Company or the shareholders or otherwise be detrimental to the
interests of the Company;

e) in all other circumstances as the Board of Directors may deem appropriate in accordance with the terms and conditions

set out in this Articles or in the Company’s private placement memorandum.

Except in the cases c) and e) above the Board of Directors may impose such penalty as it deems fair and appropriate.
All redeemed shares or fractions thereof shall be automatically cancelled.

Art. 15. Board of Directors. The Company will be managed by the Board of Directors of the Company, composed of

not less than three (3) members. The members of the Board of Directors need not be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period not exceeding six (6)

years and shall hold office until their successor are elected. A Director may be removed with or without cause and replaced
at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors

may meet and elect, by majority of vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of the shareholders.

Art. 16. Chairman. The Board of Directors shall elect from among its members a Chairman and may choose from among

its members one or more Vice-Chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a Director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors
shall meet upon call by the Chairman, or two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The Chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the Vice-Chairman or

another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore, or in their absence or inability
to act, the shareholders may appoint another Director or an officer of the Company as chairman pro tempore by vote of the
majority of shares present or represented at any such meeting.

The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, or in his absence or inability to act, the Vice-

Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore.

The Board of Directors shall from time to time appoint any officer or agent of the Company considered necessary for

the operation and management of the Company, who need not be Directors or shareholders of the Company. The officers
appointed unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the power and duties granted to them by the Board of
Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours

in advance of the hour set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by e-mail, telefax or any
other similar or electronic communication means from each Director. Separate notice shall not be required for meetings
held at times and places set out in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy, which

appointment shall be in writing or by e-mail, telefax or any other similar or electronic communication means.

Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by telephone link or telephone conference,

provided that the vote be confirmed in writing or by e-mail, telefax or any other similar or electronic communication means.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company by
their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or

represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at
such meeting, the Chairman having a casting vote.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by facsimile or any other similar or electronic communication means.

Art. 17. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or, in his

absence, by the chairman pro-tempore who presided at such meeting or by two (2) Directors.

Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the

Chairman or by the chairman pro-tempore of that meeting, or by two (2) Directors or the secretary or an assistant secretary.

146505

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Power. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration, dispo-

sition and execution in the Company’s interest. All powers not expressly restricted by law or by the present Articles of
Association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 19. Delegation of Power. The Board of the Company may delegate its powers to conduct the daily management

and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out
acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need
not be Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board of Directors
so authorizes, sub-delegate their powers.

The Board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
The Board may further decide to create either at the level of the Company or for a specific sub-fund any committee the

members of which need not be Directors. The Board shall organize such committee functioning and determine the powers
of their members as further described in the private placement memorandum of the Company.

Art. 20. The Company has appointed Cellyant Capital Management S.A. a Luxembourg management company incor-

porate under chap. 16 of the Law of 17 December 2010 to act as its alternative investment manager (“AIFM”) pursuant to
the provision of the Law of 12 July 2013 (the AIFM Law).

Art. 21. Conflicts of Interest. No contract or other transaction between the Company, the AIFM and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers or agent or daily manager
or employee of the Company is interested in, or is a director, associate, officer, agent, daily manager or employee of such
other company or firm. Any Director, officer, agent, daily manager or employee of the Company who serves as a director,
officer, agent, daily manager or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director, officer, agent, daily manager or employee of the Company may have, in any transaction

of the Company, an interest opposite to the interests of the Company, such Director, officer, agent, daily manager or
employee shall make known to the Board of Directors such opposite interest and shall not consider or vote on any such
transaction, and such transaction and such Director's, officer’s, agent’s, daily manager’s or employee’s interest therein shall
be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

The term “opposite interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any

matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by the
Board of Directors in its discretion.

Art. 22. Signature. The Company shall be bound by the joint signature of any two (2) Directors or by the individual

signature(s) of any duly authorized Director or officer, or agent or daily manager of the Company or by the individual
signature of the Chairman or any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 23. Indemnification. The Company will indemnify any Director, officer or member of any committee referred to

above and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director, officer or
member of any committee of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder
or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company
is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of
indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 24. General meetings of shareholders. The general meeting of shareholders of the Company shall represent the

entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders of the Company. It
shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors. It may also be called upon the

written request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.

Upon request of shareholders representing at least one tenth of the share capital, one or more new items shall be added

to the agenda of any general meeting of shareholders. Such demand shall be addressed to the registered office of the
Company by registered mail at least five (5) days before such meeting.

The annual meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, on the

last day of April each year at 3 p.m. Luxembourg time. The first annual meeting shall be held in 2017.

If such day is a legal or bank holiday in Luxembourg, the annual meeting shall be held on the next banking day.
Other meetings of shareholders, including meetings of shareholders of one specific sub-fund or class of shares, may be

held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

146506

L

U X E M B O U R G

The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the Company unless otherwise provided herein.

Any shareholder may participate in a general meeting of shareholders by video conference, or by conference call or

similar means of communication equipment which enables his/her identification and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting. The means of communication used must allow all the persons
taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such
persons in the meeting. The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to
attend any meeting of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which

shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each whole share of the Company is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles of

Association. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a proxy to another person in writing or by
facsimile transmission or any other similar or electronic communication means, who need not be a shareholder and who
may be a Director of the Company.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the

votes validly cast, unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the Articles, in which case the resolution
will be passed with a majority of the two thirds of the votes validly cast.

Art. 25. Financial Year. The Company’s financial year begins on 1 

st

 January and closes on 31 

st

 December of the same

year.

Art. 26. Accounts. Each year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company. The annual

accounts shall be approved by the annual general meeting of shareholders upon proposal of the Board of Directors. The
accounts shall be expressed in Euro.

Art. 27. Supervision. The operations of the Company and its financial situation shall be supervised by one independent

auditor qualifying as a “réviseur d’entreprises agréé” who shall be appointed by the shareholders. The independent auditor
shall be remunerated by the Company and shall remain in office until its successor is appointed. The independent auditor
shall fulfill all duties prescribed by the 2007 Law.

Art. 28. Distribution. Subject to permitted reinvestments, and the requirements of Luxembourg law, distributions shall

be payable by the Company on its shares upon decision by the Board of Directors in accordance with the Company’s private
placement memorandum.

No distribution may be made if after the declaration of such distribution the net asset value of the Company would fall

below EUR 1,250,000.- (one million two hundred fifty thousand Euros). Dividends not claimed within five years of their
due date will lapse and revert to the relevant class of shares.

Art. 29. Custodian. The Company shall enter into a custodian agreement with a financial institution, which shall satisfy

the requirements of the 2007 Law and the AIFM Law. The custodian shall assume towards the Company and the share-
holders the responsibilities set out in the AIFM Law, the custodian agreement and any other law applicable.

In the event of termination of the custodian agreement or the resignation of the custodian, the Board of Directors shall

use its best endeavors to find a financial institution to act as custodian and upon doing so the Board of Directors shall
appoint such financial institution to be custodian in place of the former custodian.

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several

liquidators (whether natural persons or legal entities approved by the CSSF) named pursuant to a general meeting effecting
such dissolution and at which meeting the liquidators' powers and compensation shall be determined. The operations of
liquidation will be carried out pursuant to the 1915 Law.

The net proceeds of liquidation in respect of each sub-fund or, as the case may be, of each class within each sub-fund,

shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of the relevant class in proportion to their holding of such
shares in such sub-fund or class, and whether such proceeds shall be distributed in cash or kind.

If the Company's share capital (i.e. the aggregate of all sub-funds) falls below two-thirds of the minimum capital (EUR

1,250,000.-), the Board of Directors must submit a proposal for the Company's termination to a general meeting for deli-
beration. No quorum requirements will be applied; winding-up may be pronounced by a simple majority of the validly cast
votes.

If the Company's share capital falls below one quarter of the minimum capital increased by the share premium (EUR

1,250,000.-), the Board of Directors must submit a proposal for the Company's termination to the general meeting for
deliberation. No quorum requirements will be applied; winding-up may be pronounced by the shareholders owning one
quarter of the validly cast votes.

The aforesaid meetings shall be convened within forty days of the date at which it was ascertained that the net assets

fell below two-thirds or one quarter of the minimum capital, respectively. Moreover, the Company may be terminated by
resolution of the general meeting in accordance with the pertinent provisions of these Articles of Association.

146507

L

U X E M B O U R G

The resolutions of the general meeting of shareholders or of a court of law pronouncing the termination and winding-

up of the Company are to be published in compliance with applicable laws. The choice of which newspapers are to carry
the publication is made at the discretion of the liquidator(s).

The amounts that have not been claimed by the shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation of the

Company shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg.

Art. 31. Termination, liquidation and merger of sub-funds or classes of shares. The Board of Directors may decide to

close one or more classes or sub-funds (having or not a limited duration) in the best interests of the shareholders, if there
has been a substantial modification in the political, economic, regulatory or monetary situation pertinent to a class or sub-
fund, which, in the opinion of the Board of Directors renders this decision necessary, or where such action is required in
order to protect the interests of shareholders, or if for any reason whatsoever, the value of the net assets of a sub-fund falls
below an amount determined in the Company’s private placement memorandum and the Board of Directors determines
that the interests of the shareholders of that same class or subfund demand such action to be taken.

The Company shall serve a notice in writing to the shareholders of the relevant class or sub-fund, which will indicate

the reasons and the procedure for the redemption operations.

The Company shall base these redemptions on the net asset value taking into account liquidation expenses.
The amounts that have not been claimed by the shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation of a class

or sub-fund shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg.

All redeemed Shares may be cancelled.
A termination contemplated above may be combined with a contribution to one or several subfund(s) or class(es) within

the Company or to one or several other sub-fund(s) or class(es) of another undertaking for collective investment (under the
corporate or the contractual type form) in the best interests of the shareholders.

Where the undertaking for collective investment that will receive the contribution is a mutual fund (fonds commun de

placement), the decision to contribute will only be binding on shareholders who have agreed to make a contribution.

A  sub-fund  may  exclusively  be  contributed  to  a  foreign  undertaking  for  collective  investment  with  the  unanimous

approval of the shareholders of the relevant sub-fund or under the condition that only the assets of the consenting share-
holders shall be so contributed.

Art. 32. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the 1915 Law and the 2007 Law for which no specific

provision is made in these Articles of Association.

Art. 33. Definitions and Interpretation. References to articles are to the Articles of these Articles of Association. Words

importing gender include each gender. References to persons include bodies corporate, firms and unincorporated associa-
tions. The singular includes the plural and vice versa. Headings of articles are included for convenience only and do not
affect their interpretation. References to all or any part of any statute or statutory instrument include any statutory amend-
ment, modification or re-enactment in force from time to time and references to any statute include any statutory instrument
or regulations made under it. Any reference to the Company, the Board of Directors, agents, etc, includes a reference to its
or their duly authorized agents or delegates.

<i>Transitional measures

Exceptionally, the first financial year shall begin on the date hereof and end on 31 

st

 December 2016.

The first annual general meeting shall be held in April 2017.

<i>Subscription and Payment

The initial capital of the Company amounts to thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) and has been totally subscribed

by Mr. Nicolas HAMAR who holds thirty-one (31) shares.

The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed, who expressly ack-
nowledges this.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in the 1915 Law, and

confirms that these conditions have been observed.

<i>Estimate of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid

by the Company as a result of its incorporation amount approximately to 3,300 euro.

<i>General meeting of shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been duly

convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

146508

L

U X E M B O U R G

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote

and with the approval of the Board of Directors:

<i>First resolution:

The following persons are elected as member of the Board of Directors for a period ending at the annual general meeting

of shareholders to be held in 2017:

- Nicolas HAMAR, born on 21 January 1974 in Paris, France, having professional address at 5, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Director and Chairman of the Board of Directors;

- Gary BRENNAN, born on 15 October 1970 in Dublin, Ireland, having professional address at 93A, Sandymount Road,

Dublin 4, Ireland, as Director; and

- Marc BAILEY, born on 4 June 1964 in Torquay, United Kingdom, having professional address at 24, Mimosa Street,

London, SW 4DT, United Kingdom, as Director.

<i>Second resolution

The address of the registered office of the Company is set at 5, allée Scheffer L-2520, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

Has been elected as approved statutory auditor (réviseur d’entreprise agréé) until the annual general meeting of share-

holders to be held in 2017:

Ernst &amp; Young Luxembourg
7, rue Gabriel Lippman - Parc d’activité Syrdall 2
L-5365 Munsbach - Luxembourg

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English only.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The  document  having  been  read  to  the  person  appearing,  known  to  the  notary  by  surname,  name,  civil  status  and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 octobre 2015. Relation: EAC/2015/24143. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015178944/422.
(150199618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

AIH-IP (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 58.239,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 155.466.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth of October
Before Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the undersigned;

APPEARED:

ACQUIS HOLDING LIMITED, a private company limited by shares, incorporated under the laws of the United King-

dom, registered with Companies House of Wales and England, under number 09165786, having its registered office at
Integra House, Vaughan Court, Newport NP108BD, United Kingdom, duly represented by Mrs. Sabine PERRIER, with
professional address at 124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under
private seal in Newport, United Kingdom, on 19 October 2015.

The said power, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his capacity, declares and requests the notary to act:
1.- That the private limited liability company («société à responsabilité limitée») "AIH-IP (Luxembourg) S.à r.l..", with

registered office à L-2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse, registered at the Trade and Companies' Register
of Luxembourg («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg»), section B, under the number 155.466, (herei-
nafter referred to as the «Company»), has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary

146509

L

U X E M B O U R G

residing in Luxembourg, on 13 September 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2284 of 26 October 2010. The articles of incorporation have been amended at last pursuant to a deed of the undersigned
Notary, on 30 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 281 of 31
January 2014.

2.-That the corporate capital is set at fifty-eight thousand two hundred and thirty-nine Euro (EUR 58.239,00) represented

by fifty-eight thousand two hundred and thirty-nine (58.239) units with a par value of one Euro (EUR 1,-) each, subscribed
and entirely paid up.

3.-That the appearing party, represented as said before, is the sole owner (“Sole Shareholder”) of all the units of the

Company.

4.-That  the  activity  of  the  Company  has  ceased,  and  that  the  appearing,  represented  as  said  before,  resolves  in  an

extraordinary general meeting to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company.

5.-That the Sole Shareholder, has designated, Mrs Sabine PERRIER, born on 22 April 1959 in Thionville (France),

residing professionally in L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, as liquidator of the Company, who has
accepted the mission in accordance with the provisions set forth by the law of 10 

th

 August 1915 as modified on commercial

companies.

6.-That the liquidator, in her capacity, has requested the officiating notary to authenticate her declaration that (i) the

Company has a positive net asset value in accordance with the dissolution and liquidation accounts to 15 October 2015 as
enclosed; (ii) the liabilities of the Company have been settled and (iii) the liabilities in relation of the close down of the
liquidation have been duly accrued. The liquidator furthermore declares that with respect to eventual liabilities of the
Company presently unknown that remain unpaid, the Sole Shareholder irrevocably undertakes to pay all such eventual
liabilities, and to this end, empowers Mrs Sabine PERRIER, pre-named, to do whatever is deemed necessary and required
in view of settling through the bank account of the Company, any debts known or unknown to-date. As a consequence
thereof, all the liabilities of the company are paid and the remaining assets, consisting of the shares of Acquis Insurance
Management Ltd and the cash at bank, shall be transferred to the Sole Shareholder;

7.-That the declarations of the liquidator have been verified, pursuant to a report that remains attached as appendix and

issued by Mrs Sylvaine AUBARD, born on 23 August 1973 in Sarcelles (France), professionally with address at 124,
Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, acting as auditor to the liquidation designated by the Sole Shareholder;

8.-That the liquidation of the Company is done and finalised;
9.-That full discharge is granted to (i) the Company's Managers for their respective duties to-date, (ii) the liquidator and

(iii) the auditor to the liquidation;

10.-That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at the

registered office of the Company, being at L-2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse.

Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of the dissolved company or the reimbursement to

the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) as from
the date of the publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved and liquidated
has requested the creation of security.

The attorney then presents to the Notary the share register of the Company for cancellation.
For the completion of all formalities related to the registration, publications, strike off, filings and any other formalities

deemed required or necessary, the bearer of the present deed is herewith fully empowered.

<i>Costs

The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and

charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil status

and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gnée;

A COMPARU:

146510

L

U X E M B O U R G

ACQUIS HOLDING LIMITED, une société à responsabilité limitée, constituée suivant les lois régissant les sociétés

au Royaume-Uni, enregistrée au Registre «Companies House» du pays de Galles et d’Angleterre, sous le numéro 09165786,
ayant son siège social à Integra House, Vaughan Court, Newport NP108BD, Royaume-Uni, ici représentée par Madame
Sabine PERRIER, avec adresse professionnelle au 124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privé lui délivrée à Newport, Royaume-Uni, le 19 octobre 2015 cv,

Ladite procuration signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1.- Que la société à responsabilité limitée "AIH-IP (Luxmbourg) S.à r.l.", avec siège social à L-2330 Luxembourg, 124,

Boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
155.466, (ci-après dénommée la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire
de résidence à Luxembourg, le 13 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2284 du 26 octobre 2010. Les statuts ont été amendés pour la dernière fois, suivant un acte reçu par le notaire soussigné,
en date du 30 décembre 2013, publié au Méorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 281 du 31 janvier 2014.

2.- Que le capital social est fixé à cinquante-huit mille deux cent trente-neuf Euros (EUR 58.239,00), représenté par

cinquante-huit  mille  deux  cent  trente-neuf  (58.239)  parts  sociales  d'une  valeur  nominale  d’un  Euro  (EUR  1,-),  toutes
souscrites et entièrement libérées.

3.- Que l’associée unique est l’unique propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
4.- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’associée unique, représentée comme dit ci-avant, siégeant en assemblée

générale extraordinaire, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5.- Que l’associée unique a désigné Madame Sabine PERRIER, née le 22 avril 1959 à Thionville (F), demeurant pro-

fessionnellement à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, comme liquidateur de la Société, laquelle a accepté
la mission suivant les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

6.- Que le liquidateur de la Société a requis le notaire instrumentant d’acter ses déclarations que (i) la Société a une

valeur d’actif net positive, suivant les états financiers de liquidation clos au 15 Octobre 2015 ci-annexés; (ii) le passif de
la Société est réglé et (iii) le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné. Le liquidateur déclare
en outre que, par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, l’associée
unique assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel et mandate, à cet effet, Mme Sabine PERRIER,
prénommée, de faire tout ce qui est utile et nécessaire, aux fins de régler par le compte bancaire de la Société, toutes dettes
connues ou inconnues à ce jour. En conséquence, tout le passif de ladite Société est réglé et les actifs restants, composés
entre autres, des actions de la société Acquis Insurance Management Ltd et des fonds en banque, seront transférés au profit
de l’associée unique.

7.- Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, établi par Mme

Sylvaine AUBARD, née le 23 août 1973 à Sarcelles (France), désignée "commissaire-vérificateur" par l’associée unique
de la Société.

8.- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
9.- Que décharge pleine et entière est accordée (i) aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à

ce jour, (ii) au liquidateur et (iii) au commissaire vérificateur de la liquidation.

10.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien

siège social de la Société à L-2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de, ou remboursement à, l’Associée

Unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de
la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé la constitution
de sûretés.

La mandataire présente alors le registre des associés de la Société au Notaire instrumentaire, pour annulation.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et toutes autres for-

malités qui puissent s’avérer utiles et nécessaires, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à

raison de cet acte, est dès lors évalué à mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec Nous notaire le présent acte.

146511

L

U X E M B O U R G

Signé: S. Perrier et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 27 octobre 2015. 2LAC/2015/24110. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Référence de publication: 2015178039/140.
(150198258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Paddock S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 25.205.

L'an deux mille quinze, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PADDOCK S.A.", ayant son siège social

à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro B 25.205, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 19 novembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
46, le 24 février 1987. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank MOLITOR,
alors notaire de résidence à Dudelange, en date du 12 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 775, le 18 septembre 2001.

L'Assemblée est présidée par Madame Alexandra AUGÉ, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Ber-

trange (le «Président»).

Le Président nomme Madame Manon SCHELLEN, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Bertrange,

comme secrétaire de l'Assemblée (le «Secrétaire»).

L'Assemblée élit Madame Danielle UMSTADT, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Bertrange, comme

scrutateur de l'Assemblée (le «Scrutateur»).

(Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement appelé le «Bureau»).
Le Bureau ayant été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées par le Bureau, les comparants et le notaire instru-
mentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations
d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et que l'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour,

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège;
2. Modification subséquente de l'article correspondant des statuts;
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'Assemblée décide, avec effet au 1 

er

 avril 2015, de transférer le siège de la société à L-8070 Bertrange, 37, rue du

Puits Romain.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts comme suit:

« Art. 3. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution

de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses
actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

146512

L

U X E M B O U R G

Le  conseil  d'administration  de  la  Société  (le  "Conseil  d'Administration")  ou  l'Administrateur  Unique  est  autorisé  à

changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que tou-
tefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la
nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.».

<i>Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant

individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès
du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et,
le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent
acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus aucun actionnaire ne désirant prendre la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Bertrange, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. AUGE. M. SCHELLEN, D. UMSTADT, J-P. MEYERS.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21591. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157573/71.
(150173491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

PEH Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 61.128.

Die Aktionäre der PEH SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. November 2015 um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des zugelassenen Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Juli 2015
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder
8. Sonstiges

Die Abstimmung über die Punkte der Tagesordnung erfordert kein bestimmtes Anwesenheitsquorum und die Beschlüsse

werden  durch  die  einfache  Mehrheit  der  abgegebenen  Stimmen  der  anwesenden  oder  vertretenen  Aktionäre  gefasst.
Grundlage für die Beschlussfassung sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im
Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame
Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.

Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Axxion S.A., 15, rue de Flax-
weiler, L-6776 Grevenmacher, (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern und werden gebeten, diese
bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.

Aktionäre können ab dem fünfzehnten Tag vor der ordentlichen Generalversammlung den geprüften Jahresbericht zum

31. Juli 2015 bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail:
legal@axxion.lu) anfordern.

146513

L

U X E M B O U R G

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015175684/32.

JPMorgan Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 8.478.

Notice of

ANNUAL GENERAL MEETING

THE MEETING
Location: Registered office of the Fund (see below)
Date and time: Wednesday, <i>18 November 2015 at 15:00 CET
Quorum: None required
Voting: Agenda items will be resolved by a simple majority of the votes cast

THE FUND
Name: JPMorgan Funds
Legal form: SICAV
Fund type: UCITS
Auditors: PricewaterhouseCoopers Société coopérative
Registered office: 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Fax: +352 3410 8000
Registration number (RCS Luxembourg): B 8.478
Past fiscal year: 12 months, ended 30 June 2015

The meeting will be held at the location and time stated above. All appointments being voted on are for terms that end

at the next annual general meeting.

<i>Agenda for Meeting and Shareholder Vote:

1. Presentation of the report from Auditors and Board for the past fiscal year.
2. Should shareholders adopt the Audited Annual Report for the past fiscal year?
3. Should shareholders agree to discharge the Board for the performance of its duties for the past fiscal year?
4. Should shareholders approve the Directors' fees?
5. Should the following Directors be reappointed to the Board?

Jacques Elvinger, Jean Frijns, John Li-How-Cheong, Iain Saunders, Peter Schwicht

6. Should shareholders confirm the appointment of Daniel Watkins, co-opted by the Board of Directors with effect

from 13 December 2014, in replacement of Berndt May, and his election to serve as a Director of the Company?

7. Should Massimo Greco be appointed to the Board?
8. Should shareholders reappoint PricewaterhouseCoopers Société cooperative as its Auditors?
9. Should shareholders approve the payment of any distributions shown in the Audited Annual Report for the past fiscal

year?

To vote by proxy, use the proxy form at jpmorganassetmanagement.com/extra. Your form must arrive at the registered

office, via post or fax, by 18:00 CET on Monday, 16 November 2015.

To vote in person, attend the meeting in person.

Important information for bearer share holders: If you are a physical bearer share holder you must take action to be

eligible to vote in the AGM. Please go to www.jpmorganassetmanagement.lu → Our Funds → Official Communications
→ 2015-02-18 “Notice of Changes Impacting Bearer Shares” for more information.

Référence de publication: 2015175786/755/42.

amandea, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 9. Oktober 2015 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement

wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

146514

L

U X E M B O U R G

Munsbach, den 9. Oktober 2015.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2015178414/11.
(150197912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

MUGC/WA Asian USD Bond Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion modifié de MUGC/WA ASIAN USD BOND FUND a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2015.

MUGC Lux Management S.A.
Jean-François Fortemps
<i>Managing Director

Référence de publication: 2015178592/12.
(150198369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

MUGC/WA U.S. High Yield Credit Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion modifié de MUGC/WA U.S. HIGH YIELD CREDIT FUND a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2015.

MUGC Lux Management S.A.
Jean-François Fortemps
<i>Managing Director

Référence de publication: 2015178593/12.
(150198374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

McLaren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 169.878.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2015.
Référence de publication: 2015179949/10.
(150200003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2015.

2 boulevard Konrad Adenauer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 96.624.

ARC Global II DB Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 193.643.

COMMON PROPOSAL FOR THE MERGER

THE BOARDS OF MANAGERS OF:
1. 2 Boulevard Konrad Adenauer S.à r.l. a société à responsabilité limitée, having its registered office at 9A, Boulevard

Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of commerce
and companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (RCSL) under number B 96624, having a share
capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) (the Absorbing Company); and

146515

L

U X E M B O U R G

2. Arc Global II DB Lux S.à r.l. a société à responsabilité limitée, having its registered office at 9A, Boulevard Prince

Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCSL under number B 193 643, having a
share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) (the Absorbed Company and together with the Absorbing
Company, the Merging Companies).

The Merging Companies wish to record the following common merger proposal (the Merger Proposal):
WHEREAS:
(A) The board of managers of the Merging Companies propose, subject to the prior satisfaction of certain conditions

precedent, the merger by absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company and without liquidation of the
Absorbed Company (the Merger) in accordance with Articles 261 to 276 of the law of August 10 

th

 1915 on commercial

companies, as amended (the Law).

(B) Upon the effectiveness of the Merger, all the assets and liabilities of the Absorbed Company shall be transferred to

the Absorbing Company by operation of law, the Absorbed Company shall be dissolved without liquidation and all its
shares shall be cancelled. The Absorbing Company shall persist as legal entity.

(C) The Merger is subject to the condition precedent that the shareholders of the Merging Companies will approved the

Merger in accordance with Article 263 of the Law.

NOW, THEREFORE, the boards of managers of the Merging Companies have established this Merger Proposal in

accordance with Article 261 of the Law.

1. Merging Companies.
1.1. The Absorbing Company
1.1.1. 2 Boulevard Konrad Adenauer S.à r.l. is a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée) incorporated by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, dated October 13 

th

 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial), on

November 25 

th

 2003, number 1247, page 59850. The articles of association of 2 Boulevard Konrad Adenauer S.à r.l. have

been amended several times and for the last time by a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch,
Grand Duchy of Luxembourg dated May 18 

th

 2015, published in the Mémorial on July 23 

rd

 2015, number 1842, page

88383.

1.1.2. The registered office of the Absorbing Company is located at, 9A Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

1.1.3. The issued share capital of the Absorbing Company, as of the date hereof, amounts to twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each, all
subscribed and fully paid-up (2BKA Shares).

1.2. The Absorbed Company
1.2.1. Arc Global II DB Lux S.à r.l. is a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)

incorporated by a deed of Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated
December 22 

nd

 2014, published in the Mémorial on February 18 

th

 2015, number 439, page 2104. Since its incorporation,

the articles of association of Arc Global II DB Lux S.à r.l. have not been amended.

1.2.2. The registered office of the Absorbed Company is located at 9A Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

1.2.3. The issued share capital of the Absorbing Company, as of the date hereof, amounts to twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1)
each, all subscribed and fully paid-up (Arc Shares).

1.3. Shareholding of the Merging Companies
1.3.1. Arc Global (Luxembourg) Holdings II S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at

9A, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCSL under number
B 196 379, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) (Arc Global Lux), is the sole
shareholder of the Absorbed Company.

1.3.2. The Absorbed Company holds five hundred (500) shares of the Absorbing Company representing approximately

100% of the issued share capital of the Absorbing Company.

2. Purpose of the Merger. The acquisition of the Absorbing Company by the Absorbed Company back on 18 May 2015

(the Acquisition) was the sole reason for the incorporation of the Absorbed Company back in December 22 

nd

 2014. The

Absorbed Company is a special purpose vehicle used by ARC Global Lux and its ultimate shareholders to carry out the
acquisition of the Absorbing Company.

The existence of both Merging Companies also required some specific dovetailing of the two different lending facilities

made available for the purposes of financing the Acquisition and refinancing the debt at the level of the Absorbed Company
(which was maturing as a result of the Acquisition). One of the facilities was made available to the Absorbed Company by
virtue of a mezzanine facility agreement dated May 13 

th

 2015 (MFA) by M&amp;G Investment Management Limited, while

146516

L

U X E M B O U R G

the other was made available pursuant to a loan agreement dated May 18 

th

 2015 (SFA) by Deutsche Postbank AG. Both

SFA and MFA contain specific provisions for the Merger to take place, so that the company with the relevant economic
activity (i.e., the Absorbing Company, which is the owner of the income-producing asset) becomes the borrower under the
MFA.

Therefore, the purpose of the Merger is primarily twofold. First, to reorganise and simplify in Luxembourg the structure

of the group of companies to which the Merging Companies belong, bringing it in line with the streamlined structure of
the group elsewhere, which is a requirement for the effective and efficient management of the investments in Europe of
the ultimate shareholder of ARC Global Lux. Concentrating mezzanine and senior debt in one company will also allow
gains of synergies to manage these liabilities and the correlative assets they finance from a corporate governance standpoint.
And second, to simplify the structure in accordance with the discussions of the Merging Companies with the lenders that
made possible the Acquisition (as agreed to and provided for in both the SFA and the MFA).

In addition, the Merger is integrated in the long term investment profile of American Realty Capital Global Trust II,

Inc., the indirect shareholder of ARC Global Lux and the Merging Companies, which aims at enabling as well to streamline
the structure and make it commercially more appealing for third party investors (in case syndication to other investors is
considered during the structure’s lifetime) or third party acquirers (at the end of the investment period and in case additional
flexibility is required).

The Merger allows as well achieving an easier to manage structure in case new financing needs to flow down the chain

from current investors or in case there is recourse to banks for the purposes of a structure refinancing.

3. Type of Merger.
3.1. The Absorbed Company shall merged into the Absorbing Company by way of a merger by absorption by the

Absorbing Company of the Absorbed Company and without liquidation of the Absorbed Company pursuant to (i) the
provisions of Section XIV of the Law, and (ii) the terms and conditions included in this Merger Proposal ((i) and (ii) are
collectively referred to the Merger Terms and Conditions).

3.2. Upon effectiveness of the Merger, (i) all the assets and liabilities of the Absorbed Company (as such assets and

liabilities shall exist on the Effective Date (as defined below)) shall be transferred to the Absorbing Company by operation
of law, (ii) the Absorbed Company shall cease to exist and the Absorbing Company shall issue new shares to Arc Global
Lux, in accordance with the Merger Terms and Conditions and (iv) all shares of the Absorbing Company held by the
Absorbed Company and transferred to the Absorbing Company pursuant to the Merger shall be cancelled, pursuant to
Clause 10.5 (Cancellation of shares of the Absorbing Company held by the Absorbed Company).

4. Merger formalities.
4.1. The Absorbing Company shall carry out all formalities including such announcements as are prescribed by law,

which are necessary or useful to carry out and to effect the Merger and to transfer and assign the assets and liabilities of
the Absorbed Company in accordance with Article 274 of the Law.

4.2. As far as legally required, the Absorbed Company will execute any documents and perform any acts, if necessary,

before the Effective Date (as defined below), in order to allow the transfer of its assets and liabilities to the Absorbing
Company following the Merger.

5. Effective Date.
5.1. The Merger shall become effective between the Merging Companies on the date at which the shareholders of the

Merging Companies shall decide on the approval of the Merger, i.e., the date of the extraordinary general meetings of the
Merging Companies (the Effective Date).

5.2. Towards third parties, the Merger shall become effective upon the publication in the Mémorial of the notarial deeds

recording the resolutions of the general meetings of shareholders of the Merging Companies approving the decision to
merge in accordance with Article 9 and Article 273 of the Law.

5.3. From an accounting and fiscal point of view, the operations of the Absorbed Company shall be considered as

accomplished for the account of the Absorbing Company as from May 18 

th

 2015. All recorded assets and liabilities of the

Absorbed Company and the Absorbing Company shall be carried forward at their historical book values, and the income
of the Absorbing Company shall include the income of the Absorbed Company as of May 18 

th

 2015.

6. Rights conferred by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to the holders of securities

other than shares, or the measures proposed to them. All the shares of the Absorbing Company are identical and grant the
same rights and advantages to their holders. Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Company have issued
shares or other securities granting special rights to the holders thereof.

7. Special advantages.
7.1. Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Company has granted or shall grant any special advantage to

the members of the board of managers of the Merging Companies.

7.2. The mandate of the managers of the Absorbed Company shall come to an end on the Effective Date.

146517

L

U X E M B O U R G

8. Waivers.
8.1. Waiver to independent expert’s report
The shareholders of the Merging Companies have unanimously waived (and will confirm such waiver at the extraor-

dinary general meeting of shareholders of the Merging Companies approving the Merger) in accordance with Article 266
(5) of the Law, the requirement to have the Merger Proposal examined by one or several independent expert(s) and to have
a report established by such independent expert(s) on the Merger Proposal in accordance with Article 266 (1) of the Law.

8.2. Waiver to the detailed written managers’ report
The shareholders of the Merging Companies have unanimously waived (and will confirm such waiver at the extraor-

dinary general meeting of shareholders of the Merging Companies approving the Merger) in accordance with Article 265
(3) of the Law, the requirement to have a detailed written report established by the boards of managers of the Merging
Companies in accordance with Article 265 (1) of the Law and to receive an information on any material change in the
assets and liabilities in accordance with Article 265 (2) of the Law.

8.3. Waiver to the accounting statements
The shareholders of the Merging Companies have unanimously waived (and will confirm such waiver at the extraor-

dinary general meeting of the shareholders of the Merging Companies approving the Merger) in accordance with Article
267 (1) paragraph 2 of the Law, the requirement to have an accounting statement drawn up as at the date which must be
no earlier than the first day of the third month preceding the date of the Merger proposal

9. Reference accounts - valuation.
9.1. The Merger Terms and Conditions have been determined by reference to:
9.1.1. the interim accounts (including the balance sheet, the profit and loss statements and the notes thereto) of the

Absorbed Company as of May 18 

th

 2015, provided, however, that the assets and liabilities of the Absorbed Company shall

be transferred to the Absorbing Company in their condition existing on the Effective Date,and

9.1.2. the interim accounts (including the balance sheet, the profit and loss statements and the notes thereto) of the

Absorbing Company as of May 18 

th

 2015.

9.2. The transferred assets and assumed liabilities of the Absorbed Company shall be assessed at their historical book

value.

10. Share exchange ratio.
10.1. Valuation of the Absorbing Company
The subscribed share capital of the Absorbing Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)

represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each The value of the Absorbing
Company is EUR 8,878,769.40. Subsequently, the net value of one share is EUR 17,757.54.

10.2. Valuation of the Absorbed Company
The subscribed share capital of the Absorbed Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)

represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1) each. The value of the
Absorbed Company is EUR 4,704.76. Subsequently, the net value of one share is EUR 0.38.

10.3. Exchange Ratio
10.3.1. The exchange ratio (the Exchange Ratio) is 1 shares of the Absorbing Company for 25 shares of the Absorbed

Company. There will be no balancing cash adjustment.

10.3.2. The Exchange Ratio is fair and reasonable, since following the cancellation of the 2BKA shares held by the

Absorbed Company pursuant to Clause 10.5 (Cancellation of shares of the Absorbing Company held by the Absorbed
Company), the new shares of the Absorbing Company shall only be issued to Arc Global Lux, which shall remain the sole
shareholder of the Absorbing Company upon the effectiveness of the Merger.

10.3.3. Since the Exchange Ratio has been adopted as a matter of convention, which seems adequate in the context of

the merger between two companies, where the new shares shall only be issued to the sole shareholder of the surviving
company, and no shareholder shall be diluted in the merger, no other specific valuation methods have been used or applied,
and, therefore, no specific difficulties have arisen in relation to the determination of such Exchange Ratio.

10.4. Capital increase
As a consequence of the transfer by operation of law to the Absorbing Company of all the assets and liabilities of the

Absorbed Company by way of the Merger, the Absorbing Company shall, on the Effective Date:

10.4.1. increase its share capital by an amount of Euro 12,500 by the issue of 500 shares of twenty five Euro (EUR 25)

each, in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to the amount of
Euro 25,000.

10.4.2. issue to Arc Global Lux 500 shares of twenty five Euro (EUR 25) each.
10.5. Cancellation of shares of the Absorbing Company held by the Absorbed Company
All the 2BKA Shares held by the Absorbed Company and transferred to the Absorbing Company pursuant to the Merger

shall be cancelled. Such cancellation shall be offset against the share capital of the Absorbing Company to the extent of

146518

L

U X E M B O U R G

the nominal value of these shares. The shareholders of the Absorbing Company shall vote on such cancellation of shares
at the same extraordinary general meeting of shareholders that shall be convened to adopt the decision to merge the Absorbed
Company into the Absorbing Company as contemplated by this Merger Proposal.

11. Modalities of delivery of the newly issued shares of the Absorbing Company.
11.1. On the Effective Date, Arc Global Lux shall automatically receive newly issued shares of the Absorbing Company

in accordance with the applicable Exchange Ratio and on the basis of its holding as entered in the shareholders’ register
of the Absorbed Company.

11.2. The newly issued shares of the Absorbing Company shall be registered in the name of Arc Global Lux in the

shareholders register of the Absorbing Company effective on the Effective Date.

12. Date as of which the newly issued shares of the Absorbing Company give a right to participate to the profits.
12.1. The newly issued shares of the Absorbing Company shall have the same rights as the existing 2BKA Shares.
12.2. The newly issued shares of the Absorbing Company shall be entitled to take part in the Absorbing Company’s

profits as from the Effective Date.

13. Board of managers’ approval.

13.1. The board of managers of the Absorbing Company approved the Merger Proposal on October 30 

th

 2015.

13.2. The board of managers of the Absorbed Company approved the Merger Proposal on October 30 

th

 2015.

14. Documents available at the offices of the Merging Companies.
14.1. All the shareholders of the Absorbing Company and of the Absorbed Company are entitled to inspect the following

documents specified in Article 267, (1) (a), (b) and (d) of the Law at the registered office of the Merging Companies at
least one month before the date of the extraordinary general meeting of shareholders of the Merging Companies approving
the Merger:

14.1.1. the Merger Proposal;
14.1.2. the annual statutory accounts of the Absorbing Company for 2014, 2013 and 2012 as approved by the shareholders

of the Absorbing Company;

14.1.3. considering that the Absorbed Company has been incorporated on December 22 

nd

 2015 and that the first exercise

will end on December 31 

st

 2015, no annual statutory accounts will be available for the Absorbed Company.

14.2. Each shareholder may obtain a copy of the above referred documents upon request and free of charge.

15. Corporate records of the Absorbed Company. All corporate documents, files and records of the Absorbed Company

shall be kept at the registered office of the Absorbing Company for the duration prescribed by law.

16. Expenses. The expenses, costs, fees and charges resulting from the Merger shall be borne by the Absorbing Company.

17. Language. An unofficial English translation of this Merger Proposal shall be available at the offices of the Merging

Companies. For purposes of Luxembourg law, the French language version of this Merger Proposal is binding.

Luxembourg, on October 30 

th

 2015 in 3 original copies.

2 Boulevard Konrad Adenauer S.à r.l. / Arc Global II DB Lux S.à r.l.
Represented by Grenville Carr-Jones / Yves Cheret
<i>Authorized signatory and Class B Manager / Authorized signatory and Class B Manager

Suit la traduction française du texte qui précède:

PROJET COMMUN DE FUSION

Les conseils de gérance de:
1. 2 Boulevard Konrad Adenauer S.à r.l. une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9A, Boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des
sociétés, Luxembourg (RCSL) sous le numéro B 96624, ayant un capital social de douze mille cinq cent euros (EUR 12,500)
(la Société Absorbante); et

2. Arc Global II DB Lux S.à r.l. une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9A, Boulevard Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du RCSL sous le numéro B 193643, ayant
un capital social de douze mille cinq cent euros (EUR 12,500) (la Société Absorbée et ensemble avec la Société Absorbante,
les Sociétés Fusionnantes).

Les Sociétés Fusionnantes souhaitent enregistrer le projet commun de fusion suivant (le Projet de Fusion):
ALORS QUE:
(A)  Les  conseils  de  gérance  des  Sociétés  Fusionnantes  proposent,  à  la  condition  préalable  de  répondre  à  certaines

conditions suspensives, la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante et sans liquidation de la

146519

L

U X E M B O U R G

Société Absorbée (la Fusion) conformément aux articles 261 à 276 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi).

(B) Une fois la fusion effective, tout l’actif et le passif de la Société Absorbée sera transféré à la Société Absorbante de

plein droit, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation et toutes ses parts seront annulées. La Société Absorbée
subsistera en tant que personne morale.

(C) La Fusion est soumise à la condition suspensive que les associés des Sociétés Fusionnantes approuveront ladite

Fusion conformément aux dispositions de l’article 261 de la Loi.

EN CONSEQUENCE, les conseils de gérance des Sociétés Absorbantes ont préparé cette Proposition de Fusion con-

formément à l’article 261 de la Loi.

1. Les Sociétés Fusionnantes.
1.1. La Société Absorbante
1.1.1. 2 Boulevard Konrad Adenauer S.à r.l. est une société à responsabilité limitée constituée suivant un acte de Maître

Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 13 Octobre 2003, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) en date du 25 Novembre 2003, numéro 1247, page
59850. Les statuts de 2 Boulevard Konrad Adenauer S.à r.l. ont été modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant
un acte de Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 18 mai
2015, publié au Mémorial le 23 juillet 2015 sous le numéro 1842, page 88383.

1.1.2. Le siège social de la Société Absorbante est situé au 9A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

1.1.3. Le capital social émis de la Société Absorbante, s’élève à ce jour à douze mille cinq cent euros (EUR 12,500)

représenté par cinq cent (500) parts d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, entièrement souscrites
et intégralement libérées (les Parts 2BKA).

1.2. La Société Absorbée
1.2.1. Arc Global II DB Lux S.à r.l. est une société à responsabilité limitée constituée suivant un acte de Maître Cosita

DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 décembre 2014 publié au
Mémorial en date du 18 février 2015, numéro 439, page 2104. Depuis sa constitution, les statuts d’Arc Global II DB Lux
S.à r.l. n’ont pas été modifiés.

1.2.2. Le siège social de la Société Absorbée est situé au 9A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

1.2.3. Le capital social émis de la Société Absorbée, s’élève à ce jour à douze mille cinq cent euros (EUR 12,500)

représenté par à douze mille cinq cent (12,500) parts d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées (les Action Arc).

1.3. Actionnariat des Sociétés Fusionnantes
1.3.1. Arc Global (Luxembourg) Holdings II S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9A,

Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du RCSL sous le numéro
B 196 379, ayant un capital social de douze mille cinq cent euros (EUR 12,500) (Arc Global Lux) est l’unique associé de
la Société Absorbée.

1.3.2. La Société Absorbée détient cinq cent (500) parts de la Société Absorbante, représentant approximativement 100%

du capital social émis de la Société Absorbante.

2. Objectif de la Fusion. L’acquisition de la Société Absorbante par la Société Absorbée en date du 18 mai 2015 (l’Ac-

quisition) représente l’unique raison pour laquelle la Société Absorbée a été constituée en date du 22 décembre 2014. En
effet, La Société Absorbée est un «special purpose vehicle» ayant été utilisé par Arc Global Lux et ses associés ultimes
afin de procéder à l’Acquisition.

L’existence des Sociétés Fusionnantes nécessite également la description de deux facilités de crédit accordées aux fins

du financement de l’Acquisition et du refinancement de la dette de la Société Absorbée, qui est devenue remboursable suite
à l’Acquisition. Une des facilité de crédit a été accordée en vertu d’un contrat de prêt dit «mezzanine» en date du 23 mai
2015 (MFA) par M&amp;G Investment Management Limited, alors que l’autre facilité de crédit a été accordé à la suite d’un
contrat de prêt dit en date du 18 mai 2015 (SFA) par Deutsche PostBank AG. Le SFA et le MFA contiennent chacun des
dispositions spécifiques aux fins de la Fusion, afin que la société ayant l’activité économique pertinente, c’est-à-dire la
Société Absorbante, détentrice de l’actif générateur de revenu, devienne l’emprunteur en vertu du MFA.

L’objectif de la Fusion est donc double. En premier lieu il s’agit de simplifier et de réorganiser à Luxembourg le groupe

de sociétés auquel les Sociétés Fusionnantes appartiennent, afin de le rendre symétrique à la structure du groupe de sociétés
ailleurs dans le monde, ce qui est nécessaire à une gestion effective et efficace des investissements en Europe de l’associé
ultime de Arc Global Lux. Rassembler la dette issue du MFA et du SFA en une seule et même société permettra également
de gagner en facilité concernant la gestion de ces dettes et des actifs y relatifs d’un point de vue de corporate governance.
En second lieu, il s’agit également de simplifier la structure du groupe de sociétés conformément aux discussions des
Sociétés Fusionnantes et des sociétés prêteuses, ce qui a rendu possible l’Acquisition (en vertu des accords et des dispo-
sitions du SFA et du MFA).

146520

L

U X E M B O U R G

En outre, la Fusion fait également partie de la stratégie d’investissement à long terme de American Realty Capital Global

Trust II, Inc., l’associé indirect de Arc Global Lux et des Sociétés Fusionnantes, dont le but est de favoriser et de moderniser
la structure du groupe de sociétés et la rendre commercialement plus intéressante pour des tiers investisseurs (si la syndi-
cation avec d’autres investisseurs est envisagée pendant la vie du groupe de sociétés) ou des tiers acquéreurs (à la fin d’une
période d’investissement et si une flexibilité additionnelle est nécessaire).

La Fusion permettra également de réaliser une gestion plus facile de la structure du groupe de sociétés en cas de nouveaux

besoins financiers tout au long de la chaine des investisseurs actuels ou s’il est nécessaire d’avoir recours à des banques
afin de refinancer la structure.

3. Type de Fusion.
3.1. La Société Absorbée fusionnera avec la Société Absorbante par voie d’une fusion par absorption par la Société

Absorbante de la Société Absorbée et sans liquidation de la Société Absorbée en vertu (i) des dispositions de la Section
XIV de la Loi et (ii) des termes et conditions contenus dans ce Projet de Fusion ((i) et (ii) collectivement, les Termes et
Conditions de la Fusion).

3.2. Lors de la prise d’effet de la Fusion, (i) tous les actifs et les passifs de la Société Absorbée (tels qu'ils existeront à

la Date Effective (telle que définie ci-dessous)) seront transférés de plein droit à la Société Absorbante, (ii) la Société
Absorbée cessera d’exister, et (iii) la Société Absorbante devra émettre de nouvelles parts à Arc Global Lux, conformément
aux Termes et Conditions de la Fusion et (iv) toutes les parts de la Société Absorbante détenues par la Société Absorbée
et transférées à la Société Absorbante en vertu de la Fusion seront annulées conformément à la clause 10.5 (Annulation
des parts de la Société Absorbante détenues par la Société Absorbée).

4. Formalités de la Fusion.
4.1. La Société Absorbante accomplira toutes les formalités y inclus toutes annonces qui sont légalement prescrites, qui

sont nécessaires ou utiles afin de procéder à la Fusion et au transfert et à la cession des actifs et des passifs de la Société
Absorbée conformément à l’article 274 de la Loi.

4.2. Dans la limite des exigences légales, la Société Absorbée signera tout document et entreprendra tout acte, si né-

cessaire, avant la Date effective (telle que définie ci-dessous), afin de permettre le transfert de ses actifs et ses passifs à la
Société Absorbante suite à la Fusion.

5. Date Effective.
5.1. La Fusion prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes à partir de la date de l’approbation de la Fusion par chacune

des assemblées générales extraordinaires des actionnaires des Sociétés Fusionnantes, c'est-à-dire la date de la tenue desdites
assemblées (la Date Effective).

5.2. A l’égard des tiers, la Fusion prendra effet au jour de la publication dans le Mémorial de l’acte notarié recensant

les résolutions des assemblées générales extraordinaires des Sociétés Fusionnantes qui approuvent la décision de fusionner
conformément aux articles 9 et 273 de la Loi.

5.3. D’un point de vue fiscal et comptable, les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme accomplies

pour le compte de la Société Absorbante au 18 mai 2015. Tous les actifs et les passifs comptabilisés de la Société Absorbée
et la Société Absorbante seront reportés à leur valeur comptable historique, et les revenus de la Société Absorbante incluront
les revenus de la Société Absorbante au 18 mai 2015.

6. Droits conférés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux détenteurs de valeurs mobi-

lières autres que des parts sociales, ou mesures qui leur sont proposées. Toutes les parts sociales de la Société Absorbante
sont  identiques  et  confèrent  les  mêmes  droits  et  avantages  à  leurs  détenteurs.  Ni  la  Société  Absorbante,  ni  la  Société
Absorbée n’ont émis de parts ou d’autres titres conférant des droits spéciaux à leurs détenteurs.

7. Avantages spéciaux.
7.1. Ni la Société Absorbante, ni la Société Absorbée n’a accordé ou n’accordera un avantage particulier dans le cadre

de la Fusion aux membres du conseil de gérance des Sociétés Fusionnantes.

7.2. Le mandat des gérants de la Société Absorbée prendra fin à la Date d’Effective.

8. Renonciation.
8.1. Renonciation au rapport de l’expert indépendant
8.1.1. Les associés des Sociétés Fusionnantes ont à l’unanimité renoncés (et confirmeront cette renonciation lors des

assemblées générales extraordinaires des associés des Sociétés Fusionnantes approuvant la Fusion) conformément à l’ar-
ticle 266 (5) de la Loi, l’exigence d’avoir le Projet de Fusion examiné par un ou plusieurs expert(s) indépendant(s) ainsi
que d’avoir un rapport établi par un tel ou de tels expert(s) indépendant(s) concernant le Projet de Fusion conformément à
l’article 266 (1) de la Loi.

8.2. Renonciation au rapport écrit détaillé établi par les conseils de gérance
8.2.1. Les associés des Sociétés Fusionnantes ont à l’unanimité renoncés (et confirmeront cette renonciation lors des

assemblées générales extraordinaires des associés des Sociétés Fusionnantes approuvant la Fusion) conformément à l’ar-
ticle 265 (3) de la Loi, l’exigence d’avoir un rapport écrit détaillé établi par les conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes

146521

L

U X E M B O U R G

conformément à l’article 265 (1) de la Loi ainsi que de recevoir des informations sur toute modification importante de
l’actif et du passif conformément à l’article 265 (2) de la Loi.

8.2.2. Renonciation à l’état comptable
8.2.2.1. Les associés des Sociétés Fusionnantes ont à l’unanimité renoncés (et confirmeront cette renonciation lors des

assemblées générales extraordinaires des associés des Sociétés Fusionnantes approuvant la Fusion) conformément à l’ar-
ticle 267 (1) alinéa 2 de la Loi, l’exigence d’avoir un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au
premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion.

9. Comptes de référence - évaluation.
9.1. Les Termes et Conditions de la Fusion ont été déterminés par référence à:
9.2. des comptes intérimaires (y compris, le bilan, les comptes des résultats et les notes qui y sont annexées) de la Société

Absorbée en date du 18 mai 2015, à la condition toutefois, que les actifs et les passifs de la Société Absorbée seront transférés
à la Société Absorbante tels qu'ils existent à la Date Effective, et

9.3. des comptes intérimaires (y compris, le bilan, les comptes des résultats et les notes qui y sont annexées) de la Société

Absorbante en date du 18 mai 2015.

9.4. Les actifs transférés et les passifs pris en charge par la Société Absorbée seront évalués à leur valeur comptable

historique.

10. Rapport d’échange des parts.
10.1. Valorisation de la Société Absorbante
10.1.1. Le capital social émis de la Société Absorbante, s’élève à ce jour à douze mille cinq cent euros (EUR 12,500)

représenté par cinq cent (500) parts d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. La valorisation de la
Société Absorbante est de EUR 8,878,769.40. En conséquence, la valeur nette d’une action est de EUR 17,757.54.

10.2. Valorisation de la Société Absorbée
10.2.1. Le capital social émis de la Société Absorbée, s’élève à ce jour à douze mille cinq cent euros (EUR 12,500)

représenté par à douze mille cinq cent (12,500) parts d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune. La valorisation
de la Société Absorbante est de EUR 4,704.76. En conséquence, la valeur nette d’une action est de EUR 0.38.

10.3. Rapport d’échange
10.3.1. Le rapport d’échange (le Rapport d’Echange) est d’une part de la Société Absorbante pour 25 parts de la Société

Absorbée. Il n’y aura pas de soulte en espèce.

10.3.2. Le Rapport d’Echange est équitable et raisonnable car après l’annulation des Parts 2BKA détenues par la Société

Absorbée en vertu de la clause 10.5 (Annulation des parts de la Société Absorbante détenues par la Société Absorbée), les
nouvelles parts de la Société Absorbante seront uniquement émises à Arc Global Lux, qui deviendra l’associé unique de
la Société Absorbante, une fois que la fusion sera effective.

10.3.3. Comme le Rapport d’Echange a été adopté de manière conventionnelle, ce qui semble approprié dans le cadre

de la fusion entre deux sociétés, où les nouvelles parts sociales seront émises à l’associé unique de la société survivante et
où la fusion n’entraîne aucune dilution de l’actionnariat, il n’est recouru à aucune autre méthode d’évaluation spécifique;
de ce fait, aucune difficulté spécifique ne s’est présentée en relation avec la détermination de ce Rapport d’Echange.

10.4. Augmentation de capital
En conséquence du transfert de plein droit de tout l’actif et du passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante

suite à la Fusion, la Société Absorbante devra, à la Date Effective:

10.4.1. Augmenter son capital d’un montant de EUR 12,500 par l’émission de 500 parts d’une valeur de vingt-cinq euros

(EUR 25) chacune, afin de d’augmenter son capital actuel de EUR 12,500 à EUR 25,000;

10.4.2. Emettre à Arc Global Lux 500 parts d’une valeur de EUR 25 chacune.
10.5. Annulation des parts de la Société Absorbante détenues par la Société Absorbée
10.5.1. Toutes les Parts 2BKA détenues par la Société Absorbée et transférées à la Société Absorbante suite à la Fusion

devront être annulées. Cette annulation sera compensée par le capital social de la Société Absorbante et par la valeur
nominale desdites parts. Les Associés des Sociétés Fusionnantes devront voter l’annulation des parts pendant l’assemblée
générale extraordinaire approuvant la Fusion.

11. Modalités de remise des parts nouvellement émises par la Société Absorbante.
11.1. A la Date Effective, Arc Global Lux devra automatiquement recevoir les nouvelles parts émises de la Société

Absorbante conformément au Rapport d’Echange et en enregistrant sa participation dans le registre des associés de la
Société Absorbante.

11.2. Les nouvelles parts émises de la Société Absorbante devront être enregistrées au nom d’Arc Global Lux dans le

registre des associés de la Société Absorbante au jour de la Date Effective.

12. Date à laquelle les nouvelles parts de la Société Absorbante donneront droit de participer aux profits.
12.1. Les nouvelles parts émises de la Société Absorbante devront avoir les mêmes droits que les Parts 2BKA existantes.

146522

L

U X E M B O U R G

12.2. Les nouvelles parts émises de la Société Absorbante donneront droit de participer aux profits de la Société Ab-

sorbante au jour de la Date Effective.

13. Approbation par le conseil de gérance.
13.1. Le conseil de gérance de la Société Absorbante a approuvé le Projet de Fusion le 30 octobre 2015.
13.2. Le conseil de gérance de la Société Absorbée a approuvé le Projet de Fusion le 30 octobre 2015.

14. Documents disponibles au siège social des Sociétés Fusionnantes.
14.1. Tous les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont le droit de prendre connaissance des

documents suivants tels que spécifiés à l’Article 267, (1) (a), (b) et (c) de la Loi, au siège social des Sociétés Fusionnantes
au moins un mois avant la date de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires des Sociétés Fusionnantes approu-
vant la Fusion:

14.1.1. le Projet de Fusion;
14.1.2. les comptes annuels de la Société Absorbante de 2014, 2013 et 2012 tels qu'approuvés par les actionnaires de la

Société Absorbante;

14.1.3. prenant en considération que la Société Absorbée n’a été constituée qu'en date du 22 décembre 2014 et que son

premier exercice social se termine le 31 décembre 2015, aucun compte annuel ne sera disponible pour la Société Absorbée;

14.1.4. Chaque associé pourra obtenir gratuitement une copie des documents mentionnés ci-dessus sur demande.

15. Documents sociaux de la Société Absorbée. Tous les documents sociaux, les fichiers et les registres de la Société

Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour la durée prévue par la loi.

16. Dépenses. Les dépenses, coûts, frais et charges découlant de la Fusion seront à la charge de la Société Absorbante.

17. Langue. Une traduction non officielle en anglais du présent Projet de Fusion sera disponible au siège social des

Sociétés Fusionnantes. La version française du présent Projet de Fusion prévaut.

Luxembourg, le 30 octobre 2015 en trois copies originales.

2 Boulevard Konrad Adenauer S.à r.l. / Arc Global II DB Lux S.à r.l.
Représenté par Grenville Carr-Jones / Yves Cheret
<i>Signataire autorisé et gérant de catégorie B / Signataire autorisé et gérant de catégorie B

Référence de publication: 2015180232/428.
(150199345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2015.

Herald, the Henderson European Retail Property Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

In accordance with article 24.2 of its management regulations and following a decision of the General Meeting of the

Unitholders dated 21 April 2015 to bring forward the Fund's term from 15 December 2015 to 30 September 2015, Herald,
the Henderson European Retail Property Fund FCP - FIS has been put into liquidation with effect as of 30 September 2015.

Henderson European Retail Property Fund Management S.à r.l., its Management Company, was appointed as liquidator

with effect as of 30 September 2015.

Henderson European Retail Property Fund Management S.à r.l.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015180245/12.

HA Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 174.541.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 03 septembre 2014,

<i>lors du conseil d'administration de la Société Fisconsult s.a.

Le conseil d'administration de la société Fisconsult S.A. certifie lors de la présente réunion que la société HA Invest

S.A., dont le numéro RCS est le B 174.541 et avec qui elle avait un contrat de domiciliation n'a plus son siège social au
L-1630 Luxembourg, rue Glesener 56.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association.

Fisconsult S.A.
Signature

Référence de publication: 2015180957/14.
(140175301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2014.

146523

L

U X E M B O U R G

Edelveys Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 177.292.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the first of October
Before Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the undersigned;

APPEARED:

EDELVEYS INTERNATIONAL LIMITED, a private limited liability company incorporated under the laws of Malta,

registered with the Registrar of Companies of Valletta, Malta, under number C 59291, having its registered office at Vincenti
Buildings, 28/19 (Suite 1301) Strait Street, Valletta VLT 1432, MALTA, duly represented by Mrs. Sabine PERRIER, with
professional address at 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under
private seal in London, Great Britain, on 24 September 2015.

The said power, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his capacity, declares and requests the notary to act:
1.- That the private limited liability company («société à responsabilité limitée») "EDELVEYS GROUP S.A.R.L.", with

registered office à L-2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse, registered at the Trade and Companies' Register
of Luxembourg («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg »), section B, under the number 177.292, (he-
reinafter referred to as the «Company»), has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary
residing in Luxembourg, on 13 May 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
1618 of 6 July 2013. The articles of incorporation have not been amended since incorporation.

2.- That the corporate capital is set at fifteen thousand Euro (EUR 15.000) represented by fifteen thousand (15.000)

units with a nominal value of one Euro (EUR 1,-) each, subscribed and fully paid up.

3.- That the appearing party, represented as said before, is the sole owner (“Sole Shareholder”) of all the units of the

Company.

4.- That the activity of the Company has ceased, and that the appearing, represented as said before, resolves in an

extraordinary general meeting to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company.

5.- That the Sole Shareholder, has designated, Mrs Sabine PERRIER, born on 22 April 1959 in Thionville (France),

residing professionally in L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, as liquidator of the Company, who has
accepted the mission in accordance with the provisions set forth by the law of 10 

th

 August 1915 as modified on commercial

companies;

6.- That the liquidator, in her capacity, has requested the officiating notary to authenticate her declaration that (i) the

Company has a negative net asset value, taking into account the loss incurred in accordance with the dissolution and
liquidation accounts to 23 September 2015 as enclosed; (ii) the liabilities of the Company have been settled and (iii) the
liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly accrued. The liquidator furthermore declares that
with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, the Sole Shareholder irrevocably
undertakes to pay all such eventual liabilities. As a consequence thereof, all the liabilities of the company are paid and the
remaining assets shall, as the case may be, be transferred to the Sole Shareholder;

7.- That the declarations of the liquidator have been verified, pursuant to a report that remains attached as appendix and

issued by Mrs Sylvaine AUBARD, born on 23 August 1973 in Sarcelles (France), professionally with address at 124,
Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, acting as auditor to the liquidation designated by the Sole Shareholder;

8.- That the liquidation of the Company is done and finalised;
9.- That full discharge is granted to (i) the Company's Managers for their respective duties to-date, (ii) the liquidator

and (iii) the auditor to the liquidation;

10.- That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at the

registered office of the Company, being at L-2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse.

Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of the dissolved company or the reimbursement to

the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) as from
the date of the publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved and liquidated
has requested the creation of security.

The attorney then presents to the Notary the share register of the Company for cancellation.
For the completion of all formalities related to the registration, publications, strike off, filings and any other formalities

deemed required or necessary, the bearer of the present deed is herewith fully empowered.

146524

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and

charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at one thousand three hundred Euro (EUR 1,300).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil status

and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le premier Octobre
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gnée;

A COMPARU:

EDELVEYS INTERNATIONAL LIMITED, une société à responsabilité limitée, constituée suivant les Lois de Malte,

enregistrée au Registre des Sociétés de Malte, sous le numéro C 59291, ayant son siège social à Vincenti Buildings, 28/19
(Suite 1301) Strait Street, Valletta VLT 1432, MALTE, ici représentée par Madame Sabine PERRIER, avec adresse pro-
fessionnelle au 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée
à Londres, Royaume Uni, le 24 Septembre 2015,

Ladite procuration signée « ne varietur » par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1.- Que la société à responsabilité limitée "Edelveys Group S.A.R.L.", avec siège social à L-2330 Luxembourg, 124,

Boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
177.292, (ci-après dénommée la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire
de résidence à Luxembourg, le 13 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1618 du
6 juillet 2013. Les statuts n'ont pas fait l'objet de modification ultérieure.

2.- Que le capital social est fixé à quinze mille Euros (EUR 15.000), représenté par quinze mille (15.000) parts sociales

d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-), toutes souscrites et entièrement libérées.

3.- Que l'associée unique est l'unique propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
4.- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'associée unique, représentée comme dit ci-avant, siégeant en assemblée

générale extraordinaire, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5.- Que l'associée unique a désigné Madame Sabine PERRIER, née le 22 avril 1959 à Thionville (F), demeurant pro-

fessionnellement à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, comme liquidateur de la Société, laquelle a accepté
la mission suivant les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

6.- Que le liquidateur de la Société a requis le notaire instrumentant d'acter ses déclarations que (i) la Société a une

valeur d'actif net négative, avec la perte subie suivant les états financiers de liquidation clos au 23 septembre 2015 ci-
annexés ; (ii) le passif de la Société est réglé et (iii) le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment
provisionné. Le liquidateur déclare en outre que, par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et
non payés à l'heure actuelle, l'associée unique assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel. En
conséquence, tout le passif de ladite Société est réglé et les actifs restants sont transférés, le cas échéant, au profit de
l'associée unique.

7.- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, établi par Mme

Sylvaine AUBARD, née le 23 août 1973 à Sarcelles (France), désignée "commissairevérificateur" par l'associée unique de
la Société.

8.- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
9.- Que décharge pleine et entière est accordée (i) aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à

ce jour, (ii) au liquidateur et (iii) au commissaire vérificateur de la liquidation.

10.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien

siège social de la Société à L-2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'Associée

Unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de
la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution
de sûretés.

La mandataire présente alors le registre des associés de la Société au Notaire instrumentaire, pour annulation.

146525

L

U X E M B O U R G

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et toutes autres for-

malités qui puissent s'avérer utiles et nécessaires, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à

raison de cet acte, est dès lors évalué à mille trois cents Euros (EUR 1.300.-).

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Perrier et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 6 octobre 2015. Relation: 2LAC/2015/22346. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Référence de publication: 2015168301/132.
(150185960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

Cemex Global Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 43-49, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 138.861.

<i>Certificat émis en application de l'article 273 de la LSC

The undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, certifies that in

accordance to article 273 of the law on commercial companies of the Grand Duchy of Luxembourg, dated August 10 

th

 ,

1915, that

(i) according a deed drawn up by Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

dated May 12 

th

 , 2015, published in the official gazette («Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations»), number

1356, dated May 28 

th

 , 2015, the quotaholders of Cemex Hungary Kft., a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) incorporated under the laws of Hungary, having its registered office at Kapás u. 6-12., 3 

rd

 - 4 

th

floors, H-1027 Budapest and registered with the Trade Register of Hungary under number 01-09-698135, and the mana-
gement of Cemex Global Funding S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 43-49, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, and registered
with the Luxembourg trade and companies register under number B 138.861, have established common draft terms of
cross-border merger, in which the company «Cemex Hungary Kft.,» declared to absorb the company «Cemex Global
Funding S. à r.l.».

(ii) The said COMMON DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER have been published in the official gazette

(“Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”) number 1356 dated May 28 

th

 , 2015, and until today no one made

an opposition to this merger between the two (2) companies.

(iii) The officiating notary states that the merger between the absorbing company and the absorbed company has become

effective counting from October 31 

st

 , 2015, and from an accounting perspective from October 31 

st

 , 2015, so that the

company «Cemex Global Funding S. à r.l.» has definitely ceased to exist.

Follows the French translation:

Je soussigné Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, certifie qu'en

application de l'article 273 de la loi sur les sociétés commerciales du Grand-Duché de Luxembourg, du 10 août 1915, que

(i) suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en

date du 12 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1356 du 28 mai 2015, les
actionnaires de Cemex Hungary Kft., société à responsabilité limitée de droit hongrois, ayant son siège social sis à Kapás
u. 6-12., 3 

ème

 et 4 

ème

 étages, H-1027 Budapest et immatriculée auprès du registre de commerce hongrois sous le numéro

01-09-698135, et la gérance de Cemex Global Funding S. à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

146526

L

U X E M B O U R G

ayant son siège social sis au 43-49, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, et immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le matricule B 138.861, ont établi un projet commun de fusion, aux termes duquel la société
«Cemex Hungary Kft.,» absorbe la société «Cemex Global Funding S. à r.l.».

(ii) Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1356 du 28 mai

2015, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne s’est opposé à la fusion des deux (2) sociétés.

(iii) Le notaire instrumentant confirme que dès lors la fusion entre la société absorbante et la société absorbée est devenue

effective à partir du 31 octobre 2015, et d’un point de vu comptable du 31 octobre 2015, et que la société «Cemex Global
Funding S. à r.l.» a donc définitivement cessé d'exister.

Junglinster, le 31 octobre 2015.

Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2015178184/45.
(150198759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Investprojet Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 88.341.

Leudelange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 82.723.

PROJET DE FUSION

L’an deux mille quinze, le trois novembre
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

A comparu:

1. Monsieur Anthony THILLMANY, employé privé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,
agissant en tant que mandataire des gérants de la société à responsabilité limitée «INVESTPROJET S.à r.l.», ayant son

siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, Rue de Merl (matricule 2002 24 10 521) constituée aux termes d'un acte reçu
par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1400
du 27 septembre 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.341;

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil de gérance prise en sa réunion du 20 octobre 2015.
Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

2. Monsieur Anthony THILLMANY, employé privé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme «LEUDELANGE S.A.», ayant son

siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, Rue de Merl (matricule 2001 22 15 984) inscrite au R.C.S. Luxembourg sous
la section B et le numéro 82.723, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence
à Dudelange par acte du 19 juin 2001, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1232
du 27 décembre 2001,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolution du conseil d'administration en sa réunion du 20 octobre 2015.
Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lequel mandataire, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter le projet de fusion qui suit:
1) La société à responsabilité limitée «INVESTPROJET S.à r.l.», détient l'intégralité (100%) des actions représentant

la totalité du capital social de la société anonyme «LEUDELANGE S.A.» et s’élevant à cent mille euros (EUR 100.000,-),
représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

2) La société à responsabilité limitée «INVESTPROJET S.à r.l.», (encore appelée la société absorbante) entend fusionner

conformément aux dispositions de l'article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que
modifiée par les textes subséquents, avec la société anonyme «LEUDELANGE S.A.» (encore appelée la société absorbée)
par absorption de cette dernière.

3) La société anonyme «LEUDELANGE S.A.» (encore appelée la société absorbée) détient une place sise à Leudelange,

Rue Léon Laval.

4) La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme

accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1 

er

 décembre 2015.

5) Aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

146527

L

U X E M B O U R G

6) La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

7) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du

projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents indiqués à l'article 267(1) a) b) et c) de la loi sur
les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir copie intégrale sans frais et sur simple demande.

8) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital

souscrit,  ont  le  droit  de  requérir,  pendant  le  même  délai,  la  convocation  d’une  assemblée  appelée  à  se  prononcer  sur
l'approbation de la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.

9) A défaut de la réquisition d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive,

comme indiqué ci-avant au point 6) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales et notamment sous son littera a).

10) Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les décla-

rations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports
faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

11) Décharge pleine et entière est accordée au(x) gérant(s) de la société absorbée.
12) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société

absorbante.

<i>Formalités

La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra

pour faire mettre à son nom les éléments d’actif apportés,

- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

<i>Remise de titres

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous

ses  actes  constitutifs  et  modificatifs  ainsi  que  les  livres  de  comptabilité  et  autres  documents  comptables,  les  titres  de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d’actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats, archives pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

<i>Frais et droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dûs par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au

titre des exercices non encore imposés définitivement.

<i>Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour

toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.

<i>Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et faire

toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés com-

merciales la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'article 278 de la loi sur les sociétés.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant agissant en ses dites qualités, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: THILLMANY, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03/11/2015. Relation: EAC/2015/25422. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2015.

Référence de publication: 2015179145/92.
(150198900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

146528

L

U X E M B O U R G

Market Access II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 129.800.

DISSOLUTION

In the year two thousand fifteen, on the twenty-third day of October.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand- Duchy of Luxembourg.

There appeared

“The Royal Bank of Scotland plc”, a public limited company incorporated under the laws of Scotland and having its

registered office at 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, acting through its offices located 135 Bishopsgate, EC2M
3UR London, United Kingdom,

represented by Me Raoul HEINEN, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, which proxy, after having been initialled “ne varietur” by the appearing person

and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The appearing person, acting in such capacity as mentioned above, requested the undersigned notary to record that:
- The société d’investissement à capital variable MARKET ACCESS II, (the “Company”), having its registered office

in Luxembourg, has been constituted under the deed of Maître Jean-Paul HENCKS, notary residing in Luxembourg, acting
in replacement of Maître Gérard LECUIT, on 13 July 2007, as published in the Mémorial C number 1709 on 13 August
2007;

- The corporate capital of the Company amounts as of this date to one hundred eleven euros (EUR 111.-) represented

by one (1) share without a par value (as stated in the share register report of the Company and the overview of the assets
and liabilities of the Company both remaining attached to the present deed in order to be registered with it);

- The person represented has become the owner of the abovementioned share and has decided to wind up the Company.
After these statements, the person represented, acting in its capacity of liquidator of the Company as well as in its capacity

as sole shareholder of the Company declares:

- to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company pursuant to the audited

accounts for the period from 1 

st

 January 2015 to 23 

rd

 October 2015 (attached to the present deed);

- to proceed with the immediate dissolution and liquidation of the Company;
- that all assets have been realised and converted into cash;
- that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed;
- full discharge is given to the members of the board of directors of the Company for the execution of their mandates;
- the books and documents of the Company shall remain for a period of five years at the address of RBC Investor Services

Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed have been estimated at about EUR 1,800.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, first name, civil status and

residence, the said person, who requested that the deed should be documented in the English language, has signed the
present deed together with Us, the notary, having personal knowledge of the English language.

Signé: Raoul HEINEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 octobre 2015. Relation GAC/2015/9191. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015179229/51.
(150198716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

146529

L

U X E M B O U R G

Carmel Capital VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.621.965,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 158.035.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 17 septembre 2015 que:
- Monsieur Frédéric Feyten a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet immédiat;
- Madame Martine Gerber-Lemaire, née le 17 juillet 1965 à Saint Dié, France, résidant professionnellement au 291,

route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée illimitée;

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais des gérants suivants:
1. Mr. Dominic Spiri, gérant;
2. Mr. Patrick Finan, gérant;
3. Mr. Gérard Maîtrejean, gérant;
4. Mr. Stéphane Hadet, gérant; et
5. Ms. Martine Gerber-Lemaire, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015157289/23.
(150173618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

IV Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 154.054.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

Référence de publication: 2015156801/10.
(150172957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Jack RIBEIRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 151.468.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, 83 rue de Hollerich, le 15 septembre

<i>2015.

L'Assemblée générale renouvelle le mandat de l'administrateur unique à savoir M. Joao Jacques Magalhaes Ribeiro.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.

L'assemblée renouvelle le mandat du commissaire à savoir, la société Compliance &amp; Control. Son mandat prendra fin

lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2015.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015156802/17.
(150172729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

146530

L

U X E M B O U R G

Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 93.557.

Les comptes annuels de la société Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015156803/10.
(150172332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

KPI Residential Property 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 114.517.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Le 13 avril 2015, l'actionnaire unique de la Société a décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.
Les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse

suivante:

6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

<i>Pour la Société
Un Mandataire

Référence de publication: 2015156823/17.
(150172922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Juler Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 165.596.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2015156804/11.
(150172352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

MWD, MWD - Marc Weiler Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2526 Luxembourg, 4, rue Schrobilgen.

R.C.S. Luxembourg B 200.155.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le dix-sept septembre.
Par-devant  Nous  Me  Jean-Paul  MEYERS,  notaire  de  résidence  à  Esch-sur-Alzette,  Grand-Duché  de  Luxembourg,

soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Marc WEILER, né le 3 avril 1965 à Luxembourg, graphiste, demeurant à 20, Domaine des Ormilles à L-8088

Bertrange.

Laquelle partie comparante, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée

à constituer comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MWD - Marc Weiler

Design S.à r.l., en abrégé MWD (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les
lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

146531

L

U X E M B O U R G

Art. 2. L'objet de la Société est le commerce en général ainsi que l'exploitation d'un atelier créatif de conception graphique

et de communication visuelle regroupant plusieurs métiers de la communication et du graphisme, la conception d'outils de
communication visuelle la conception et réalisation d'agencement de stands, décors, exposition ou PLV et la gestion de
marques.

L'objet de la Société est encore la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement

par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette
ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements

et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La  Société  peut  effectuer  toutes  les  opérations  commerciales,  financières  ou  industrielles  et  toutes  les  transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La société peut également créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou

succursales.

Art. 4. La durée de la Société est illimitée.

Art. 5. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) divisé en cent (100) parts sociales

ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- €) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et

200-2, entre autres, de la Loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat
entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne
sont pas applicables.

La Société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas
de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts entre vifs à des non-associés sont

subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit

être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein
droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 8. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la Société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait

146532

L

U X E M B O U R G

l'avance, et la Société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport

supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la Société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de

décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils
doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 11. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou, si plus d'un Gérant a été

nommé, par la signature conjointe de deux Gérants dont un au moins celui qui aura l'autorisation d'établissement.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la Société et pour représenter la Société

judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui peuvent engager la Société par leurs signatures

individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 12. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions légales.

Art. 14. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au trente-et-un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 17.  L'excédent  favorable  du  compte  de  profits  et  pertes,  après  déduction  des  frais  généraux,  charges  sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et

affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris
jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.
Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 18. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales

qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 20. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la Société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre de cette année.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent (100) parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-

cinq Euros (125,- €) ont été souscrites par l'Associé Unique Monsieur Marc Weiler, né le 03.04.1965 à Luxembourg,
graphiste, demeurant à 20, Domaine des Ormilles, L-8088 Bertrange, et libérées entièrement moyennant un versement en
numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) se trouve dès-à-présent à la libre disposition
de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

146533

L

U X E M B O U R G

<i>Résolutions prises par l'associée unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes

en tant qu'associé unique:

1. Le siège social est établi à 4, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée comme Gérant Unique de la Société pour une durée indéfinie:
Monsieur Marc WEILER, né le 03.04.1965 à Luxembourg, graphiste, demeurant à 20, Domaine des Ormilles, L-8088

Bertrange.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 1.300,- euros.

<i>Autorisation de commerce - activités réglementées

Le notaire soussigné a informé la partie comparante qu'avant l'exercice de toute activité commerciale ou bien dans

l'éventualité où la société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la société doit être au préalable
en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s'acquitter de toutes autres formalités aux fins
de rendre possible l'activité de la société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu par
la partie comparante.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Marc Weiler, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21600. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015157546/151.
(150173651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

PineBridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 179.707.

La nomination de Paul Guillaume, employé privé, né le 10 février 1959 à Luxembourg, résidant professionnellement à

370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que gérant avec effet au 6 août 2015 et pour une période de temps
illimitée.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme il suit:
- M. Alain Guérard, Gérant
- M. David Giroux, Gérant
- M. Anders Faergemann, Gérant
- Mme. Kamala Anantharam, Gérant
- M. George Hornig, Gérant
- M. Paul Guillaume, Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015156948/19.
(150172977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Place Ovale Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 99.227.

Les comptes annuels de la société Place Ovale Holding S.A. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

146534

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015156949/10.
(150172292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Partners Group Search S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 881.901,93.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 175.919.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société datées du 17 septembre 2015

En date du 17 septembre 2015, les associés de la Société ont pris connaissance de la démission de Monsieur Christian

Unger en tant qu'administrateur avec effet au 3 septembre 2015 et ont décidé:

- de nommer Monsieur Stephan Seissl, né le 16 août 1983 à Schwaz en Autriche, demeurant professionnellement au

110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur avec effet au 3 septembre 2015 et pour
une durée déterminée se terminant lors de l'approbation des comptes annuels de 2020 qui aura lieu en 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015156944/18.
(150172899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Offset Moselle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 40, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 26.676.

Der Jahresabschluss vom 01.01.2014 - 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg

hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015156936/10.
(150173075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Oerlikon Balzers Coating Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4562 Differdange, route de Bascharage, Zone Industrielle Haanebesch.

R.C.S. Luxembourg B 73.684.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015156929/9.
(150172221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Office Portfolio Minerva I Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.075.384,96.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 135.148.

CLOSURE OF LIQUIDATION

Le 7 mai 2015, l'actionnaire unique de la Société a décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.
Les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse

suivante:

6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

146535

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

<i>Pour la Société
Un Mandataire

Référence de publication: 2015156930/17.
(150172921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

PAN European Value Added Venture Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 186.798.

Les statuts coordonnés au 08/09/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015156991/12.
(150172999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Partners of Excellence S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 111, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 187.082.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, den 22.09.2015.

Référence de publication: 2015156993/10.
(150172621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Pharma Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 146.904.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés de la Société en date du 14 Septembre 2015 que l'associé unique de la Société a

pris acte de:

- la démission de Monsieur Vittorio Rizzo du conseil de gérance de la Société en tant que gérant unique avec effet au

14 Septembre 2015;

- la nomination de Monsieur Giuseppe Miglio, né le 1 

er

 avril 1935 à Crevacuore (BI), Italie, résidant au 16, via Cervi-

gnano, 20137 Milan, Italie, avec effet au 14 Septembre 2015 et pour une durée illimitée en tant que gérant unique de la
Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015156995/19.
(150172890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Participations A &amp; F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 70.807.

Les documents de clôture de l'année 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 22 septembre 2015.

Référence de publication: 2015156992/10.
(150172374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

146536

L

U X E M B O U R G

PALLINGHURST INVESTOR CONSORTIUM II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 341.400,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 152.918.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Sophie Zintzen
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015156990/12.
(150172375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Property Leasing S.à r.l., Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 7.044.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 23 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157572/10.
(150173563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Pan European Value Added Venture German Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 186.975.

Les statuts coordonnés au 08/09/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015157574/12.
(150173653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Parc Belair S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 34.508.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 août 2015:

L'associé unique a décidé de nommer comme gérant administratif M. Marcel Goeres, demeurant au 111, Avenue du X

Septembre L-2551 Luxembourg pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157575/12.
(150173289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Prima Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 150.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

146537

L

U X E M B O U R G

PRIMA PRIVATE EQUITY S.A.

Référence de publication: 2015157586/10.
(150173342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Prodilux Diffusion s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,00.

Siège social: L-8399 Windhof, 5, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 165.420.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société du 23 septembre 2015 que:
- Monsieur Jean-Claude BOSSI a été révoqué avec effet au 23 septembre 2015 en tant que gérant administratif de la

Société;

- Monsieur Armand HELLERS a démissionné avec effet au 23 septembre 2015 de son mandat de gérant administratif

de la Société;

- Monsieur Mehdi JOUIHRI, sera désormais gérant unique de la Société, qu'il engagera en toutes circonstances par sa

seule signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015157588/18.
(150173514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Plumeau S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 66.251.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que Monsieur Fabrizio Terenziani, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, est nommé représentant permanent de Lux Business Management
S.à.r.l. en remplacement de Monsieur Christian KNAUFF qui occupait jusqu'alors cette fonction, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 Septembre 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015157581/14.
(150173884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Ergan International SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 188.882.

Ergan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 153.057.

PROJET COMMUN DE FUSION

L’an deux mille quinze, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1. Madame Laure SINESI, employée, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, agissant en

tant que mandataire pour le compte de la gérance de ERGAN INTERNATIONAL S.à r.l., une société à responsabilité
limitée  de  droit  luxembourgeois,  ayant  son  siège  social  à  L-2529  Howald,  45  rue  des  Scillas,  inscrite  au  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18882, constituée suivant acte reçu par Maître Roger AR-
RENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 15 juillet 2014, publié au
Mémorial C numéro 2576 du 23 septembre 2014, dont les statuts ont été modifiés, en dernier lieu, suivant acte reçu par
Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 juin 2015, publié
au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  numéro  2283  du  27  août  2015,  ci-après  dénommée  «la  Société

146538

L

U X E M B O U R G

Absorbante», en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision de la gérance de la Société Absorbante en date du
8 octobre 2015.

2. Madame Laure SINESI, employée, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, agissant en

tant que mandataire pour le compte de la gérance de ERGAN S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 153057, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 7 mai 2010, publié au Mémorial C numéro 1352 du 1 

er

 juillet

2010, dont les statuts ont été modifiés, en dernier lieu, suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence
à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2356 du 2 septembre 2015, ci-après dénommée «la Société Absorbée», en vertu des pouvoirs qui lui
ont été conférés par décision de la gérance de la Société Absorbée en date du 8 octobre 2015.

Les copies des procès-verbaux des réunions, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire des comparantes et

le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter le projet commun

de fusion suivant:

La gérance de la Société Absorbante et la gérance de la Société Absorbée ont établi conformément aux articles 261 et

suivants de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), le projet de fusion suivant
(le «Projet Commun de Fusion»):

Il est proposé une fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (ensemble les «Sociétés

Fusionnantes») moyennant transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée, par suite d'une
dissolution sans liquidation, à la Société Absorbante conformément aux articles 278 et suivants de la Loi (la «Fusion»).

Ce Projet Commun de Fusion sera publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg au

moins un mois avant la réalisation de la Fusion.

1. Forme, Dénomination et siège social des sociétés qui fusionnent.
- Société Absorbante: ERGAN INTERNATIONAL S.à r.l.
Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de trente millions cent-quatre-vingt-dix-sept mille

euros (EUR 30'197'000), représenté par trois-cent-un mille neuf-cent-soixante-dix (301'970) parts sociales de cent euros
(EUR 100.-) chacune, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188882, ayant
son siège social à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

- Société Absorbée: ERGAN S.à r.l.
Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de douze mille cinq-cents euros (EUR 12'500),

représenté par douze mille cinq-cents (12'500) parts sociales d’un euro (EUR 1.-) chacune, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153057, ayant son siège social à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

2. Rapport d'échange - Soulte. Sous condition qu'au moment de la Fusion, la Société Absorbante détient cent pour cent

(100 %) des actions de la Société Absorbée, les allégements prévus à l'article 278 de la Loi seront d’application. L’absorption
se fera en ce cas sans émission de parts sociales nouvelles, ni paiement de soulte.

3. Actifs et Passifs apportés. En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée, suivant sa dissolution sans liquidation,

transmet tous ses actifs et son passif à la Société Absorbante.

4. Date de prise d'effet de la Fusion. La Fusion prendra effet entre les parties lorsque seront intervenues les décisions

concordantes des assemblées générales de la Société Absorbée et la Société Absorbante approuvant la Fusion (la «Date
d'Effet»), dont la tenue est programmée dans un délai de 4 à 8 semaines après la publication du présent Projet Commun de
Fusion.

La Fusion telle que proposée est subordonnée à la condition suspensive que, préalablement à la Date d'Effet, l'acquisition

de toutes les parts sociales de la Société Absorbée par la Société Absorbante ait été réalisée et que la Société Absorbante
soit ainsi devenue l'associée unique de la Société Absorbée.

Vis-à-vis des tiers, la Fusion n'aura d'effet qu'après la publication des procès-verbaux de ces assemblées au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations.

La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme

accomplies pour le compte de la Société Absorbante sera le 1 

er

 octobre 2015.

5. Droits des associés ayant des droits spéciaux et des porteurs de titres autres que des parts sociales. Les Sociétés

Fusionnantes n'ont pas émis de parts sociales comportant des droits spéciaux, ni des titres autres que des parts sociales.

6. Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion et aux commissaires des sociétés qui fusionnent

ainsi qu'à l'expert au sens de l'article 266 de la Loi. Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de
gestion et de contrôle des sociétés qui fusionnent. L'intervention d'un expert au sens de l'article 266 de la loi n'est pas requise
dans le cadre d'une fusion simplifiée par application des articles 278 et suivants de la Loi.

146539

L

U X E M B O U R G

7. Documentation. Tout associé de la Société Absorbante et de la Société Absorbée pourront prendre connaissance à

leur siège social respectif des documents suivants:

- le Projet Commun de Fusion;
- les comptes annuels et rapports de gestion des trois derniers exercices ainsi qu'un état comptable arrêté au 30 septembre

2015 de la Société Absorbée;

- les comptes annuels et rapports de gestion des trois derniers exercices ainsi qu'un état comptable arrêté au 30 septembre

2015 de la Société Absorbante.

Une copie intégrale ou partielle des documents sera délivrée à tout associé sur simple demande et sans frais.
Tous les documents sociaux, dossiers et procès-verbaux de la Société Absorbée seront, après la date d'effet, conservés

au siège social de la Société Absorbante pour la durée prévue par la Loi.

8. Dissolution de la Société Absorbée. La Fusion entraîne de plein droit que la Société Absorbée cessera d'exister.
Le notaire soussigné certifie l'existence et la légalité du Projet Commun de Fusion et de tous les actes, documents, et

formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes conformément à l'article 271 (2) de la Loi.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en français suivi par une traduction anglaise. A la demande de cette même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Howald, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh of October,
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg),

The following parties appeared:

1. Ms Laure SINESI, employee, residing professionally at 45 rue des Scillas, L-2529 Howald, representing the man-

agement of ERGAN INTERNATIONAL S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (limited liability company),
having its registered office at 45 rue des Scillas, L-2529 Howald, registered at the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 18882, incorporated pursuant to an instrument received by Maître Roger Arrensdorff, notary
residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) dated 15 July 2014, published in the Mémorial C number 2576 of
23 September 2014, whose Articles of Association were last amended pursuant to an instrument received by Maître Jean
Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, dated 30 June 2015, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 2283 of 27 August 2015, hereinafter the “Absorbing Company”, by virtue of
the powers conferred upon her by decision of the management of the Absorbing Company of 8 October 2015.

2. Ms Laure SINESI, employee, residing professionally at 45 rue des Scillas, L-2529 Howald, representing the man-

agement of ERGAN S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (limited liability company), having its registered
office at 45 rue des Scillas, L-2529 Howald, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 153057, incorporated pursuant to an instrument received by Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg) dated 7 May 2010, published in the Mémorial C number 1352 of 1 July 2010, whose Articles
of Association were last amended pursuant to an instrument received by Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster,
Grand Duchy of Luxembourg, dated 30 June 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 2356 of 2 September 2015, hereinafter the “Absorbed Company”, by virtue of the powers conferred upon her by
decision of the management of the Absorbed Company of 8 October 2015.

Copies of the minutes of meetings, after being signed ne varietur by the representative of the parties appearing and the

officiating notary, shall remain appended hereto.

The parties appearing, represented as indicated above, have asked the officiating notary to register the following joint

merger proposal:

The management of the Absorbing Company and the management of the Absorbed Company have drawn up, in ac-

cordance with articles 261 et seq. of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), the
following merger proposal (the “Joint Merger Proposal”):

It is proposed that the Absorbed Company merge by absorption with the Absorbing Company (together the “Merging

Companies”) via a transfer of all the Absorbed Company's assets and liabilities, following its dissolution without liquidation,
to the Absorbing Company in accordance with articles 278 et seq. of the Law (the “Merger”).

This Joint Merger Proposal shall be published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg

at least one month before the completion of the Merger.

146540

L

U X E M B O U R G

1. Form, name and registered offices of the merging companies.
- Absorbing Company: ERGAN INTERNATIONAL S.à r.l.
A société à responsabilité limitée (limited liability company) under Luxembourg law with capital of thirty millions one

hundred ninety-seven thousand euro (EUR 30'197'000), represented by three hundred one thousand nine hundred seventy
(301'970) shares of one hundred euro (EUR 100) each, registered in the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 188882, having its registered office at 45 rue des Scillas, L-2529 Howald.

- Absorbed Company: ERGAN S.à r.l.
A Luxembourg société à responsabilité limitée (limited liability company) with capital of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12'500), represented by twelve thousand five hundred (12'500) shares of one euro (EUR 1) each, registered in
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153057, having its registered office at 45 rue des Scillas,
L-2529 Howald.

2. Exchange Ratio - Cash Balance. Provided that at the time of the merger the Absorbing Company owns one hundred

per cent (100%) of the shares of the Absorbed Company, the tax relief provided for in article 278 of the Law shall apply.
In this case the absorption shall not entail a new share issuance or payment of a balance.

3. Assets and Liabilities contributed. As a result of the Merger, the Absorbed Company, following its dissolution without

liquidation, shall transfer all of its assets and liabilities to the Absorbing Company.

4. Effective date of the Merger. The Merger shall take effect between the parties when the concordant decisions of the

general meetings of the Absorbed Company and the Absorbing Company approving the merger have been taken (the
“Effective Date”), which is scheduled to occur between four and eight weeks after the publication of this Joint Merger
Proposal.

The Merger proposed is subject to the condition precedent that, prior to the Effective Date, the Absorbing Company has

acquired all the shares in the Absorbed Company and has thus become the sole shareholder of the Absorbed Company.

As regards third parties, the Merger shall become effective only after the minutes of these meetings have been published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The operations of the Absorbed Company shall be considered from an accounting point of view as being performed on

behalf of the Absorbing Company with effect from 1 October 2015.

5. Rights of shareholders enjoying special rights and the holders of securities other than shares. The Merging Companies

have not issued shares with special rights or securities other than shares.

6. Particular benefits awarded to members of the managing bodies, to the auditors of the merging companies and to the

expert within the meaning of article 266 of the Law. No particular benefits shall be awarded to members of the management
and supervisory bodies of the merging companies. The intervention of an expert within the meaning of article 266 of the
law is not required in the case a simplified merger, in application of articles 278 et seq. of the Law.

9. Documentation. Any shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Company may consult the following

documents at their respective registered offices:

- the Joint Merger Proposal;
- the annual financial statements and management reports for the last three financial years as well as an accounting

statement as at 30 September 2015, for the Absorbed Company;

- the annual financial statements and management reports for the last three financial years as well as an accounting

statement as at 30 September 2015, for the Absorbing Company.

A full or partial copy of the documents will be issued to any shareholder on request, for no charge.
After the effective date, all the corporate documents, records and minutes of the Absorbed Company shall be kept at the

registered office of the Absorbing Company for the period stipulated by the Law.

10. Dissolution of the Absorbed Company. The Merger shall automatically entail the closure of the Absorbed Company.
The undersigned notary certifies the existence and legality of the Joint Merger Proposal and of all the instruments,

documents, and formalities that are binding upon the Merging Companies in accordance with article 271 (2) of the Law.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person acting through its attorney, the present deed is worded in French followed by a English translation and that in case
of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

In witness whereof, done and executed in Howald on the date indicated in the header hereof.
After this instrument was read and explained to the representative of the appearing parties, she signed it, together with

the notary.

Signé: Laure SINESI, Jean SECKLER.

146541

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 octobre 2015. Relation GAC/2015/9195. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015178305/187.
(150198709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Guidance Immobilière s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 196, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 201.159.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le vingt-deux octobre,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

Ont comparu:

Monsieur Francis WEYDERS, managing director, né à Pétange, le 05 septembre 1960, demeurant à L-8371 Hobscheid,

10, rue de Koerich,

Et
Madame Corinne CARRARO, corporate manager, née à Villerupt, France, le 03 novembre 1960, demeurant à L-8371

Hobscheid, 10, rue de Koerich.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu’ils constituent entre

eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «GUIDANCE

IMMOBILIERE s.à r.l.»

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Strassen.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand- Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière ainsi que l'étude et la promotion de toutes réali-

sations  immobilières,  plus  spécialement  l'achat,  la  vente,  l'échange  d'immeubles  bâtis  et  non  bâtis,  la  transformation,
l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la prise à
bail, la location de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l'administration ou l'ex-
ploitation de tous immeubles, ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

Elle pourra emprunter, avec ou sans affectation hypothécaire, gager ses biens ou se porter caution au profit d’autres

entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération est de nature à favoriser son développement.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu’elle ne soit spécialement réglementée.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (Eur 50.000,-) divisé en deux cents (200) parts sociales d’une

valeur nominale de deux cent cinquante Euros (€ 250,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif

net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de

mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée
sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien

déterminées pourront faire l’objet d’un contrat d’association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents

statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu’il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d’effet vis-à-

vis des tiers qu’après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

146542

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur

les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir
leurs droits, ils devront se rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l’Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de
leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les

pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal

jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ mille trois cents
Euros (Eur 1.300,-).

Le notaire instrumentant attire l’attention des comparants qu'avant toute activité commerciale de la société présentement

fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

Les comparants reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives

à l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération et

déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées à l’article 506-1
du code pénal luxembourgeois.

<i>Souscription

Les 200 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire

qui le constate expressément, et toutes souscrites comme suit:

Monsieur Francis WEYDERS, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 parts sociales
Madame Corinne CARRARO, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts sociales

TOTAL: deux cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 parts sociales

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil seize.

<i>Assemblée générale

Les fondateurs prénommés, détenant l’intégralité des parts sociales, se sont constitués en Assemblée Générale et ont

pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à L-8010 Strassen, 196, route d’Arlon.

146543

L

U X E M B O U R G

2) La société sera gérée par un gérant, savoir:
Monsieur Francis WEYDERS, managing director, né à Pétange, le 05 septembre 1960, demeurant à L-8371 Hobscheid,

10, rue de Koerich, nommé pour une durée indéterminée.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte, après s’être

identifiés au moyen d’une copie de leurs cartes d’identité.

Signé: F. WEYDERS, C. CARRARO, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/33774. Reçu soixante-quinze euros.

75,-€

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 3 novembre 2015.

Référence de publication: 2015179111/113.
(150199803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Kisifrott S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 108.019.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2015156820/10.
(150172991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

King's Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 181.932.

Les comptes annuels au 14 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015156817/9.
(150172140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Lennon J1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 187.281.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015156833/10.
(150173011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Advanced Communication Technologies Consulting, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3871 Schifflange, 13, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 164.382.

Les comptes annuels au 12/03/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015155896/9.
(150171672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

146544


Document Outline

2 boulevard Konrad Adenauer S.à r.l.

ACMBernstein SICAV

Advanced Communication Technologies Consulting

AIH-IP (Luxembourg) S.à.r.l.

amandea

ARC Global II DB Lux S.à.r.l.

Carmel Capital VI S.à r.l.

Cellyant Global SICAV-SIF

Cemex Global Funding S.à r.l.

ComStage

Edelveys Group S.à r.l.

Ergan International SARL

Ergan S.à r.l.

Groupe Figueira S.à.r.l.

Guidance Immobilière s.à r.l.

HA Invest S.A.

Herald, the Henderson European Retail Property Fund

Investprojet Sàrl

IV Capital S.à r.l.

Jack RIBEIRO S.A.

Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l.

JPMorgan Funds

Juler Holding S.à r.l.

King's Group S.A.

Kisifrott S.A.

KPI Residential Property 14 S.à r.l.

Lennon J1 Sàrl

Leudelange S.A.

Maestro SICAV (Lux)

Market Access II

McLaren S.A.

MI-FONDS (Lux)

MUGC/WA Asian USD Bond Fund

MUGC/WA U.S. High Yield Credit Fund

MWD - Marc Weiler Design S.à r.l.

Oerlikon Balzers Coating Luxembourg, S.à r.l.

Office Portfolio Minerva I Sàrl

Offset Moselle S.à r.l.

Paddock S.A.

PALLINGHURST INVESTOR CONSORTIUM II (Lux) S.à r.l.

PAN European Value Added Venture Feeder S.C.A.

Pan European Value Added Venture German Feeder S.C.A.

Parc Belair S.à r.l.

Participations A &amp; F S.A.

Partners Group Search S.A.

Partners of Excellence S.à r.l.

PEH Sicav

Pharma Investors S.A.

PineBridge S.à r.l.

Place Ovale Holding S.A.

Plumeau S.A.

Prima Private Equity S.A.

Prodilux Diffusion s.à r.l.

Property Leasing S.à r.l.

Quoniam Funds Selection SICAV

SOP I SICAV