This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3009
4 novembre 2015
SOMMAIRE
Abbey Barn Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
144402
ABF Preston Park S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
144408
Association Luxembourgeoise des Parents
d'Elèves de l'Education Differenciée . . . . . . .
144399
Athalia VI B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144414
Axelline S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144432
Axelline S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144432
Digital Services XXIV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
144422
K Alpha S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144399
Ken-Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144420
Lesing Fabfab S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144386
Margaux Immobilière S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
144402
McKesson Information Solutions Capital S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144386
McKesson Information Solutions Finance S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144398
Mill Luxembourg Holdings 1 . . . . . . . . . . . . . .
144398
Mill Luxembourg Holdings 2 . . . . . . . . . . . . . .
144402
Mobilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144432
Mobilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144432
MOSSACK FONSECA & Co. (Luxembourg)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144408
MOSSFON (Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . .
144411
Mousel's Cantine S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
144432
MT Projet Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144411
Naet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144420
Naropère S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144412
Naturmat S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144420
Navarre Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144422
NB Renaissance Partners MHF S.à r.l. . . . . . .
144429
Nemset S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144413
Nestor Lux 2007 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144422
NetJets Luxembourg Holding Company S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144412
Network Technology & Communication Ex-
pertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144432
Nordim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144422
Opti-Style Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144428
Organic Food & More, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
144428
Orion Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144429
Palenque S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144430
Panthelux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144430
Plastic Logic Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
144431
Prater S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144431
Prestige Motor Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
144431
Propharma-Developpement S.à r.l. . . . . . . . . .
144431
Rodenbach S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144430
Saint Amand GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144412
144385
L
U X E M B O U R G
McKesson Information Solutions Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 85.933.
Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015154502/10.
(150169954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Lesing Fabfab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 136.000,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 200.044.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fist of August.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Lesing Eastbrook Limited -, a non-cellular company within the meaning of section 2 (1) (c) of the Companies (Guernsey)
Law 2008, incorporated under the laws of Guernsey, with registered office at Sarnia House, Le Truchot, St Peter Port,
Guernsey GY1 4NA, being registered with the Guernsey Company Registry under number 53510,
here represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg 74, Ave-
nue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal on August 20
th
, 2015.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”):
1. Form - Corporate name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of "LESING FABFAB
S.à r.l." (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from
time to time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the Shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including
Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects.
3.1 The Company's object is to directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Luxem-
bourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or participations;
144386
L
U X E M B O U R G
3.2 The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature.
3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means;
3.4 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations
in subsidiaries of the Company owning such investments;
3.5 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect Shareholder of the
Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Compa-
nies") or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it
to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector;
3.6 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not
enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:
3.6.1 - to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;
3.6.2 - to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
3.6.3 - to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of
and in accordance with the provisions of Luxembourg Law.
3.7 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,
all transactions which are necessary to fulfill its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The issued share capital of the Company is set at one hundred thirty-six thousand euro (EUR 136,000) represented
by ten thousand (10,000) shares divided into:
one thousand (1,000) Class A Shares,
one thousand (1,000) Class B Shares,
one thousand (1,000) Class C Shares,
one thousand (1,000) Class D Shares,
one thousand (1,000) Class E Shares,
one thousand (1,000) Class F Shares,
one thousand (1,000) Class G Shares,
one thousand (1,000) Class H Shares,
one thousand (1,000) Class I Shares, and
one thousand (1,000) Class J Shares
each such "Share" with a nominal value of thirteen euro and sixty cent (EUR 13.60) and with such rights and obligations
as set out in the present Articles.
5.2 The capital of the Company may be increased or reduced by a Shareholders' Resolution adopted in the manner
required for amendment of these Articles.
5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation
of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class(es).
In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares, such cancellations and repurchases of Shares shall be
made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).
5.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the
order provided for in Article 5.3), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general
meeting of Shareholders (the "Shareholders' Meeting")) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class
of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the
relevant Class held by them and cancelled.
5.5 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will
become due and payable by the Company.
144387
L
U X E M B O U R G
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that repre-
sentative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other
payment rights.
7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders
holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer at a Shareholders' Meeting;
7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by
article 189 of the 1915 Law;
7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.
8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil
de gérance (the "Board of Managers").
8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with
Luxembourg Law and these Articles.
9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10. Representation and signature power.
10.1 Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or represented towards
third parties by:
10.1.1 if the Company has a Sole Manager, the sole signature of the Sole Manager;
10.1.2 if the Company has more than one Manager, the sole signature of any Manager;
10.1.3 the sole or joint signature(s) of any person(s) to whom such power has been delegated in accordance with Article
11.
11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, any Manager may delegate
any of its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent’s powers and respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.
12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers
shall appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.
12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's
Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or
participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or
represented, among which must be at least one Luxembourg resident Manager. Decisions of the Board of Managers shall
be adopted by a simple majority.
12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons partici-
pating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way
is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to
144388
L
U X E M B O U R G
Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed
to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of Managers (or
their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.
12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)
shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.
12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Manager present at the Board Meeting.
13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution
may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office outside the boundaries of the same municipality), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a
majority in number of the Shareholders representing three quarters of the Shares.
13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company needs to be passed
by the Shareholders' Meeting at the majority required for the amendment of these Articles.
13.6 A Shareholders' Meeting may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening
requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either
in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.
13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
13.8 a) If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed
by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the precise
wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted.
b) The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis mutandis
to the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall be validly passed imme-
diately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments)
of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8. a) and the above provisions of this Article
13.8 b), irrespective of whether all Shareholders have voted or not.
14. Business year and annual accounts. The Company’s financial year starts on 1
st
January and ends on the 31
st
December of each year.
15. Distributions on shares.
15.1 From the annual net profits of the Company, five per cent. (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
share capital of the Company, as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5 above, but
shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth (1/10).
15.2 The balance may be distributed to the Shareholders upon decision of a Shareholders' Meeting in accordance with
the provisions set forth hereafter.
15.3 The Shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared
by the Sole Manager, or as the case may be the Board of Managers, showing that sufficient funds are available for distri-
bution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last
accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and
sums to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.
15.4 The share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a Shareholders' Meeting in
accordance with the provisions set forth hereafter. The Shareholders' Meeting may decide to allocate any amount out of
the share premium account to the legal reserve account.
15.5 The dividends declared may be paid in any currency selected by the Sole Manager or as the case may be the Board
of Managers and may be paid at such places and times as may be determined by the Sole Manager or as the case may be
the Board of Managers The Sole Manager or as the case may be the Board of Managers may make a final determination
of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but
not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, but shall be forfeited by the
144389
L
U X E M B O U R G
holder of such Share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which
are held by the Company on behalf of holders of Shares.
15.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) each Class A Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty per
cent (0.60%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(ii) each Class B Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty-five
per cent (0.55%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(iii) each Class C Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty per
cent (0.50%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(iv) each Class D Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty-five
per cent (0.45%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(v) each Class E Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty per
cent (0.40%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(vi) each Class F Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty-five
per cent (0.35%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(vii) each Class G Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty
per cent (0.30%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(viii) each Class H Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty-
five per cent (0.25%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(ix) each Class I Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty per
cent (0.20%) per annum of the nominal value of such Share; and
(x) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the
reverse alphabetical order (i.e. first Class J Shares, then if no Class J Shares are in existence, Class I Shares and in such
continuation until only class A Shares are in existence).
16. Dissolution and liquidation.
16.1 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' Meeting in accordance with Luxembourg
Law and Article 13.5. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve to
liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.
16.2 After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set in Article 15 for dividend distributions.
17. Interpretation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications)
thereof.
17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general
words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular
class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;
17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 Definitions:
Available Amount
Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward
profits) to the extent the Shareholder would have been entitled to dividend
distributions according to Article 15, increased by (i) any freely distributable reserves
and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal
reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any
losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s)
pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the
relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting)
so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR)
Whereby:
144390
L
U X E M B O U R G
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to
the Class of Shares to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of
Luxembourg Law or of the Articles
In case the Company would realize additional profit (e.g. an earn-out payment) after
the repurchase and cancellation of one Class of Shares (the "Repurchase"), further to
an operation which was realized prior to the Repurchase, then the Available Amount
computed at the occasion of the Repurchase will take into account such additional
profit.
Cancellation Value Per Share
Means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the
number of shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.
Interim Accounts
Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date
Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the Repurchase of the
relevant Class of Shares.
Shareholders
Means the Shareholders of the Company.
Total Cancellation Amount
Means an amount determined by the Sole Manager or as the case may be the Board
of Managers, and approved by the Shareholders' Meeting on the basis of the relevant
Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G,
F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time
of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the Shareholders'
Meeting in the manner provided for an amendment of the Articles provided however
that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.
17.3 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year begins on the date of incorporation and ends on 31
st
of December 2015
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Lesing Eastbrook Limited, prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to
the whole share capital of the Company and to have fully paid up all ten thousand (10,000) shares with a nominal value of
thirteen euro and sixty cent (EUR 13.60) each, by contribution in cash, so that the sum of one hundred thirty-six thousand
euro (EUR 136,000) corresponding to a share capital of one hundred thirty-six thousand euro (EUR 136,000) is forthwith
at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand eight hundred Euro (EUR
1,800.-).
<i>Extraordinary shareholder's resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, representing the entirety of the subscribed
share capital and exercising the powers devolved to the shareholders' meeting, passed, through its proxyholder, the fol-
lowing resolutions:
1) The following persons are appointed as Managers of the Company for an undetermined period and with immediate
effect:
- Mr. Bakary Sylla, born November 1
st
, 1976, in Monrovia (Republic of Liberia), with business address at 55, Avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- Mr. Robert Kimmels, born March 4
th
, 1969, in Breukelen (Netherlands), with business address at 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg.
2) The Company shall have its registered office at 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
144391
L
U X E M B O U R G
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with the notary the present
deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahr zweitausendfünfzehn, am einundzwanzigsten Tag des Monats August.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Lesing Eastbrook Limited, eine Zellfirma (Zellgesellschaft) innerhalb der Bedeutung des section 2 (1) (c) of the Com-
panies (Guernsey) Law 2008, vereinigt nach den Gesetzen Guernseys, mit eingetragenem Sitz in Sarnia House, Le Truchot,
St Peter Port, Guernsey GY1 4NA, eingetragen beim Guernsey Company Registry unter der Nummer 53510,
vertreten durch, Herrn Liridon ELSHANI, Privatangestellter, mit beruflicher Anschrift in L-1750 Luxemburg, 74, Ave-
nue Victor Hugo, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 20. August 2015
Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung „ne varietur“ durch die erschienene Partei und den beurkundenden
Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.
Die Erschienene, vertreten wie oben erwähnt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée) wie folgt zu beurkunden:
1. Form und Name. Dieses Dokument stellt die Satzung (die "Satzung") der "LESING FABFAB S.à r.l." (die "Gesell-
schaft") dar, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche nach den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg einschließlich des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert
(das "Gesetz von 1915"), gegründet wurde.
2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft (der "Gesellschaftssitz") ist in der Stadt Luxemburg Großherzogtum Luxemburg.
2.2 Der Gesellschaftssitz kann verlegt werden:
2.2.1 innerhalb derselben Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg durch:
(a) Beschluss des Alleingeschäftsführers (wie in Artikel 8.2 beschrieben) wenn die Gesellschaft nur einen Alleinge-
schäftsführer hat; oder
(b) Beschluss des Rates der Geschäftsführer der Gesellschaft (wie in Artikel 8.3 beschrieben), soweit die Gesellschaft
einen Rat der Geschäftsführer besitzt; oder
2.2.2 an jeden Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg (entweder innerhalb derselben Gemeinde oder nicht)
durch Beschluss der Gesellschafterversammlung (der "Beschluss der Gesellschafterversammlung"), gemäß der vorliegen-
den Satzung - einschließlich des Artikels 13.4 - und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg einschließlich des
Gesetzes von 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das "Luxemburger Recht").
2.3 Sollte eine Situation eintreten oder als voraussehbar betrachtet werden, die die normale Geschäftstätigkeit am Ge-
sellschaftssitz oder den ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland durch außergewöhn-
liche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder sonstiger Art gefährdet werden, so kann
der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden;
diese Maßnahmen betreffen jedoch in keiner Weise die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche ungeachtet der vo-
rübergehenden Sitzverlegung, eine Luxemburger Gesellschaft bleibt. Der Beschluss über die vorübergehende Sitzverle-
gung der Gesellschaft wird durch den Alleingeschäftsführer oder, im Fall von mehreren Geschäftsführern, durch den Rat
der Geschäftsführer der Gesellschaft getroffen.
2.4 Geschäftsstellen oder andere Zweigniederlassungen können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im
Ausland eröffnet werden.
3. Zweck.
3.1 Zweck der Gesellschaft ist es, auf jede Art und Weise, Anteile und Beteiligungen in Luxemburger oder fremden
Unternehmen direkt oder indirekt zu erwerben, zu halten oder über diese zu verfügen und das Halten von diesen Anteilen
und Beteiligungen zu verwalten, zu entwickeln und zu managen;
3.2 Die Gesellschaft kann weiter in den Erwerb und die Verwaltung eines Portfolios von Patenten oder anderen Rechten
and geistigem Eigentum jeglicher Art zu investieren;
3.3 Die Gesellschaft kann ebenso auf jede Art und Weise direkt oder indirekt in jegliche Art von Vermögenswerten
investieren, diese erwerben, halten oder über sie verfügen;
3.4 Die Gesellschaft kann immobilienbezogene Anlagen tätigen entweder durch direkte oder indirekte Beteiligungen
in Tochtergesellschaften der Gesellschaft, welche solche Anlagen besitzen;
3.5 Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften oder Gesellschaften an welchen sie eine direkte oder indirekte
Beteiligung hält oder jeder Gesellschaft, die ein direkter oder indirekter Anteilsinhaber der Gesellschaft ist oder jeder
Gesellschaft, die zur selben Gruppe wie die Gesellschaft gehört (im Folgenden als die "Verbundenen Gesellschaften") oder
jeder anderen juristischen Person jegliche Unterstützung zukommen lassen, sei es durch Darlehen, Garantien oder auf
144392
L
U X E M B O U R G
andere Weise, wobei davon ausgegangen wird, dass die Gesellschaft keine Transaktion ohne entsprechende Erlaubnis nach
Luxemburger Recht tätigt, welche eine reglementierte Tätigkeit des Finanzsektors darstellen würde;
3.6 Die Gesellschaft kann insbesondere die folgenden Transaktionen durchführen, wobei davon ausgegangen wird, dass
die Gesellschaft keine Transaktion ohne entsprechende Erlaubnis nach Luxemburger Recht tätigt, welche eine reglemen-
tierte Tätigkeit des Finanzsektors darstellen würde;
3.6.1 Kredite in jeglicher Form aufnehmen und sonstige Kreditfazilitäten nutzen oder Gelder aufbringen, durch ein-
schließlich, aber nicht ausschließlich, die Ausgabe, stets auf privater Basis, von Anleihen, Schuldscheinen, Wechseln und
anderen konvertierbaren oder nicht konvertierbaren Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten, den Gebrauch von Fi-
nanzderivaten oder sonstigem;
3.6.2 Geld und Vermögensmittel der Gesellschaft vorstrecken, verleihen oder anlegen oder Kredite gewähren oder einen
Schuldtitel, der von einer Luxemburger oder einer fremden juristischen Person ausgegeben wurde, zu Bedingungen, die
als angemessen erachtet werden, zeichnen oder kaufen, mit oder ohne Stellung von Sicherheiten;
3.6.3 Garantien geben, Bürgschaften übernehmen oder andere Formen von Sicherheiten einräumen, entweder durch
persönliche Zusage oder durch Hypothek oder Belastung über die Gesamtheit oder einen Teil der Unternehmung, der
Vermögenswerte (gegenwärtige und zukünftige) oder auf andere Weise, die die Einhaltung von Verträgen oder Verpflich-
tungen der Gesellschaft und der Verbundenen Gesellschaften, im Rahmen und im Einklang mit den Vorschriften des
Luxemburger Rechts.
3.7 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, kommerziellen, technischen und finanziellen Investitionen und Operationen
und im generellen alle Transaktionen durchführen, welche nötig sind, um den Gesellschaftszweck zu erfüllen sowie alle
Operationen ausführen, welche direkt oder indirekt für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks in allen Bereichen wie oben
beschrieben als zuträglich erachtet werden.
4. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Zeitdauer errichtet.
5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Kapital wird auf einhundertsechsunddreissigtausend Euro (EUR 136,000-) festgelegt und in zehntausend
(10,000.-) Anteile zu jeweils dreizehn Euro und sechzig Cent (EUR 13.60.-) unterteilt, die wie folgt aufgeteilt werden:
- eintausend (1,000) Klasse A Anteile, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt;
- eintausend (1,000) Klasse B Anteile, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt;
- eintausend (1,000) Klasse C Anteile, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt;
- eintausend (1,000) Klasse D Anteile, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt;
- eintausend (1,000) Klasse E Anteile, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt;
- eintausend (1,000) Klasse F Anteile, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt;
- eintausend (1,000) Klasse G Anteile, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt;
- eintausend (1,000) Klasse H Anteile, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt;
- eintausend (1,000) Klasse I Anteile, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt;
- eintausend (1,000) Klasse J Anteile, alle gezeichnet und vollständig eingezahlt;
5.2 Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung in der Art und
Weise erhöht oder herabgesetzt werden
5.3 Das Grundkapital der Gesellschaft kann durch den Rückkauf und die Annullierung einer oder mehrerer gesamten
Anteilsklassen jedoch mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft zu keinem Zeitpunkt die Anteile der Klasse A zu stornieren
reduziert werden. Im Falle der Rückkauf oder die Annullierung von Anteilsklassen Diesen Rücknahmen oder Annullie-
rungen von Anteilen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge vorgenommen werden (beginnend mit der Klasse J).
5.4 Im Falle einer Herabsetzung des Grundkapitals durch den Rückkauf und die Annullierung einer Anteilsklasse (in
der in Artikel 5.3 vorgesehenen Reihenfolge), diese Anteilsklasse verleiht rechten an die Inhaber davon im Verhältnis ihrer
Beteiligung an solchen Klasse der verfügbare Betrag (mit der Einschränkung, jedoch auf den Gesamtabrechnungsbetrag
wie von der Hauptversammlung der Anteilinhaber (die "Hauptversammlung") festgelegt) und die Inhaber von Anteilen
des zurückgekauft und entwertet Anteilsklasse wird von der Gesellschaft einen Betrag gleich der Stornowert pro Anteil
für jeden Anteil der betreffenden Klasse von ihnen gehaltenen und entwertet.
Nach dem Rückkauf und die Annullierung von Anteilen der jeweiligen Klasse, wird der Stornowert je Aktie fällig und
von der Gesellschaft zahlbar werden.
6. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.
6.1 Jeder Gesellschaftsanteil ist unteilbar.
6.2 Ein Gesellschaftsanteil kann im Namen von mehr als einer Person registriert werden, sofern alle Inhaber eines
Gesellschaftsanteils der Gesellschaft schriftlich mitteilen, welcher von ihnen als ihr Vertreter angesehen werden soll; die
Gesellschaft wird diesen Vertreter so behandeln, als sei er der alleinige Gesellschafter bezüglich dieses Gesellschaftsanteils,
einschließlich hinsichtlich Abstimmungen, Dividenden und anderen Zahlungsrechten
144393
L
U X E M B O U R G
7. Übertragung der Gesellschaftsanteile.
7.1 Falls die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar.
7.2 Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern:
7.2.1 Gesellschaftsanteile dürfen lediglich von Todes wegen auf Drittpersonen übertragen werden, es sei denn, Gesell-
schafter mit mehr als drei Viertel der Gesellschaftsanteile haben der Übertragung im Wege einer Gesellschafterversamm-
lung zugestimmt.
7.2.2 Gesellschaftsanteile dürfen von Todes wegen nicht auf Drittpersonen übertragen werden, die keine Gesellschafter
sind, es sei denn, dass entweder diejenigen Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel der Gesellschaftsanteile der Über-
lebenden halten, der Übertragung zugestimmt haben, oder dass gemäß den Bestimmungen des Artikels 189 des Gesetzes
von 1915 gehandelt wird.
7.2.3 Die Übertragung der Gesellschaftsanteile unterliegt den Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes von
1915.
8. Geschäftsführung.
8.1 Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern ("Geschäftsführer"), die durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung gemäß Luxemburger Recht und den Bestimmungen dieser Satzung bestellt werden.
8.2 Für den Fall, dass die Gesellschaft nur über einen Geschäftsführer verfügt, wird dieser als "Alleingeschäftsführer"
bezeichnet.
8.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, bilden die Geschäftsführer den Rat der
Geschäftsführer oder conseil de gérance (der "Rat der Geschäftsführer").
8.4 Ein Geschäftsführer kann jederzeit aus jedem Grund durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung gemäß
dem Luxemburger Recht und den Bestimmungen dieser Satzung abberufen werden.
9. Befugnisse der Geschäftsführer. Der Alleingeschäftsführer, wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat oder,
im Fall von mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer, kann alle Rechtsgeschäfte und Tätigkeiten vornehmen,
die wichtig oder nötig sind, um den Gesellschaftszweck zu erreichen, mit Ausnahme der Befugnisse, die ausdrücklich durch
das Luxemburger Recht oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
10. Rechtmässige Vertretung.
10.1 Gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts und der vorliegenden Satzung, sind folgende Personen befugt,
die Gesellschaft nach außen wirksam zu vertreten:
10.1.1 Wenn die Gesellschaft einen Alleingeschäftsführer hat, durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers;
10.1.2 Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, durch die Unterschrift eines jeden Geschäftsführers;
10.1.3 Durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift von Personen, die gemäß Artikel 11 die Vertretungsbefugnis
übertragen bekommen hat.,
11. Bevollmächtigter des Alleingeschäftsführers Oder des Rates der Geschäftsführer. Der Alleingeschäftsführer oder,
im Fall von mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer, kann einem zu diesem Zweck berufenen Vertreter
für spezifische Aufgaben Untervollmacht erteilen und bestimmt den Verantwortungsbereich und (gegebenenfalls) die Be-
zahlung, die Dauer und alle anderen wesentlichen Bedingungen der Vertretung.
12. Geschäftsführerversammlung.
12.1 Jeder Geschäftsführer kann die Versammlung des Rates der Geschäftsführer ("Geschäftsführerversammlung")
einberufen. Der Rat der Geschäftsführer wählt einen Vorsitzenden.
12.2 Der Rat der Geschäftsführer kann während einer Geschäftsführerversammlung wirksam beraten und ohne vorherige
Einberufungserfordernisse oder Einberufungsformalitäten Beschlüsse fassen, wenn alle Geschäftsführer schriftlich oder
während der entsprechenden Geschäftsführerversammlung, persönlich oder durch einen ermächtigten Vertreter auf die
Einberufungserfordernisse oder Einberufungsformalitäten verzichtet haben.
12.3 Jeder Geschäftsführer kann sich durch einen anderen Geschäftsführer (nicht aber irgendeine andere Person) auf
einer Geschäftsführerversammlung vertreten lassen (der "Vertreter eines Geschäftsführers") um in seinem Namen an dieser
Sitzung teilzunehmen, zu verhandeln, abzustimmen und all seine Funktionen auszuüben. Ein Geschäftsführer kann als
Vertreter für mehrere Geschäftsführer auf einer Geschäftsführerversammlung auftreten, unter der Voraussetzung (ohne
Beeinträchtigungen auf die Anwesenheitsbedingungen), dass mindestens zwei Geschäftsführer physisch auf der Ge-
schäftsführerversammlung anwesend sind oder in persona unter der Voraussetzungen des Artikels 12.5 an der Versamm-
lung teilnehmen.
12.4 Der Rat der Geschäftsführer kann nur wirksam beraten und Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Mehrheit der
Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist,darunter muss mindestens eine in Luxemburg an säsisge Manager sein. Die
Entscheidungen des Rates der Geschäftsführer werden durch [einfache Mehrheit] getroffen.
12.5 Ein Geschäftsführer oder der Vertreter eines Geschäftsführers kann wirksam an einer Geschäftsführerversammlung
via Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausge-
setzt, dass alle teilnehmenden Personen während der gesamten Sitzung in der Lage sind, sich gegenseitig zu hören und zu
144394
L
U X E M B O U R G
sprechen. Eine in dieser Weise teilnehmende Person gilt als persönlich in der Sitzung anwesend, wird im Quorum mitgezählt
und kann ihre Stimme abgeben. Gemäß Luxemburger Recht, gelten alle auf diese Art und Weise von den Geschäftsführern
getätigten Geschäfte, zum Zwecke der vorliegenden Satzung als zulässig und wirksam in der Geschäftsführerversammlung
getätigt, ungeachtet der Tatsache, dass weniger als die für eine Abstimmung vorausgesetzte Zahl der Geschäftsführer (oder
deren Vertreter) physisch an einem Ort anwesend sind.
12.6 Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern (oder in Bezug auf einen Geschäftsführer, dem Vertreter
des Geschäftsführers) unterzeichnet wurde, ist ordnungsgemäß und rechtskräftig, wenn er in einer ordnungsgemäß einbe-
rufenen und abgehaltenen Geschäftsführerversammlung beschlossen wurde und er kann aus einem einzigen Dokument
oder verschiedenen, den gleichen Inhalt enthaltenden Dokumenten bestehen, die von oder im Namen eines oder allen
betreffenden Mitgliedern des Rates der Geschäftsführer unterschrieben wurden.
12.7 Jeder in der Geschäftsführerversammlung anwesende Geschäftsführer kann die Sitzungsprotokolle der Geschäfts-
führerversammlung unterschreiben und die Auszüge der Sitzungsprotokolle zertifizieren.
13. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat eine Stimme für jeden Gesellschaftsanteil, den er hält.
13.2 Gemäß Artikel 13.3, 13.4 und 13.5, sind Beschlüsse der Versammlung der Gesellschafter nur dann wirksam an-
genommen, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mehr als die Hälfte der Gesellschaftsanteile halten;
sofern diese Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung oder der ersten schriftlichen Konsultation nicht erreicht
ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal mittels Einschreiben einberufen oder konsultiert, und dieser Beschluss
benötigt unabhängig von der Anzahl der repräsentierten Gesellschaftsanteile die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
13.3 Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder die Verpflichtung der Gesellschafter ihre Beteiligung an der
Gesellschaft zu erhöhen, bedürfen der Einstimmigkeit der Gesellschafter.
13.4 Gemäß Artikel 13.3, können Beschlüsse von Satzungsänderungen (einschließlich der Verlegung des Gesellschafts-
sitzes, außerhalb der grenzen derselben Gemeinde), vorbehaltlich etwaiger gegenteiliger Regelungen, nur durch eine
Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel der Gesellschaftsanteile halten, beschlossen werden.
13.5 Beschlüsse bezüglich der Auflösung der Gesellschaft, oder der Festlegung einer Liquidationsmethode der Gesell-
schaft, muss von der Gesellschafterversammlung am für die Änderung dieser Satzung erforderlichen en Mehrheit gefasst
werden.
13.6 Eine Gesellschafterversammlung kann ohne vorherige Einberufungserfordernisse oder Einberufungsformalitäten
abgehalten werden, wenn alle Gesellschafter persönlich oder deren Vertretungsberechtigte schriftlich auf die entsprech-
enden Einberufungserfordernisse oder Einberufungsformalitäten auf dem Schriftwege oder persönlich bzw. durch den
Vertretungsberechtigten auf der entsprechenden Gesellschafterversammlung, verzichtet haben.
13.7 Ein Gesellschafter kann sich auf einer Gesellschafterversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax, E-Mail
oder ähnlichem Kommunikationsmittel) bestellten Stellvertreter oder Bevollmächtigten, der selbst kein Gesellschafter sein
muss, vertreten lassen.
13.8 a) Sofern die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, kann ein Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung durch schriftliche Abstimmung der Gesellschafter anstelle im Wege einer Gesellschafterversammlung
erfolgen, vorausgesetzt, ein jeder Gesellschafter hat den genauen Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse oder Entschei-
dungen erhalten
b) Die Mehrheitsanforderungen für die Beschlussfassung durch eine Gesellschafterversammlung sind mutatis mutandis
auf die Durchführung von schriftlichen Beschlüssen der Gesellschafter anzuwenden. Schriftliche Beschlüsse der Gesell-
schafter sind in dem Moment unmittelbar wirksam gefasst, in dem der Gesellschaft Originalkopien (oder Kopien, die per
Faxübertragung oder als E-Mail Anhang gesendet wurden) der Gesellschafterstimmen gemäß den Regelungen in Artikel
13.8 a) und den obigen Voraussetzungen von dieses Artikel 13.8 b) zugehen, unabhängig davon, ob alle Gesellschafter
abgestimmt haben oder nicht.
14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. De-
zember eines jeden Jahres.
15. Ausschüttungen.
15.1 Vom Jahresüberschuss der Gesellschaft sollen 5 Prozent (5 %), wie vom Gesetz verlangt, in die Rücklagen ein-
gestellt werden. Solche Einstellungen sind nicht mehr erforderlich, sobald diese gesetzlichen Rücklagen sich auf zehn
Prozent (10 %) des gezeichneten Grundkapitals der Gesellschaft, wie es gemäß obigem Artikel 5 festgestellt oder jeweils
erhöht oder vermindert worden ist, belaufen; sie werden aber für den Fall wieder zwingend erforderlich, dass die Rücklagen
unter dieses eine Zehntel (1/10) absinken.
15.2 Die Waage kann an die Gesellschafter durch Beschluss der Gesellschafterversammlung gemäß den nachstehenden
Bestimmungen verteilt werden.
15.3 Die Gesellschafter können sich entscheiden, zu erklären und auszuzahlen Zwischendividenden auf der Grundlage
der Rechnungsabschlüsse von der Alleingeschäftsführer bereit, oder wie der Fall kann der Geschäftsführerversammlung
zu sein, zeigt, dass ausreichende Mittel für die Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei gilt, dass die Höhe verteilt
möglicherweise nicht Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht um Gewinnvorträge und ausschüttbaren
144395
L
U X E M B O U R G
Reserven realisiert, sondern auf ein Schutzgebiet von Verlustvorträgen und Beträge verringert, die zugeteilt werden, über-
steigt den durch Gesetz festgelegt werden, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen eingestellt her Jenseits.
15.4 Das Kapitalrücklage kann an die Gesellschafter durch Beschluss der Gesellschafterversammlung gemäß den nach-
stehenden Bestimmungen verteilt werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jede Menge aus der Kapi-
talrücklage in die gesetzliche Rückkonto zuordnen.
15.5 Die deklarierten Dividenden können in jeder Währung durch den Alleingeschäftsführer oder wie der Fall ausge-
wählt gezahlt werden, können der Geschäftsführerversammlung sein und kann an solchen Orten und Zeiten, wenn es die
Sole-Manager oder je nach Fall der Verwaltungsrat bestimmt werden bezahlt werden der Manager der alleinige Geschäfts-
führer oder als der Fall sein kann der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eine endgültige Bestimmung der
Rate der für Dividendenfonds in die Währung ihren Zahlungs übersetzen Austausch zu machen. Eine Dividende erklärt,
aber nicht fünf Jahre lang auf einer Aktie kann danach nicht mehr durch den Inhaber eines solchen Teilen in Anspruch
genommen werden, aber ist vom Inhaber dieser Anteils verfallen und werden an die Gesellschaft zurück. Keine Zinsen auf
Dividenden erklärt und nicht beansprucht, die von der Gesellschaft im Namen der Anteilinhaber gehalten werden, bezahlt
werden.
15.6 Im Falle einer Dividendenerklärung, so werden diese Dividenden zugeordnet und bezahlt werden wie folgt:
- sind die Inhaber von Anteilen der Klasse A berechtigt, Dividenden-Ausschüttungen in Bezug auf das betreffende Jahr
in Höhe von Null Komma 60 Prozent (0,60 %) des Nennwertes der Aktien der Klasse A zu erhalten, danach
- sind die Inhaber von Anteilen der Klasse B berechtigt, Dividenden-Ausschüttungen in Bezug auf das betreffende Jahr
in Höhe von Null Komma 55 Prozent (0,55 %) des Nennwertes der Aktien der Klasse B zu erhalten, danach;
- sind die Inhaber von Anteilen der Klasse C berechtigt, Dividenden-Ausschüttungen in Bezug auf das betreffende Jahr
in Höhe von Null Komma 50 Prozent (0,50 %) des Nennwertes der Aktien der Klasse C zu erhalten, danach;
- sind die Inhaber von Anteilen der Klasse D berechtigt, Dividenden-Ausschüttungen in Bezug auf das betreffende Jahr
in Höhe von Null Komma 45 Prozent (0,45 %) des Nennwertes der Aktien der Klasse D zu erhalten, danach
- sind die Inhaber von Anteilen der Klasse E berechtigt, Dividenden-Ausschüttungen in Bezug auf das betreffende Jahr
in Höhe von Null Komma 40 Prozent (0,40 %) des Nennwertes der Aktien der Klasse E zu erhalten, danach
- sind die Inhaber von Anteilen der Klasse F berechtigt, Dividenden-Ausschüttungen in Bezug auf das betreffende Jahr
in Höhe von Null Komma 35 Prozent (0,35 %) des Nennwertes der Aktien der Klasse F zu erhalten, danach
- sind die Inhaber von Anteilen der Klasse G berechtigt, Dividenden-Ausschüttungen in Bezug auf das betreffende Jahr
in Höhe von Null Komma 30 Prozent (0,30 %) des Nennwertes der Aktien der Klasse G zu erhalten, danach
- sind die Inhaber von Anteilen der Klasse H berechtigt, Dividenden-Ausschüttungen in Bezug auf das betreffende Jahr
in Höhe von Null Komma 25 Prozent (0,25 %) des Nennwertes der Aktien der Klasse H zu erhalten, danach
- sind die Inhaber von Anteilen der Klasse I berechtigt, Dividenden-Ausschüttungen in Bezug auf das betreffende Jahr
in Höhe von Null Komma 20 Prozent (0,20 %) des Nennwertes der Aktien der Klasse I zu erhalten, danach
- der Rest der Gesamtausschüttungsbetrag soll in seiner Gesamtheit an die Inhaber der letzten Klasse in umgekehrter
alphabetischer Reihenfolge (zugeordnet werden, dh ersten Anteile der Klasse J, dann, wenn keine Anteile der Klasse J sind
in der Existenz, Anteile der Klasse I und in solchen Fortsetzung bis nur Anteile der Klasse A sind in der Existenz).
Nach Begleichung aller Forderungen und Gebühren an die Gesellschaft sowie der Kosten der Abwicklung, ist der Netto-
Liquidationserlös in Übereinstimmung mit dem Ausschüttungs-Regelwerk für Dividendenausschüttungen und so, um auf
aggregierter Basis das gleiche wirtschaftliche Ergebnis zu erzielen, an die Aktionäre auszuschütten
16. Auflösung und Liquidation.
16.1 Die Entscheidung über die Auflösung der Gesellschaft wird von der Gesellschafterversammlung in Übereinstim-
mung mit dem Luxemburgischen Recht und Artikel 13.5 getroffen. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat,
kann dieser Gesellschafter, sich dazu entschließen die Gesellschaft aufzulösen und persönlich alle Vermögenswerte und
Schulden der Gesellschaft, bekannte wie auch unbekannte, zu übernehmen.
17. Nach Begleichung aller Forderungen und gebühren an die gesellschaft sowie der kosten der Abwicklung, ist der
Netto-Liquidationserlös in Übereinstimmung mit dem Ausschüttungs-Regelwerk für Dividendenausschüttungen und so,
um auf Aggregierter Basis das gleiche wirtschaftliche Ergebnis zu erzielen in Article 15 für die Dividendenausschüttungen
eingestellt. Interpretation und Luxemburger recht.
17.1 In der vorliegenden Satzung:
17.1.1 Umfasst/umfassen:
(a) Personenbezeichnungen, welche aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen
Form verwendet werden, auch das jeweils andere Geschlecht;
(b) (soweit sich aus dem Sachzusammenhang nichts anderes ergibt) Begriffe, die in der Einzahl verwendet werden auch
die Mehrzahl und vice versa;
(c) eine "Person" sowohl ein Individuum, als auch eine Firma, eine Gesellschaft, ein Unternehmen oder ein anderes
Gesellschaftsorgan, die Regierung, den Staat oder eine Staatliche Agentur oder ein Joint Venture, einen Verein, eine
Partnerschaft, einen Betriebsrat oder den Arbeitnehmervertreter (mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit);
144396
L
U X E M B O U R G
(d) eine satzungsgemäße Regelung oder gesetzliche Vorschrift beinhaltet alle Änderungen und die Wiederinkraftset-
zungen (mit oder ohne Änderungen) hiervon.
17.1.2 die Wörter "umfassen" und "sich auf etwas beziehen" beinhalten stillschweigend den Zusatz der Wörter "ohne
Einschränkung" und allgemeinen Wörtern darf kein restriktiverer Sinn gegeben werden, auf Grund der Tatsache, dass ihnen
Wörter vorangestellt sind oder ihnen folgen, die auf Handlungen, Angelegenheiten oder Sachen hinweisen oder deren
Beispiele einen allgemeinen Sinn haben;
17.1.3 die Überschriften der vorliegenden Satzung haben keinen Einfluss auf deren Auslegung oder Konstruktion.
17.2 Definition
Verfügbarer Betrag
bedeutet: der Gesamtbetrag des Nettogewinnes der Gesellschaft (einschließlich des
Gewinnvortrags) insoweit den Anteilseignern nach der Satzung eine
Dividendenausschüttung zusteht, vermehrt um (i) alle frei ausschüttbaren Rücklagen
und (ii) gegebenenfalls um den Betrag, um den das Grundkapital und die Gesetzlichen
Rücklagen mit Bezug auf eine zu liquidierende Klasse der Anteile verringert werden,
aber vermindert durch (i) alle Verluste (einschließlich des Verlustvortrags) und (ii)
alle Beträge, die nach Bestimmungen des Gesetzes oder der Satzung in die Rücklagen
einzustellen sind, und wie sie jeweils in den relevanten Zwischenabschlüssen (ohne,
zur Vermeidung von Zweifeln, jede Doppelzählung) ausgewiesen werden, so dass:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Wobei:
AA = der Verfügbare Betrag
NP = der Nettogewinn (einschließlich des Gewinnvortrags)
P = alle frei ausschüttbare Rücklagen (einschließlich Emissionsagio)
CR = der Betrag der Auflösung von Grundkapital und gesetzlichen Rücklagen jeweils
in Bezug auf die Klasse der Anteile, die aufgelöst werden soll.
L = Verluste (einschließlich des Verlustvortrags)
LR = alle Beträge, die aufgrund gesetzlicher oder satzungsgemäßer Anforderungen
in die Rücklagen einzustellen sind.
Für den Fall, würde die Gesellschaft zusätzlichen Gewinn (zB eine Earn-out-Zahlung)
nach dem Rückkauf und die Annullierung von einer Anteilsklasse zu realisieren (die
"Rückkauf"), weiter zu einer Operation, die vor dem Rückkauf realisiert wurde, wird
der zur Verfügung stehende Betrag berechnet anlässlich des Rückkaufs wird
Berücksichtigung zusätzlicher Gewinn zu nehmen.
Der Stornierungswert pro Anteil soll berechnet werden, in dem man den gesamten Stornierungsbetrag einer
Anteilsklasse, die gelöscht werden soll, durch die Anzahl der Anteile in dieser
Anteilsklasse teilt.
Zwischenabschluss
Bedeutet, dass die Zwischenabschluss der Gesellschaft zum jeweiligen
Zwischenkonto Datum.
Zwischenabschluss Datum
Ist der Tag, nicht früher als acht (8) Tage vor dem Datum der Rückkauf der
betreffenden Anteilsklasse.
Gesellschaft
Bedeutet, dass die Gesellschafter der Gesellschaft.
Gesamtstornierungsbetrag
Bedeutet eine Menge von der Sole-Manager oder wie der Fall ermittelt kann der
Verwaltungsrat Managers zu sein, und von der Hauptversammlung auf der Grundlage
der entsprechenden Zwischenabschluss gebilligt. Die Gesamtabrechnungsbetrag für
jede der Klassen J, I, H, G, F, E, D, C, B und A wird der verfügbare Betrag der
entsprechenden Klasse zum Zeitpunkt der Löschung der betreffenden Klasse sein,
sofern nichts anderes beschlossen von der Hauptversammlung in der für eine
Änderung der jedoch vorgesehen Artikeln vorgesehenen Weise, dass der
Gesamtabrechnungsbetrag wird nie höher als solche zur Verfügung stehende Betrag
sein.
17.3 Zusätzlich zu dieser Satzung wird die Gesellschaft ebenfalls von den Bestimmungen des Luxemburger Rechts
geregelt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Daraufhin Lesing Eastbrook Limited, vorgenannt und vertretet wie hier angegeben-oben erklärt, um auf die gesamte
Grundkapital der Gesellschaft angemeldet hat und haben alle zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nennwert von drei-
zehn Euro und sechzig Cent bezahlt (EUR 13,60), die jeweils durch Bareinlage, so dass die Summe von einhundertsech-
144397
L
U X E M B O U R G
zigtausend Euro (EUR 136.000,-), ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht, was vor dem beurkundenden Notar
nachgewiesen wurde.
<i>Kostenschätzungi>
Die der Gesellschaft für diese Gründung entstandenen oder von ihr zu tragenden Kosten, Ausgaben, Entgelte und Ge-
bühren jeglicher Art, belaufen sich auf ungefähr eintausendachthundert Euro (EUR 1.800,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Unmittelbar nach der Gesellschaftsgründung fasst die wie oben benannte Erschienene, welche das gesamte gezeichnete
Gesellschaftskapital vertritt und die Befugnisse ausübt, welcher ihr durch Beschluss der Gesellschafter übertragen worden
sind, durch ihren Vertreter folgende Beschlüsse:
1) Die folgende Person wird auf unbestimmte Dauer und mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Gesellschaft
benannt:
- Herrn Bakary Sylla, geboren am 1. November 1976 in Monrovia, (Liberia), geschäftsansässig in 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxemburg;
- Herrn Robert Kimmels, geboren am 4. März 1969 in Breukelen, (Niederlande), geschäftsansässig in 55, Avenue
Pasteur, L-2311 Luxemburg.
2) Als Adresse des Gesellschaftssitzes wird 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg bestimmt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in
Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen
und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.
WORÜBER URKUNDE, erstellt wurde zu Luxemburg, mit Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns,
dem unterzeichnenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 31 août 2015. Relation: 2LAC/2015/19549. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 18 septembre 2015.
Référence de publication: 2015155571/692.
(150171428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.
McKesson Information Solutions Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 81.540.
Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015154503/10.
(150169955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Mill Luxembourg Holdings 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 176.460.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 16 septembre 2015 a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Eric Jan van de Laar, en tant que gérant B de la Société, est acceptée avec effet au 17 août 2015.
- Peter Lundin, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé gérant B de
la Société avec effet au 17 août 2015 pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
144398
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 16 septembre 2015.
Référence de publication: 2015154515/15.
(150169781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
K Alpha S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.968.
Les décisions suivantes ont été approuvées et ratifiées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société
qui s'est tenue en date du 30 juillet 2015:
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période se terminant lors de l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2016:
* Monsieur Cedric Stebel, Administrateur DH;
* Monsieur Graeme Stening, Administrateur DH;
* Monsieur Fabian Sires, Administrateur DH.
- Confirmation que le conseil d'administration de la Société est désormais composé par les administrateurs suivants:
* Monsieur Cedric Stebel, Administrateur DH;
* Monsieur Graeme Stening, Administrateur DH;
* Monsieur Fabian Sires, Administrateur DH.
- Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, en tant que commissaire aux comptes avec effet immédiat et
pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.
De plus, veuillez prendre note de la nouvelle adresse de PricewaterhouseCoopers se trouvant désormais au 2, rue Gerhard
Mercator L-2182 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B65477.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2015.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015154941/29.
(150170280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.
ALPEED, Association Luxembourgeoise des Parents d'Elèves de l'Education Differenciée, Association sans but
lucratif.
Siège social: L-4972 Dippach, 96, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg F 10.520.
STATUTS
Entre les soussignés:
1. Allard-Morth Mady, sans profession, demeurant à L-4446 Belvaux, 47 rue de France, de nationalité luxembourgeoise
2. Bernardo Lima Tania, sans profession, demeurant à L-4831 Rodange, 315 route de Longwy, de nationalité portugaise
3. Christophe Sandrine, sans profession, demeurant à L-4170 Esch-sur-Alzette, 40 Boulevard J.F. Kennedy, de natio-
nalité française
4. Dos Reis Christina, Aide sociale familiale, demeurant à L-4798 Linger, 95 rue de la Libération, de nationalité por-
tugaise
5. Hubert Valérie, sans profession, demeurant à L-4972 Dippach, 96 route de Luxembourg, de nationalité belge
6. Jans Sandra, sans profession, demeurant à L-4955 Bascharage, 3 rue des Coquelicots, de nationalité luxembourgeoise
7. Rosàrio, Eduarda, ingénieur agronome, demeurant à L-4220 Esch-sur-Alzette, 20 rue de Luxembourg, de nationalité
portugaise
8. Simon Martine, fonctionnaire communale, demeurant à L-4347 Esch-sur-Alzette, 36 rue Dr Welter, de nationalité
luxembourgeoise
9. Wotipka Marco, agent de la BCL, demeurant à L-4135 Esch-sur-Alzette, 16 rue Saint-Henri, de nationalité luxem-
bourgeoise
144399
L
U X E M B O U R G
Avec les membres fondateurs et toutes les personnes qui viendront y adhérer ultérieurement, est constituée une asso-
ciation sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les
fondations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.
I. Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. L'association prend la dénomination ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PARENTS D'ELEVES
DE L'EDUCATION DIFFERENCIEE- en abrégé ALPEED.
Son siège est à route de Luxembourg, 96 - 4972 Dippach. Il pourra toutefois être transféré en tout autre lieu du Grand-
Duché sur simple décision de l'assemblée générale. La durée de l'association est illimitée.
Art. 2. L'association a pour objet la défense collective des intérêts éducatifs, sociaux, moraux et matériels, au sens le
plus large de l'ensemble de ses adhérents, leur représentation officielle, ainsi que la représentation au sein de tout autre
organe officiel intéressant ses affiliés. Elle s'interdit toutes activités, tant politiques et idéologiques que religieuse. L'asso-
ciation pourra effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son susdit objet social.
Les biens meubles et immeubles dont l'association est ou pourra devenir propriétaire ne pourront servir qu'à la réalisation
de son objet.
II. Composition, Admission, Exclusion, Démission, Cotisation
Art. 3. L'adhésion est réservée aux parents, et tuteurs d'enfants, de l'éducation différenciée et afférente, à besoins spé-
cifiques présentant un handicap. Peuvent également adhérer à l'association, les parents ayant eu un enfant dans l'éducation
différenciée. L'adhésion est également possible en tant que membre honoraire sans droit de vote, les personnes intéressées
par les buts de l'association qui n'ont pas été exclus de l'association.
Art. 4. Les associés sont admis par cooptation par décision du Conseil d'Administration de l'association statuant sur une
demande écrite ou verbale du postulant.
Art. 5. L'association se compose de membres actifs et de membres honoraires.
Art. 6. Les premiers membres actifs de l'association sont les signataires des présents statuts. Le nombre des membres
actifs ne peut être inférieur à cinq. Seuls les membres actifs jouissent des droits et avantages que la loi modifiée du 21 avril
1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, réservés aux «membres»
et aux «associés» de l'association. En particulier, seuls les membres actifs disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale.
Art. 7. Sont admis comme membres honoraires, les personnes, morales ou physiques, qui soutiennent l'association par
une cotisation annuelle fixée par l'assemblée générale ou par des dons en nature ou en espèces.
Art. 8. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite au
Conseil d'Administration. Dans ce cas, la cotisation initiale payée par le membre démissionnaire reste acquis à l'association.
Est également réputé démissionnaire, à compter du jour de l'échéance, le membre qui refuse, malgré rappel resté infructueux
pendant 6 semaines, de payer la cotisation. La qualité de membre de l'association se perd encore par voie d'une exclusion
prononcée par le Conseil d'Administration pour cause d'actes contraires aux intérêts de l'association posés par ce membre.
A partir de la proposition d'exclusion formulée par le Conseil d'Administration et jusqu'à la décision définitive à prendre
par l'assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées, le membre dont l'exclusion
est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions au sein de l'association. Les associés, démissionnaires ou exclus
ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont par ailleurs aucun droit à faire valoir sur le patrimoine de
l'association.
Art. 9. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont opérées jusqu'au
30 septembre de l'année concernée.
Art. 10. La cotisation annuelle des membres est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut dépasser la somme de 50,-
EUR (cinquante euros).
Art. 11. Les membres sont admis à la suite d'une demande écrite ou d'une demande verbale.
III. Assemblée Générale
Art. 12. L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres actifs, est convoquée par le conseil d'administration
régulièrement une fois par an, à savoir au début de l'année scolaire mais au plus tard le 30 novembre et, extraordinairement,
chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un cinquième des membres le demandent par écrit au conseil
d'administration. Les membres honoraires n'ont pas le droit de vote à l'assemblée générale.
Art. 13. L'assemblée générale se réunit tous les ans entre septembre et octobre au plus tard le 31 octobre. Elle est
convoquée par le Conseil d'Administration, ordinairement, une fois par an, au jour et à l'heure fixée par ce dernier et,
extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'au moins un cinquième des membres le
demandent par écrit au Conseil d'Administration. La convocation se fait au moins 20 (vingt) jours avant la date fixée pour
l'assemblée générale, moyennant simple missive prévoyant l'ordre du jour proposé. Toute proposition écrite, signée d'un
144400
L
U X E M B O U R G
vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle, doit porter à l'ordre du jour. Aucune décision ne
peut être prise sur un objet ne figurant pas à l'ordre du jour.
Art. 14. L'assemblée générale est notamment investie des pouvoirs suivants: 1. la modification des statuts de l'association,
2. la nomination et la révocation des administrateurs, 3. l'approbation des budgets et comptes annuels, l'exercice social
s'étendant du 1
er
octobre au 30 septembre de chaque année, 4. la décharge à accorder au trésorier, 5. la nomination et la
révocation des réviseurs de caisse, 6. la fixation des cotisations pour les membres actifs et les membres honoraires, 7.
l'exercice de tous les autres pouvoirs découlant de la loi et des présents statuts, 8. la dissolution de l'association.
Art. 15. A part les modifications des statuts et la dissolution de l'association, pour lesquelles s'appliquent les dispositions
légales (1. indications dans la lettre de convocation de l'objet et du texte de la modification proposée, 2. quorums de présence
de 2/3 des membres de l'association), l'assemblée est valablement constituée et délibère valablement sur les points portés
à son ordre du jour, quel que soit le nombre des membres actifs présents ou représentés. Toutefois, au cas où la modification
proposée porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, la seconde assemblée ne sera valablement
constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et la décision ne sera réputée admise que
si elle est votée à la majorité des trois quarts (3/4) des voix présentes ou représentées. A moins que la loi modifiée du 21
avril 1928 ne fixe d'autres modalités et quorums, les résolutions sont adoptées à la majorité simple des voix des membres
actifs présents ou représentés à l'assemblée.
En cas de partage des voix, celle du Président de l'association ou le cas échéant celle du vice-président sera prépondérante
au second vote.
Art. 16. Les délibérations de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres par voie d'un bulletin de
liaison périodique.
IV. Administration
Art. 17. L'association est administrée par un Conseil d'Administration, composé de trois (3) administrateurs au moins
et de quinze (15) membres au plus. Le Conseil d'Administration est chargé de diriger les affaires courantes de l'association
et d'exécuter les décisions prises par l'assemblée générale. Il gère en particulier les finances de l'association. Le Conseil
peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou à plusieurs de ses membres. Pour assurer
sa mission précitée, le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus. Ces pouvoirs englobent notamment tous les actes
d'administration et de disposition. Le Conseil représente l'association dans les relations avec les tiers dans tous les actes
judiciaires et extra judiciaires. L'association sera valablement engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux
administrateurs, parmi lesquelles doit nécessairement figurer celle du trésorier, du président sans que les signataires n'aient
à justifier d'aucune délibération, autorisation ou autre pouvoir spécial.
Art. 18. Les membres du Conseil sont désignés pour deux ans par décision de l'assemblée générale, statuant à la majorité
simple des voix présentes ou représentées. Les administrateurs sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, statuant
à la même majorité. Le mandat des administrateurs sortant est renouvelable à l'infini. Le Conseil choisit parmi ses membres
son président, son secrétaire et son trésorier.
Art. 19. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou de deux de ses membres aussi souvent
que les intérêts de l'association l'exigent. Il ne peut délibérer valablement que si trois membres au moins sont présents et
dont le président ou le secrétaire y figurent. Le Conseil peut s'adjoindre des experts avec voix consultative. Les décisions
sont adoptées à la majorité des membres présents du Conseil. En cas d'égalité des voix, celle du président ou le cas échéant
celle du secrétaire sera prépondérante au second vote.
Art. 20. Le Conseil d'Administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale les comptes de
l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
L'exercice budgétaire commence le 30 octobre de chaque année et se clôture au 29 octobre de l'année suivante. Le
premier exercice commence à la date de la constitution de l'association.
Les comptes sont arrêtés le 29 octobre de chaque année et sont soumis à l'assemblée générale avec le rapport des réviseurs
de compte. Aux fins d'examen, l'assemblée générale désigne deux réviseurs de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible
avec celui de membre du Conseil d'Administration de l'association.
V. Ressources
Art. 21. Les recettes de l'association sont constituées par:
1. les cotisations des membres actifs et honoraires,
2. les subsides et subventions,
3. les dons et legs des particuliers ou des associations,
4. toutes les autres ressources compatibles avec l'objet social de l'association.
Le patrimoine de l'association répond seul des engagements pris en son nom et aucun des membres actifs ou des membres
du Conseil d'Administration de l'association ne pourra être rendu personnellement tenu de ces engagements.
144401
L
U X E M B O U R G
Art. 22. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives de
toute rémunération. Toutefois, sur décision préalable du conseil, les frais de participation et/ou de déplacement à une réunion
à l'étranger au service de l'association peuvent être pris en charge par l'association.
VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. La dissolution de l'association ne pourra être prononcée par l'assemblée générale qu'aux conditions de présence
et de quorum fixé par les prescriptions légales. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'association, les biens de
l'association dissoute seront affectés à une ou à plusieurs oeuvres sociales à désigner par l'assemblée générale.
VII. Dispositions Générales
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas autrement réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi modifiée du 21
avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et les établissements publics. Pour le première Assemblée
Générale, les statuts de l'association ayant ainsi été arrêtés, les membres fondateurs se réunissent en une première assemblée
générale à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
Référence de publication: 2015155206/143.
(150171430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.
Mill Luxembourg Holdings 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 176.461.
EXTRAIT
En date du 15 septembre 2015, l'associé unique de la Société a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Erik Johan van de Laar, en tant que gérant B de la Société, est constatée avec effet au 17 août 2015;
- La nomination de Peter Lundin, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en tant
que gérante B de la Société, est acceptée avec effet au 17 août 2015 pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 16 septembre 2015.
Référence de publication: 2015154516/15.
(150169706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Margaux Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 7, rue Mil Neuf Cents.
R.C.S. Luxembourg B 139.181.
Les comptes annuels au 30.09.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015154519/9.
(150169780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Abbey Barn Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 200.053.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the fifteenth of September.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
ABBEY BARN INVESTMENTS LTD, a company incorporated under the British Virgin Islands laws, having its re-
gistered office at Quijano &Associates (BVI) Ltd, Quijano Chambers, Po Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands and registered with the British Virgin Islands Registry under number 1884937,
here represented by Mr Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, réviseur d'entreprises, with professional address in Lu-
xembourg by virtue of a proxy given under private seal on 21
st
August 2015.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder of the appearing party and the notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
144402
L
U X E M B O U R G
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a public limited
company which he intends to organise among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued,
a company in the form of a public limited company ("société anonyme"), under the name of "ABBEY BARN HOLDINGS
S.A." (hereafter the "Company").
Art. 2. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors.
It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the
board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner in any
curreny as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management,
control and development of its portfolio.
The company can equally buy and develop intellectual property rights and other related rights connected to these, or
assist in their completion.
The Company can borrow and grant companies in which it has direct or indirect, interest, every assistance, loans,
advances, or guarantees.
The Company shall be able to carry out any operation, whether commercial, industrial, or financial, including the direct
purchase and sale of property, that is deemed to be in its interest and the achievement of its objects.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into one
thousand (1.000) shares of no par value The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its
own shares.
Board of Directors and Statutory Auditors
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be
shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general
meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors may be
limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one share-
holder in the Company.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by
general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place
will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented. Proxies
between directors are permitted; with the restriction that one director can only represent one of the members of the board
of directors.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors'
meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the
chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the
debates.
144403
L
U X E M B O U R G
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10
th
, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence
of the board of directors.
Art. 11. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the
Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents,
associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the
board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors
to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 12. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to
whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one
(1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the
general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out
or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by
law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the
convening notice on the first Thursday of the month of April at 11.30. a.m..
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written
request of shareholders representing ten percent of the company's share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognise only one holder for each share; in
case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to
that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1
st
and ends on December 31 of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before
the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such
contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General Dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these
articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2016.
144404
L
U X E M B O U R G
The first annual general meeting shall be held in 2016.
<i>Subscription and Paymenti>
The 1,000 (one thousand) shares issued have been subscribed by ABBEY BARN INVESTMENTS LTD aforementio-
ned, for the price of EUR 31,000.- (thirty one thousand euro).
The shares so subscribed by ABBEY BARN INVESTMENTS LTD have been fully paid up by a contribution in cash
so that the amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) is as of now available to the Company, as it has been
justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred fifty Euro
(EUR 1,150.-).
<i>Resolutions of the Sole Shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg;
2. The following persons are appointed as directors of the Company for a term of 6 (six) years:
- Mr Daniel MARTIN, born on 12 January 1954 in Haarlem (The Netherlands), with address at Kievitstraat 17, B-2920
Kalmthout;
- Mr Nabil CHARTOUNI, born on 7 June 1945 in Moualaka (Lebanon), with address at 5705 Ksara, Zahle, Lebanon;
- Mr Nicolas BOUVIER DE LAMOTTE, born on 6 June 1956 in Stafford (United Kingdom) with professional address
at 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3. The following has been appointed as statutory auditor, for a term of six (6) years:
- “BDO Audit”, a “société anonyme” with its registered office in L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles De Gaulle,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 147.570.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, known to the notary, by his surname,
Christian names, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le quinze septembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ABBEY BARN INVESTMENTS LTD, une société établie dans les Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à
Quijano & Associates (BVI) Ltd, Quijano Chambers, Po Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands et enre-
gistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1884937,
ici représenté par Monsieur Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 21 août 2015.
Ladite procuration, paraphée et signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de "ABBEY BARN HOLDINGS S.A." (ci-après la "Société").
Art. 2. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du conseil d'administration. Il pourra
être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des ac-
tionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du
conseil d'administration.
144405
L
U X E M B O U R G
Dans l'hypothèse où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-
nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité
normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation
complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et sous toute forme de placement, acquisition par achat, souscription ou autre, transfert par vente,
échange ou autre de valeurs mobilières de tout type, et dans toute devise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut aussi acheter et développer des droits de propriété intellectuelle et d'autres droits en relation avec ceux-
ci ou assister à leur réalisation.
La Société peut garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une parti-
cipation directe ou indirecte.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière, immobilière, l'achat direct,
estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000.-) divisé en mille (1.000) actions sans valeur
nominale.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'exi-
stence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la
durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-
més ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à
l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses
collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax,
ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration
et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous lés actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avan-
tages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
144406
L
U X E M B O U R G
Art. 12. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque
le conseil d'administration est composé d'un seul (1) membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale
qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le troisième lundi du mois d'avril à Luxembourg à 11.30 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) com-
missaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire
au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Dispositions générales
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2016.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2016.
<i>Souscription et Paiementi>
Les 1.000 (mille) actions émises ont été souscrites par Abbey Barn Investments Ltd., susmentionnée, pour un prix d'EUR
31.000,- (trente et un mille euros).
Toutes les actions souscrites par Abbey Barn Investments Ltd, susmentionnée, ont été intégralement libérées par voie
d'apport en numéraire de sorte que le montant de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) est dès à présent à la disposition
de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille cent cinquante euros (EUR1.150,-).
144407
L
U X E M B O U R G
<i>Décisions de l'actionnaire uniquei>
L'actionnaire constituant, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de
convocation, a adopté les décisions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs pour une durée de 6 (six) ans:
- Mr Daniel MARTIN, né le 12 janvier 1954 à Haarlem (Pays-Bas), ayant son adresse à Kievitstraat 17, B-2920 Kalm-
thout (Belgique);
- Mr Nabil CHARTOUNI, né le 7 juin 1945 in Moualaka (Liban), ayant son adresse à 5705 Ksara, Zahle, Liban;
- Mr Nicolas VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, né le 6 juin 1956 à Stafford (Royaume-Uni) ayant son adresse
professionnelle à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal;
3. La personne suivante est nommée en tant que commissaire aux comptes pour une durée de 6 (six ans):
- «BDO Audit», une société anonyme ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles De Gaulle,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.570.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande de la comparante, que le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande de la même comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Bouvier De Lamotte, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29367. Reçu soixante-quinze
euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 21 septembre 2015.
Référence de publication: 2015155209/305.
(150171609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.
MOSSACK FONSECA & Co. (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 155.349.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015154527/11.
(150169840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
ABF Preston Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 14.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 140.332.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of August.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
BV ABF Delaware Inc., a company incorporated under the laws of the Netherlands (and domesticated as a corporation
in Delaware, United States of America, known as B.V. ABF Delaware, Inc.) having its seats in Rotterdam, the Netherlands,
and its Delaware registered agent address at 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, United States of America,
duly represented by Mr. Giuseppe CAFIERO, lawyer, residing professionally at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de
la Pétrusse, by virtue of a power of attorney given under private seal in US on 26
th
of August, 2015,
144408
L
U X E M B O U R G
which proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party represented as here above stated, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That it is the sole member (the “Sole Member”) of ABF Preston Park S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), having its registered office at L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.332, incorporated pursuant to a deed received by
Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, on 21 July 2008, pu-
blished in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) under number 1955 on 9
August 2008 and whose articles of association have been amended several time and for the last time pursuant to a deed of
the undersigned notary on 25 August 2015, not yet published with the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil
des Sociétés et des Associations) (the “Company”).
II. That the corporate capital of the Company is set at fourteen thousand five hundred United State Dollars (USD 14,500.-)
represented by five million (5,000,000) corporate units without designation of par value, which have been fully paid up.
III. That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:
1. Decision to put the Company into voluntary liquidation with immediate effect;
2. Appointment of Mr. François BROUXEL, lawyer, born on 16 September 1966 in Metz, France, residing professionally
at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, as liquidator (the “Liquidator”) of the Company;
3. Determination of the powers, duties and remuneration of the Liquidator;
4. Discharge (quitus) granted to the Company's managers with respect to the performance of their entire mandates as
managers of the Company;
5. Granting of authorisation to the Liquidator and/or to any lawyer of the law firm Wildgen, Partners in Law, to carry
out any required step relating to the resolutions to be taken on the basis of the present agenda;
6. Miscellaneous.
IV. That the Sole Member took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolved to put the Company into voluntary liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The Sole Member resolved to appoint Mr. François BROUXEL, lawyer, born on 16 September 1966 in Metz, France,
residing professionally at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, as Liquidator of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Member resolved to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without prior consent of the Sole Member of the Company.
The Liquidator is exempted from the obligation of drawing-up an inventory, and may in this respect fully rely on the
books of the Company.
The Liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his
powers and for such duration as he may deems fit, to one or several representatives.
The Liquidator shall also be authorised to make advance payments of any surplus assets of the Company to the Sole
Member of the Company as he deems fit.
In dealing with third parties as well as in justice, the Liquidator will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances.
The Sole Member resolved to approve the remuneration of the Liquidator as it has been agreed by the concerned parties.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Member resolved to grant full discharge to the Company's managers for the performance of their entire man-
dates as managers of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Member resolved to grant power of authorisation to the Liquidator and/or to any lawyer of the law firm Wildgen,
Partners in Law, to carry out any required step relating to the resolutions taken at the present extraordinary general meeting
of the Sole Member.
<i>Costsi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present deed, is
estimated at mille one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).
144409
L
U X E M B O U R G
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person and
in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.
WHEREOF, the present notarized deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, such person, represented as here above stated, signed together
with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois d'août.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
La société BV ABF Delaware Inc., une société constituée selon le droit Néerlandais (et enregistrée comme une société
au Delaware, Etats-Unis d'Amérique, connue sous le nom de B.V. ABF Delaware, Inc.) ayant son siège à Rotterdam (Pays-
Bas), et l'adresse de son agent enregistré au Delaware au 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, Etats-Unis
d'Amérique,
dûment représentée par Maître Giuseppe CAFIERO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à US le 26 août 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme ci-avant indiqué, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Qu'elle est l'associé unique (l'«Associé Unique») de la société ABF Preston Park S.à r.l., une société dûment constituée
sous la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-2310 Luxembourg,
16 avenue Pasteur, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
140.332, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 21 juillet
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1955 du 9 août 2008 et dont les statuts
ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte reçu par le notaire soussigné le 25 août 2015, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).
II. Que le capital souscrit de la Société est fixé à quatorze mille cinq cents Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
14.500,-), représenté par cinq millions (5.000.000) parts sociales entièrement libérée et sans désignation de valeur nominale.
III. Que l'agenda de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1. Décision de mettre la Société en liquidation volontaire avec effet immédiat;
2. Nomination de M. François BROUXEL, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz, France, résidant profes-
sionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, comme liquidateur de la Société (le «Liquidateur»);
3. Détermination des obligations et pouvoirs du Liquidateur;
4. Décharge (quitus) donné aux gérants de la Société pour l'exercice de l'intégralité de leur mandat de gérants de la
Société;
5. Octroi d'autorisation au Liquidateur et/ou tout avocat du cabinet d'avocats Wildgen, Partners in Law, pour prendre
toute mesure nécessaire pour la réalisation des résolutions prises sur base du présent agenda;
6. Divers.
IV. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de mettre la Société en liquidation volontaire avec effet immédiat.
<i>Second résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de nommer M. François Brouxel, avocat à la Cour, résidant professionnellement au L-2320
Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, comme liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de conférer au Liquidateur les pouvoirs définis à l'article 144 et suivants de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et effectuer toutes opérations, y compris celles mentionnées à l'article
145 de la Loi, sans consentement préalable de l'Associé Unique.
Le Liquidateur est exempté de l'obligation d'établir un inventaire et peut sur ce point se fier entièrement aux livres de
la Sociétés.
144410
L
U X E M B O U R G
Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou
plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.
Le Liquidateur est autorisé à verser à l'Associé Unique des acomptes sur le boni de liquidation tel qu'il le jugera opportun.
Vis-à-vis des tiers et en justice, le Liquidateur aura, en toute circonstance, tous les pouvoirs pour agir au nom de la
Société.
L'Associé Unique a décidé d'approuver la rémunération du Liquidateur tel que convenu entre les parties concernées.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de donner décharge (quitus) aux gérants de la société pour l'exercice de l'intégralité de leur
mandat en tant que gérants de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'autoriser le Liquidateur et/ou tout avocat du cabinet d'avocats Wildgen, Partners in Law,
pour prendre toutes mesures nécessaires pour la réalisation des résolutions prises par L'Associé Unique au cours de la
présente assemblée générale extraordinaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte sont estimés à mille trois cents Euros (EUR 1.300,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, ledit mandataire a
signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: G. Cafiero et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 4 septembre 2015. Relation: 2LAC/2015/19906. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 18 septembre 2015.
Référence de publication: 2015155210/151.
(150170847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.
MOSSFON (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 145.548.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015154528/11.
(150169852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
MT Projet Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4340 Esch-sur-Alzette, 77, rue de l'Usine.
R.C.S. Luxembourg B 180.165.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la cession de partsi>
Suite à une convention de cession de parts sociales par acte sous-seing privé du 15 septembre 2015, Monsieur Marc
TRITZ, artisan, né à Grindorff en France, le 14 juin 1966, demeurant à F-57480 Waldwisse, 10, rue de la Gare, a cédé 760
(sept cent soixante) parts sociales représentatives du capital social de la société à responsabilité limitée “MT PROJET LUX
S.à r.l.» établie et ayant son siège social à L-4340 Esch-sur-Alzette, 77, rue de l'usine, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 180.165, à Madame Stéphanie TRITZ, exerçant la fonction
144411
L
U X E M B O U R G
d'assistante administrative, née à Wadern en République Fédérale d'Allemagne, le 11 décembre 1971, et demeurant à
F-57480 Waldisse, 10, rue de la Gare.
Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 2015.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015154531/17.
(150169873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Saint Amand GP, Société Anonyme.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 180.546.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 11 Septembre 2015 a décidé:
I. de renouveler le mandat de:
- Mme Sara SPEED, ayant pour adresse professionnelle 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- Mr. Eric FORT 14, rue Erasme, L-2082 LUXEMBOURG
- Mr. Max WELBES 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBOURG
en leur qualité d'administrateur pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2016,
II. de renouveler le mandat de:
- Mme Sara SPEED, ayant pour adresse professionnelle 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
en qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016,
III. de renouveler le mandat de:
- KPMG Luxembourg, 39 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
en qualité de Réviseur d'entreprises agréé pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2016.
<i>Pour Saint Amand GP
i>Société anonyme
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015154594/26.
(150169743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Naropère S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 113.787.
Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015154532/9.
(150169913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
NetJets Luxembourg Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.748.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 144.464.
En date du 31 août 2015, l'Associé Unique de la Société a pris connaissance de la démission de Mr. Johannes Laurens
de Zwart de son poste de gérant de classe B avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NetJets Luxembourg Holding Company S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015154533/14.
(150169714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
144412
L
U X E M B O U R G
Nemset S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 70.156.
L'an deux mille quinze, le quatrième jour du mois de septembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg “NEMSET S.A.”, en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à L-1820 Luxembourg,
10, rue Antoine Jans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 70156,
(la “Société”), constituée originairement sous la dénomination sociale de “ROSEWOOD S.A.”, suivant acte reçu par Maître
André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 27 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 622 du 18 août 1999,
et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire André-Jean-Joseph SCHWACHT-
GEN:
- en date du 21 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 656 du 30 août 1999, et
- en date du 6 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 763 du 14 septembre
2001, contenant notamment l'adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle.
La Société a été dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à
Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 12 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1287 du 15 décembre 2004.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alberto VARETTO, commerçant, demeurant à I-42012 Carpi (MO) Via Fornaci,
5 (Italie).
Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Diego VARETTO, employé
privé, demeurant à I-42012 Carpi (MO), Via Fornaci, 5 (Italie).
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social à L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon et modification afférente de la première phrase de
l'article 3 des statuts;
2. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés
sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les mandataires et les membres du bureau
de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social à L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon et de modifier subséquemment
la première phrase de l'article 3 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:
“Le siège social est établi à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg).”
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide (i) de révoquer la société “WILONA GLOBAL S.A.” de sa fonction de liquidateur et (ii) de nommer
Monsieur Diego VARETTO, employé privé, né à Turin (Italie), le 17 mars 1947, demeurant à I-42012 Carpi (MO), Via
Fornaci, 5 (Italie), comme nouveau liquidateur de la Société.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans le cas où cette autorisation est normalement requise.
144413
L
U X E M B O U R G
Le liquidateur est notamment autorisé à vendre tous les immeubles appartenant à la société “NEMSET S.A.”, en liqui-
dation volontaire, dont notamment:
<i>Désignations:i>
- Immeuble inscrit sous “Comune di Modena (Mo), Cod. H4AA, Catasto U, Sez. -Fgl. 122 Part. 71, Sub. 1, Nat. D7,
Piano PT, sis à Via Chiesa 183”;
- Immeuble inscrit sous “Comune di Modena (Mo), Cod. H4AA, Catasto U, Sez. -Fgl. 51 Part. 74, Sub. 6, Nat. D7,
Piano T., sis à Via S. Allende”;
- Immeuble inscrit sous “Comune di Modena (Mo), Cod. H4AA, Catasto U, Sez. -Fgl. 51 Part. 74, Sub. 7, Nat. A10,
Piano P1, sis à Via S. Allende”;
- Immeuble inscrit sous “Comune di Bomporto (Mo), Cod. H4AC, Catasto U, Sez. - Fgl. 25 Part. 406, Sub.4, Nat. A2,
N. Vani 5, Piano T, sis à Prov. Sorbarese”;
- Immeuble inscrit sous “Comune di Modena (Mo), Cod. H4AA, Catasto U, Sez. -Fgl. 48 Part 258, Sub. 12, Nat. D7,
Piano T., sis à Via Belgio”.
Le liquidateur est expressément autorisé à percevoir une compensation forfaitaire pour sa mission jusqu'à ce jour pour
les frais et dépenses occasionnés à hauteur de cent trente mille euros (EUR 130.000,-).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite
clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. VARETTO, D. VARETTO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 10 septembre 2015. 2LAC/2015/20227. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 16 septembre 2015.
Référence de publication: 2015155655/85.
(150171078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.
Athalia VI B, Société Civile.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg E 5.584.
The meeting was called to order at 4.45 p.m. and was chaired by Maître Nicolas Gauzes, lawyer, residing in Luxembourg
(the “Chairman”), The Chairman appointed, Maître Caroline Pimpaud, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of
the meeting.
The meeting elected as scrutineer Ms Jennifer Ferrand, legal manager, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman recalled that the agenda of the meeting reads as
follows:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of three hundred sixteen thousand five hundred United
States dollars (USD 316,500 -) so as to raise it from its present amount of twenty United States dollars (USD 20.-) to an
amount of three hundred sixteen thousand five hundred twenty United States dollars (USD 316,520.-).
2 To issue three hundred sixteen thousand five hundred (316,500) new shares with a nominal value of one United States
dollars (USD 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares
3 To accept subscriptions for these new shares as well as payment in full for such new shares by a contributions in cash.
4 To approve the buy back of all the Company's shares other than the new shares to be issued according to the above
and one (1) share held by ASF VI GP Limited for a purchase price of one United States dollar (USD 1-) per share
5 To decrease the share capital of the Company by an amount of nineteen United States dollars (USD 19-) so as to reduce
it from its current amount of three hundred sixteen thousand five hundred twenty United States dollars (USD 316,520.-)
to an amount of three hundred sixteen thousand five hundred one United States dollars (USD 316,501.-) by cancellation
of nineteen (19) shares, having a nominal value of one United States dollar (USD 1 -) each.
144414
L
U X E M B O U R G
6 To amend the first paragraph of article 12 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital
increase and the subsequent capital decrease.
(i) The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented
shareholders and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present minutes.
(ii) The whole corporate capital is represented at the present meeting and all the shareholders present or represented
declare that they have been duly informed on all items of the above agenda prior to the meeting.
(iii) The present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda,
The statements made above by the Chairman are approved by the meeting.
The meeting then discussed all items of the agenda and unanimously adopted each of the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to increase the corporate capital of the Company by an
amount of three hundred sixteen thousand five hundred United States dollars (USD 316,500.-) so as to raise it from its
present amount of twenty United States dollars (USD 20.-) to an amount of three hundred sixteen thousand five hundred
twenty United States dollars (USD 316,520.-).
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to issue three hundred sixteen thousand five hundred
(316,500) new shares with a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) per share, having the same rights and
privileges as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared:
Mr Michael BANE, born on 30 April 1980 in Boston (USA), having his professional address at 1370 Avenue of the
Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019, USA (“M.Bane”), hereby represented by Nicolas Gauzes, lawyer, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 March 2015;
Mr Alexis BEBEAR, born on 25 November 1989 in Paris (France), having his professional address at 1370 Avenue of
the Americas 22
nd
Floor New York NY 10019, USA (“A.Bebear”), hereby represented by Nicolas Gauzes, lawyer, residing
In Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 March 2015;
Mr Mark BENEDETTI, bom on 30 September 1980 in Montreal (Canada), having his professional address at 1370
Avenue of the Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019. USA (“M.Benedetti”), hereby represented by Nicolas Gauzès,
lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 27 March 2015;
Mr Vladimir COLAS, born on 18 February 1980 in Paris (France), having his professional address at 1370 Avenue of
the Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019, USA (“V.Colas”). hereby represented by Nicolas Gauzès, lawyer, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 24 March 2015;
Mr Lucas COLEON, born on 1 December 1989 in Paris (France), having his professional address at 1370 Avenue of
the Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019, USA (“L.Coleon”), hereby represented by Nicolas Gauzes, lawyer, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 24 March 2015;
Mr Michel FELLMANN, born on 22 June 1984 in Sursee (Switzerland), having his professional address at 1370 Avenue
of the Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019, USA (“M.Fellmann”), hereby represented by Nicolas Gauzes, lawyer,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 22 March 2015;
Mr Michael Patrick FERRAGAMO, born on 17 January 1968 in New York (USA), having his professional address at
1, Grafton Street, London W1S 4FE - United Kingdom (“MP.Ferragamo”), hereby represented by Nicolas Gauzes, lawyer,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 25 March 2015;
Ms Sara HUANG, born on 13 July 1984 in Ningbo (China), having her professional address at 1370 Avenue of the
Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019, USA (“S.Huang”), hereby represented by Nicolas Gauzès, lawyer, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 27 March 2015;
Mr Aymeric LEPEU, born on 10 December 1975 in Suresnes (France), having his professional address at 1370 Avenue
of the Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019, USA (“A.Lepeu”), hereby represented by Nicolas Gauzes, lawyer,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 24 March 2015;
Mr Zachary LEVINE, born on 14 September 1989 in Boston (USA), having his professional address at 1370 Avenue
of the Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019, USA (“Z.Levfne”), hereby represented by Nicolas Gauzes, lawyer,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 26 March 2015;
Mr Daryl LI WEIMING, born on 9 November 1982 in Singapore (Singapore), having his professional address at 1370
Avenue of the Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019, USA (“D.Li Weiming”), hereby represented by Nicolas Gauzes
lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 26 March 2015;
144415
L
U X E M B O U R G
Ms Jessica SALOMONS-BORDES, born on 13 June 1985 in New York (USA), having her professional address at 1370
Avenue of the Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019, USA (“J.Salomons-Bordes”) hereby represented by Nicolas
Gauzes, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 22 March 2015;
Mr Wilfred SMALL III. born on 19 December 1988 in New York (USA), having his professional address at 1370 Avenue
of the Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019, USA (“W.Small III”), hereby represented by Nicolas Gauzes, lawyer,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 26 March 2015;
Mr Yan TIEGEN born on 26 March 1984 in Bayonne (France), having his professional address at 1370 Avenue of the
Americas 22
nd
Floor, New York NY 10019, USA (“Y.Tiegen”). hereby represented by Nicolas Gauzès lawyer, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2015.
All the above referred proxies, signed by the proxyholder and the bureau of the meeting, will remain annexed to the
present minutes.
M.Bane A.Bébéar M. Benedetti, V.Colas, L.Coleon, M.Fellmann, MP.Ferragamo S.Huang, A.Lepeu, Z.Levine, D.Li
Weiming, J.Salomons-Bordes, W.Small III and Y.Tiegen are together referred to as the “Subscribers”.
The Subscribers declared to subscribe for the new shares in the amount set aside their respective names in the below
table, at a subscription price for each share of one United-States dollar (USD 1.-) without any share premium, and to fully
pay in cash for these shares.
Subscribers
Subscribed shares
Amount of the contribution (USD)
M. Bane . . . . . . . . . . . . . . .
Fifteen thousand (15,000) shares
Fifteen thousand United-States dollars
(USD 15,000.-)
A. Bébéar . . . . . . . . . . . . .
Twelve thousand (12,000) shares
Twelve thousand United-States dollars
(USD 12,000.-)
M. Benedetti . . . . . . . . . . .
Ninety thousand (90,000) shares
Ninety thousand United-States dollars
(USD 90,000.-)
V. Colas . . . . . . . . . . . . . .
Ninety thousand (90,000) shares
Ninety thousand United-States dollars
(USD 90,000.-)
L. Coleon . . . . . . . . . . . . .
Twelve thousand (12,000) shares
Twelve thousand United-States dollars
(USD 12,000.-)
M. Fellmann . . . . . . . . . . .
Twelve thousand (12,000) shares
Twelve thousand United-States dollars
(USD 12,000.-)
MP. Ferragamo . . . . . . . . .
Six thousand (6,000) shares
Six thousand United-States dollars
(USD 6,000.-)
S. Huang . . . . . . . . . . . . . .
Nine thousand (9,000) shares
Nine thousand United-States dollars
(USD 9,000.-)
A. Lepeu . . . . . . . . . . . . . .
Three thousand (3,000) shares
Three thousand United-States dollars
(USD 3,000.-)
Z. Levine . . . . . . . . . . . . . .
Nine thousand (9,000) shares
Nine thousand United-States dollars
(USD 9,000.-)
D. Li Welming . . . . . . . . .
Thirty thousand (30,000) shares
Thirty thousand United-States dollars
(USD 30,000.-)
J. Salomons-Bordes . . . . . . One thousand five hundred (1,500) shares
One thousand five hundred
United-States dollars (USD 1,500.-)
W. Small III . . . . . . . . . . .
Twenty-one thousand (21,000) shares Twenty-one thousand United-States dollars
(USD 21,000.-)
Y. Tiegen . . . . . . . . . . . . .
Six thousand (6,000) shares
Six thousand United-States dollars
(USD 6,000.-)
Total . . . . . . . . . . . . . . . . .
Three hundred sixteen thousand five
hundred (316,500) shares
Three hundred sixteen thousand five hundred
United-States dollars (USD 316,500.-)
The amount of three hundred sixteen thousand five hundred United States dollars (USD 316,500.-) was thus as from
that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the bureau of the meeting.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to accept said subscriptions and payments and to allot newly
issued shares according to the above mentioned subscriptions.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to approve the buy back of all the Company's shares other
than the new shares issued according to the above resolutions and one (1) share held by ASF VI GP Limited for a purchase
price of one United States dollar (USD 1.-) per share, as accepted by the relevant holders of these shares.
144416
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to decrease the share capital of the Company by an amount
of nineteen United States dollars (USD 19.-) so as to reduce it from its current amount of three hundred sixteen thousand
five hundred twenty United States dollars (USD 316,520.-) to an amount of three hundred sixteen thousand five hundred
one United States dollars (USD 316,501.-) by cancellation of the nineteen (19) shares having a nominal value of one United
States dollar (USD 1.-) each redeemed pursuant to the Fourth Resolution above.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to amend paragraph 1 of article 12 of the Company's articles
of association to reflect the above mentioned capital increase and the capital decrease.
As a consequence paragraph 1 of article 12 of the Company's articles of association shall from now on read as follows:
“ Art. 12. Share capital (paragraph 1). The issued capital of the Company is set at three hundred sixteen thousand five
hundred one United States dollars (USD 316,501.-) divided into three hundred sixteen thousand five hundred one (316,501)
Shares having a nominal value of one Unites States dollar (USD 1.-) each.”
The general meeting of shareholders further resolved to acknowledge that paragraphs 2 and 3 of article 12 of the Com-
pany's articles of association remain unchanged
The members of the bureau, stated that the present minutes have been worded in English followed by a French version;
and in case of divergences between the English and the French text the English text will prevail
There being no other business to be discussed, the meeting was adjourned at 5.00 p.m. and these minutes signed by the
members of the bureau of the meeting.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'assemblée est déclarée ouverte à 16.45 heures et est présidée par Maître Nicolas Gauzès avocat, demeurant à Luxem-
bourg (le «Président»).
Le Président désigne comme secrétaire Maître Caroline Pimpaud, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Mme Jennifer Ferrand, responsable juridique, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois cent seize mille cinq cents dollars
des Etats-Unis d'Amérique (USD 316.500,-) pour le porter de son montant actuel de vingt dollars des Etats-Unis d'Amérique
(USD 20,-) à un montant de trois cent seize mille cinq cent vingt dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 316.520,-).
2 Émission de trois cent seize mille cinq cents (316.500) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un dollar des
Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales à libérer intégralement par apport en espèces.
4 Acceptation du rachat de toutes les parts sociales de la Société hormis les nouvelles parts sociales à émettre tel que
prévu ci-dessus ainsi qu'une (1) part sociale détenue par ASF VI GP Limited pour un prix d'achat d'un dollar des Etats-
Unis d'Amérique (USD 1,-) par part sociale.
5 Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de dix-neuf dollars des Etats-Unis d'Amérique
(USD 19,-) pour le réduire de son montant actuel de trois cent seize mille cinq cent vingt dollars des Etats-Unis d'Amérique
(USD 316.520,-) à un montant de trois cent seize mille cinq cent un dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 316.501,-)
par annulation de dix-neuf (19) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-)
chacune.
6 Modification du premier paragraphe de l'article 12 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital
et la réduction de capital consécutive.
(i) Les associés présents et représentés, les mandataires des associés présents et représentés et le nombre des parts sociales
détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des associés représentés et
par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à original du présent procès-verbal.
(ii) L'intégralité du capital social émis est représentée à l'assemblée générale et tous les associés présents ou représentés
déclarent avoir dûment pris connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée.
(iii) La présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour.
Les propositions faites par le Président ont été approuvées par l'assemblée.
L'assemblée, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés, à l'unanimité, a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de
trois cent seize mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 316.500,-) pour le porter de son montant actuel
144417
L
U X E M B O U R G
de vingt dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20,-) à trois cent seize mille cinq cent vingt dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 316.520,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des associés, à l'unanimité, a décidé d'émettre de trois cent seize mille cinq cents (316.500) parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits
et privilèges que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite ont comparu:
M. Michael BANE, né le 30 avril 1980 à Boston (USA), ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue of the
Americas 22 Etage, New York NY 10019, USA («M.Bane»), représenté par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 mars 2015;
M. Alexis BEBEAR, né le 25 novembre 1989 à Paris (France), ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue of
the Americas 22 Etage, New York NY 10019, USA («A.Bébéar»), représenté par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 mars 2015;
M. Mark BENEDETTI, né le 30 septembre 1980 à Montréal (Canada), ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue
of the Americas 22 Etage, New York NY 10019, USA («M.Benedetti»), représenté par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 mars 2015;
M. Vladimir COLAS, né le 18 février 1980 in Paris (France), ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue of the
Americas 22
ème
Etage, New York NY 10019, USA («V.Colas»), représenté par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 mars 2015;
M. Lucas COLEON, né le 1 décembre 1989 à Paris (France), ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue of the
Americas 22
ème
Etage, New York NY 10019, USA («L.Coleon»), représenté par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 mars 2015;
M. Michel FELLMANN, né le 22 juin 1984 à Sursee (Suisse), ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue of the
Americas 22
ème
Etage. New York NY 10019, USA («M.Fellmann»), représenté par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 22 mars 2015;
M. Michael Patrick FERRAGAMO, né le 17 janvier 1968 à New-York, USA, ayant son adresse professionnelle au 1
Grafton Street, Londres W1S 4FE, Royaume-Uni («MP.Ferragamo») représenté par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 25 mars 2015;
Mme Sara HUANG, née le 13 juillet 1984 à Ningbo (Chine), ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue of the
Americas 22
ème
Etage, New York NY 10019, USA («S.Huang»), représentée par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 mars 2015;
M. Aymeric LEPEU, né le 10 décembre 1975 à Suresnes (France), ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue
of the Americas 22
ème
Etage, New York NY 10019, USA («A.Lepeu»), représenté par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 mars 2015;
M. Zachary LEVINE, né le 14 septembre 1989 à Boston (USA), ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue of
the Americas 22
ème
Etage, New York NY 10019, USA («Z.Levine»), représenté par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 mars 2015;
M. Daryl LI WEIMING, né le 9 novembre 1982 à Singapour (Singapour), ayant son adresse professionnelle au 1370
Avenue of the Americas 22
ème
Etage, New York NY 10019, USA («D.Li Weiming»), représenté par Nicolas Gauzès,
avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 mars 2015;
Mme Jessica SALOMONS-BORDES, née le 13 juin 1985 à New York, USA, ayant son adresse professionnelle au 1370
Avenue of the Americas 22
ème
étage, New York NY 10019. USA («J.Salomons-Bordes»), représentée par Nicolas Gauzès,
avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 22 mars 2015;
M. Wilfred SMALL III, né le 19 décembre 1988 à New York (USA), ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue
of the Americas 22
ème
Etage, New York NY 10019, USA («W.Small III»), représenté par Nicolas Gauzès, avocat, de-
meurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 mars 2015;
M. Yan TIEGEN, né le 26 mars 1984 à Bayonne (France), ayant son adresse professionnelle au 1370 Avenue of the
Americas 22
ème
Etage, New York NY 10019, USA («Y.Tiegen»), représenté par Nicolas Gauzès, en vertu d'une procu-
ration donnée le 23 mars 2015,
Les procurations susmentionnées, après avoir été signées par le mandataire et par le bureau de l'assemblée, resteront
annexées au présent procès-verbal.
M.Bane, A.Bébéar. M.Benedetti, V.Colas, L.Coleon, M.Fellmann, MP.Ferragamo, S.Huang, A.Lepeu, Z.Levine, D.Li
Weiming, J.Salomons-Bordes, W.Small III et Y.Tiegen sont collectivement dénommés les «Souscripteurs».
144418
L
U X E M B O U R G
Les Souscripteurs ont déclaré souscrire les parts sociales nouvelles pour le montant reporté à côté de leur nom respectif
dans le tableau ci-dessous, à un prix de souscription pour chaque part sociale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD
1,-), sans paiement de prime d'émission, et libérer intégralement ces parts sociales en espèces,
Souscripteurs
Parts sociales Souscrites
Montant de la contribution (USD)
M. Bane . . . . . . . . . . .
Quinze mille (15.000) parts sociales
Quinze mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 15.000,-)
A. Bébéar . . . . . . . . . .
Douze mille (12.000) parts sociales
Douze mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 12.000.-)
M. Benedetti . . . . . . . Quatre-vingt-dix-mille (90.000) parts sociales
Quatre-vingt-dix-mille dollars
des Etats-Unis d'Amérique (USD 90.000,-)
V. Colas . . . . . . . . . . .
Quatre-vingt-dix-mille (90000) parts sociales
Quatre-vingt-dix-mille dollars
des Etats-Unis d'Amérique (USD 90.000,-)
L. Coleon . . . . . . . . . .
Douze mille (12.000) parts sociales
Douze mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 12.000,-)
M. Fellmann . . . . . . . .
Douze mille (12.000) parts sociales
Douze mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 12.000,-)
MP. Ferragamo . . . . .
Six mille (6.000) parts sociales
Six mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 6.000,-)
S. Huang . . . . . . . . . .
Neuf mille (9.000) parts sociales
Neuf mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 9.000,-)
A. Lepeu . . . . . . . . . .
Trois mille (3.000) parts sociales
Trois mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 3.000,-)
Z. Levine . . . . . . . . . .
Neuf mille (9.000) parts sociales
Neuf mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 9.000,-)
D. LI Weiming . . . . . .
Trente mille (30.000) parts sociales
Trente mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 30.000,-)
J. Salomons-Bordes
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mille cinq cent (1.500) parts sociales
Mille cinq cent dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 1.500,-)
W. Small III . . . . . . . .
Vingt et un mille (21.000) parts sociales
Vingt et un mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 21.000,-)
Y. Tiegen . . . . . . . . . .
Six mille (6.000) parts sociales
Six mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 6.000,-)
Total . . . . . . . . . . . . .
Trois cent seize mille cinq cent (316.500)
parts sociales
Trois cent seize mille cinq cent dollars
des Etats-Unis d'Amérique (USD 316.500,-)
Le montant de trois cent seize mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 316.500,-) a dès lors été à la
disposition de la Société, la preuve ayant été rapportée au bureau de l'assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des associés, à l'unanimité, a décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et
d'émettre les parts sociales nouvelles conformément aux souscriptions ci-dessus mentionnées.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des associés, à l'unanimité, a décidé d'accepter le rachat de toutes les parts sociales de la Société
hormis les nouvelles parts sociales émises conformément aux résolutions ci-dessus ainsi qu'une (1) part social détenue par
ASF VI GP Limited pour un prix d'achat d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) par part sociale, tel qu'accepté
par les détenteurs de ces parts sociales.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale des associés, à l'unanimité, a décidé de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un
montant de dix-neuf dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 19,-) pour le réduire de son montant actuel de trois cent seize
mille cinq cent vingt dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 316.520,-) à un montant de trois cent seize mille cinq cent
un dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 316.501,-) par annulation de dix-neuf (19) parts sociales d'une valeur nominale
d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune rachetées conformément à la Quatrième Résolution ci-dessus.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale des associés, à l'unanimité, a décidé de modifier le 1
er
paragraphe de l'article 12 des statuts de la
Société afin de refléter l'augmentation de capital et la réduction de capital mentionnées ci-dessus.
En conséquence, le 1
er
paragraphe de l'article 12 des statuts de ta Société sera dorénavant rédigé comme suit:
144419
L
U X E M B O U R G
« Art. 12. Capital social (paragraphe 1). Le capital social émis de la Société est fixé à la somme de trois cent seize mille
cinq cent un dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 316.501,-) divisé en trois cent seize mille cinq cent un (316 501)
Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d Amérique (USD 1,-) chacune.»
L'assemblée générale des associés a ensuite décidé de prendre acte que les paragraphes 2 et 3 de l'article 12 des statuts
de la Société restent inchangés.
Les membres du bureau déclarent que le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française,
et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures et le procès verbal est signé par les membre du
bureau.
Signatures
<i>Chairman / Secretary / Scrutineeri>
Référence de publication: 2015155238/309.
(150171024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.
Naet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 47.518.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Citco C&T (Luxembourg) S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015154540/11.
(150169865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Naturmat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 31, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 198.487.
Aus der außerordentlichen Generalversammlung vom 31/08/2015 geht folgendes hervor:
1. Ernennung von einem zusätzlichen technischer Geschäftsführer wird folgende Person ernannt:
- Herr Luc TANGETEN, wohnhaft in 4960 Malmédy, Place de Beaune 146;
Der Geschäftsführer erhält begrenzte Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu handeln, alle irgendwelche mit dem
Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehenden Rechtsgeschäfte vorzunehmen und die Gesellschaft rechtverbindlich
zu verpflichten. Diese Befugnisse beschränken sich auf die ordentlichen und üblichen Entscheidungen die im Tagesgeschäft
getroffen werden müssen.
Référence de publication: 2015154542/14.
(150169532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Ken-Lux, Association sans but lucratif.
Siège social: L-8021 Strassen, 11, rue de l'independance.
R.C.S. Luxembourg F 10.519.
STATUTS
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de l’association est “KEN-LUX”. Dans la conduite de ces affaires, elle pourra être
dénommée “KEN-LUX” ou “KENYA LUXEMBOURG ASSOCIATION”.
Le siège social se situe au 11, rue de l'independance, L-8021 Strassen, Luxembourg.
Art. 2. Objet. But de l’association: Soutenir et participer au développement des projets dans les domaines d’échange
culturel entre Kenya et Luxembourg
Art. 3. Les membres fondateurs. Le nombre minimum d’associés s’élève au nombre de trois (3). Il s’agit de:
i) Nom: James Mulli
Date de naissance: 24 mars 1961
Lieu de naissance: Machakos, Kenya
Profession: Educator
Adresse: 11, rue de L’independance
144420
L
U X E M B O U R G
Nationalité: Kenya
ii) Nom: David Karonei
Date de naissance: 10 Décembre 1983
Lieu de naissance: Nairobi, Kenya
Profession: Entraîneur
Adresse: 137, rue des pommiers L-2343 Luxembourg
Nationalité: Luxembourg
iii) Nom: Samuel Muthoka Kilei
Date de naissance: 19 Décembre 1969
Lieu de naissance: Machakos, Kenya
Profession: Traducteur
Adresse: 29, Avenue de la gare, Wiltz L-9540
Nationalité: Luxembourg
Art. 4. Affiliation et cotisations. L’affiliation ou l’entrée se fait sur proposition soumise aux membres fondateurs James
Mulli, David Karonei et Samuel Muthoka Kilei, sans frais de cotisation.
La sortie de s'effectue sur demande effective auprès des membres fondateurs.
Art. 5. L’assemblée générale. L’assemblée générale est une réunion composée de tous les membres de l’association.
Les réunions se tiendront au moins une fois par an sur notification préalable du fait des administrateurs au conseil d’ad-
ministration afin de, tel que le requiert la loi luxembourgeoise:
- modifier les présents statuts
- nominer ou destituer les administrateurs au conseil d’administration
- adopter les comptes et budgets annuels
- dissoudre l’association
L’assemblée peut être convoquée par les administrateurs lorsqu'un cinquième des membres fondateurs en font la de-
mande.
Tout membre de KEN-LUX doit être informé et convoqué par tout moyen pertinent, y compris des moyens éléctroniques,
avant la-dite réunion, de l’intention du conseil d’administration quant à la tenue d’une assemblée générale. L’ordre du jour
doit être joint à cette convocation conformément à la loi.
Les résolutions de l’assemblée sont adoptées à la majorité simple des votes des membres présents.
Une fois adoptées, les résolutions sont portées à l’attention des membres fondateurs, administrateurs, membres et tiers,
par tout moyen, y compris électroniques comme à titre d’exemple, les e-mails.
Art. 6. Le conseil d’administration. KEN-LUX aura un conseil d’administration composé d’au moins trois membres
fondateurs, James Mulli, David Karonei et Samuel Muthoka Kilei. Dans cette limite, le conseil d’administration pourra
diminuer ou augmenter le nombre de ces administrateurs, y compris dans le but de redéfinir le mandat des administrateurs.
Les pouvoirs de l’association seront exercés sous l’autorité du conseil d’administration et la conduite des affaires de
KEN-LUX sera aussi faite sous la direction du conseil d'administration, sauf si la loi fait mention du contraire.
Les administrateurs sont élus lors des conseils d’administration à la majorité qualifiée des membres du conseil d’admi-
nistration. L’élection des administrateurs remplaçants ceux dont le mandat est arrivé à terme se fera en janvier de chaque
année.
Une infraction aux présents statuts ou une faute grave à l’égard de ses responsabilités vis à vis de l’association peut
causer la destitution d’un administrateur.
i. Les réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunira au minimum quatre fois lors d’une année calendaire aux lieux et heures qu'il aura
fixé au préalable. Les réunions du conseil d’administration se feront sur notification préalable de quatre jours par courrier
recommandé, voie électronique, fax, ou notification préalable sur remise en main propre ou par telephone 48 heures à
l’avance. Dans l’hypothèse d’un envois par courrier postal, transmission par facsimile, ou par voie électronique, la notifi-
cation sera tenue pour délivrée lors du dépôt en boîte aux lettres ou par système de transmission. La notification précisera
le lieu, le jour, et l’heure de la réunion. L’objet de la réunion ne sera pas spécifié.
ii. Modalité de vote et de prise de décision.
(a) Quorum. La majorité des administrateurs en poste lors d’une réunion constitue un quorum autorisant les transactions
dans la conduite des affaires lors d’une réunion du conseil d’administration. La conduite des affaires courantes ne sera
point abordée par le conseil d’administration si le quorum n’est pas réuni.
(b) Vote à la majorité simple. À moins que la loi ou les articles des présents statuts n’en stipulent autrement, les décisions
prises à la majorité simple des administrateurs présents lors d’une réunion pour laquelle le quorum est réuni seront consi-
dérées comme des décisions du conseil d’administration.
144421
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Année fiscale. Une année fiscale correspond à une année civile.
Art. 8. Prépartion des comptes annuels. Lorsque la loi le requiert, le conseil d’administration présente les comptes de la
dernière année fiscale, et le budget de la prochaine, afin qu'ils soient adoptés par l’assemblée générale.
Art. 9. Modification des statuts. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts
que si l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres.
La procédure et le mode de publication sont soumis aux règle de la loi modifiée de 1928.
Art. 10. Dissolution. En cas de dissolution, les biens de l’association sont distribués en accord avec la décision d’arbitrage
faite un arbitre choisis par le conseil d’administration.
Art. 11. Règlement des litiges. Tout litige fera l’objet d’un arbitrage à Luxembourg.
Référence de publication: 2015154948/83.
(150171202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.
Navarre Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 88.472.
Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015154543/9.
(150169881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Nestor Lux 2007 S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 138.461.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution du liquidateur du 11 septembre 2015 que le siège social de la société a été transféré au 10, rue
Antoine Jans, L-1820 Luxembourg
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015154544/11.
(150169494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Nordim S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 106.036.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 02 mars 2015i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 02 mars 2015:
L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Visaka KIMARI, au poste de délégué à la gestion journalière.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2015154546/12.
(150169659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Digital Services XXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.451.
In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of July,
before us, Maître Marc Loesch, civil law notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG), a Societas Europaea existing under the laws of Germany, registered
with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 165662 B, having its registered
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (“Rocket”),
144422
L
U X E M B O U R G
being the holder of twelve thousand four hundred ninety nine (12,499) common shares and becoming the holder of one
thousand two hundred ninety-three (1,293) new series A2 shares,
here represented by Mr David Al Mari, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Berlin, on July 29, 2015;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-
chränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court
of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Germany (hereinafter “Bambino 53. V V”),
being the holder of one (1) common share,
here represented by Mr David Al Mari, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Berlin, on July 29, 2015;
3. Insight Venture Partners VIII L.P., an exempted limited partnership incorporated and existing under the laws of the
Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC-71022,
having its registered address at 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands (hereinafter “Insight I”),
being the holder of four thousand and twelve (4,012) series A1 shares and becoming the holder of eight hundred two
(802) new series A2 shares,
here represented by Mr David Al Mari, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in New York, on July 29, 2015;
4. Insight Venture Partners (Delaware) VIII L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the
State Delaware, United States of America, registered with the Secretary of the State of Delaware under number 5289013,
having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware
19801, United States of America (hereinafter “Insight II”),
being the holder of one thousand two hundred and seventy two (1,272) series A1 shares and becoming the holder of two
hundred fifty-four (254) new series A2 shares,
here represented by Mr David Al Mari, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in New York, on July 29, 2015;
5. Insight Venture Partners (Cayman) VIII L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the
Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC-71029,
having its registered address at 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands (hereinafter “Insight III”),
being the holder of one thousand and thirty eight (1,038) series A1 shares, and becoming the holder of two hundred
eight (208) new series A2 shares,
here represented by Mr David Al Mari, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in New York, on July 29, 2015;
6. Insight Venture Partners (Co-Investors) VIII L.P., an exempted limited partnership incorporated and existing under
the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number
MC-71024, having its registered address at 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands (hereinafter
“Insight IV”),
being the holder of one hundred and forty three (143) series A1 shares and becoming the holder of twenty-nine (29)
new series A2 shares,
here represented by Mr David Al Mari, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in New York, on July 29, 2015;
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties are all the shareholders of Digital Services XXIV S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des
Sociétés) under number B 188,451 and incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, civil law residing in
Luxembourg on 18 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2383 dated 5
September 2014. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, civil law notary residing in Luxembourg, on 13 November 2014, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 313 dated 5 February 2015.
The shareholders representing the whole share capital and having waived any notice requirement, the general meeting
of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to create one (1) additional class of shares, so that the Company will hence have three (3) classes of shares,
divided into common shares (hereinafter “Common Shares”), series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”) and series
A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”).
144423
L
U X E M B O U R G
2. Increase of the Company’s share capital by an amount of two thousand five hundred eighty-six Euros (EUR 2,586.00)
so as to raise it from its current amount of eighteen thousand nine hundred sixty-five Euros (EUR 18,965.00) up to twenty-
one thousand five hundred fifty-one Euros (EUR 21,551.00) by issuing two thousand five hundred eighty-six (2,586) Series
A2 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.
3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as
follows:
“ 5.1. The Company’s share capital is set at twenty-one thousand five hundred fifty-one Euros (EUR 21,551.00), re-
presented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of
one Euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 six thousand four hundred sixty-five (6,465) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), with a nominal
value of one Euro (EUR 1.00) each, and
5.1.3 two thousand five hundred eighty-six (2,586) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares” and together with
the Series A1 Shares also referred to as “Series A Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.”
4. Amendment of article 16 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:
“ 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval of
(i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority. Any amendment of these articles of
association that materially or adversely affects the rights of the holders of Series A Shares requires the consent of all of the
holders of those Series A Shares.”
5. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mrs. Magdalena
Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to subsequently update and sign solely the share-
holders register of the Company.
6. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned
notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, so that the Company will hence
have three (3) classes of shares, divided into common shares (hereinafter “Common Shares”), series A1 shares (hereinafter
“Series A1 Shares”) and series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”).
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s share capital by an amount of two thousand
five hundred eighty-six Euros (EUR 2,586.00) so as to raise it from its current amount of eighteen thousand nine hundred
sixty-five Euros (EUR 18,965.00) up to twenty-one thousand five hundred fifty-one Euros (EUR 21,551.00) by issuing
two thousand five hundred eighty-six (2,586) new Series A2 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.
<i>Subscriptioni>
The two thousand five hundred eighty-six (2,586) Series A2 Shares have been duly subscribed as follows:
- one thousand two hundred ninety-three (1,293) Series A2 Shares have been duly subscribed by Rocket for the price
of one thousand two hundred ninety-three Euros (EUR 1,293);
- eight hundred two (802) Series A2 Shares have been duly subscribed by Insight I for the price of eight hundred two
Euros (EUR 802);
- two hundred fifty-four (254) Series A2 Shares have been duly subscribed by Insight II for the price of two hundred
fifty-four Euros (EUR 254);
- two hundred eight (208) Series A2 Shares have been duly subscribed by Insight III for the price of two hundred eight
Euros (EUR 208);
- twenty-nine (29) Series A2 Shares have been duly subscribed by Insight IV for the price of twenty-nine Euros (EUR
29).
<i>Paymenti>
The two thousand five hundred eighty-six (2,586) Series A2 Shares subscribed by Rocket, Insight I, Insight II, Insight
III and Insight IV, aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash for an aggregate amount of
two thousand five hundred eighty-six Euros (EUR 2,586).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
144424
L
U X E M B O U R G
The contribution in the amount of two thousand five hundred eighty-six Euros (EUR 2,586) is entirely allocated to the
share capital of the Company.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company so that
it shall now henceforth read as stated in the agenda of the present deed.
<i>Fourth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article 16 of the articles of association of the Company which
shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Fifth Resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well
as Mrs. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to subsequently update and sign
solely the shareholders register of the Company.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and in
case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einunddreißigsten Juli,
vor uns, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea) bestehend unter
deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB
165662 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),
Inhaberin von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen und zukünftige Inhaberin von eintau-
sendzweihundertdreiundneunzig (1.293) neuen Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn David Al Mari, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer Vollmacht vom 29. Juli 2015, ausgestellt in Berlin;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und be-
stehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der
Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland (im Folgenden „Bambino 53. V V“),
Inhaberin eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Herrn David Al Mari, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer Vollmacht vom 29 Juli 2015, ausgestellt in Berlin;
3. Insight Venture Partners VIII L.P., eine Gesellschaft (exempted limited partnership) gegründet und bestehend unter
dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), eingetragen im Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands
unter der Nummer MC-71022, mit Sitz in 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands (im Folgenden
„Insight I“),
Inhaberin von viertausendzwölf (4.012) Anteilen der Serie A1 und zukünftige Inhaberin von achthundertzwei (802)
neuen Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn David Al Mari, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer Vollmacht vom 29 Juli 2015, ausgestellt in New York;
4. Insight Venture Partners (Delaware) VIII L.P., eine Gesellschaft (limited partnership) gegründet und bestehend unter
dem Recht des Bundesstaates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen beim Secretary of the State of
Delaware unter der Nummer 5289013, mit Sitz in Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19801, Vereinigte Staaten von Amerika (im Folgenden „Insight II“),
Inhaberin von eintausendzweihundertzweiundsiebzig (1.272) Anteilen der Serie A1 und zukünftige Inhaberin von
zweihundertvierundfünfzig (254) neuen Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn David Al Mari, geschäftsansässig in Luxemburg,
144425
L
U X E M B O U R G
gemäß einer Vollmacht vom 29. Juli 2015, ausgestellt in New York;
5. Insight Venture Partners (Cayman) VIII L.P., eine Gesellschaft (limited partnership) gegründet und bestehend unter
dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), eingetragen im Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands
unter der Nummer MC-71029, mit Sitz in 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands (im Folgenden
„Insight III“),
Inhaberin von eintausendachtunddreißig (1.038) Anteilen der Serie A1 und zukünftige Inhaberin von zweihundertacht
(208) neuen Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn David Al Mari, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer Vollmacht vom 29. Juli 2015, ausgestellt in New York;
6. Insight Venture Partners (Co-Investors) VIII L.P., eine Gesellschaft (exempted limited partnership) gegründet und
bestehend unter dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), eingetragen im Registrar of Limited Partnerships of the
Cayman Islands unter der Nummer MC-71024, mit Sitz in 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands
(im Folgenden „Insight IV“),
Inhaberin von einhundertdreiundvierzig (143) Anteilen der Serie A1 und zukünftige Inhaberin von neunundzwanzig
(29) neuen Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn David Al Mari, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer Vollmacht vom 29. Juli 2015, ausgestellt in New York;
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur paraphiert
wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien sind alle Gesellschafter der Digital Services XXIV S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsre-
gister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 188.451, gegründet am 18. Juni 2014 gemäß einer
Urkunde des Notars Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 5. September 2014 im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 2383, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 13.
November 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx geändert, welche am 5. Februar 2015 im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 313, veröffentlicht wurde.
Da die Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet haben,
ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende Tagesord-
nung verhandeln:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse, sodass die Gesellschaft nunmehr drei (3) An-
teilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“), Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) und
Anteile der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“).
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von achtzehntausendneunhun-
dertfünfundsechzig Euro (EUR 18.965,00) um einen Betrag von zweitausendfünfhundertsechsundachtzig Euro (EUR
2.586,00) auf einen Betrag von einundzwanzigtausend-fünfhunderteinundfünfzig Euro (EUR 21.551,00) durch die Aus-
gabe von zweitausendfünfhundertsechsundachtzig (2.586) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1,00).
3. Anschließende Änderung des Artikels 5.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ 5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einundzwanzigtausendfünfhunderteinundfünfzig Euro (EUR
21.551,00), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”), mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1),
5.1.2 sechstausendvierhundertfünfundsechzig (6.465) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), und
5.1.3 zweitausendfünfhundertsechsundachtzig (2.586) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“ und gemeinsam
mit den Anteilen der Serie A1 auch die „Anteile der Serie A“), mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.“
4. Änderung des Artikels 16 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit bilden. Änderungen dieser Satzung, durch
welche die Rechte der Inhaber der Anteile der Serie A erheblich oder nachteilig beeinflusst werden, bedürfen der Zustim-
mung aller Inhaber dieser Anteile der Serie A.“
144426
L
U X E M B O U R G
5. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie Frau
Magdalena Staniczek zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung nachträglich zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
6. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht den unterzeichnenden Notar, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Anteilsklasse zu schaffen, sodass die Gesellschaft nunmehr
drei (3) Anteilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“), Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie
A1“) und Anteile der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“).
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von achtzehntausendneunhundertfünfundsechzig Euro (EUR 18.965,00) um einen Betrag von zweitausendfünfhundert-
sechsundachtzig Euro (EUR 2.586,00) auf einen Betrag von einundzwanzigtausendfünfhunderteinundfünfzig Euro (EUR
21.551,00) durch die Ausgabe von zweitausendfünfhundertsechsundachtzig (2.586) neuen Anteilen der Serie A2 mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die zweitausendfünfhundertsechsundachtzig (2.586) Anteile der Serie A2 wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:
- eintausendzweihundertdreiundneunzig (1.293) Anteile der Serie A2 wurden ordnungsgemäß von Rocket zum Preis
von eintausendzweihundertdreiundneunzig Euro (EUR 1.293) gezeichnet;
- achthundertzwei (802) Anteile der Serie A2 wurden ordnungsgemäß von Insight I zum Preis von achthundertzwei
Euro (EUR 802) gezeichnet;
- zweihundertvierundfünfzig (254) Anteile der Serie A2 wurden ordnungsgemäß von Insight II zum Preis von zwei-
hundertvierundfünfzig Euro (EUR 254) gezeichnet;
- zweihundertacht (208) Anteile der Serie A2 wurden ordnungsgemäß von Insight III zum Preis von zweihundertacht
Euro (EUR 208) gezeichnet;
- neunundzwanzig (29) Anteile der Serie A2 wurden ordnungsgemäß von Insight IV zum Preis von neunundzwanzig
Euro (EUR 29) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Rocket, Insight I, Insight II, Insight III und Insight IV, vorbenannt, gezeichneten zweitausendfünfhundertsech-
sundachtzig (2.586) Anteile der Serie A2 wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von zweitausend-
fünfhundertsechsundachtzig Euro (EUR 2.586).
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Die Einlage in Höhe von zweitausendfünfhundertsechsundachtzig Euro (EUR 2.586) wird vollständig dem Gesell-
schaftskapital zugeführt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie
in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie
in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Frau Magdalena Staniczek, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit
uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung nachträglich zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500.-) geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
144427
L
U X E M B O U R G
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Signé: D. Al Mari, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 août 2015. GAC/2015/6800. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 17 septembre 2015.
Référence de publication: 2015154798/292.
(150170247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.
Organic Food & More, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 185.233.
Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lionel PEYTAVIN / Vital.Med S.à r.l.
<i>Le gérant technique / Le gérant administratifi>
Référence de publication: 2015154548/11.
(150169784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Opti-Style Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9051 Ettelbruck, 62-64, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 172.903.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausend fünfzehn, den zweiten September.
Vor dem unterzeichneten Pierre PROBST, Notar mit Amtssitz in Ettelbruck.
Sind erschienen:
1. Frau Michele STAUDT, Angestellte, geboren in Ettelbruck am 17. Juni 1956, wohnhaft in L-7730 Colmar-Berg, 14,
rue de la Poste;
2. Herr Henri BOULMONT, Geschäftsführer, geboren in Luxemburg am 26. Dezember 1960 wohnhaft in L-7730
Colmar-Berg, 14, rue de la Poste;
3. Frau Beate SLOMA, Designerin, geboren in Melle (Deutschland) am 5. Mai 1967, wohnhaft in D-88085 Langenargen,
14, Krumme Jauchert (Deutschland)
4. Herr Michael GANAL, Designer, geboren in Nonnenhom (Deutschland) am 24. Oktober 1959, wohnhaft in D-88131
Lindau, Giebelmoos (Deutschland).
Welche erklären einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung «OPTI-STYLE SARL» mit Sitz in
L-9051 Ettelbruck, 62-64, Grand-rue, RCS B 172.903 zu sein, welche Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde
aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 12. November 2012, veröffentlicht im Memorial C No 3090 vom 27.
Dezember 2012.
Sodann haben die Komparenten den Notar ersucht ihre Erklärungen und Feststellungen wie folgt zu beurkunden:
1) dass das Gesellschaftskapital vorgenannter Gesellschaft zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) beträgt und
eingeteilt ist in hundert (100) Geschäftsanteile zu je hundert fünfundzwanzig Euro (125,-EUR).
2) dass die Komparenten alleinige Eigentümer der genannten Gesellschaft sind und erklären die Gesellschaft aufzulösen
und in Liquidation zu setzen.
<i>Erster Beschlussi>
- Dass die alleinigen Anteilhaber, welche das gesamte Gesellschaftskapital halten, die Auflösung und Liquidation der
Gesellschaft beschliessen; Sie bestimmen sich selbst als Liquidatoren der Gesellschaft
- und erklären in dieser Eigenschaft dass, nachdem die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft eingestellt wurde, alle Aktiva
und Passiva auf die Komparenten als einzige Eigentümer sämtlicher Anteile andurch übertragen werden, welche alle
Schulden der aufgelösten Gesellschaft beglichen haben und sich solidarisch und unteilbar verpflichten, für alle, bis jetzt
nicht bekannten Verbindlichkeiten persönlich zu haften;
144428
L
U X E M B O U R G
- Dass die Gesellschaft als liquidiert zu betrachten ist;
- Dass allen Verwaltern vollumfängliche Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate gewährt wird;
- Dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren am Gesellschaftssitz verwahrt
werden;
<i>Erklärung der Unterzeichneri>
Die Gesellschafter erklären hiermit, dass er der dinglich Begünstigte der Gesellschaft, die Gegenstand dieser Urkunde
ist, im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 in der abgeänderten Fassung, und bescheinigt, dass die Mittel / Güter /
Rechte die das Kapital der Gesellschaft bilden nicht von irgendeiner Tätigkeit, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches
oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der
Drogenabhängigkeit oder einer terroristische Handlung stammen im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als
Finanzierung des Terrorismus definiert).
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbruck in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienen, dem Notar nach Namen gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Michele STAUDT, Henri BOULMONT, Beate SLOMA, Michael GANAL, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 4 septembre 2015. Relation: DAC/2015/14497. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung
im Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 16. September 2015.
Référence de publication: 2015154550/56.
(150169633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Orion Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 21.550,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 111.055.
En date du 31 août 2015, l'Associé Unique de la Société a pris connaissance de la démission de Mr. Johannes Laurens
de Zwart de son poste de gérant B avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ORION FINANCE S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015154551/14.
(150169712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
NB Renaissance Partners MHF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 193.658.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 9 mars 2015i>
En date du 9 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter les démissions de Monsieur Christian NEIRA et Mesdames Yonah FEDER et Kimberly MARLAR de leur
mandat de gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Francesco MOGLIA, né le 27 mai 1968 à Rome, Italie, résidant professionnellement à l'adresse
suivante: 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet Immédiat et ce
pour une durée indéterminée;
- de nommer Madame Teale LONG, née le 21 septembre 1985 à New York, Etats-Unis d'Amérique, résidant profes-
sionnellement à l'adresse suivante: 605, Third Avenue, 22
nd
Floor, 10158 New York, Etats-Unis d'Amérique, en tant que
nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;
144429
L
U X E M B O U R G
- de nommer KPMG Luxembourg, une société coopérative, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant l'adresse suivante: 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B149133, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société
avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui
statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2015.
NB Renaissance Partners MHF S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015155012/27.
(150170441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.
Palenque S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.053.
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 7 septembre 2015i>
- Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé M.B.A., né le 8 octobre 1961 à Metz, France, demeurant professionnel-
lement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration pendant toute la
durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2021.
Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2015.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2015154552/13.
(150169577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Panthelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 146.896,88.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 188.460.
L'adresse de Monsieur Jason Richard Long, associé de la Société, a changé et est désormais au 1 The Causeway, Boxford,
Sudbury, CO10 5JR, Royaume-Uni.
Eddy Perrier
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015154553/12.
(150169531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Rodenbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 177.526.
<i>Protokoll über einen Gesellschafterbeschluss ohne Versammlung im schriftlichen Verfahren der RODENBACH SARLi>
Anwesende Gesellschafter:
ALPHA INDUSTRIAL HOLDING S.A. (AIH)
vertreten durch den Verwaltungsratsvorsitzenden Herrn Marcellino Graf HOENSBROECH und die Aktionäre Axel
KÖNIG und Jörg SCHRÖDER
(eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés unter B 129732)
RODENBACH Sàrl (ROD)
vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Mirko FISCHER
(eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés unter B 177526)
Die Gesellschafter beschließen unter Verzicht auf alle gesetzlichen und/oder satzungsmäßigen Form- und Fristvors-
chriften für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren einstimmig über
nachstehenden Sachverhalt wie folgt:
- Herrn Benjamin ANDREASEN, beruflich wohnhaft in 1, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg, wird mit
sofortiger Wirkung nach Eintragung im Handelsregister zum Geschäftsführer berufen.
144430
L
U X E M B O U R G
Herr Andreasen vertritt die Gesellschaft mit einzelner Vertretungsberechtigung.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Luxemburg, den 10.09.2015.
ALPHA INDUSTRIAL HOLDING S.A / - / -
Marcellino Graf von und zu HOENSBROECH / Axel KÖNIG / Jörg SCHRÖDER
<i>- / AKTIONÄRE / -
i>RODENBACH SARL
Mirko FISCHER
Référence de publication: 2015155750/29.
(150171534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.
Plastic Logic Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 151.999.
Les statuts coordonnés au 30 juillet 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015154559/11.
(150170000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Prater S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 115.776.
Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015154561/9.
(150169912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Prestige Motor Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 173.816.
Le bilan au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2015154563/11.
(150170037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Propharma-Developpement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.177.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue au siège social le 19 juin 2015 à 10:30i>
<i>Première résolutioni>
Le soussigné Monsieur Vincent J. DERUDDER, né le 23 février 1948 à Clichy La Garenne (France), demeurant au 20,
rue d'Amsterdam L-1126 Luxembourg, présente sa démission du mandat de Gérant de la société PROPHARMA-DEVE-
LOPPEMENT Sàrl, enregistrée au Registre des Commerces et des Sociétés à Luxembourg, sous la référence B139 177,
dont le siège social est situé à Luxembourg, 19 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
144431
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer comme Gérant Monsieur Eric Pierre VANCON, né le 27 février 1961 à
Gérardmer (France), demeurant au 20, rue d'Amsterdam L-1126 LUXEMBOURG.
Le mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire 2020, qui statuera sur les comptes annuels
de l'année 2019.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PROPHARMA DEVELOPPEMENT SARL
Référence de publication: 2015155719/23.
(150170873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.
Mobilu, Société à responsabilité limitée,
(anc. Axelline S.à r.l.).
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 151.181.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kehlen, le 17 septembre 2015.
Référence de publication: 2015155001/10.
(150170250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.
Mobilu, Société à responsabilité limitée,
(anc. Axelline S.à r.l.).
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 151.181.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kehlen, le 17 septembre 2015.
Référence de publication: 2015155002/10.
(150170251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.
Mousel's Cantine S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1343 Luxembourg, 46, Montée de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 20.421.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 17 septembre 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015155003/10.
(150170202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.
Network Technology & Communication Expertise, Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 62, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 143.201.
Le siège social de la société, actuellement à L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage, est transféré à L-2560
Luxembourg, 62, rue de Strasbourg.
Luxembourg, le 17 septembre 2015.
NETWORK TECHNOLOGY & COMMUNICATION EXPERTISE
Référence de publication: 2015155007/11.
(150170463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
144432
Abbey Barn Holdings S.A.
ABF Preston Park S.à r.l.
Association Luxembourgeoise des Parents d'Elèves de l'Education Differenciée
Athalia VI B
Axelline S.à r.l.
Axelline S.à r.l.
Digital Services XXIV S.à r.l.
K Alpha S.A.
Ken-Lux
Lesing Fabfab S.à r.l.
Margaux Immobilière S.à r.l.
McKesson Information Solutions Capital S.à r.l.
McKesson Information Solutions Finance S.à r.l.
Mill Luxembourg Holdings 1
Mill Luxembourg Holdings 2
Mobilu
Mobilu
MOSSACK FONSECA & Co. (Luxembourg)
MOSSFON (Luxembourg)
Mousel's Cantine S. à r. l.
MT Projet Lux S.à r.l.
Naet S.A.
Naropère S.à r.l.
Naturmat S.à r.l.
Navarre Finances S.A.
NB Renaissance Partners MHF S.à r.l.
Nemset S.A.
Nestor Lux 2007 S.à r.l.
NetJets Luxembourg Holding Company S.à r.l.
Network Technology & Communication Expertise
Nordim S.A.
Opti-Style Sàrl
Organic Food & More, S.à r.l.
Orion Finance S.à r.l.
Palenque S.A., SPF
Panthelux S.à r.l.
Plastic Logic Luxembourg S.à r.l.
Prater S.à r.l.
Prestige Motor Holdings S.A.
Propharma-Developpement S.à r.l.
Rodenbach S.à r.l.
Saint Amand GP