This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2789
9 octobre 2015
SOMMAIRE
Berlin (Bridge) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133826
Bishop Infrastructure Luxembourg S.à r.l. . .
133855
C4Industries S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133868
Caparmor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133857
Capital Inn Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
133826
Carnot Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
133858
Carnot Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
133857
CBV GP S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133860
Central European Participation II S.à r.l. . . .
133826
Chateaudun Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
133861
Climmolux Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133826
CM Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133861
Cofima Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133861
Cofima III S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133862
Cofima I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133862
Cofima SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133862
Cofinimmo Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
133863
"Commerz Real Fund Management S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133854
Commonwealth Luxembourg Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133855
Comptoir Immobilier Luxembourgeois . . . . .
133863
Comptoir Immobilier Luxembourgeois . . . . .
133863
Concord Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
133856
Consulting & Co. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133864
Corber Enterprises S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
133856
Cotinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133864
CSHV European Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
133865
CT Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
133865
DataEurope Founders S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
133868
Delfi Asset S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133868
Dusseldorf (Bridge) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
133869
Dynamics Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133869
DyStar Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133869
Evi Lux I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133828
Evi Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133828
HLD EUROPE S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133826
KPS Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133869
Lenmorneftegaz Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133868
Maison Pétrole Beta (Luxembourg) . . . . . . . .
133860
Maison Pétrole Delta (Luxembourg) . . . . . . . .
133861
Mominvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133872
Moneylift S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133872
New Europe Property Holdings (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133872
NN Lux Insurance International S.A. . . . . . . .
133864
Pfaudler Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133862
Stage Vision S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133857
Turchese Trading e Investimentos S.A. . . . . . .
133865
Winsley S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133856
Yalino Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
133863
133825
L
U X E M B O U R G
Berlin (Bridge) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 119.220.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143251/9.
(150156888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Capital Inn Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 162.658.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143295/9.
(150156741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Central European Participation II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 120.155.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143297/9.
(150156755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Climmolux Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 182.191.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2015.
Référence de publication: 2015143305/10.
(150156759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
HLD EUROPE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 198.109.
L'an deux mille quinze, le troisième jour du mois d'août;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling,
agissant en qualité de mandataire (le “Mandataire”) du représentant du gérantassocié-commandité (le “Gérant”) de “HLD
EUROPE S.C.A.”, une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 198106, (la “Société”),
en vertu d'un pouvoir lui conféré par décisions du Gérant, prises en date du 30 juillet 2015 (les “Résolutions”); une copie
des Résolutions, après avoir été signée “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera formalisée.
Lequel Mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:
1. La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 juin 2015, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
133826
L
U X E M B O U R G
et les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 16 juillet 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2. Le capital social souscrit est fixé à cent deux millions six cent soixante et onze mille trois cent vingt-huit euros
(102.671.328,- EUR), divisé en cent deux millions six cent soixante et onze mille trois cent vingt-huit euros (102.671.328)
Actions, réparties entre les catégories suivantes:
- 1 (une) action de commandité ayant une valeur nominale d'un euro (1,-EUR), dont les caractéristiques sont décrites
dans les présents Statuts, souscrites en totalité et intégralement libérées (l’“Action de Commandité”);
- 102.421.327 actions de commanditaire et de préférence ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR), dites de
catégorie A, dont les caractéristiques sont décrites dans les présents Statuts, souscrites en totalité et intégralement libérées
(les “Actions A”); et
- 250.000 actions de commanditaire et de préférence ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR), dites de catégorie
B, dont les caractéristiques sont décrites dans les présents Statuts, souscrites en totalité et intégralement libérées (les
“Actions B”).
3. Conformément à l'article 10 des Statuts, le capital autorisé est fixé à un montant de vingt-cinq millions d’euros
(25.000.000,- EUR), représenté par vingt-cinq millions (25.000.000) Actions A avec une valeur nominale d'un euro (1,-
EUR) chacune.
Pendant une période de 18 mois à compter de la date de publication des présents Statuts ou, le cas échéant, de la décision
de renouveler ou d’augmenter le capital autorisé conformément à cet article, le Gérant est autorisé à émettre des Actions
A dans les limites du capital autorisé au profit des Actionnaires et aux conditions qu'il estimera opportunes lui permettant
notamment de procéder à cette émission sans qu'un droit préférentiel de souscription aux actions nouvellement émises ne
soit réservé aux Actionnaires existants. Nonobstant ce droit, le Gérant ne pourra procéder à l’émission d’Actions A nouvelles
que dans le strict respect des dispositions du Pacte.
Cette autorisation pourra être renouvelée par une décision de l’assemblée générale des Actionnaires, prise aux conditions
requises pour la modification des Statuts, à chaque fois pour une période ne pouvant excéder une durée de cinq (5) ans.
4. Par résolution du 30 juillet 2015, le Gérant a réalisé une augmentation de capital à hauteur de dix millions six cent
six mille soixante euros (10.606.060,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de cent deux
millions six cent soixante et onze mille trois cent vingt-huit euros (102.671.328,- EUR) à cent treize millions deux cent
soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-huit euros (113.277.388,- EUR), par la création de dix millions six cent six
mille soixante (10.606.060) Actions A, émises avec une prime d’émission de trente-deux cents (0,32 EUR) par action (les
“Actions Nouvellement Emises”).
5. Les Actions Nouvellement Emises ont été souscrites pour les souscripteurs énoncés dans les Résolutions. Les Actions
Nouvellement Emises ont été libérées intégralement, ensemble avec la prime d'émission, par les souscripteurs prédits
moyennant un apport en numéraire, preuve en a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressément.
6. En conséquence d'une telle augmentation du capital, l'article 8 des Statuts est modifié et se lit désormais comme suit:
“ Art. 8. Capital social. Le capital social s'élève à la somme de cent treize millions deux cent soixante-dix-sept mille
trois cent quatre-vingt-huit euros (113.277.388,- EUR).
Il est divisé en cent treize millions deux cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-huit (113.277.388) Actions,
réparties entre les catégories suivantes:
- 1 (une) action de commandité ayant une valeur nominale d'un euro (1,-EUR), dont les caractéristiques sont décrites
dans les présents Statuts, souscrites en totalité et intégralement libérées (l’“Action de Commandité”);
- 113.027.387 (cent treize millions vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-sept) actions de commanditaire et de préfé-
rence ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR), dites de catégorie A, dont les caractéristiques sont décrites dans les
présents Statuts, souscrites en totalité et intégralement libérées (les “Actions A”); et
- 250.000 (deux cent cinquante mille) actions de commanditaire et de préférence ayant une valeur nominale d'un euro
(1,- EUR), dites de catégorie B, dont les caractéristiques sont décrites dans les présents Statuts, souscrites en totalité et
intégralement libérées (les “Actions B”).”
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à cinq mille cinq cent cinquante
euros (5.550,-EUR).
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile,
ledit Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 06 août 2015. 2LAC/2015/18107. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
133827
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 19 août 2015.
Référence de publication: 2015144137/81.
(150157653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.
Evi Lux I S.A., Société Anonyme,
(anc. Evi Lux I S.à r.l.).
Capital social: EUR 181.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 191.481.
In the year two thousand and fifteen, the thirtieth day of July,
before Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange/Attert, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of EVI Lux I S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 191481 and having a
share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) (the Company). The Company was incorporated on 24
October 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 3591 on 27 November 2014. The articles of asso-
ciation of the Company (the Articles) have been amended by a notarial deed dated 12 January 2015 of Maître Francis
Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 414 of February 14,2015,
There appeared:
Institutional Investment Partners GmbH, acting in its capacity as management company for AEW Europe Value Inves-
tors, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Hamburger Allee 45, D-60486
Frankfurt am Main, Germany, and registered with the commercial register (Handelsregister) of the local court (Amtsgericht)
of Frankfurt am Main under the number HRB 90129 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Annick Braquet, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy,
dated July 30, 2015.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that all the 125 (one hundred and twenty-five) shares of the Company, having a nominal value of EUR 100 (one
hundred Euros) each, representing the entire share capital of the Company amounting to EUR 12,500 (twelve thousand
five hundred Euros), are present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate
on all the items on the agenda;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
(1) waiver of the convening notice;
(2) increase of the share capital of the Company by a nominal amount of EUR 168,500 (one hundred sixty-eight thousand
five hundred Euros), by way of creation and issue of 1,685 (one thousand six hundred eighty-five) shares, having a nominal
value of EUR 100 (one hundred Euros) each;
(3) subscription of the share capital increase specified under item 2. above by the Sole Shareholder by way of conversion
of an amount of EUR 168,500 (one hundred sixty-eight thousand five hundred Euros) out of the distributable reserves of
the non-share contribution account (compte des actionnaires non remunérées pas des parts sociales) of the Company;
(4) change of the corporate form of the Company from its current form of a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) into a public limited liability company (société anonyme) and change of the corporate name of the
Company from “EVI Lux I S.à r.l.” into “EVI Lux I S.A.”;
(5) acknowledgment of the resignation Bruno Bagnouls and Jean-Philippe Fiorucci as managers of the Company and
granting of discharge;
(6) reclassification of the existing 1,810 (one thousand eight hundred and ten) shares of the Company into 310 (three
hundred and ten) ordinary shares (the Ordinary Shares), 150 (one hundred and fifty) shares of class A (the Class A Shares),
150 (one hundred and fifty) shares of class B (the Class B Shares), 150 (one hundred and fifty) shares of class C (the Class
C Shares), 150 (one hundred and fifty) shares of class D (the Class D Shares), 150 (one hundred and fifty) shares of class
E (the Class E Shares), 150 (one hundred and fifty) shares of class F (the Class F Shares), 150 (one hundred and fifty)
shares of class G (the Class G Shares), 150 (one hundred and fifty) shares of class H (the Class H Shares), 150 (one hundred
133828
L
U X E M B O U R G
and fifty) shares of class I (the Class I Shares) and 150 (one hundred and fifty) mandatory redeemable preferred shares (the
MRPS) of the Company, with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each;
(7) amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety in order to reflect, among
other things, but not limited to, the changes set out under the above agenda items;
(8) appointment of Jean-Philippe Fiorucci, Bruno Bagnouls and Damien Schuind as directors of the Company for a term
which will expire after the annual general meeting to be held in 2016, approving the annual accounts for the financial year
ending on 31 December 2015;
(9) appointment of PricewaterhouseCoopers, société cooperative, as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé)
of the Company and determination of the term of its mandate;
(10) amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to
any directors of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, to individually
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued and converted shares in the share register of the
Company and the registration of the changes required by the matters set out above; and
(11) miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the
convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having
perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 168,500 (one hundred sixty-
eight thousand five hundred Euros) in order to bring the Company's share capital from its current amount of EUR 12,500
(twelve thousand five hundred Euros), represented by 125 (one hundred and twenty-five) shares having a nominal value
of EUR 100 (one hundred Euros) each, to an amount of EUR 181,000 (one hundred eighty-one thousand Euros) by way
of the issuance of 1,685 (one thousand six hundred eighty-five) new shares of the Company having a nominal value of
EUR 100 (one hundred Euros) each (the New Shares).
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital increase
referred to under the second resolution above as follows:
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder represented as stated above, intervenes at the Meeting and hereby declares to subscribe to the
New Shares, having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each.
The Meeting resolves and the Sole Shareholder acknowledges that the New Shares shall be fully paid-up by way of the
conversion of an amount of EUR 92,478,800 (ninety-two million four hundred seventy-eight thousand eight hundred Euros)
out of the Company's account 115 (apport en capitaux propres non rémunéré par des titres) as defined in the Luxembourg
standard Chart of Accounts (the Account 115) (the Contribution).
The Contribution made to the Company shall be allocated as follows:
(i) EUR 168,500 (one hundred sixty-eight thousand five hundred Euros) to the share capital account of the Company;
(ii) EUR 92,310,300 (ninety-two million three hundred ten thousand three hundred Euros) to the share premium account
of the Company (the Share Premium Account).
The Meeting acknowledges that, on the basis of the interim accounts of the Company dated April 30, 2015 (the Interim
Accounts) supported by a certificate issued on July 30, 2015 on behalf of the managers of the Company (the Valuation
Certificate) and a certificate of the managers of the Company dated July 30, 2015 (the Management Certificate), the
Company has sufficient distributable reserves in the Account 115 in order to fully pay-up the New Shares.
The Interim Accounts, the Valuation Certificate and the Management Certificate, after having been signed ne varietur
by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to
be registered with it.
The Meeting acknowledges that, as a result of the above, the share capital of the Company is set at EUR 181,000 (one
hundred eighty-one thousand Euros), represented by 1,810 (one thousand eight hundred and ten) shares having a nominal
value of EUR 100 (one hundred Euros) each.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to change the current corporate form of the Company from the one of a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) into the one of a public limited liability company (société anonyme), having a
share capital of EUR 181,000 (one hundred eighty-one thousand Euros), divided into 1,810 (one thousand eight hundred
133829
L
U X E M B O U R G
and ten) shares, having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each, with such shares being all in registered
form.
Pursuant to article 26-1 and article 31-1 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the
valuation of the Company has been the subject of a report dated 30 July 2015 prepared by Grant Thornton Lux Audit S.A.,
a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 89a, Pafebruch,
L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 43298 as independent auditor (cabinet de révision agréé), and the conclusion of such report is as follows:
“Based on our work, no fact came to our attention, which will make us believe that the global value of the net shareholders'
equity of the Company as at April 30, 2015, after the proposed capital increase of 168.500, - EUR, is not in relation with
the amount of the minimum share capital of a public limited liability company (Société anonyme)”
The said report, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Meeting further resolves to change the name of the Company from “EVI Lux I S.à r.l.” into “EVI Lux I S.A.” and
to subsequently amend the Articles to reflect such change of name which shall henceforth read as per the amended and
restated articles of association of the Company adopted under the seventh resolution below.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting acknowledges the resignation of Bruno Bagnouls and Jean-Philippe Fiorucci from their mandates as mem-
bers of the board of managers of the Company, with immediate effect.
The Meeting resolves to grant discharge to Bruno Bagnouls and Jean-Philippe Fiorucci from their liability for the
performance of their duties until the date hereof, to the extent permitted by law.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to reclassify the existing 1,810 (one thousand eight hundred and ten) shares of the Company into
various new classes of shares, as follows:
- 310 (three hundred and ten) of the existing shares into 310 (three hundred and ten) ordinary shares (the Ordinary
Shares);
- 150 (one hundred and fifty) of the existing shares into 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class A (the Class
A Shares);
- 150 (one hundred and fifty) of the existing shares into 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class B (the Class
B Shares);
- 150 (one hundred and fifty) of the existing shares into 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class C (the Class
C Shares);
- 150 (one hundred and fifty) of the existing shares into 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class D (the Class
D Shares);
- 150 (one hundred and fifty) of the existing shares into 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class E (the Class
E Shares);
- 150 (one hundred and fifty) of the existing shares into 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class F (the Class
F Shares);
- 150 (one hundred and fifty) of the existing shares into 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class G (the Class
G Shares);
- 150 (one hundred and fifty) of the existing shares into 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class H (the Class
H Shares);
- 150 (one hundred and fifty) of the existing shares into 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class I (the Class
I Shares); and
- 150 (one hundred and fifty) of the existing shares into 150 (one hundred and fifty) mandatory redeemable preferred
shares (the MRPS),
each having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros).
The Meeting further resolves to proportionally reclassify the existing Share Premium Account into an MRPS premium
account (the MRPS Premium Account) and subsequently reallocate an amount of EUR 83,969,075 (eighty-three million
nine hundred sixty-nine thousand seventy-five Euros of the share premium from the Share Premium Account to the MRPS
Premium Account.
The Meeting expressly acknowledges that as a consequence of the above reclassification, an amount of EUR 8,341,225
(eight million three hundred forty-one thousand two hundred twenty-five Euros) will remain allocated to the Share Premium
Account.
<i>Seventh resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend and fully restate the Articles, so that they
read henceforth as follows:
133830
L
U X E M B O U R G
“ARTICLES OF ASSOCIATION
<i>Definitionsi>
Alphabet Shares has the meaning given to it in article 5;
Alphabet Shareholder has the meaning given to it in article 5;
Articles means the articles of association of the Company, as amended from time to time;
Available Amount shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased
by (i) any freely distributable reserves and/or share premium and (ii) as the case may be, by the amount of the capital
reduction and legal reserve reduction relating to the class of Alphabet Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses
(included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requi-
rements of the applicable laws or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the
avoidance of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares
pursuant to the Articles and (iv) any Profit Entitlement so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Whereby:
- AA = Available Amount.
- NP = net profits (including carried forward profits).
- P = any freely distributable share premium and reserves.
- CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Alphabet Shares to be
cancelled.
- L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
- LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Companies Act or of the Articles.
- OD = any annual fixed dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles.
- PE = Profit Entitlement (the annual fixed dividends to which the holder(s) of the Alphabet Shares and the holder(s) of
the MRPS is are entitled pursuant to the Articles.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by
the Sole Director or, in case of plurality of Directors, the Board of Directors of the Company in good faith and with the
view to the Company's ability to continue as a going concern.
Available Liquidities shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining
maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any
receivable which in the opinion of the Board of Directors will be paid to the Company in the short term less any indebtedness
or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating
to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of
other kind held by the Company;
Board has the meaning given to it in article 4;
Business Day means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open in Luxembourg-City
for normal business;
Cancellation Amount shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period
(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities
relating to the relevant Class Period (or New Period);
Chairman has the meaning given to it in article 15;
Class Period shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the Class
E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period and the Class I Period;
Companies Act means the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended;
Company means EVI Lux I S.A.;
Directors means the members of the Board and Director means any of them;
Fixed Alphabet Share Dividend has the meaning given to it in article 25;
Fixed Preferred MRPS Dividend has the meaning given to it in article 25;
General Meetings means the general meetings of Shareholders of the Company and General Meeting means any of
them;
Interim Accounts shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date;
Interim Account Date shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the date
of the repurchase and cancellation of the relevant class of Alphabet Shares;
Instruments has the meaning given to it in article 5.1;
Investment means the shareholder loans granted from time to time by the Company to its subsidiaries to the extent
financed by the MRPS;
133831
L
U X E M B O U R G
Laws means the laws and regulations of Luxembourg in force from time to time;
Legal Entity has the meaning given to it in article 14;
Legal Reserve has the meaning given to it in article 25;
Luxembourg means the Grand Duchy of Luxembourg;
Maturity Date has the meaning given to it in article 10;
MRPS has the meaning given to it in article 5;
MRPS Holder has the meaning given to it in article 5;
New Period has the meaning given to it in article 10:
Ordinary Shareholder has the meaning given to it in article 5;
Ordinary Shares has the meaning given to it in article 5;
Period has the meaning given to it in article 5.1;
Profit Entitlement shall mean the dividend entitlement on the classes of Alphabet Shares and the MRPS not being
redeemed;
Redemption Price has the meaning given to it in article 10;
Shareholders has the meaning given to it in article 5;
Share Premium Accounts has the meaning given to it in article 5;
Shares means all the issued and outstanding shares of the Company with a nominal value of EUR 100 each (one hundred
Euro) and carrying the rights and obligations set forth in the Articles;
Sole Director has the meaning given to it in article 4; and
Sole Shareholder has the meaning given to it in article 1.
Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of “EVI Lux
I S.A.” (the Company).
The Company may have one Shareholder (the Sole Shareholder) or more Shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Any reference to the Shareholders in the Articles of the Company shall be a reference to the Sole Shareholder of the
Company if the Company has only one Shareholder.
Art. 2. Corporate object. The sole purpose of the company is the direct and / or indirect holding of participations in
companies whose purpose is the acquisition, development and management of real property and equivalent rights, which
are located in a state of the EEA or a full member state of the OECD.
The Company may otherwise perform all the activities that are directly or indirectly related to the corporate purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred within the boundaries of the municipality of the city of Luxembourg by a resolution of the board
of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole
Director.
The Board or, as the case may be, the Sole Director, shall further have the right to set up branches, offices, administrative
centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.
Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary
circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 181,000 (one hundred eighty-one thousand Euros), and
is represented by 1,810 (one thousand eight hundred ten) Shares, fully paid-up, divided into:
- 310 (three hundred and ten) ordinary shares (the Ordinary Shares);
- 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class A (the Class A Shares);
- 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class B (the Class B Shares);
- 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class C (the Class C Shares);
- 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class D (the Class D Shares);
- 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class E (the Class E Shares);
- 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class F (the Class F Shares);
- 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class G (the Class G Shares);
- 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class H (the Class H Shares);
133832
L
U X E M B O U R G
- 150 (one hundred and fifty) alphabet shares of class I (the Class I Shares and together with the alphabet shares of class
A to H, the Alphabet Shares); and
- 150 (one hundred and fifty) mandatory redeemable preferred shares (the MRPS, and together with the Ordinary Shares
and the Alphabet Shares, the Shares)
with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each and carrying the rights and obligations set forth in these
Articles.
The holders of the Ordinary Shares are referred to as Ordinary Shareholders, and individually as Ordinary Shareholder.
The holders of the Alphabet Shares are referred to Alphabet Shareholders, and individually as Alphabet Shareholder.
The holders of the MRPS are referred to as MRPS Holders (and together with the Ordinary Shareholders and the Alphabet
Shareholders, the Shareholders), and individually as MRPS Holder.
In addition to the issued share capital, the Company shall maintain share premium accounts to which any premium
allocated to the respective class of Shares issued or to be issued is booked (the Share Premium Accounts). The amount of
the Share Premium Accounts may be used to provide for the payment of any Shares, which the Company may repurchase
from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders in the form of a dividend
or to allocate funds to the legal reserve. The Company shall maintain a share premium account for each class of issued
shares.
Any contribution in cash or in kind made as share premium in connection with the subscription of a specific class of
shares will be booked in the share premium account of the relevant class of shares and is available only (i) for the purpose
of distributions, whether by dividend, share redemption or otherwise, to the holders of the respective class of shares and
(ii) to be incorporated in the share capital to issue shares corresponding to the respective class of shares only.
For the avoidance of doubt, the Share Premium Accounts shall constitute freely distributable reserves of the Company.
The General Meeting is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a
payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting, within the
limit prescribed by Luxembourg law (the Capital Surplus). A capital contribution without the issuance of new shares shall
be booked in a capital surplus account in accordance with Luxembourg law (the Capital Surplus Account). The Company
shall maintain a Capital Surplus Account for each class of issued shares.
Any contribution in cash or in kind made as Capital Surplus in connection with the subscription of a specific class of
shares will be booked in the Capital Surplus Account of the relevant class of shares and is available only (i) for the purpose
of distributions, whether by dividend, share redemption or otherwise, to the holders of the respective class of shares and
(ii) to be incorporated in the share capital to issue shares corresponding to the respective class of shares only.
For the avoidance of doubt, Capital Surplus Accounts shall constitute freely distributable reserves of the Company.
5.1 Authorisation for the Board to increase the share capital
Size of the authorisation
The authorised capital of the Company is set at EUR 500,000 (five hundred thousand Euros) represented by a maximum
of 5000 (five thousand) shares, each with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros).
Terms of the authorisation
The Board is authorised, during a period starting on 30 July 2015 and expiring on the fifth anniversary of such date (the
Period), to increase the current share capital up to the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to
time, (i) by way of issuance of shares in consideration for a payment in cash, (ii) by way of issuance of shares in consideration
for a payment in kind and (iii) by way of capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and
capital surplus, with or without an issuance of new shares.
The Board is authorised to determine the terms and conditions attaching to any subscription and issuance of shares
pursuant to the authority granted under this Article 5.1, including by setting the time and place of the issue or the successive
issues of shares, the issue price, with or without a share premium, and the terms and conditions of payment for the shares.
The Board is authorised to (i) during the Period, (a) issue convertible bonds, or any other convertible debt instruments,
bonds carrying subscription rights or any other instruments entitling their holders to subscribe for or be allocated with
shares, such as, without limitation, warrants (the Instruments), and (b) issue shares subject to and effective as of the exercise
of the rights attached to the Instruments, until, with respect to both items (a) and (b), the amount of increased share capital
that would be reached as a result of the exercise of the rights attached to the Instruments is equal to the authorised share
capital, and (ii) issue shares pursuant to the exercise of the rights attached to the Instruments until the amount of increased
share capital resulting from such issuance of shares is equal to the authorised share capital, at any time, whether or not
during the Period; provided that the Instruments are issued during the Period. The issuance of the shares following the
exercise of the rights attached to the Instruments may be carried out by a payment in cash, a payment in kind or a capita-
lisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus.
The Board is authorised to determine the terms and conditions of the Instruments, including the price, the interest rate,
the exercise rate, conversion rate or the exchange rate, and the repayment conditions, and to issue such Instruments.
Authorisation to cancel or limit the pre-emptive rights
133833
L
U X E M B O U R G
The Board is authorised to cancel or limit the pre-emptive rights of the shareholders set out in the Companies Act, as
reflected in Article 5, in connection with an issue of new shares and Instruments made pursuant to the authority granted
under this Article 5.1.
Recording of capital increases in the Articles
Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect each increase in share capital pursuant to the use of the
authorisation granted to the Board under this Article 5 and the Board shall take or authorise any person to take any necessary
steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amendments to the Articles before a notary.
Art. 6. Shares. The Shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered
form.
A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder.
Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by
it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of Shares and the dates of such transfers. The ownership of the
Shares will be established by the entry in this register.
The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as sole owner
in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and
a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
The Ordinary Shares and the Alphabet Shares each carry one voting right at a General Meeting.
The Company may redeem its Shares within the limits set forth by the law.
The MRPS and the Alphabet Shares are redeemable shares issued under article 49-8 of the Companies Act, and can be
redeemed in accordance with the Companies Act and the terms of these Articles only.
The MRPS are non-voting shares in accordance with articles 44 to 47 of the Companies Act. In accordance with article
46 of the Companies Act, each MRPS is nevertheless entitled to one vote in every General Meeting called upon to deal
with the following matters:
- The issue of new shares carrying preferential rights;
- The determination of the preferential cumulative dividend attaching to the MRPS;
- The conversion of MRPS into Alphabet Shares or Ordinary Shares;
- The reduction of the capital of the Company;
- The change of the corporate object of the Company;
- The issue of convertible bonds;
- The dissolution of the Company before its term; and
- The transformation of the Company into a company of another legal form.
The MRPS shall also carry one vote each with respect to any proposed change to the rights, preferences or privileges
of the MRPS.
The MRPS Holders shall have the same voting rights than the holders of the Ordinary Shares and Alphabet Shares at
all General Meetings if, despite the existence of profits available for that purpose, the Fixed Preferred MRPS Dividend has
not been paid for any reason whatsoever for a period of two successive financial years and until such time as all Fixed
Preferred MRPS Dividend shall have been received in full.
Art. 7. Amendments to the share capital. The share capital of the Company may be increased or decreased at any time
by a decision of the Sole Shareholder or by a decision of the General Meeting, in accordance with article 13 of these Articles.
Art. 8. Profit sharing. The profits which the Company may decide to distribute shall be applied as described in article
25 of these Articles in any year in which the Sole Shareholder or the General Meeting, as the case may be, resolves to make
any distribution of dividends.
Art. 9. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the
register of the Shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee
or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims
provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
Art. 10. Redemption of Shares. The Company shall have power to acquire Shares in its own share capital provided that
the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect and always subject to the mandatory provisions
of the Companies Act.
The Company may redeem each class of Alphabet Shares within the respective Class Periods only:
- The period for the Class A Shares is the period starting on the date of this notarial deed of 30 July 2015 and ending no
later than on 31 December 2015 (the Class A Period);
133834
L
U X E M B O U R G
- The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no later than
31 December 2016 (the Class B Period);
- The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than on
31 December 2017 (the Class C Period);
- The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than
on 31 December 2018 (the Class D Period);
- The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later than
31 December 2019 (the Class E Period);
- The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later than
31 December 2020 (the Class F Period);
- The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later than
31 December 2021 (the Class G Period);
- The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than
on 31 December 2022 (the Class H Period); and
- The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than on
31 December 2023 (the Class I Period).
Where a class of Alphabet Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemp-
tion and cancellation of such class(es) of Alphabet Shares can be made during a new period (the New Period) which shall
start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New
Period of another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall
start on the day after the Class I Period and the class of Alphabet Shares not repurchased and not cancelled in their respective
Class Period shall come in the order from class A to class I (to the extent not previously repurchased and cancelled).
For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Alphabet Shares shall take place
prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as
the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of Alphabet Shares
and shall continue to end on the day such as initially defined in the Articles above.
Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and
payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt the
Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.
The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the Sole Director or,
in case of plurality of Directors the Board of Directors (as both terms defined below) in its reasonable discretion and within
the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the Sole Director or, in case of plurality the Board
of Directors can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount
the freely distributable reserves either in part or in totality.
The Company may redeem its own Shares at any time. In case of MRPS, the Company can optionally redeem such
MRPS before the 10th anniversary of their respective date of issuance (the Maturity Date) and must redeem such MRPS
at the latest on the Maturity Date.
Without prejudice to this article 10, the redemption shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and
conditions to be decided upon by the Sole Shareholder or the General Meeting, as the case may be, upon proposal by the
Board. The quorum and majority requirements applicable for the amendments of these Articles shall apply.
The redemption shall take place only where the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the
redemption results from a decrease of the Company's share capital and always subject to the mandatory provisions of the
Companies Act.
Where MRPS are issued by the Company, the following additional condition shall apply:
- upon redemption of MRPS, each MRPS Holder is entitled to receive a payment in cash or in kind per redeemed MRPS
equal to the nominal value of its redeemed MRPS plus the portion of the Share Premium Account attached thereto, if any,
plus a payment corresponding to the right to any Fixed Preferred MRPS Dividend accrued and not paid at the date of
redemption (the Redemption Price).
However, on the Maturity Date, if the sums available for redemption are insufficient for the Company to redeem all the
relevant MRPS, the redemption of all the relevant MRPS will not be hindered; such insufficiency only entails the deferment
of the payment of the Redemption Price due upon redemption of the MRPS. In this latter case, the Company shall pay to
the holders of the redeemed MRPS whatever amount up to the sums available for redemption on the Maturity Date, the
remaining part of the Redemption Price plus a 3 % (three per cent) interest per annum over said remaining part of the
Redemption price to be paid as and when the Company will have sufficient sums available for this purpose.
As long as the Redemption Price of the redeemed MRPS has not been paid in full, no dividend or any other distributions
whatsoever shall be paid on the Ordinary Shares.
The redeemed MRPS shall be cancelled and the share capital and share premium attached to the redeemed MRPS (if
any) including the corresponding portion of share premium allocated to the legal reserve, if any, shall be decreased accor-
dingly.
133835
L
U X E M B O U R G
The MRPS Holders acknowledge and agree that any recourse they may have against the Company with respect to any
amounts owed to it under the MRPS shall be limited to any funds, monies or assets received for, in relation to or deriving
from the relevant Investment, and the MRPS Holder will have no recourse to any other assets of the Company which are
not related to the relevant Investment.
Art. 11. Powers of the General Meeting of the Company. As long as the Company has only one Shareholder, the Sole
Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised,
by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the
Company has only one Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.
In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of
Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Company.
Art. 12. Annual General Meeting of the Shareholders - Other Meetings. The annual General Meeting shall be held, in
accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other
place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first
Monday in May at 11.00 a.m. of each year. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General
Meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of the Shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
In case of plurality of shareholders and under exceptional circumstances only any Shareholder may participate in a
General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the
Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to
each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly
deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
Art. 13. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote. The notice periods and quorum provided for
by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.
The Board or, as the case may be, the Sole Director, as well as the statutory auditors or, if exceptional circumstances
require so, any two directors acting jointly may convene a general meeting. They shall be obliged to convene it so that it
is held within a period of one month, if Shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing, with an
indication of the agenda. One or more Shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require
the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at
least 5 (five) days before the relevant General Meeting.
Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements pu-
blished twice, with a minimum interval of eight days, and eight days before the meeting, in the Official Journal (Mémorial)
and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent eight days before the meeting to registered Shareholders.
Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only.
MRPS shall be non-voting unless stipulated otherwise by the Companies Act or the Articles.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed
by a simple majority of those present or represented and voting.
However, resolutions to amend the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at least
one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the
case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions is not
satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published
twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two
Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the
previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At
both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant
General Meeting. Votes relating to shares for which the Shareholder did not participate in the vote, abstain from voting,
cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.
The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with
the unanimous consent of the Shareholders and bondholders.
A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who does not need to be a Shareholder as
its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Lu-
xembourg law) is affixed.
If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as
being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
The Shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) on resolutions submitted to the General Meeting
provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and the signature of the relevant Share-
133836
L
U X E M B O U R G
holder, (ii) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in
the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. In order
to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours) before the
relevant General Meeting.
Before commencing any deliberations, the Shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman
shall appoint a secretary and the Shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer
form the General Meeting's bureau.
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any
Shareholder who wishes to do so.
However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere
must be signed by the chairman of the Board.
Art. 14. Management. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole
Director who does not need to be a Shareholder of the Company. Where the Company has more than one Shareholder, the
Company shall be managed by a Board composed of at least three directors who need not be Shareholders of the Company.
The Sole Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible
for re-appointment.
Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as
permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of
the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act.
The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of
directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced,
at any time, by resolution adopted by the General Meeting.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may
elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.
Art. 15. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose
a secretary, who does not need to be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will
appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors
present or represented at such meeting.
The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance
of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.
No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if
they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which
is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax,
or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her
proxy.
The Board can validly debate and take decisions only if at least one half of its members are present or represented. A
director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors are
present at the meeting. Decisions are taken by the majority of the members present or represented.
In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of com-
munications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in
the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and
(iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person
at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where
other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the re-
solutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law,
by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.
Article 15 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 16. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole
Director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.
133837
L
U X E M B O U R G
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at
such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman, or the Sole Director (as the case may be).
Art. 17. Powers of the Board. The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers to
perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not
expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board,
or as the case may be, the Sole Director.
Art. 18. Delegation of powers. The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person (délégué à la
gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on
behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.
The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a Shareholder or not, either a director
or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors.
This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind
the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.
The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either director or not, for the
purposes of performing specific functions at every level within the Company.
Art. 19. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures
of any two members of the Board, or (ii) in the case of a Sole director, the sole signature of the Sole Director. The Company
shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom specific signatory
power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power. Within the boundaries
of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case may be, of the person appointed to
that effect in accordance with the first paragraph of Article 18 above.
Art. 20. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.
In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the
Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote
upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following
General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.
For so long as the Company has a Sole Director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director
and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes.
The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions
made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.
Art. 21. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administra-
tors, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be
made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other
corporation of which the Company is a Shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach
of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 22. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (réviseur d'entreprises). The
operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or,
where required by law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected
for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.
The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration
and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or
without cause.
Art. 23. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of
each year.
Art. 24. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board or, as the case may be, the Sole Director
will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the applicable laws.
At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will
submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may
133838
L
U X E M B O U R G
be required by law to the statutory auditor(s) or the independent auditor(s) of the Company who will thereupon draw up
its report.
At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the
reports of the Board and of the statutory auditor(s) or the independent auditor(s) and such other documents as may be
required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by
the Shareholders during regular business hours.
Art. 25. Allocation of profits, Reserves.
a. Legal Reserve
From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required
by law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal
Reserve amounts to 10 % (ten per cent) of the share capital of the Company.
The Shareholder(s) determine how the balance of the annual net profits is allocated. It/they may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
b. Distribution of profits
After allocation to the Legal Reserve, the balance of the annual net profits shall be distributed in the following order:
(i) Each MRPS Holder shall be entitled to a fixed cumulative and preferred dividend equal to six point eight per cent
(6,8%) of all issued and outstanding MPRS per annum (the Fixed Preferred MRPS Dividend) which shall accrue on a daily
basis (calculated on a basis of three hundred sixty (360) days per calendar year) on the sum of (i) the aggregate nominal
value of the MRPS held by the relevant MRPS Holder plus (ii) the share premium contributed or paid in by the relevant
MRPS Holder upon subscription for such MRPS and/or a capital contribution paid by the relevant Shareholder with respect
to such MRPS, as the case may be.
(ii) After payment in full of the Fixed Preferred MRPS Dividend, each holder of Alphabet Shares shall be entitled to a
fixed preferred dividend (the Fixed Alphabet Share Dividend), in the following order:
1. the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 1% of the nominal value of the Class A
Shares;
2. the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 2% of the nominal value of the Class B
Shares;
3. the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 3% of the nominal value of the Class C
Shares;
4. the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 4% of the nominal value of the Class D
Shares;
5. the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 5% of the nominal value of the Class E
Shares;
6. the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 6% of the nominal value of the Class F
Shares;
7. the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 7% of the nominal value of the Class G
Shares;
8. the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 8% of the nominal value of the Class H
Shares; and
9. the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 9% of the nominal value of the Class I
Shares.
If the Fixed Alphabet Share Dividends are not declared or paid during one or more particular years, despite the availability
of sufficient annual net profits, the dividend entitlement shall continue to accrue.
In case of distribution, the balance shall be allocated pro rata to the Alphabet Shareholders pursuant to a decision taken
by the General Meeting.
(iii) Each Ordinary Shareholder shall be entitled to a fixed dividend equal to 10% of the nominal value of the Ordinary
Shares.
(iv) The balance of the annual net profits, if any, may be used for a possible redemption of a class of Alphabet Shares
or the MRPS.
(v) The balance of the annual net profits, if any, can be distributed among the Ordinary Shareholders pro-rata to the
number of Ordinary Shares held by them.
Dividends are only payable to the Shareholder(s) once declared by the Sole Shareholder or the General Meeting, as the
case may be, pursuant to this article 25 or pursuant to the declaration by the Sole Director or the Board, as the case may
be, pursuant to article 16 above.
The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies
Act.
133839
L
U X E M B O U R G
Art. 26. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting adopted
in the manner required for the amendment of these Articles, as prescribed in article 13 above. In the event of a dissolution
of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal
entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers
and the remuneration of such liquidator(s).
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions under article 25 above. For the avoidance of doubt, the net
liquidation proceeds shall be distributed as follows:
- where MRPS are issued by the Company, the MRPS Holders are entitled to a preferential right of reimbursement of
the contribution in consideration for which the MRPS have been issued (nominal value and share premium attached thereto,
including any unpaid Fixed Preferred MRPS Dividends, if any); and
- any surplus will be allocated to the Sole Shareholder, or in case of plurality of Shareholders, only to the holder(s) of
Alphabet Shares or the Ordinary Shares proportionally to the Alphabet Shares or Ordinary Shares he/she/it/they hold(s).
As a consequence of the foregoing provisions, the MRPS Holder(s) has/have, other than the preferential right mentioned
above, no right on the liquidation proceeds.
Art. 27. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Companies Act.”
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting resolves to set the number of members of the board of directors of the Company (the Board of Directors)
at three and to appoint the following persons as members of the Board of Directors:
(i) Jean-Philippe Fiorucci, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg;
(ii) Bruno Bagnouls, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg; and
(iii) Damien Schuind, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
The Meeting resolves that the term of the office of the members of the Board of Directors shall end after the annual
general meeting of the Company approving the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2015.
As a result of the above resolutions, the board of directors of the Company is composed as follows:
(i) Jean-Philippe Fiorucci;
(ii) Bruno Bagnouls; and
(iii) Damien Schuind.
<i>Ninth resolutioni>
The Meeting resolves to appoint PricewaterhouseCoopers, société cooperative, as independent auditor (réviseur d'en-
treprises agréé). The term of its mandate shall end after the annual general meeting of the Company approving the annual
accounts for the financial year ending on 31 December 2015.
<i>Tenth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above change of corporate form
of the Company as per the fourth resolution above as well as to see to the registration of the newly issued and reclassified
shares of the Company as per the second resolution and the sixth resolution respectively above and hereby empowers and
authorizes any member of the board of directors of the Company as well as any lawyer or employee of Allen & Overy,
société en commandite simple, to proceed on behalf of the Company to the registration of the above changes in the share
register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts
the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-1, 26-3 and 26-5 of the
Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 7,500.-
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the German and the English text, the English version shall prevail.
133840
L
U X E M B O U R G
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, the proxyholder of the Sole Shareholder
signed together with us, the notary, the present original deed.
Es folgt die Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am dreißigsten Juli,
vor der unterzeichneten Notarin Danielle Kolbach, mit Amtssitz in Redange/Attert, handelnd in Vertretung von Notar
Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welch Letzterem gegenwärtige Urkunde ver-
bleibt,
hat eine außerordentliche Hauptversammlung (die Hauptversammlung) der Gesellschafterin der EVI Lux I S.à r.l. statt-
gefunden, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz
in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg
unter der Nummer B 191481, mit einem aktuellen Stammkapital in Höhe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro)
(die Gesellschaft). Die Gesellschaft wurde gemäß einer Urkunde vom 24. Oktober 2014 gegründet, aufgenommen durch
den Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, die im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations - N° 3591 vom 27. November 2014 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft (die
Satzung) wurde zuletzt durch eine Urkunde, aufgenommen am 12. Januar 2015 durch den Notar Francis Kesseler, mit
Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, verändert, die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations veröffentlicht wurde.
Ist erschienen:
Institutional Investment Partners GmbH, handelnd in ihrer Kapazität als Verwaltungsgesellschaft für AEW Europe
Value Investors, eine deutsche Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in der Hamburger Allee 45, D-60486 Frankfurt am Main,
Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB
90129 (die Alleingesellschafterin);
vertreten durch Frau Annick Braquet, beruflich ansässig in Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten
Vollmacht vom 30. Juli 2015.
Die ordnungsgemäß durch die Erschienene und den instrumentierenden Notar ne varietur unterschriebene Vollmacht
der vertretenen Alleingesellschafterin bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Alleingesellschafterin, vertreten wie oben beschrieben, hat den Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:
I. dass sämtliche 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile der Gesellschaft, mit einem Nennwert von jeweils 100 EUR
(einhundert Euro), die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 12.500 EUR (zwölftausendfünfhundert
Euro) darstellen, anwesend oder vertreten sind, und dass die gegenwärtige Hauptversammlung somit rechtsgültig zusam-
mengetreten ist und über alle Punkte der Tagesordnung rechtskräftig Beschlüsse fassen kann;
II. dass die Tagesordnung der Hauptversammlung folgende Punkte enthält:
(1) Verzicht auf die Einberufungsformalitäten;
(2) Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um den Betrag in Höhe von EUR 168.500 (einhundertachtundsech-
zigtausendfünfhundert Euro), durch die Ausgabe von 1.685 (eintausendsechshundertfündundachtzig) neuen Anteilen mit
einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro);
(3) Zeichnung der Stammkapitalerhöhung gemäß Punkt (2) durch die Alleingesellschafterin, mittels Umwandlung eines
Betrags in Höhe von EUR 168.500 (einhundertachtundsechzigtausendfünfhundert Euro) aus den Kapitalrücklagen der
Gesellschaft;
(4) Umwandlung der Gesellschaftsform der "société à responsabilité limitée" in eine "société anonyme", sowie Abän-
derung der Bezeichnung der Gesellschaft von „EVI Lux I S.à r.l.“ in „EVI Lux I S.A.“;
(5) Anerkennung der Amtsniederlegung und Entlastung sämtlicher Mitglieder des Geschäftsführerrates der Gesellschaft,
also demzufolge von Bruno Bagnouls und Jean-Philippe Fiorucci;
(6) Umwandlung der 1.810 (eintausendachthundert) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je EUR 100
(einhundert Euro) in 310 (dreihundertzehn) Stammaktien (die Stammaktien), 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der
Klasse A (die A¬Aktien), 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse B (die B-Aktien), 150 (einhundertfünfzig)
Alphabet Aktien der Klasse C (die C-Aktien), 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse D (die D-Aktien), 150
(einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse E (die E-Aktien), 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse F
(die F-Aktien), 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse G (die G-Aktien), 150 (einhundertfünfzig) Alphabet
Aktien der Klasse H (die H-Aktien), 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse I (die I-Aktien), und 150 (ein-
hundertfünfzig)verpflichtend rückzahlbare Vorzugsaktien (die MRPS) der Gesellschaft, alle mit einem Nennwert von je
EUR 100 (einhundert Euro);
(7) Neufassung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit um, unter anderem die oben genannten Änderungen
umzusetzen;
(8) Ernennung von Jean-Philippe Fiorucci, Bruno Bagnouls und Damien Schuind zu Mitgliedern des Verwaltungsrats
der Gesellschaft, für ein Mandat welches nach der Generalversammlung im Jahre 2016, welche den Jahresabschluss des
Geschäftsjahres von 2015 genehmigt, endet;
133841
L
U X E M B O U R G
(9) Ernennung von PricewaterhouseCoopers, société coopérative, zum Wirtschaftsprüfer (reviseur d'entreprises agréé)
der Gesellschaft und Bestimmung der Dauer seines Mandats;
(10) Erfassung der vorgenannten Änderungen im Aktienregister der Gesellschaft, Erteilung der nötigen Vollmachten
an jedes Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und Anwalt oder Angestellten von Allen & Overy, société en
commandite simple, um im Auftrag der Gesellschaft, die Eintragung der neu ausgegebenen und umgewandelten Aktien
im Aktienregister vorzunehmen sowie die Erfassung der Änderungen gemäß den oben genannten Punkte; und
(11) Verschiedenes.
III. Sodann trifft die Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Da die Gesamtheit des Stammkapitals bei der gegenwärtigen Hauptversammlung vertreten ist, verzichtet die Haupt-
versammlung auf die Einberufungsformalitäten, die Alleingesellschafterin betrachtet sich als ordnungsgemäß geladen und
bestätigt, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihr im Voraus übermittelt wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von
EUR 168.500 (einhundertachtundsechzigtausendfünfhundert Euro), um es von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert
Euro), unterteilt in 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils EUR 100
(einhundert Euro), auf einen Betrag von EUR 181.000 (einhunderteinundachtzigtausend Euro) zu erhöhen, durch Ausgabe
von 1.685 (eintausendsechshundertfündundachtzig) Anteilen der Gesellschaft, mit einem Nennwert von jeweils EUR 100
(einhundert Euro) (die Neuen Anteile).
<i>Dritter Beschluss - Zeichnung und Einzahlungi>
Die Hauptversammlung akzeptiert die Zeichnung der Neuen Anteile im Rahmen der Kapitalerhöhung und dessen volle
Einzahlung wie folgt:
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Die Alleingesellschafterin, hier wie zuvor erwähnt vertreten, beschließt, die Neuen Anteile, mit einem Nennwert von
jeweils EUR 100 (einhundert Euro) zu zeichnen.
Die Hauptversammlung beschließt und die Alleingesellschafterin bestätigt dass die Neuen Anteile voll eingezahlt wer-
den mittels Umwandlung eines Betrags in Höhe von EUR 92.478.800 (zweiundneunzig Millionen vierhundertachtund-
siebzigtausendachthundert Euro) aus dem Konto für die Verbuchung von Einlagen, die ohne Ausgabe neuer Anteile
geleistet werden (Konto 115 des standardisierten Luxemburger Kontenplans vom 10. Juni 2009) (das Eigenkapital-Konto)
(compte 115 - apport en capitaux propres non rémunéré par des titres) (die Einlage).
Die Einlage wird wie folgt zugeordnet:
(i) EUR 168.500 (einhundertachtundsechzigtausendfünfhundert Euro), zum Stammkapital-Konto der Gesellschaft; und
(ii) EUR 92,310,300 (zweiundneunzig Millionen dreihundertzehntausenddreihundert Euro) zum Kapitalrücklagen-
Konto der Gesellschaft (das Kapitalrücklagen-Konto)
Die Hauptversammlung bestätigt, dass, auf Basis des Zwischenabschlusses der Gesellschaft zum 30. April 2015 (der
Zwischenabschluss), gestützt durch eine Bescheinigung ausgesellt am 30. Juli 2015 im Namen der Geschäftsführer (die
Werthaltigkeitsbescheinigung) und eine Bescheinigung der Geschäftsführung vom 30. Juli 2015 (die Bescheinigung der
Geschäftsführung) die Gesellschaft genügend Kapitalrücklagen hat um die Neuen Anteile vollständig einzuzahlen.
Eine Kopie des Zwischenabschlusses, der Werthaltigkeitsbescheinigung und der Bescheinigung der Geschäftsführung
bleibt ne varietur nach Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten, der im Namen und im Auftrag der Alleingesellschaf-
terin handelt, und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert
zu werden.
Die Hauptversammlung bestätigt, dass, auf Grund des Obengenannten, das Stammkapital der Gesellschafft nunmehr
bei EUR 181.000 (einhunderteinundachtzigtausend Euro) liegt, unterteilt in 1.810 (eintausendachthundert) Anteile mit
einem Nennwert von jeweils EUR 100 (einhundert Euro).
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt einstimmig, die Gesellschaftsform der "société à responsabilité limitée" in eine "
société anonyme" umzuwandeln, mit einen Stammkapital von EUR 181.000 (einhunderteinundachtzigtausend Euro) liegt,
unterteilt in 1.810 (eintausendachthundert) Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 100 (einhundert Euro).
Im Einklang mit Artikel 26-1 und Artikel 31-1 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften, wurde die Gesellschaft durch einen Bericht vom 30. Juli 2015, erstellt von Grant Thornton Lux Audit S.A., einer
société anonyme luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 89a, Pafebruch, L-8303 Capellen, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 43298 als unabhängiger Wirtschaftsprüfer (cabinet de
révision agréé) bewertet, mit folgendem Ergebnis:
133842
L
U X E M B O U R G
„Auf der Grundlage unserer Arbeit sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme verlassen,
dass, der Globalwert des NettoEigenkapitals der Gesellschaft zum 30. April 2015, nach der geplanten Kapitalerhöhung
von 168.500 EUR, nicht mit der Höhe des Mindeststammkapitals einer Aktiengesellschaft (société anonyme) überein-
stimmt.“
Der oben genannte Bericht, nachdem er ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne
varietur unterschriebene wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Hauptversammlung beschließt des Weiteren die Bezeichnung der Gesellschaft von „EVI Lux I S.à r.l.“ in „EVI Lux
I S.A.“ zu ändern. Dieser Beschluss wird wirksam gleich nach der Annahme der neuen Satzung der Gesellschaft im siebten
Beschluss hierunter.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung nimmt die Amtsniederlegung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates zur Kenntnis und
stimmt demzufolge dem sofortigen Rücktritt von Bruno Bagnouls und Jean-Philippe Fiorucci zu und beschließt jedem
einzelnen Mitglied des Verwaltungsrates Entlastung für die Ausübung seines Mandats zu gewähren mit Wirkung vom Tag
seiner Ernennung bis zum heutigen Tag.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt die 1.810 (eintausendachthundert) bestehenden Anteile der Gesellschaft mit einem Nenn-
wert von je EUR 100 (einhundert Euro) wie folgt umzuwandeln:
- 310 (dreihundertzehn) der bestehenden Anteile in 310 (dreihundertzehn) Stammaktien (die Stammaktien);
- 150 (einhundertfünfzig) der bestehenden Anteile in 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse A (die A-
Aktien);
- 150 (einhundertfünfzig) der bestehenden Anteile in 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse B (die B-
Aktien);
- 150 (einhundertfünfzig) der bestehenden Anteile in 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse C (die C-
Aktien);
- 150 (einhundertfünfzig) der bestehenden Anteile in 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse D (die D-
Aktien);
- 150 (einhundertfünfzig) der bestehenden Anteile in 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse E (die E-
Aktien);
- 150 (einhundertfünfzig) der bestehenden Anteile in 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse F (die F-
Aktien);
- 150 (einhundertfünfzig) der bestehenden Anteile in 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse G (die G-
Aktien);
- 150 (einhundertfünfzig) der bestehenden Anteile in 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse H (die H-
Aktien);
- 150 (einhundertfünfzig) der bestehenden Anteile in 150 (einhundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse I (die I-
Aktien); und
- 150 (einhundertfünfzig) der bestehenden Anteile in 150 (einhundertfünfzig) verpflichtend rückzahlbare Vorzugsaktien
(die MRPS)
alle mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro).
Die Versammlung beschließt das existierende Kapitalrücklagen-Konto der Gesellschaft proportional in ein MPRS
Rücklagen Konto (das MRPS Rücklagen Konto) umzuwandeln und folglich EUR 83.969.075 (dreiundachtzig Millionen
neunhundertneunundsechzigtausendfünfundsiebzig Euro) der Kapitalrücklagen vom Kapitalrücklagen-Konto dem MRPS
Rücklagen Konto zuzuweisen.
Die Versammlung bestätigt, dass als Folge der obigen Umwandlung, ein Betrag in Höhe von EUR 8.341.225 (acht
Millionen dreihunderteinundvierzigtausendzweihundertfünfundzwanzig Euro) dem Kapitalrücklagen-Konto zugeordnet
bleiben.
<i>Siebter Beschlussi>
Folglich der vorhergehenden Beschlüsse, beschließt die Versammlung einstimmig, die Gesamtneufassung der Satzung
der Gesellschaft, die nun folgendermaßen lautet:
„SATZUNG DER GESELLSCHAFT
<i>Definitioneni>
Alphabet Aktien hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;
Alphabet Aktien Inhaber hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;
Satzung bedeutet die Satzung der Gesellschaft, in ihrer jeweils geltenden Fassung;
133843
L
U X E M B O U R G
Verfügbarer Betrag ist der Gesamtbetrag des Bilanzgewinns der Gesellschaft (einschließlich der übertragenen Gewinne)
erhöht durch (i) frei ausschüttbare Reserven und / oder Kapitalrücklage und (ii) den Betrag der Kapitalherabsetzung und
der Reduktion der gesetzlichen Rücklage, welche im Zusammenhang mit den zu annullierenden Alphabet Aktien gemacht
werden, aber reduziert durch (i) etwaige Verluste (inklusive Verlustvorträge), die als ein Plus ausgedrückt werden, (ii)
etwaige Beträge die gemäß dieser Satzung oder anwendbarem Recht in Rücklagen eingezahlt werden (ohne Doppelzäh-
lung), (iii) sämtliche Dividenden, auf die Inhaber von Stammaktien laut der Satzung ein Recht haben und (iv) jegliche
Gewinnansprüche, so dass:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Wobei:
- AA = Verfügbarer Betrag.
- NP = Bilanzgewinn (inklusive vorgetragene Gewinne).
- P = sämtliche frei ausschüttbare Reserven und Rücklagen.
- CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und Reduktion der gesetzlichen Reserven im Bezug auf die zu annullierende
Klasse von Alphabet Aktien.
- L = Verluste (inklusive vorgetragener Verluste), als ein Plus ausgedrückt.
- LR = sämtliche Summen die laut Bestimmungen des Handelsgesetzes oder dieser Statuten in die Kapitalrücklagen
eingebracht werden müssen.
- OD = jährliche feste Dividendenansprüche von Stammaktien Inhabern.
- PE = Gewinnanspruch (die jährlichen festen Dividendenansprüche der Inhaber der Alphabet Aktien und der Inhaber
der MRPS laut dieser Satzung).
Der Verfügbare Betrag muss in dem Zwischenabschluss des jeweiligen Referenzzeitraums festgelegt werden und wird
von dem Alleinigen Verwaltungsrat oder, im Falle von mehreren Mitgliedern, dem Verwaltungsrat in gutem Glauben und
mit dem Blick auf die Fähigkeit der Unternehmensfortführung der Gesellschaft bewertet werden.
Verfügbare Liquidität bezeichnet (i) die gesamten von der Gesellschaft gehaltenen liquiden Mittel (außer Kassengeld-
anlagen mit einer Restlaufzeit von mehr als sechs (6) Monaten), (ii) marktgängige Geldmarktinstrumente, Anleihen und
Schuldverschreibungen und alle Forderungen der in der Ansicht des Verwaltungsrates an die Gesellschaft kurzfristig ge-
zahlt werden, abzüglich aller Verschuldung oder anderer Schulden des Unternehmens die, auf der Grundlage des
Zwischenabschlusses im Zusammenhang mit dem jeweiligen Referenzzeitraum (beziehungsweise dem Neuen Zeitraum),
in weniger als sechs (6) Monaten zahlbar sind, und (iii) alle von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerte wie Anteile,
Aktien oder Wertpapiere anderer Art;
Verwaltungsrat hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 4 gegeben wird;
Bankarbeitstag bezeichnet einen Tag (außer Samstag und Sonntag) an dem die Banken in Luxembourg-Stadt geöffnet
sind;
Annullierungsbetrag bezeichnet einen Betrag, der nicht höher ist als der verfügbare Betrag für den jeweiligen Refe-
renzzeitraum, (beziehungsweise den Neuen Zeitraum), vorausgesetzt dass ein solcher Annullierungsbetrag nicht höher als
die Verfügbare Liquidität für den jeweiligen Referenzzeitraum (oder den Neuen Zeitraum);
Vorsitzender hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 15 gegeben wird;
Referenzzeitraum bedeutet jeweils den Klasse A Referenzzeitraum, den Klasse B Referenzzeitraum den Klasse C Re-
ferenzzeitraum, den Klasse D Referenzzeitraum, den Klasse E Referenzzeitraum, den Klasse F Referenzzeitraum, den
Klasse G Referenzzeitraum, den Klasse H Referenzzeitraum und den Klasse I Referenzzeitraum;
Handelsgesetz bedeutet das Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner konsoli-
dierten Fassung;
Gesellschaft bedeutet EVI Lux I S.A.;
Mitglieder des Verwaltungsrats bedeutet die Mitglieder des Verwaltungsrats und Mitglied des Verwaltungsrats bedeutet
einer von ihnen;
Feste Alphabet-Vorzugsdividende hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 25 gegeben wird;
Feste MRPS-Vorzugsdividende hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 25 gegeben wird;
Hauptversammlungen bedeutet die Hauptversammlungen der Gesellschafter der Gesellschaft, und Hauptversammlung
bedeutet eine von ihnen;
Zwischenabschluss bedeutet der Zwischenabschluss der Gesellschaft zum jeweiligen Zwischenabschlussdatum;
Zwischenabschlussdatum darf nicht früher als dreißig (30) Tage und nicht später als zehn (10) Tage vor dem Datum
des Rückkaufs und Annullierung der jeweiligen Klasse von Alphabet Aktien sein;
Instrument hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5.1 gegeben wird;
Investment bezeichnet die Gesellschafterdarlehen die die Gesellschaft von Zeit zu Zeit ihren Tochtergesellschaften
gewährt, sofern durch die MRPS finanziert;
Gesetze bedeutet die jeweils in Luxemburg geltenden Gesetze und Vorschriften;
Rechtsperson hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 14 gegeben wird;
133844
L
U X E M B O U R G
Gesetzliche Rücklage hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 25 gegeben wird;
Luxemburg bedeutet das Großherzogtum Luxemburg;
Fälligkeitsdatum hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 10 gegeben wird;
MRPS hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;
MRPS Inhaber hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;
Neue Zeitraum hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 10 gegeben wird;
Stammaktien Inhaber hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;
Stammaktien hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;
Zeitspanne hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5.1 gegeben wird;
Gewinnanspruch bezeichnet den Anspruch auf Dividenden den die jeweiligen Klassen der Alphabet Aktien und die
MRPS haben, die nicht zurück gekauft werden;
Rücknahmepreis hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 10 gegeben wird;
Aktionäre hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;
Kapitalrücklagekonten hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;
Aktien bezeichnet alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gesellschaft, mit einem Nominalwert von EUR 100
(einhundert Euro), die alle Rechte und Pflichten tragen wie sie in dieser Satzung festgelegt sind;
Alleiniger Verwaltungsrat hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 4 gegeben wird; und
Alleiniger Aktionär hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 1 gegeben wird.
Art. 1. Form und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung
„EVI Lux I S.A.“ (die Gesellschaft).
Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesell-
schaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation oder
den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.
Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär der Gesellschaft falls die
Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär hat.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist das direkte und/oder indirekte Halten von
Beteiligungen an Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Bebauung und Verwaltung von Grundstücken oder grund-
stücksgleichen Rechten, die in einem Staat des EWR oder Vollmitgliedstaat der OECD belegen sind.
Die Gesellschaft darf sonst alle Aktivitäten ausführen, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Gesell-
schaftszweck stehen.
Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg - Stadt.
Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) oder im Falle eines
alleinigen Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat), vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeinde-
grenzen der Stadt Luxemburg verlegt werden.
Der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat haben des Weiteren das Recht Betriebsstätten,
Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.
Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche
politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass diese
Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die
Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt
werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung der
Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität und
bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 181.000 (einhunderteinundachtzig-
tausend Euro), eingeteilt in 1.810 (eintausendachthundertundzehn) vollständig einbezahlte Aktien, unterteilt in:
- 310 (dreihundertzehn) Stammaktien (die Stammaktien);
- 150 (hundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse A (die Klasse A Aktien);
- 150 (hundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse B (die Klasse B Aktien);
- 150 (hundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse C (die Klasse C Aktien);
- 150 (hundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse D (die Klasse D Aktien);
- 150 (hundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse E (die Klasse E Aktien);
- 150 (hundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse F (die Klasse F Aktien);
- 150 (hundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse G (die Klasse G Aktien);
133845
L
U X E M B O U R G
- 150 (hundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse H (die Klasse H Aktien);
- 150 (hundertfünfzig) Alphabet Aktien der Klasse I (die Klasse I Aktien, und zusammen mit den Alphabet Aktien der
Klassen A bis H, die Alphabet Aktien); und
- 150 (hundertfünfzig) verpflichtend rückzahlbare Vorzugsaktien (die MRPS, und zusammen mit den Stammaktien und
den Alphabet Aktien, die Aktien),
mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro), ausgestattet mit den Rechten und Pflichten wie sie in dieser
Satzung dargelegt sind.
Die Inhaber der Stammaktien werden im Weiteren als die Stammaktien Inhaber bezeichnet.
Die Inhaber der Alphabet Aktien werden im Weiteren als Alphabet Aktien Inhaber bezeichnet.
Die Inhaber der MRPS werden im Weiteren als MRPS Inhaber bezeichnet (und zusammen mit en Stammaktien Inhabern
und den Alphabet Aktien Inhabern als die Aktionäre).
Zusätzlich zu dem ausgegebenen Aktienkapital, unterhält die Gesellschaft Kapitalrücklagekonten, auf welche die Ka-
pitalrücklagen der jeweiligen Klassen von Aktien gebucht werden (die Kapitalrücklagekonten). Die Rücklagen auf den
Kapitalrücklagekonten können zur Zahlung der durch die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückgekauften Aktien, zum
Ausgleich jeglicher Netto-Verluste, um Ausschüttungen in Form von Dividenden an Aktionäre zu machen oder um Rück-
lagen zur Gesetzlichen Rücklage zuzuführen, genutzt werden. Die Gesellschaft unterhält ein Kapitalrücklagekonto für jede
Klasse ausgegebener Aktien.
Jede Geld- oder Sacheinlage die als Kapitalrücklage im Zusammenhang mit der Zeichnung einer bestimmten Klasse
von Aktien gemacht wird, wird in das Kapitalrücklagekonto der jeweiligen Klasse verbucht und ist nur verfügbar, (i) für
den Zweck einer Ausschüttung, ob in Form einer Dividende, eines Aktienrückkaufs oder in einer anderen Form, an die
Inhaber der jeweiligen Klasse von Aktien, und (ii) um gegen Ausgabe von Aktien der jeweiligen Klasse in das Gesell-
schaftskapital aufgenommen zu werden.
Zur Vermeidung von Missverständnissen: Die Kapitalrücklagekonten stellen frei ausschüttbare Rücklagen der Gesell-
schaft dar.
Die Hauptversammlung ist befugt, Kapitaleinlagen in Form von Geld- oder Sacheinlagen, oder anderen Formen, ohne
die Ausgabe neuer Aktien, nach den Bestimmungen der Hauptversammlung und im zulässigen Rahmen der Luxemburger
Gesetze, zu akzeptieren (der Kapitalüberschuss). Eine Kapitaleinlage ohne die Ausgabe neuer Aktien wird in ein Kapital-
überschusskonto (das Kapitalüberschusskonto) gemäß Luxemburg Recht gebucht. Die Gesellschaft unterhält ein Kapital-
überschusskonto für jede Klasse ausgegebener Aktien.
Jede Geld- oder Sacheinlage die als Kapitalüberschuss im Zusammenhang mit der Zeichnung einer bestimmten Klasse
von Aktien gemacht wird, wird in das Kapitalüberschusskonto der jeweiligen Klasse verbucht und ist nur verfügbar, (i) für
den Zweck einer Ausschüttung, ob in Form einer Dividende, eines Aktienrückkaufs oder in einer anderen Form, an die
Inhaber der jeweiligen Klasse von Aktien, und (ii) um gegen Ausgabe von Aktien der jeweiligen Klasse in das Gesell-
schaftskapital aufgenommen zu werden.
Zur Vermeidung von Missverständnissen: Die Kapitalüberschusskonten stellen frei ausschüttbare Rücklagen der Ge-
sellschaft dar.
5.1 Ermächtigung für den Verwaltungsrat das Stammkapital zu erhöhen
(a) Höhe der Ermächtigung
Das genehmigte Kapital ist auf EUR 500.000 (fünfhunderttausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 5000 (fünftausend)
Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 100 (einhundert Euro).
(b) Bedingungen der Ermächtigung
Der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat, ist befugt das aktuelle Stammkapital bis zur erlaubten Kapi-
talsumme , von Zeit zu Zeit, ganz oder teilweise, während einer Zeitspanne beginnend am 30. Juli 2015 und endend am
fünften Jahrestag dieses Datums (die Zeitspanne), zu erhöhen, durch (i) Ausgabe von Aktien als Gegenleistung für eine
Zahlung in bar, (ii) durch Ausgabe von Aktien als Gegenleistung für eine Sacheinlage und (iii) durch Aktivierung des
Bilanzgewinns und Reserven, einschließlich Kapitalrücklagen und Eigenkapital, mit oder ohne Ausgabe neuer Aktien.
Der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat ist befugt die Bedingungen zur Zeichnung und Ausgabe von
Aktien im Rahmen dieses Artikels 5.1 zu bestimmen, einschließlich der Bestimmung von Ort und Zeit der Ausgabe oder
der aufeinanderfolgenden Ausgaben von Aktien, des Ausgabepreises, mit oder ohne Kapitalrücklage, und die Bedingungen
zur Bezahlung der Aktien.
Der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat ist befugt (i) während der Zeitspanne, (a) zur Ausgabe von
Wandelanleihen oder anderer wandelbarer Schuldinstrumente, Wandelanleihen mit Bezugsrechten auf Aktien oder andere
Instrumente die ihren Inhaber berechtigen Aktien zu zeichnen, wie zum Beispiel, ohne Einschränkung, Optionsscheine
(die Instrumente), und (b) zur Ausgabe von Aktien gemäß und wirksam ab Ausübung an die Instrumente gekoppelten
Rechte und wirksam bis, in Bezug auf beide Punkte (a) und (b), der Betrag Stammkapitals das genehmigte Kapital als
Ergebnis der Ausübung der mit den Instrumenten verbundenen Rechte erreicht hat, und (ii) zur Ausgabe von Aktien
aufgrund der Ausübung der mit den Instrumenten verbundenen Rechte, bis die Summe des erhöhten Stammkapitals gleich
dem genehmigten Stammkapital ist, zu jeder Zeit, ob innerhalb der Zeitspanne oder nicht, vorausgesetzt, die Instrumente
wurden während der Zeitspanne ausgegeben. Die Ausgabe der Aktien nach Ausübung der mit den Instrumenten verbun-
133846
L
U X E M B O U R G
denen Rechte können gegen eine Einzahlung in bar, eine Sacheinlage oder eine Aktivierung des Bilanzgewinns und der
Reserven, einschließlich Kapitalrücklage und der Kapitalüberschuss erfolgen.
Der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Bedingungen der Instrumente, einschließlich
des Preises, des Zinssatzes, der Ausübungsquote, dem Umwandlungskurs oder dem Wechselkurs, und den Rückzahlungs-
bedingungen zu bestimmen, und zur Ausgabe der Instrumente.
(c) Ermächtigung Vorzugsrechte zu limitieren oder zu löschen
Der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat, ist hiermit befugt die Vorzugsrechte der Aktionäre, die im
Handelsgesetz vorgesehen sind, wie in Artikel 5 wiedergegeben, im Zusammenhang mit der Ausgabe neuer Aktien im
Rahmen ihrer Ermächtigung unter Artikel 5.1, zu löschen oder zu limitieren.
(d) Aufnahme der Kapitalerhöhungen in die Satzung
Jedes Mal wenn der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung innerhalb des genehmigten
Kapitals vornimmt, muss dieser Artikel 5 dem entsprechend abgeändert werden und der Verwaltungsrat muss gegebenen-
falls die nötigen Schritte einleiten oder eine Person damit beauftragen die nötigen Schritte einzuleiten um die Ausführung
und Veröffentlichung solcher Änderungen, einschließlich der Eintragung einer solchen Kapitalerhöhung und der daraus
folgenden Änderungen der Satzung vor einem Notar, festzulegen.
Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives) und werden Namensaktien bleiben.
Ein Aktienregister wird im eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zwecks Inspektion zur
Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder sein Wahldomizil, die Anzahl
der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe welche für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und
das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Falls eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat
die Gesellschaft das Recht die Ausführung aller Rechte, die dieser Aktie anhaften, aufzuheben bis eine Person als einziger
Besitzer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Regel wird angewandt wenn es einen Konflikt zwischen
dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen einem Pfandgeber und einem
Pfandhalter gibt.
Die Stammaktien und die Alphabet Aktien halten je ein Stimmrecht bei einer Hauptversammlung.
Die Gesellschaft kann ihre Aktien unter Vorbehalt der vom Gesetz festgelegten Bedingungen zurückkaufen.
Die MRPS und die Alphabet Aktien sind gemäß Artikel 49-8 des Handelsgesetzes ausgegebene rückkaufbare Aktien,
und können nur im Einklang mit dem Handelsgesetz und den Bedingungen dieser Satzung zurückgekauft werden.
Die MRPS sind nicht stimmberechtigten Aktien in Übereinstimmung mit den Artikeln 44 bis 47 des Handelsgesetzes.
In Übereinstimmung mit Artikel 46 des Handelsgesetzes ist jede MRPS dennoch zu einer Stimme in jeder Hauptversamm-
lung berechtigt, die die folgenden Punkte behandelt:
- Die Ausgabe neuer Aktien mit Vorzugsrechten;
- Die Bestimmung der kumulativen Vorzugs - Dividende der MRPS;
- Die Umwandlung von MRPS in Alphabet Aktien oder Stammaktien;
- Die Reduzierung des Kapitals der Gesellschaft;
- Die Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft;
- Die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen;
- Die Auflösung der Gesellschaft vor dem Ende ihrer festgelegten Dauer; und
- Die Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit einer anderen Rechtsform.
Die MRPS halten auch jeweils eine Stimme für Entscheidungen im Bezug auf jede vorgeschlagene Änderung der Rechte,
Vorrechte oder Privilegien der MRPS.
Die MRPS Inhaber halten dieselben Stimmrechte wie die Inhaber von Stammaktien und Alphabet Aktien bei allen
Hauptversammlungen, wenn, trotz der Existenz von zu diesem Zweck verfügbaren Gewinnen, die Feste MRPS-Vorzugs-
dividende, aus irgendeinem Grund, über den Zeitraum von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren, nicht ausbezahlt
worden ist, und dies so lange, bis alle Festen MRPS-Vorzugsdividenden voll ausbezahlt worden sind.
Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Stammkapital der Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss
des Alleingesellschafters oder durch einen Beschluss der Hauptversammlung, in Übereinstimmung mit Artikel 13 dieser
Satzung, erhöht oder reduziert werden.
Art. 8. Gewinnbeteiligung. Die Gewinne, die die Gesellschaft beschließen kann zu verteilen, werden in dem Jahr, in
dem der Alleingesellschafter oder die Hauptversammlung eine Ausschüttung von Dividenden beschließt, wie in Artikel
25 dieser Satzung beschrieben, zugeteilt.
Art. 9. Übertragung der Aktien. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung,
welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden
und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von
133847
L
U X E M B O U R G
Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unter-
schrieben werden.
Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesellschaft
die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.
Art. 10. Rückkauf von Aktien. Die Gesellschaft ist befugt, ihre eigenen Aktien zu erwerben, vorausgesetzt, dass die
Gesellschaft über ausreichende ausschüttungsfähigen Rücklagen und Kapital verfügt, und stets unter Beachtung der zwin-
genden Bestimmungen des Handelsgesetzes.
Die Gesellschaft kann jede Klasse der Alphabet Aktien nur in deren jeweiligen Referenzzeitraum zurückkaufen:
- Der Referenzzeitraum der Klasse A Aktien ist der Zeitraum ab dem Datum dieser notariellen Urkunde vom 30. Juli
2015 und endet nicht später als am 31. Dezember 2015 (der Klasse A Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse B Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse A Zeitraums
beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2016 endet (der Klasse B Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse C Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse B Zeitraums
beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2017 endet (der Klasse C Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse D Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse C Zeitraums
beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2018 endet (der Klasse D Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse E Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse D Zeitraums
beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2019 endet (der Klasse E Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse F Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse E Zeitraums
beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2020 endet (der Klasse F Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse G Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse F Zeitraums
beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2021 endet (der Klasse G Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse H Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse G Zeitraums
beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2022 endet (der Klasse H Zeitraum); und
- Der Referenzzeitraum der Klasse I Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse H Zeitraums
beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2023 endet (der Klasse I Zeitraum).
Wenn eine Klasse von Alphabet Aktien nicht im Referenzzeitraum der jeweiligen Klasse zurückgekauft und annulliert
worden ist, kann der Rückkauf und die Annullierung solcher Klassen von Alphabet Aktien in einem neuen Zeitraum
geschehen (der Neue Zeitraum), welcher am Tag nach dem letzten Referenzzeitraum (beziehungsweise am Tag nach dem
direkten vorangehenden Neuen Zeitraum einer anderen Klasse von Alphabet Aktien) beginnt, und nicht später als ein Jahr
nach Beginn dieses Neuen Zeitraums endet. Der erste Neue Zeitraum beginnt am Tag nach dem Klasse I Zeitraum, und
die Klasse von Alphabet Aktien die nicht in ihrem jeweiligen Referenzzeitraum zurückgekauft und annulliert wurde kom-
men in der Reihenfolge von Klasse A bis Klasse I an die Reihe (sofern sie nicht vorher zurückgekauft und annulliert worden
sind).
Zur Vermeidung von Missverständnissen, sollte ein Rückkauf und die Annullierung von einer Klasse von Alphabet
Aktien vor dem Ende des jeweiligen Referenzzeitraums (beziehungsweise dem Neuen Zeitraum) stattfinden, so fängt der
folgende Referenzzeitraum (beziehungsweise der Neue Zeitraum) am Tag nach dem Rückkauf und der Annullierung einer
solchen Klasse von Alphabet Aktien an und endet an dem Tag wie oben beschrieben.
Nach dem Rückkauf und die Annullierung von der gesamten relevanten Klasse(n), wird der Annullierungsbetrag fällig
und ist von der Gesellschaft an die Aktionäre anteilig zu ihrer Beteiligung an solchen Klasse(n) zu zahlen. Die Gesellschaft
kann die Zahlungsverpflichtung in Form von Geld-, oder Sachleistung oder durch Aufrechnung erfüllen.
Die Höhe des obengenannten Annullierungsbetrags wird vom Alleinigen Verwaltungsrat, oder, im Falle mehrerer Mit-
glieder des Verwaltungsrats, dem Verwaltungsrat (wie unten definiert) nach deren billigen Ermessen und im besten
Interesse der Gesellschaft bestimmt. Zur Vermeidung von Missverständnissen, der Alleinige Verwaltungsrat oder der
Verwaltungsrat, kann in seinem eigenen Ermessen entscheiden, die frei ausschüttbaren Rücklagen, zum Teil oder ganz, in
seine Berechnung des Annullierungsbetrages mit einzubeziehen oder nicht.
Die Gesellschaft kann jederzeit ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Im Falle der MRPS kann die Gesellschaft diese
MRPS vor dem 10. Jahrestag ihrer jeweiligen Ausgabe (das Fälligkeitsdatum) einlösen, und muss diese spätestens am
Fälligkeitsdatum einlösen.
Unbeschadet dieses Artikels 10 findet der Rückkauf der Aktien, auf den Vorschlag durch den Verwaltungsrat hin, durch
einen Beschluss und zu den beschlossenen Bedingungen des Alleinigen Aktionärs oder der Hauptversammlung statt. Es
gelten dieselben Beschlussfähigkeit- und Mehrheitserfordernisse wie für die Änderung dieser Satzungen.
Der Rückkauf kann nur erfolgen wenn die Gesellschaft über ausreichend ausschüttungsfähige Rücklagen zu diesem
Zweck verfügt oder wenn der Rückkauf sich aus der Reduzierung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft ergibt, und
stets unter Beachtung der zwingenden Vorschriften des Handelsgesetzes.
- Wenn MRPS von der Gesellschaft ausgegeben werden, gelten die folgenden zusätzlichen Bedingungen:
- Bei einem Rückkauf von MRPS ist jeder MRPS Inhaber berechtigt pro zurückgekaufter MRPS eine Zahlung in bar
oder in Form einer Sachleistung zu erhalten, die gleich dem Nennwert der zurückgekauften MPRS plus dem dazugehör-
133848
L
U X E M B O U R G
enden Anteil des Kapitalrücklagekontos, sowie eine Zahlung die der Festen MRPS Vorzugsdividende, die nicht dem
Kapitalrücklagekonto zugeordnet worden ist und am Tag des Rückkaufs nicht ausbezahlt ist (der Rücknahmepreis).
Sollten am Fälligkeitsdatum die verfügbaren Summen für den Rückkauf aller relevanten MRPS nicht ausreichen, so
wird der Rückkauf dieser MRPS dadurch nicht behindert, sondern nur die Zahlung des Rücknahmepreises der zum Rück-
kauf der MRPS fällig wäre, wird aufgeschoben. In letzterem Fall zahlt die Gesellschaft dem Inhaber der zurückgekauften
MRPS die Summe die für den Rückkauf am Fälligkeitsdatum vorhanden ist, der restliche Teil des Rücknahmepreises sowie
3% (drei Prozent) Zinsen pro Jahr über den restlichen Teil des Rücknahmepreises werden bezahlt, wenn die Gesellschaft
ausreichend Liquidität zur Verfügung hat.
Solange der Rücknahmepreis der zurückgekauften MRPS nicht vollständig bezahlt ist, ist keine Dividende oder andere
Ausschüttung auf die Stammaktien zu zahlen.
Die zurückgekauften MRPS werden gelöscht und das Stammkapital mit der zugehörigen Kapitalrücklage, sowie dem
zugehörige Teil der Gesetzlichen Rücklage, werden dementsprechend reduziert.
Die MRPS Inhaber nehmen zur Kenntnis, dass jeder Anspruch den sie gegenüber der Gesellschaft in Bezug auf sämtliche
Summen, die ihnen unter den MRPS geschuldet sind, sich auf Rücklagen, Gelder oder Vermögenswerte beschränken die
im Zusammenhang mit dem jeweiligen Investment stehen oder daraus resultieren, und dass die MRPS Inhaber keinen
Anspruch auf andere Vermögenswerte der Gesellschaft, die nicht mit dem jeweiligen Investment in Zusammenhang stehen,
haben.
Art. 11. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat,
übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne
dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entschei-
dungen oder Befugnisse vom alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.
Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der
Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.
Art. 12. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche Hauptversamm-
lung der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen,
im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, welcher sich in der gleichen Gemeinde befindet, am ersten Montag im Mai
um 11.00 Uhr jedes Jahres statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt,
wird die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag stattfinden.
Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen
Einberufungsschreiben angegeben sind.
Im Falle mehrerer Aktionäre und nur im Falle außerordentlicher Ereignisse kann jeder Aktionär an der Hauptversamm-
lung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, voraus-
gesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an
der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbro-
chen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit
Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.
Art. 13. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung. Die vom
Gesetz vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die Ab-
haltung der Hauptversammlung Anwendung, außer wenn im nachfolgenden Text etwas anderes vorgesehen ist.
Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat und der oder die Rechnungsprüfer (commissaire
(s) aux comptes) oder, wenn es außergewöhnliche Umstände verlangen, zwei Verwaltungsratsmitglieder, welche gemein-
sam handeln können eine Hauptversammlung einberufen. Sie sind verpflichtet diese innerhalb eines Monats mit Angabe
der Tagesordnung einzuberufen, wenn Aktionäre, welche ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, dies schriftlich
verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten,
können verlangen, dass der Tagesordnung einer oder mehrere Einträge hinzugefügt werden. Die Anfrage muss der Ge-
sellschaft mindestens 5 (fünf) Tage vor der entsprechenden Hauptversammlung übermittelt werden.
Einberufungsschreiben für alle Hauptversammlungen müssen die Tagesordnung der Versammlung enthalten und müs-
sen als Bekanntmachungen mit einem Mindestabstand von acht Tagen, und bis spätestens acht Tage vor der Hauptver-
sammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht werden.
Acht Tage vor der Versammlung müssen Einberufungsschreiben par Brief an Inhaber von Namensaktien versendet
werden.
Wenn alle Aktien Namensaktien sind, kann die Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen.
MRPS sind nicht stimmberechtigt, sofern nicht anders durch das Handelsgesetz oder die Satzung vorgeschrieben.
Außer wenn vom Gesetz oder von dieser Satzung anders vorgesehen, werden Beschlüsse von einer ordnungsgemäß
einberufenen Hauptversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Anwesenden oder vertretenen Aktionäre ge-
troffen die ihre Stimme abgeben.
133849
L
U X E M B O U R G
Allerdings können Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft abändern nur von einer Hauptversammlung ange-
nommen werden, in welcher mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und deren Tagesordnung die
vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält und gegebenenfalls den Wortlaut der Satzungsänderungen, die den
Zweck oder die Form der Gesellschaft betreffen. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite
Versammlung einberufen werden, wie in der Satzung beschrieben, indem die Einberufung zweimal und mit einem Min-
destabstand von fünfzehn Tagen, und bis spätestens fünfzehn Tage vor der Versammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in
einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht wird. Eine solche Einberufung muss die Tagesordnung, das Datum und die
Ergebnisse der letzten Versammlung wiedergeben. Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des ver-
tretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen. Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig
sind, durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen, welche Aktien betreffen
für welche der Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten
oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt, um die Mehrheit zu errechnen.
Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre
und Schuldverschreibungsinhaber geändert bzw. erweitert werden.
Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt,
entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem
Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.
Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass sie
alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung entbehrlich.
Die Aktionäre können schriftlich (mit einem Wahlzettel) über Beschlüsse abstimmen, welche der Hauptversammlung
vorgelegt wurden, vorausgesetzt die schriftlichen Wahlzettel enthalten (i) den Namen, Vornamen, die Adresse und die
Unterschrift des entsprechenden Aktionärs, (ii) die Auflistung der Aktien durch welche der Aktionär dieses Recht ausübt,
(iii) die Tagesordnung, wie sie im Einberufungsschreiben dargelegt wurde und (iv) die Wahlvorschriften (Zustimmung,
Ablehnung, Enthaltung) für jeden Punkt der Tagesordnung. Damit er berücksichtigt wird, muss die Gesellschaft das Ori-
ginal des Wahlzettels 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor der entsprechenden Hauptversammlung erhalten
Bevor die Beratungen anfangen, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden der Hauptversammlung wählen. Der Vor-
sitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen. Der Vorsitzende, der Schriftführer
und der Stimmenzähler bilden das Büro.
Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären,
die unterschreiben möchten.
Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder
Auszüge vom Verwaltungsratsvorsitzenden unterschrieben werden.
Art. 14. Geschäftsführung. Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer
einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als
einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine
Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von
höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.
Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine
natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Alleinigen
Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51 bis des Gesetzes von 1915 vertreten wird.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die
Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied
kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben und
ersetzt werden.
Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem
anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um
die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Falls keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der
oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um neue Verwaltungsratsmitglieder zu wählen.
Art. 15. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen Mit-
gliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll
der Verwaltungsratssitzungen führen wird. In seiner/ihrer Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder
einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.
Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden oder nach Einberufung durch zwei
Verwaltungsratsmitglieder am in der Einberufung genannten Ort.
Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis
gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert
werden müssen.
133850
L
U X E M B O U R G
Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwe-
send oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es
kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Verwaltungsratsmitglieder per Original, Fax oder E-
Mail, welcher eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die
schriftliche Einberufung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an
bestimmten Orten vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, ist entbehrlich.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde
(per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist)
bei jeder Verwaltungsratsversammlung vertreten lassen.
Der Verwaltungsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur
unter der Voraussetzung, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Versammlung teilnehmen. Entschei-
dungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.
Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung, hat der Verwaltungsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.
Jeder Verwaltungsrat kann an der Versammlung des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche an der Versammlung teil-
nehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und
miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwaltungsräte können ord-
nungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche
Anwesenheit.
Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen
auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von
allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unter-
schrift versehen sind.
Artikel 15 entfällt, sollte die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsrat geführt wird.
Art. 16. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates. Die Beschlüsse
des alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbe-
wahrt wird.
Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei einer
solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten Be-
schlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.
Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden
müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben, beziehungsweise vom Alleinige Verwaltungsrat.
Art. 17. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist weit-
gehend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren
Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Haupt-
versammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen
Verwaltungsrates.
Art. 18. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine
Person als Geschäftsführer benennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder
nicht, welche umfassende Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche
Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen
der Gesellschaft ausführen.
Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwal-
tungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied
des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen und
im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen
anderen Gesellschaft binden.
Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Ver-
waltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:
(i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder (ii) im Falle eines Alleinigen Verwal-
tungsrates, die Alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird außerdem durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch den
Verwaltungsrat bekommen hat verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Grenzen
der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der Person die im ersten Abschnitt
im Artikel 18 benannt wurde verpflichtet.
133851
L
U X E M B O U R G
Art. 20. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesell-
schaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder
Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Ver-
waltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.
Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der
Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein
solches Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden
den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen
Verwaltungsrates.
Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat
ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten.
Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwal-
tungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.
Art. 21. Vergütung / Entschädigung. Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder
ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschä-
digen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren
angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft
eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und
durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.
Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater
der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungs-
recht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.
Art. 22. Rechnungsprüfer (Commissaire aux comptes) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Die Ge-
schäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire(s) aux comptes) überprüft, oder
falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Der oder die
Rechnungsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt werden.
Der oder die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und
die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Ein amtierender Rechnungsprüfer kann jederzeit von der Hauptversammlung mit
oder ohne Grund abgerufen werden.
Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 24. Jahresabschluss. Jedes Jahr, am Ende des Finanzjahres, erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der
Alleinige Verwaltungsrat den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz von 2002.
Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Allei-
nige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren
Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden dem oder den Rechnungsprüfern oder den unabhängigen Wirtschafts-
prüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.
Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlust-
rechnung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des oder der Rechnungsprüfer oder der unabhängigen Wirtschafts-
prüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz von 1915 verlangt werden am Gesellschaftssitz der
Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.
Art. 25. Verwendung der Gewinne, Rücklagen.
a. Gesetzliche Rücklage
Von dem in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinns sind mindestens fünf Prozent zur Bildung der gesetzlichen Rück-
lage (réserve légale) zu verwenden (die Gesetzliche Rücklage). Diese Zuweisung zur Gesetzlichen Rücklage ist nicht mehr
nötig, sobald die Gesetzlichen Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben
ist überschreitet.
Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit
zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft
und den anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist.
b. Verteilung der Gewinne
Nach Einlage in die gesetzliche Rücklage wird die Differenz des Jahresgewinns in der folgenden Reihenfolge verteilt:
(i) Jeder MRPS Inhaber hat das Recht auf eine feste kumulative Vorzugssdividende gleich sechs komma acht Prozent
(6,8%) aller ausgegebenen und ausstehenden MRPS pro Jahr (die Feste MRPS-Vorzugsdividende) die auf einer täglichen
Basis anwächst (berechnet auf der Grundlage von dreihundertsechzig (360) Tagen pro Kalenderjahr) auf die Summe von
(i) dem Nominalwert der vom jeweiligen MRPS Inhaber gehalten MRPS plus (ii) vom jeweiligen MRPS Inhaber gemachten
133852
L
U X E M B O U R G
Einlagen in die Kapitalrücklage bei Zeichnung solcher MRPS und / oder eine Kapitaleinlage von der betreffenden MRPS
Inhaber im Bezug auf solche MRPS.
(ii) Nach vollständiger Bezahlung der Festen MRPS-Vorzugsdividende, hat jeder Alphabet Aktien Inhaber das Recht
auf eine Vorzugsdividende (die Feste Alphabet-Vorzugsdividende), in der folgenden Reihenfolge:
1. Die Inhaber der Klasse A Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 1% des Nominalwerts der
Klasse A Aktien;
2. Die Inhaber der Klasse B Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 2% des Nominalwerts der
Klasse B Aktien;
3. Die Inhaber der Klasse C Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 3% des Nominalwerts der
Klasse C Aktien;
4. Die Inhaber der Klasse D Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 4% des Nominalwerts der
Klasse D Aktien;
5. Die Inhaber der Klasse E Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 5% des Nominalwerts der
Klasse E Aktien;
6. Die Inhaber der Klasse F Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 6% des Nominalwerts der
Klasse F Aktien;
7. Die Inhaber der Klasse G Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 7% des Nominalwerts der
Klasse G Aktien;
8. Die Inhaber der Klasse H Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 8% des Nominalwerts der
Klasse H Aktien;
9. Die Inhaber der Klasse I Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 9% des Nominalwerts der Klasse
I Aktien
Bei der Verteilung, wird die Differenz gleich zwischen Alphabet Aktien Inhabern aufgrund eines Beschlusses der
Hauptversammlung verteilt.
(iii) Jeder Stammaktien Inhaber hat das Recht auf eine feste Dividende in der Höhe von 10% des Nominalwertes der
Stammaktien.
(iv) Der Saldo des Jahresgewinns, falls vorhanden, kann für einen möglichen Rückkauf einer Klasse von Alphabet
Aktien oder MRPS verwendet werden.
(v) Der Saldo des Jahresüberschuss, falls vorhanden, kann anteilig unter den Stammaktien Inhabern verteilt werden.
Dividenden sind nur an den Anteilinhaber zu zahlen nachdem sie durch den Alleingesellschafter oder die Hauptver-
sammlung, im Einklang mit diesem Artikel 25, beziehungsweise durch den Alleinigen Verwaltungsrat oder den Verwal-
tungsrat im Einklang mit Artikel 16 hierüber, beschlossen worden sind.
Der Verwaltungsrat kann entscheiden Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb
der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.
Art. 26. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann durch einen im Einklang mit den in Artikel 13 enthaltenen
Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung
der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche natürliche oder ju-
ristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine solche Liquidation
entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder des Liquidatoren.
Nach Zahlung aller Schulden und sonstiger Kosten, einschließlich der Kosten der Liquidation, wird der Nettoliquida-
tionserlös an die Aktionäre verteilt, um auf aggregierter Basis dasselbe wirtschaftliche Ergebnis zu erreichen wie die
Verteilungsregeln für Dividendenausschüttungen unter Artikel 25 dies vorsehen. Um Zweifel auszuschließen, der Netto-
liquidationserlöse wird wie folgt verteilt:
- Wenn MRPS von der Gesellschaft ausgegeben wurden, haben die MRPS Inhaber ein Vorzugsrecht auf die Erstattung
des Beitrag der als Entgelt für die MRPS eingebracht wurde (Nominalwert mit zugehöriger Kapitalrücklage, inklusive jeder
unbezahlter Fester MRPS-Vorzugsdividende, falls vorhanden); und
- Jeglicher Überschuss wird dem Alleinigen Aktionär zugeteilt, oder im Falle von mehreren Aktionären, nur den Inhaber
(n) der Alphabet-Aktien oder der Stammaktien proportional zu den Alphabet Aktien oder Stammaktien die sie halten.
Als Konsequenz aus den vorstehenden Bestimmungen, haben die MRPS Inhaber, mit Ausnahme der oben genannten
Vorzugsrechts, kein Recht auf den Liquidationserlös.
Art. 27. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.“
<i>Achter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat)
auf drei fest zu legen, und die folgenden Personen zu Mitgliedern des Verwaltungsrates zu ernennen:
- Jean-Philippe Fiorucci, geschäftsansässig in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
133853
L
U X E M B O U R G
- Bruno Bagnouls, geschäftsansässig in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
- Damien Schuind, geschäftsansässig in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
Die Hauptversammlung beschließt dass das Mandat der Mitglieder des Verwaltungsrats nach der Generalversammlung
endet, welche den Jahresabschluss für das Jahr 2015 genehmigt.
Nach dem obigen Beschluss besteht der Verwaltungsrat der Gesellschaft aus den folgenden Mitgliedern:
- Jean-Philippe Fiorucci;
- Bruno Bagnouls; und
- Damien Schuind.
<i>Neunter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt PricewaterhouseCoopers, société cooperative, bis zur Generalversammlung im Jahre
2016, welche den Jahresabschluss des Geschäftsjahres von 2015 genehmigt, zum Wirtschaftsprüfer (reviseur d'entreprises
agréé) zu benennen.
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt das Aktienregister der Gesellschaft zu ändern um die obige Änderung der Gesell-
schaftsform der Gesellschaft im vierten Beschluss sowie die Registrierung der neu ausgegebenen und umgewandelten
Aktien durch den zweiten und den sechsten Beschluss hierüber fest zu halten, und die Erteilung der nötigen Einzelvoll-
machten an Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und jeden Anwalt oder Angestellten von Allen & Overy, société
en commandite simple, zur Erledigung aller Formalitäten in Bezug auf obigen Änderungen gegenüber dem luxemburgi-
schen Handelsregister sowie die Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und, generell, um
alle Formalitäten, die zur Umsetzung der Beschlüsse drei und vier notwendig und hilfreich sind, vorzunehmen.
<i>Erklaerungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-1 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Gebühreni>
Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft
aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, belaufen sich ungefähr auf EUR 7.500.-.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit klar, dass auf Wunsch der erschienenen Partei,
das vorliegende Dokument auf Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, erstellt wurde. Falls Unterschiede
zwischen dem englischen und dem deutschen Text bestehen, hat auf Wunsch der erschienenen Partei die englische Version
Vorrang.
Worüber in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, ein Protokoll aufgenommen wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der Partei, hat derselbe Vertreter zusammen mit dem amtie-
renden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. BRAQUET und D. KOLBACH.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 3 août 2015. Relation: 1LAC/2015/24523. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 25. August 2015.
Référence de publication: 2015144047/1502.
(150157256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.
"Commerz Real Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 189.252.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143308/9.
(150156784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
133854
L
U X E M B O U R G
Commonwealth Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.555.
En date du 14 août 2015, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Démission de Mr Johannes Laurens de Zwart, du poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 juillet 2015;
- Nomination de Ms Jana Strischek, née le 12 juin 1975 à Potsdam, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle 46A,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B pour une durée indéterminée et avec effet
au 1
er
août 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Commonwealth Luxembourg Holdings S.à r.l.
Andrea Smekalova
<i>Gérant de catégorie Bi>
Référence de publication: 2015143309/17.
(150156253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Bishop Infrastructure Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 795.246,30.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 175.350.
<i>Extrait des contrats de cession de parts sociales de la Société en date du 28 juin 2013i>
En vertu d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 28 Juin 2013, EQT Infrastructure II Limited Partnership
a transféré à EQT Services (UK) Limited, agissant en sa qualité d'associé commandité d'EQT Infrastructure II Executive
Co-Investment Limited Partnership, une société en commandite, constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles,
enregistrée auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro LP015354, ayant son siège
social au 15 Golden Square, Londres W1F 9JG (Royaume-Uni), le nombre de parts sociales suivant:
- 1.672 parts sociales de catégorie A;
- 1.672 parts sociales de catégorie B;
- 1.672 parts sociales de catégorie C;
- 1.672 parts sociales de catégorie D;
- 1.672 parts sociales de catégorie E;
- 1.672 parts sociales de catégorie F;
- 1.672 parts sociales de catégorie G;
- 1.672 parts sociales de catégorie H;
- 1.672 parts sociales de catégorie I, et;
- 1.672 parts sociales de catégorie J.
En plus du contrat de cession mentionné plus haut, EQT Infrastructure II Limited Partnership a transféré à CBTJ Financial
Resources B.V., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois des Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre
de la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 55299423 avec son siège social au 355, Schiphol Boulevard,
bâtiment World Trade Center Schiphol, H-Tower, 4eme étage, 1118 BJ Schiphol, Pays-Bas et agissant en tant que gérant
d’ EQT Infrastructure II Co-Investment Scheme, le nombre de parts sociales suivant:
- 150.914 parts sociales de catégorie A;
- 150.914 parts sociales de catégorie B;
- 150.914 parts sociales de catégorie C;
- 150.914 parts sociales de catégorie D;
- 150.914 parts sociales de catégorie E;
- 150.914 parts sociales de catégorie F;
- 150.914 parts sociales de catégorie G;
- 150.914 parts sociales de catégorie H;
- 150.914 parts sociales de catégorie I, et;
133855
L
U X E M B O U R G
- 150.914 parts sociales de catégorie J.
Luxembourg, le 25 août 2015.
Référence de publication: 2015144637/40.
(150157792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.
Concord Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 187.498.364,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.709.
En date du 18 août 2015, les associés de la société ont pris les décisions suivantes:
- Démission de Mr Johannes Laurens de Zwart, du poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 juillet 2015;
- Nomination de Ms Jana Strischek, née le 12 juin 1975 à Potsdam, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle 46A,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B pour une durée indéterminée et avec effet
au 1
er
août 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Concord Luxembourg S.à r.l.
Andrea Smekalova
<i>Gérant de catégorie Bi>
Référence de publication: 2015143311/17.
(150156211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Corber Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue de Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 186.303.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2015.
Signatures.
<i>Signataire autorisé / Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015143312/12.
(150156201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Winsley S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 148.616.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 12.05.2015i>
<i>Septième résolution:i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance en 2014, l'Assemblée Générale décide de
renouveler avec effet au 02.10.2014, le mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de Monsieur
Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23.09.1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2,
Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, les mandats d'Administrateur de Monsieur Pierre LENTZ, Expert-comp-
table, né à Luxembourg le 22.04.1959, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg; de Monsieur Gerdy ROOSE, Expert-comptable, né à Wevelgem (Belgique) le 14.02.1966, domicilié
professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire
de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469, pour une nouvelle période de six ans
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2020.
<i>Huitième résolution:i>
L'Assemblée Générale prend acte du changement de siège social du 11A Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
au 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
133856
L
U X E M B O U R G
WINSLEY SA SPF
Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2015144529/25.
(150157347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.
Caparmor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 53.226.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 21 mai 2015i>
Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de la société FMS SERVICES S.A., dont le siège social est au 3, avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, représentée par Madame Nadine LAMBALLAIS, née le 01/01/1972 à Thionville (France),
domiciliée professionnellement au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au titre d'administrateur A en remplacement
de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur A démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>CAPARMOR S.A.
Référence de publication: 2015143316/16.
(150156538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Carnot Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 191.692.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2015.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015143318/14.
(150156951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Stage Vision S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 193.096.
EXTRAIT
Il résulte de deux contrats de cession de parts sociales de la Société en date du 7 Août 2015 que, l'associé CVC Capital
Partners VI Limited a transféré la totalité des 1.250.000 parts sociales qu'il détenait dans la Société comme suit:
- Transfert de 625.000 parts sociales à Stage Vision Holdings Limited, une Limited Company, constituée et régie selon
les lois de Jersey, ayant son siège social à 1 Waverley Place, Union Street, St. Helier, Jersey JE1 1SG, Iles Anglo-Normandes
et immatriculé auprès de Jersey Financial Services Commission sous le numéro 119159;
- Transfert de 625.000 parts sociales à Stage Vision Holdings II Limited, une Limited Company, constituée et régie
selon les lois de Jersey, ayant son siège social à 1 Waverley Place, Union Street, St. Helier, Jersey JE1 1SG, Iles Anglo-
Normandes et immatriculé auprès de Jersey Financial Services Commission sous le numéro 119160
Dès lors, les parts sociales de la Société sont détenu comme suit:
Stage Vision Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.000 part sociales,
Stage Vision Holdings II Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.000 part sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
133857
L
U X E M B O U R G
Fait à Luxembourg, le 24 Août 2015.
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2015145085/24.
(150158241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.
Carnot Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 191.692.
L'an deux mille quinze, le trente et unième jour du mois de juillet;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “CARNOT TECHNOLOGIES S.A.”, une so-
ciété anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2210 Luxembourg,
38, boulevard Napoléon I
er
, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
191692, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 octobre 2014, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3648 du 1
er
décembre 2014,
et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 décembre
2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 154 du 20 janvier 2015.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Klaus KRUMNAU, juriste, demeurant professionnellement à
L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
Le Président désigne Madame Josephine LUCARELLA, employée, demeurant professionnellement à L-2210 Luxem-
bourg, 38, boulevard Napoléon I
er
, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Monsieur Luis OJEDA, employé, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 38, bou-
levard Napoléon I
er
, comme scrutateur.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinq mille quatre cent douze euros (5.412,- EUR) afin
de le porter de son montant actuel de trente-huit mille neuf cent soixante-cinq euros (38.965,- EUR) à quarante-quatre mille
trois cent soixante-dix-sept euros (44.377,- EUR), par la création de cinq mille quatre cent douze (5.412) actions nouvelles
(les “Actions Nouvelles”) avec une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, émises avec une prime d'émission de
quatre-vingt-quatre euros (84,- EUR) par action;
2. Renonciation individuelle à tout leur droit préférentiel de souscription par tous les actionnaires existants;
3. Souscription des Actions Nouvelles comme suit:
- Monsieur Vincent GUELFUCCI, cadre directeur logistique, demeurant à F-94210 Saint-Maur-des-Fossés, 4, avenue
de Brazza, à concurrence de quatre cent douze (412) actions,
- Monsieur Eric LAPCHIN, avocat, demeurant à F-92420 Vaucresson, 12, avenue Théry, à concurrence de deux cent
quatre-vingt-quinze (295) actions,
- Monsieur Pierre MOLLER, consultant en management, demeurant à Versailles (78), 6 rue de Fontenay, à concurrence
de cent dix-huit (118) actions,
- Monsieur François DEVY, cadre dirigeant, demeurant à Paris (3
ème
), 7 rue Saint-Claude, à concurrence de cinq cent
quatre-vingt-huit (588) actions
- Madame Sandrine DEVY, cadre dirigeant, demeurant à Paris (3
ème
), 7 rue Saint-Claude, à concurrence de sept cent
six (706) actions,
- Monsieur Pascal SIMONS, cadre directeur commercial, demeurant à F-92400 Courbevoie, Appartement 1105, 7 rue
Baudin, à concurrence de mille cent soixante-seize (1.176) actions,
- Monsieur Guillaume MAINBOURG, consultant en management, demeurant à F-75007 Paris, 16 rue Pérignon, à
concurrence de mille sept cent soixante-cinq (1.765) actions,
- Monsieur Dominique CHATELIN, cadre dirigeant, demeurant à F-94100 Saint-Maur-des-Fossés, 48 avenue Anatole
France, à concurrence de trois cent cinquante deux (352) actions, et
libération intégrale des Actions Nouvelles, ensemble avec la prime d'émission, moyennant apport en numéraire;
4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts;
133858
L
U X E M B O U R G
5. Modification du registre des actionnaires afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à
tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder à l'inscription dans le registre des actionnaires
des actions nouvellement émises;
6. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés
sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq mille quatre cent douze euros
(5.412,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente-huit mille neuf cent soixante-cinq euros (38.965,- EUR) à
quarante-quatre mille trois cent soixante-dix-sept euros (44.377,- EUR), par la création de cinq mille quatre cent douze
(5.412) actions nouvelles (les “Actions Nouvelles”) avec une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, émises avec
une prime d'émission de quatre-vingt-quatre euros (84,- EUR) par action et jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée constate que tous les actionnaires existants ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel concernant
la souscription des nouvelles actions à émettre par la Société.
Du fait de cette renonciation, aucun transfert de droit de souscription ne pourra intervenir entre les actionnaires.
<i>Souscription - Libérationi>
L'Assemblée reconnaît, qu'avec l'agrément de tous les actionnaires, les Actions Nouvelles ont été souscrites par:
- Monsieur Vincent GUELFUCCI, pré-qualifié, à concurrence de quatre cent douze (412) actions,
- Monsieur Eric LAPCHIN, pré-qualifié, à concurrence de deux cent quatre-vingt-quinze (295) actions,
- Monsieur Pierre MOLLER, pré-qualifié, à concurrence de cent dix-huit (118) actions,
- Monsieur François DEVY, pré-qualifié, à concurrence de cinq cent quatre-vingt-huit (588) actions,
- Madame Sandrine DEVY, pré-qualifiée, à concurrence de sept cent six (706) actions,
- Monsieur Pascal SIMONS, pré-qualifié, à concurrence de mille cent soixante-seize (1.176) actions,
- Monsieur Guillaume MAINBOURG, pré-qualifié, à concurrence de mille sept cent soixante-cinq (1.765) actions,
- Monsieur Dominique CHATELIN, pré-qualifié, à concurrence de trois cent cinquante-deux (352) actions, et
entièrement libérées, ensemble avec la prime d'émission, par lesdits souscripteurs moyennant un versement en numéraire,
de sorte que le montant total de de quatre cent soixante mille et vingt euros (460.020,- EUR), faisant cinq mille quatre cent
douze euros (5.412,- EUR) pour l'augmentation de capital et quatre cent cinquante-quatre mille et six cent huit euros
(454.608,- EUR) pour la prime d'émission, se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter lesdites souscriptions et lesdites libérations et d’attribuer les Actions Nouvelles à chacun
des souscripteurs comme mentionné ci-dessus.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts afin de lui
donner la teneur suivante:
“ Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-quatre mille trois cent soixante-dix-sept euros (44.377,- EUR), représenté
par quarante-quatre mille trois cent soixante-dix-sept (44.377) actions d’une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune,
entièrement libérées et qui ouvrent les mêmes droits à tout égard.”
133859
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et d'accorder
pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société
à l'inscription dans le registre des actionnaires des actions nouvellement émises.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne
demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à deux mille deux cent cinquante
euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. KRUMNAU, J. LUCARELLA, L. OJEDA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 06 août 2015. 2LAC/2015/18094. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 19 août 2015.
Référence de publication: 2015143317/120.
(150156941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
CBV GP S.à r.l.., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 154.873.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015143319/10.
(150156773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Maison Pétrole Beta (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 191.616.
Il résulte des résolutions écrites du 20 août 2015 de l'associé unique de la Société que Monsieur Steven Robin Bell, né
le 23 octobre 1955 à New Jersey, Etats-Unis d'Amérique et résidant professionnellement au 1800 Post Oak Boulevard,
Suite 380, 77056 Houston, Texas, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé gérant de type A de la Société avec effet au 20
août 2015 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Bernard Wirth comme gérant de type A de la Société;
- Steven Robin Bell comme gérant de type A de la Société;
- Marjorie Allo comme gérante de type B de la Société; et
- Emmanuel Natale comme gérant de type B de la Société.
Le 24 août 2015.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015143565/20.
(150156434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
133860
L
U X E M B O U R G
Chateaudun Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 124.021.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143320/9.
(150156749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
CM Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3237 Bettembourg, 19, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 169.153.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2015143321/13.
(150156752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Cofima Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 155.555.
RECTIFICATIF
Cette mention rectificative remplace la version déposée antérieurement le 20 août 2015 sous le No: L150155117
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015143323/12.
(150156407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Maison Pétrole Delta (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 191.638.
Il résulte des résolutions écrites du 20 août 2015 de l'associé unique de la Société que Monsieur Steven Robin Bell, né
le 23 octobre 1955 à New Jersey, Etats-Unis d'Amérique et résidant professionnellement au 1800 Post Oak Boulevard,
Suite 380, 77056 Houston, Texas, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé gérant de type A de la Société avec effet au 20
août 2015 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Bernard Wirth comme gérant de type A de la Société;
- Steven Robin Bell comme gérant de type A de la Société;
- Marjorie Allo comme gérante de type B de la Société; et
- Emmanuel Natale comme gérant de type B de la Société.
Le 24 août 2015.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015143566/20.
(150156433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
133861
L
U X E M B O U R G
Cofima I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 116.302.
RECTIFICATIF
Cette mention rectificative la version déposée antérieurement le 20 août 2015 sous le N° L150155108
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015143324/12.
(150156412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Cofima III S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 137.559.
RECTIFICATIF
Cette mention rectificative remplace la version déposée antérieurement le 20 août 2015 sous le N°: L150155101
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015143325/12.
(150156497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Cofima SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 157.740.
RECTIFICATIF
Cette mention rectificative remplace la version déposée antérieurement le 20 août 2015 sous le No: L150155113
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015143326/12.
(150156413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Pfaudler Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 38.900.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 191.416.
Mit Übertragungsvertrag vom 07.07.2015 überträgt die alleinige Teilhaberin der Gesellschaft, Pfaudler Holding S.à r.l.
- 2.852.667 Stammanteile der Klasse A; und
- 1.426.333 Stammanteile der Klasse B
auf die Pfaudler Co-Invest GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, mit
Geschäftsanschrift Eschenheimer Anlage 1, D-60316 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter Nummer HRA 48541.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pfaudler Midco S.à r.l.
Dr. Wolfgang Zettel / Stefan Lambert
<i>Manager / Manageri>
Référence de publication: 2015143640/18.
(150156194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
133862
L
U X E M B O U R G
Cofinimmo Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 100.044.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Cofinimmo
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015143327/11.
(150156524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Comptoir Immobilier Luxembourgeois, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 13.542.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2015.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signatures
Référence de publication: 2015143328/12.
(150156631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Comptoir Immobilier Luxembourgeois, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 13.542.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2015.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signatures
Référence de publication: 2015143329/12.
(150156632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Yalino Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 184.871.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société du 20 août 2015 que:
- La démission de M. Patrick MOINET, administrateur de classe A de la Société, avec effet au 13 février 2015, a été
acceptée.
- Monsieur Magsud AHMADKHANOV occupe, à compter du 13 février 2015, la fonction d'administrateur de classe
A de la Société et ce pour une durée de six années.
- La personne suivante a été nommée en tant qu'administrateur de classe B, avec effet au 13 février 2015 et ce pour une
durée de six années:
* Madame Yuliya BAY-LANGER, née le 20 février 1984 à Kyiv, Ukraine, résidant professionnellement au 16, avenue
Pasteur L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2015.
Référence de publication: 2015143820/19.
(150156197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
133863
L
U X E M B O U R G
Consulting & Co. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 139.664.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015143330/10.
(150156329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Cotinvest S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 127.560.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 22 juin 2015i>
Le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Julien Ruggieri vient à échéance à l'issue de la présente Assemblée.
L'Assemblée décide de renouveler son mandat de Commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle
des Actionnaires statuant sur les comptes au 31 décembre 2015.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Paul Boban
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015143331/15.
(150156418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
NN Lux Insurance International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 135.305.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 18 avril 2015i>
L'assemblée confirme la nomination de M. Quinten FRAAI comme administrateur et président en date du conseil
d'administration du 28 janvier 2015.
D'autre part, l'assemblée constate que les mandats d'administrateur de
Quinten FRAAI (Président)
Luc VERBEKEN (Vice-Président)
Pieter COOPMANS (Administrateur)
sont arrivés à leur terme.
L'assemblée décide de renouveler les mandats de
Quinten FRAAI (Président)
Luc VERBEKEN (Vice-Président)
Pieter COOPMANS (Administrateur)
pour une nouvelle période d'un an, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2015.
L'adresse professionnelle des administrateurs est fixée au 3 rue Jean Piret L-2350 Luxembourg.
D'autre part, l'assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d'Entreprises, la société anonyme ERNST & YOUNG, 7
Parc d'Activités Syrdall; L-5365 Munsbach, pour une période déterminée, qui viendra à expiration le 31 décembre 2015.
L'assemblée accepte de nommer la société anonyme KPMG, 39 Avenue John F. Kennedy; L-1855 Luxembourg, comme
nouveau réviseur d'entreprise à partir du 1
er
janvier 2016 pour une période qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée
qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2015.
Référence de publication: 2015144993/29.
(150158514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.
133864
L
U X E M B O U R G
CSHV European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 9.042,50.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 189.846.
<i>Extrait rectificatif sous référence L150133356 du 23 juillet 2015i>
Suite à une erreur matérielle il y a lieu de noter que le nouvel associé de la Société suite au contrat de cession de parts
daté du 19 juin 2015 se dénomme California State Teachers' Retirement System et non California State Teacher'Retirement
System.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015143333/15.
(150156396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
CT Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 660.895,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 169.620.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2015.
Référence de publication: 2015143334/10.
(150156913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Turchese Trading e Investimentos S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 146.459.
L'an deux mille quinze, le cinq août.
Pardevant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
DUMBARTON TRUST, un trust constitué selon le droit de la Nouvelle-Zélande, avec siège social au 12 Sayers Crescent
Ilam, Christchurch 8440, Nouvelle-Zélande, agissant par l'intermédiaire de son trustee, la société Broadgate Fiduciaries
New Zealand Ltd de droit néozélandais avec siège social au 12 Sayers Crescent Ilam, Christchurch 8440, Nouvelle-Zélande,
immatriculée auprès de Register of Commerce de Nouvelle-Zélande sous le numéro 4400018, ci-après l'Actionnaire Unique
ici représentée par Monsieur Giorgio Bianchi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante es-qualités qu'il agit et le notaire restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, prie le notaire d'acter:
I.- que l'Actionnaire Unique détient l'intégralité du capital social de la société anonyme de titrisation (hors émission en
continu de valeurs mobilières à destination du public) Turchese Trading e Investimentos S.A. établie et ayant son siège
social au 50 route d'Esch L - 1470 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section
B sous le numéro 146459 ci-après la «Société»), constituée le 15 mai 2009 suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1262 du 1
er
juillet 2009. Les statuts n'ont pas été
modifiés depuis.
II. qu'aucune valeur mobilière autres que les actions représentatives du capital de la Société n'ont été émises, qu'aucun
compartiment n'a été ouvert depuis la constitution de la Société jusqu'au jour des présentes, et que la Société n'a pas effectué
d'opération de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 telle que modifiée.
Un certificat et un bilan intermédiaire au 30 juin 2015, après avoir été signés Ne varietur par le mandataire de la partie
comparante es-qualités qu'il agit et le notaire resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de
l'enregistrement.
III. que les résolutions à prendre portent sur les points suivants:
133865
L
U X E M B O U R G
- modifier l'objet social de la Société de celui de titrisation (hors émission en continu de valeurs mobilières à destination
du public) en celui d'une société de participation financière (SOPARFI) avec effet à la date des présentes et de supprimer
tout référence à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation telle que modifiée.
- supprimer toute référence au capital autorisé, l'autorisation n'étant plus en vigueur.
- en conséquence des points précédents, modifier notamment les articles 1, 4, 5, 8, 12, 16 et 17 des statuts de la Société,
celui relatif à l'objet social se lira comme suit: «La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que
ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces
participations. La société peut réaliser, pour son propre compte, tout acte de vente et cession de biens immobiliers et
opérations y relatives. La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter. La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous
concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres
personnes morales et physiques. La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, com-
merciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»
IV.- qu'elle s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique décide de modifier son objet social de celui de titrisation (hors émission en continu de valeurs
mobilières à destination du public) en celui d'une société de participation financière (SOPARFI) avec effet à la date des
présentes et de supprimer tout référence à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation telle que modifiée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'actionnaire unique décide de supprimer toute référence au capital autorisé, l'autorisation n'étant plus en vigueur.
<i>Troisième résolutioni>
En vue de refléter les résolutions qui précédent, l'actionnaire unique décide de modifier notamment les articles 1, 4, 5,
8, 12, 16 et 17 qui auront désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de "TURCHESE TRADING E
INVESTIMENTOS S.A." (ci-après la «société»). La société est soumise aux lois du Grand-duché de Luxembourg en
particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la société n'a qu'un actionnaire unique, la
société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société.
Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la société
a un associé unique) tant que la société a un associé unique.»
« Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut réaliser, pour son propre compte, tout acte de vente et cession de biens immobiliers et opérations y
relatives.
La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs im-
mobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties. La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes
morales et physiques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»
« Art. 5. Le capital social souscrit au moment de la création est fixé à cinquante mille Euro (EUR 50.000) représenté
par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune.
Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou par des certificats repré-
sentatifs de deux ou plusieurs actions. Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales. La propriété des
actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés
d'un registre à souches et signés par deux administrateurs respectivement par l'administrateur unique.
Les actions au porteur seront déposées auprès d'un dépositaire désigné par le conseil d'administration conformément à
l'article 42 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Les actes de nomination ou changement
133866
L
U X E M B O U R G
concernant les dépositaires devront être déposés et publiés conformément à l'article 11bis §1
er
, 3), d) de ladite loi. Le
dépositaire détiendra les actions au porteur pour le compte de l'actionnaire qui en est propriétaire. La propriété de l'action
au porteur fera l'objet d'une inscription sur le registre ouvert à cet effet qui renseignera la désignation précise de chaque
actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les transferts, l'annulation
ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date. A la demande écrite de l'actionnaire au porteur, un certificat
constatant toutes les inscriptions le concernant lui sera délivré par le dépositaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.
« Art. 8. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration
et de disposition conformément à l'objet social de la société.
Le Conseil d'administration peut décider de verser des acomptes sur dividendes conformément à l'article 72-2 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont
de la compétence du Conseil d'administration.»
« Art. 12. En conformité avec la Loi, les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes, actionnaires ou non. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes doivent agir
en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.
Indépendamment de ce qui précède, la Société sera contrôlée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) dans
les cas prévus par la loi ou lorsque la loi permet à la Société d'opter pour, et que cette dernière choisit d'opter pour la
nomination d'un réviseur d'entreprise agréé en lieu et place d'un commissaire aux comptes.»
« Art. 16. L'assemblée générale des actionnaires peut décider de dissoudre la société. Si la société est dissoute, la
liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.»
« Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.».
<i>Quatrième résolutioni>
L'actionnaire unique acte la démission du réviseur d'entreprises agréé en fonction et décide de nomme comme com-
missaire aux comptes pour une durée de un an:
International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l., ayant son siège social au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,
RCS Luxembourg B numéro 107093.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400).
<i>Pouvoirsi>
La personne comparante, es qualité qu'elle agit, donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du
notaire Paul Bettingen, précité, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte rectificatif (faute(s) de frappe(s))
au présent acte.
<i>Déclarationi>
Le notaire a rendu le comparant es qualité qu'il agit attentif aux dispositions légales luxembourgeoises notamment la
loi du 10 août 1915 telle que modifiée et la loi du 22 mars 2004 telle que modifiée applicables en matière d'établissement
et la révision des comptes, qui le reconnaît et décharge le notaire de toute responsabilité y relative.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante es qualité qu'elle agit, connue du notaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Giorgio Bianchi, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 05 août 2015. 1LAC / 2015 / 24997. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 26 août 2015.
Référence de publication: 2015145132/137.
(150158392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.
133867
L
U X E M B O U R G
C4Industries S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 190.460.
La société a été constituée par acte notarié en date du 12 septembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n° 3199 du 31 octobre 2014.
Les comptes annuels de la Société au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
C4 Industries S.A.
Signature
Référence de publication: 2015143335/14.
(150156305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
DataEurope Founders S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 169.506.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015143337/10.
(150156165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Delfi Asset S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 150.505.
AUSZUG
Aus dem Protokoll der Beschlüsse des alleinigen Aktionärs der Gesellschaft vom 4. August 2015 geht hervor, dass das
Mandat von Herrn Dr. Markus Warncke als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur ordentlichen jährlichen
Hauptversammlung, die im Jahr 2016 stattfinden wird, verlängert wurde.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Für gleichlautenden Auszug
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2015143338/14.
(150156709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Lenmorneftegaz Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 185.533.
EXTRAIT
Il résulte de la décision des associés de la Société du 3 août 2015 que:
- Monsieur Donal S. Mageean a démissionné avec effet au 3 août 2015 en tant que gérant de catégorie B de la Société,
- Monsieur Michael J. Peacock, né le 16 avril 1955 à Ossett (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à 31
Novinsky Boulevard, 5
e
étage, 123242 Moscou, Russie, a été nommé avec effet au 3 août 2015 en tant que gérant de
catégorie B de la Société pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015143527/16.
(150156952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
133868
L
U X E M B O U R G
Dusseldorf (Bridge) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 119.092.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143341/9.
(150156887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
Dynamics Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 147.723.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143342/9.
(150156830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
DyStar Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.012.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 135.820.
Le bilan rectificatif (rectificatif du bilan 2014, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, réfé-
rence L150154995) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015143343/13.
(150156656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
KPS Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 194.961.
In the year two thousand and fifteen, on the seventh of August.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “KPS Holding S.A.”, a public limited company
(“société anonyme”) incorporated and existing under Luxembourg laws, having its registered office in L-1466 Luxembourg,
4, rue Jean Engling, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 194961
(the “Company”), incorporated on February 11, 2015 pursuant to a deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 968 of April 10, 2015. The articles
of incorporation of the Company (the “Articles”) have not been amended since its incorporation.
The Meeting was presided by Mrs Carine GRUNDHEBER, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appointed as Secretary and the Meeting elected as Scrutineer Mrs Natalia KORLIAKOVA, employee,
residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of article 3.1 of the by-laws of the Company, which henceforth will read as follows:
“ 3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realization of a portfolio, consisting of interests
and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or
133869
L
U X E M B O U R G
exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
In addition, the company may carry out consulting in the area of real estate investments as well as carry out all transactions
for the purpose of such investments”.
II) The represented sole shareholder, the proxyholder of the represented sole shareholder and the number of its shares
are shown on an attendance list, which, signed “ne varietur” by the proxyholder of the represented sole shareholder, the
members of the bureau of the meeting and by the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time by the registration authority.
The proxy given by the represented sole shareholder, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the
represented sole shareholder, the members of the bureau of the meeting and by the officiating notary will also remain
annexed to the present deed.
III) It appears from the attendance list that the entire share capital of the Company is represented at the present extraor-
dinary general meeting, so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the
agenda.
After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the Meeting:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolved to amend article 3.1 of the Articles of the Company, which henceforth will read as follows:
“ 3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realization of a portfolio, consisting of interests
and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or
exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
In addition, the company may carry out consulting in the area of real estate investment as well as carry out all transactions
with the purpose of such investments.”
The Meeting acknowledged that no bonds have been issued by the Company and therefore no agreement of bondholders
was required in relation with the present resolution.
No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the
Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at EUR 1,000.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons,
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le sept août.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “KPS Holding S.A.”, une société anonyme
constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 4, rue
Jean Engling, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 194961
(la “Société”), constituée le 11 février 2015 suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 968 du 10 avril 2015. Les statuts de la
Société (les “Statuts”) n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.
L'Assemblée est présidée par Madame Carine GRUNDHEBER, employée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Natalia KORLIAKOVA,
employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée générale dûment constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
133870
L
U X E M B O U R G
I) L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 3.1 des statuts de la Société, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
« 3.1. La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant
de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché de
Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par sou-
scription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres
participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce
portefeuille.
En outre, la Société peut conseiller sur investissements immobilier et peut réaliser toutes les transactions pour ces
investissements».
II) L'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il possède
sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de l'actionnaire
unique représenté, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
les besoins de l'enregistrement.
Restera également annexée aux présentes, la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été signée “ne
varietur” par le mandataire de l'actionnaire unique représenté, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instru-
mentant.
III) Il ressort de la liste de présence que l'intégralité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
les points portés à l'ordre du jour.
Après délibération, l'Assemblée a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide de modifier l'article 3.1 des Statuts de la Société, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
“ 3.1. La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant
de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché de
Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par sou-
scription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres
participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce
portefeuille.
En outre, la Société peut conseiller dans le cadre d'investissements immobiliers et peut réaliser toutes les transactions
pour ces investissements.”
L'Assemblée prend acte qu'aucune obligation n'a été émise par la Société de sorte qu'aucun accord des obligataires n'est
requis quant à la présente résolution.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé
l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à EUR 1.000,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, lesdits
comparants ont signé avec Nous, le notaire, la présente minute.
Signé: N. KORLIAKOVA, C. GRUNDHEBER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 11 août 2015. 2LAC/2015/18404. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 19 août 2015.
Référence de publication: 2015143521/131.
(150156912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.
133871
L
U X E M B O U R G
New Europe Property Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 108.116.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 17 août 2015 que Monsieur Peter Francis Griffin a démissionné de son
mandat de gérant de la société New Europe Property Holdings (Luxembourg) S.à r.l. en faillite, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 108 116, avec effet immédiat.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 17 août 2015 que Monsieur Christopher Roger Sharman a démissionné de
son mandat de gérant de la société New Europe Property Holdings (Luxembourg) S.à r.l. en faillite, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 108 116, avec effet immédiat.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 17 août 2015 que Monsieur Martin Shires a démissionné de son mandat de
gérant de la société New Europe Property Holdings (Luxembourg) S.à r.l. en faillite, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 108 116, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 25 août 2015.
CF Corporate Services
Société Anonyme
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Référence de publication: 2015144983/21.
(150157816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.
Moneylift S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 96.010.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015144980/10.
(150158167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.
Mominvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 50.651.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 26 août 2015i>
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée Générale constate que le mandat de Commissaire est arrivé à échéance le 25 septembre 2014. L'Assemblée
Générale décide de renouveler le mandat de Commissaire de I.C. Dom-Com S. à r.l. (anc. Alter Dom-Com S. à r.l.) ayant
désormais son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, à compter du 25 septembre 2014 et jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en 2015.
<i>Pour MOMINVEST S.A.i>
Référence de publication: 2015144977/14.
(150158380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
133872
Berlin (Bridge) S.à r.l.
Bishop Infrastructure Luxembourg S.à r.l.
C4Industries S.A.
Caparmor S.A.
Capital Inn Holding S.à r.l.
Carnot Technologies S.A.
Carnot Technologies S.A.
CBV GP S.à r.l..
Central European Participation II S.à r.l.
Chateaudun Investment S.à r.l.
Climmolux Holding
CM Consulting S.à r.l.
Cofima Holding S.A.
Cofima III S.A.
Cofima I S.A.
Cofima SA
Cofinimmo Luxembourg S.A.
"Commerz Real Fund Management S.à r.l.
Commonwealth Luxembourg Holdings S.à r.l.
Comptoir Immobilier Luxembourgeois
Comptoir Immobilier Luxembourgeois
Concord Luxembourg S.à r.l.
Consulting & Co. S.A.
Corber Enterprises S.à r.l.
Cotinvest S.A.
CSHV European Holdings S.à r.l.
CT Luxembourg Holdings S.à r.l.
DataEurope Founders S.à r.l.
Delfi Asset S.A.
Dusseldorf (Bridge) S.à r.l.
Dynamics Holding S.A.
DyStar Holding S.à r.l.
Evi Lux I S.A.
Evi Lux I S.à r.l.
HLD EUROPE S.C.A.
KPS Holding S.A.
Lenmorneftegaz Sàrl
Maison Pétrole Beta (Luxembourg)
Maison Pétrole Delta (Luxembourg)
Mominvest S.A.
Moneylift S.A.
New Europe Property Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
NN Lux Insurance International S.A.
Pfaudler Midco S.à r.l.
Stage Vision S.à r.l.
Turchese Trading e Investimentos S.A.
Winsley S.A., SPF
Yalino Luxembourg S.A.