logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2754

6 octobre 2015

SOMMAIRE

AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

132158

Addivant Luxembourg Holdings  . . . . . . . . . . .

132148

Al Avocado & Cy S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132165

ARM Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132146

Art Jardin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132165

Bâloise Vie Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .

132147

Bourgueil International . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132153

Cafor Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132147

C.C.Associates  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132155

CCE Holdings (Luxembourg)  . . . . . . . . . . . . .

132152

CGI Information Systems and Management

Consultants III Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . .

132165

CGI Information Systems and Management

Consultants II Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . .

132165

CH3 Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132146

Clarenville CDO S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132150

Clouse S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132146

Compagnie Ingénierie Financière (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132150

Composites GO S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132152

CRH Cities Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . .

132154

Digital Services XVII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

132153

Duvessa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132159

Empyreum S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132155

Ersel Gestion Internationale S.A.  . . . . . . . . . .

132160

Esyodis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132165

Euro Logistics & Trading S.A. . . . . . . . . . . . . .

132157

Euro Pneus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132158

EuroPRISA Lombard Street Acquisition S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132161

Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l.  . . . . . . . . . .

132166

Fiduciaire Socofisc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132188

Fifteen Episcia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132149

Fifteen Red Pine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132149

Gama Lettrage et Designs S.à r.l. . . . . . . . . . . .

132156

Harmony Multi-Manager Funds SIF-SICAV

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132162

Harmorlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132161

Highbridge Aiguilles Rouges Lux Sàrl II  . . . .

132161

HPS-GIM Credit Master Lux S.à r.l.  . . . . . . .

132162

IRAF Heidi Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132162

Mistral Partners 1 JV SCSp  . . . . . . . . . . . . . . .

132154

MPIT 1 JV SCSp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132151

Nordic Estate Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

132179

PALLINGHURST CONSOLIDATED (Lux)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132186

Patron Noosa Devco (Bath) S.à r.l.  . . . . . . . . .

132181

Patron Noosa Devco (Bournville) S.à r.l. . . . . .

132186

Patron Noosa Devco (Earley) S.à r.l.  . . . . . . . .

132184

Patron Noosa Devco (Lane End) S.à r.l.  . . . . .

132183

Patron Noosa Devco (Newbury) S.à r.l. . . . . . .

132190

Patron Noosa Devco (Solihull) S.à r.l.  . . . . . . .

132188

Thor Crewing Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . .

132147

Vidar Crewing Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

132192

132145

L

U X E M B O U R G

Clouse S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 163.904.

EXTRAIT

1) Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 23 juillet 2015 que:
- La démission de Monsieur SCHMIT Marc de ses fonctions d'Administrateur de la Société a été acceptée avec effet au

23 juillet.

- La démission de Madame BLAUEN-ARENDT Geneviève de ses fonctions d'Administrateur de la Société a été ac-

ceptée avec effet au 23 juillet.

- Monsieur John Wiseman, née le 22 août 1971 à Jersey, demeurant professionnellement au 13 Castle Street, St Helier,

Jersey JE4 5UT, a été nommée aux fonctions de gérant de la Société, à compter du 23 juillet 2015 jusqu'à assemblée générale
que se tiendra en 2021.

2) Le conseil d'Administration de la Société est dorénavant composé par:
- Fantuz Alexandra, Administrateur
- Caspers Rolf, Administrateur
- Wiseman John, Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015140684/25.
(150153128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

CH3 Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 176.287.

Banque de Patrimoines Privés, société anonyme, en sa qualité d'agent domiciliataire, a dénoncé le siège social de la

société à responsabilité limitée, CH3 CAPITAL S.à r.l., 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, RCS Luxembourg
B-176.287 avec effet immédiat et résilie la convention de domiciliation.

Luxembourg, le18 août 2015

BANQUE DE PATRIMOINES PRIVES
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2015140707/12.
(150153145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

ARM Holdings, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 171.355.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 août 2015, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Martin Raeymakers, avec professionnelle adresse au 8, Woudstraat, 3600 Genk,

Belgique de son mandat d'administrateur A, avec effet immédiat;

2. Acceptation de la démission de Paul Van Emmerick, avec adresse professionnelle au 8, Woudstraat, 3600 Genk,

Belgique de son mandat d'administrateur A, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de Matthias Georg Allgaier, avec adresse professionnelle au 25, St George Street, W1S

1FS Londres, Royaume-Uni de son mandat d'administrateur A, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140642/17.
(150153225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

132146

L

U X E M B O U R G

Cafor Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 97.864.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2014 tenue à 11.00 heures

<i>le 10 juin 2015

<i>Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux

comptes, à savoir:

<i>Administrateurs:

Mme Bourkel Anique, 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;
M. Bourkel Michel, 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;
Gestion &amp; Administration SA, Vaea Street, Level 2, Nia Mall, Apia, Samoa, Register of International and Foreign

Companies n° 29441

<i>Administrateur-délégué:

M. Bourkel Michel, 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;

<i>Commissaire aux comptes:

Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue &amp; Shirley Street S-E2, N-8188, Nassau,

Bahamas;

qui tous acceptent, pour l'année 2015 et jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2016.
Référence de publication: 2015140696/23.
(150153564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Bâloise Vie Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 54.686.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire le 13.8.2015

<i>Résolution unique

L'Assemblée nomme, sur proposition du Conseil d'Administration, Monsieur Alain NICOLAI, né le 10 octobre 1964 à

Luxembourg, demeurant à L-8021 Strassen, 34, rue de l'indépendance, comme nouvel administrateur de la société, avec
effet immédiat, pour une durée de 8 mois. Son mandat expirera donc à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice
2015.

Daniel FRANK
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015140647/15.
(150153252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Thor Crewing Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 191.796.

L'an deux mil quinze, le trois août.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Sophie Mathot, employée privée, en l’étude du notaire soussigné, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés

en vertu de l’acte numéro 48.782 du répertoire du notaire soussigné,

Lequel comparant a exposé ce qui suit:
En date du 6 novembre 2014, le notaire soussigné a reçu, sous le numéro 48.782 de son répertoire, l’acte constitutif de

THOR CREWING LUXEMBOURG SA, société anonyme, ayant son siège social à L-8399 Windhof, 11, route des Trois
Cantons, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 191796 (la
Société).

132147

L

U X E M B O U R G

Ledit acte a été enregistré le 7 novembre 2014 sous les références LAC / 2014 / 52273, déposé auprès du registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg le 14 novembre 2014 sous les références L140202482 et publié au Mémorial C
du 3 décembre 2014 numéro 3677.

Le comparant prend acte que l’actionnaire unique a décidé à l’issue dudit acte de nommer un commissaire aux comptes /

statutory auditor, alors qu'en vue de se conformer aux exigences du groupe dont fait partie la Société, les comptes devraient
être contrôlés par un réviseur d’entreprises agréé et que partant la nomination d’un commissaire aux comptes n’est pas
nécessaire.

Par la présente, le comparant, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés comme indiqué ci-avant requiert

la rectification comme suit:

Versions initiales française et anglaise à modifier

4. La personne suivante est nommée en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour une période prenant fin

à l’issue de la tenue de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2016:

La société Deloitte Audit s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf, RCSL B

67.895.

4. The following is appointed as statutory auditor for a period ending upon the holding of the annual meeting of share-

holders to be held in 2016.

Deloitte Audit s.à r.l., having its registered office in L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf, registered with the

Register of Companies of Luxembourg under number B 67.895

Versions française et anglaise qui remplacent les versions initiales

4. La personne suivante est nommée en qualité de réviseur d’entreprises agréé pour une période prenant fin à l’issue de

la tenue de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2016:

La société Deloitte Audit s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf, RCSL B

67.895.

4. The following is appointed as auditor (réviseur d’entreprises agréé) for a period ending upon the holding of the annual

meeting of shareholders to be held in 2016.

Deloitte Audit s.à r.l., having its registered office in L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf, registered with the

Register of Companies of Luxembourg under number B 67.895

Le reste de l'acte demeurant inchangé.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, celui-

ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie Mathot, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 5 août 2015. 1LAC / 2015 / 24995. Reçu 12 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 26 août 2015.

Référence de publication: 2015140509/53.
(150152575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Addivant Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 174.232.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique de la Société en date du 17 août 2015

1. Madame Antonella Graziano a démissionné de son mandat de gérant B;
2. Monsieur Andrew O'Shea, administrateur de sociétés, née à Dublin (Irlande), le 13 août 1981, demeurant profes-

sionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée
et avec effet immédiat.

3. Monsieur Olivier Hamou a démissionné de son mandat de gérant B;
4. Madame Ingrid Cernicchi, administratrice de sociétés, née à Metz (France), le 18 mai 1983, demeurant profession-

nellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérant B pour une durée indéterminée et
avec effet immédiat.

132148

L

U X E M B O U R G

<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 17 août 2015

1. Le siège social a été transféré de L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène

Ruppert avec effet immédiat.

Veuillez prendre note que le siège social de l'associé unique de la Société, Blue Holdings II, se situe désormais à L-2453

Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 18 août 2015.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Addivant Luxembourg Holdings
Un Mandataire

Référence de publication: 2015140575/26.
(150153558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Fifteen Episcia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 198.764.

Par résolutions signées en date du 4 août 2015, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Tolga Ardali, avec adresse au 24, Drosselweg, 50765 Esch Auweiler, Cologne, Allemagne, au mandat

de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en
2020;

2. Nomination de Frank Przygodda, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, au

mandat de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015 et pour une période venant à échéance lors de l' as-
semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l' exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et qui se
tiendra en 2020;

3. Nomination d'Elisabeth Wetz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, au mandat

de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015 et pour une période venant à échéance lors de l' assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l' exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en
2020;

4. Acceptation de la démission d'Antonio Longo, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xemburg, de son mandat de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015;

5. Acceptation de la démission de Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxemburg, de son mandat de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015;

6. Acceptation de la démission de José Correira, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xemburg, de son mandat de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2015.

Référence de publication: 2015140797/28.
(150153120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Fifteen Red Pine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 198.761.

Par résolutions signées en date du 4 août 2015, l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Ömer Kaan Birol Varol, avec adresse professionnelle à 16, Leopoldstrasse, 40211 Düsseldorf, Alle-

magne, au mandat de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015 et pour une période venant à échéance lors
de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et qui
se tiendra en 2020;

2. Nomination de Frank Przygodda, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, au

mandat de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015 et pour une période venant à échéance lors de l’as-
semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et qui se
tiendra en 2020;

3. Nomination d’Elisabeth Wetz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, au mandat

de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015 et pour une période venant à échéance lors de l’assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en
2020;

132149

L

U X E M B O U R G

4.  Acceptation  de  la  démission  d’Antonio  Longo,  avec  adresse  professionnelle  au  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882

Luxemburg, de son mandat de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015;

5. Acceptation de la démission de Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxemburg, de son mandat de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015;

6. Acceptation de la démission de José Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xemburg, de son mandat de «Verwaltungsratsmitglied», avec effet au 16 juillet 2015;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2015.

Référence de publication: 2015140798/28.
(150153119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Clarenville CDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 86.222.

Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du 6 août

2015:

- acceptation de la démission de Monsieur Patrick van Denzen et de Monsieur Shehzaad Atchia en tant qu'administrateurs

de la Société;

- nomination, en tant que nouveaux administrateurs de la Société, de Madame Marketa Stranska, née le 27 septembre

1973 à Praha 10 (République Tchèque) et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg et de Madame Maud Meyer, née le 25 mai 1982 à Amiens (France), ayant son adresse professionnelle au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2021;

- confirmation que le conseil d'administration de la Société est depuis le 6 août 2015 composé des administrateurs

suivants:

* Madame Marketa Stranska;
* Madame Maud Meyer; and
* Monsieur Erik van Os.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2014.

<i>Pour la Société
Erik van Os
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015140708/26.
(150153510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Compagnie Ingénierie Financière (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 45.031.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2014 tenue à 17.00 heures

<i>le 7 mai 2015

<i>Extrait des résolutions:

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, des administrateurs délégués et du commissaire

aux comptes, à savoir:

<i>administrateurs:

- M. Bourkel Michel, 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg
- M. Serge Kraemer, 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg
- Mme Bourkel Anique, 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg

<i>administrateurs-délégués:

- M. Bourkel Michel, 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg
- Mme Bourkel Anique, 9, Boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg

132150

L

U X E M B O U R G

<i>commissaire aux comptes:

- Wilbur Associates Ltd., IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue &amp; Shirley Street S-E2, Nassau, Baha-

mas, N-8188;

qui tous acceptent, pour l'exercice social 2015 et jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016.
Référence de publication: 2015140714/23.
(150153463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

MPIT 1 JV SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 199.359.

EXTRAIT

I/ La Société, MPIT 1 JV SCSp, une société en commandite spéciale, a été constituée par acte sous seing privé signé en

date du 14 août 2015 pour une durée illimitée, ayant son siège social au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.

II/ Il résulte du contrat social que l'objet social de la Société s'inscrit comme suit:
La Société peut réaliser (a) toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et la détention

de biens immobiliers (les Biens Immobiliers) et à la prise de participations dans (i) des entreprises (sous quelque forme
que ce soit) qui peuvent, conformément à leurs documents constitutifs, acquérir et détenir exclusivement des biens immo-
biliers et d'autres actifs nécessaires à la gestion de tels biens immobiliers (les Sociétés Immobilières) et (ii) des sociétés de
détention de portefeuille immobilier qui sont définies ici comme des entités dont l'objet social, conformément à leurs
documents constitutifs, est l'acquisition et la détention indirecte des biens immobiliers et autres actifs nécessaires à la
gestion de tels biens immobiliers, par le biais de l'acquisition et la prise de participations dans d'autres entités dont l'objet
social est limité de la même façon comme décrit aux points (i) et (ii) ci-dessus (les Sociétés de Détention de Portefeuille
Immobilier), ainsi que (b) l'administration, la gestion, le contrôle, le développement et la cession des Biens Immobiliers et
des participations dans les Sociétés Immobilières et les Sociétés de Détention de Portefeuille Immobilier.

Dans le cadre des objets indiqués ci-dessus, la Société peut apporter tout concours (par voie de prêts, avances, garanties,

sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière,

prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations qui se rattachent directement ou indi-
rectement à son objet social indiqué ci-dessus ou qui favorisent son développement ou son extension.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, unique-

ment par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts,
convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie
de ses avoirs.

III/ Il résulte du contrat social que la société suivante a été nommée en tant qu'associé commandité assurant les pouvoirs

de gérance de la Société pour une durée illimitée:

- MPIT 1 S.A., une société anonyme, établie et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège

sociale au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190142.

Son pouvoir est inscrit comme suit
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son associé commandité représenté par ses

signataires dûment autorisés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, 14 août 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2015140325/50.
(150152237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

132151

L

U X E M B O U R G

CCE Holdings (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 450.000,00.

Siège social: L-1818 Howald, 2, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 104.955.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale annuelle de l’associé unique de la Société prises le 27 juin 2013

L’associé unique de la Société prend acte de la démission de Jacques Purnode de ses fonctions d’administrateur de la

Société avec effet au 5 avril 2013.

L’Associé Unique a décidé de renouveler les mandats de Hubert Patricot, Marc Schmit, Frank Govaerts et Roger Gloden

de leurs fonctions d’administrateurs de la Société à compter du 27 juin 2013 et jusqu'à l’assemblée générale de l’associé
unique approuvant les comptes annuels de 2016.

L’associé unique a également décidé de renouveler le mandat de Ernst &amp; Young S.A. de sa fonction de réviseur d’en-

treprises agréé de la Société à compter du 27 juin 2013 et jusqu'à l’assemblée générale de l’associé unique approuvant les
comptes annuels de 2016.

L’associé unique a décidé de nommer à compter du 27 juin 2013, Karine Uzan-Mercie, résidant au 18, avenue Colonel

Bonnet, 75016 Paris, France, en tant que nouvel administrateur de la Société et jusqu'à l’assemblée générale de l’associé
unique approuvant les comptes annuels de 2016.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la Société prises le 15 octobre 2013

L’associé unique de la Société prend acte de la démission de Marc Schmit de ses fonctions d’administrateur de la Société

avec effet au 1 octobre 2013.

L’associé unique a décidé de nommer à compter du 15 octobre 2013, Yves Decorte, résidant au 43 Chemin d’Odrimont,

1380 Lasnes, Belgique, en tant que nouvel administrateur de la Société et jusqu'à l’assemblée générale de l’associé unique
approuvant les comptes annuels de 2016.

En conséquence de ce qui précède, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Hubert Patricot, administrateur;
- Frank Govaerts, administrateur;
- Roger Gloden, administrateur;
- Karine Uzan-Mercie, administrateur; et
- Yves Decorte, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CCE Holdings (Luxembourg)
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015140703/35.
(150153132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Composites GO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5835 Alzingen, 4, Hondsbreck.

R.C.S. Luxembourg B 177.335.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einunddreißigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine DECKER, mit Amtssitz in Hesperange.

Ist erschienen:

Herr Wolfgang STRATMANN, Diplom-Maschinenbauingenieur, geboren in Solingen (Deutschland), am 4 Juli 1955,

wohnhaft in L-5835 Alzingen, 4, Hondsbreck.

Der Komparent ersucht den unterzeichnenden Notar zu beurkunden dass:
- die Gesellschaft Composites GO S.à r.l. (die „Gesellschaft“), mit Gesellschaftssitz in L-5835 Alzingen, 4, Hondsbreck,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 177.335, gemäß Urkunde aufgenom-
men durch den amtierenden Notar, am 6. Mai 2013 gegründet wurde, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 1607 vom 5. Juli 2013;

- das Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je

fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), vollends eingezahlt;

- der Komparent Eigentümer sämtlicher Anteile der Gesellschaft ist und beschlossen hat die Gesellschaft aufzulösen

und zu liquidieren;

132152

L

U X E M B O U R G

somit die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung beschlossen ist;
die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft eingestellt wurde, alle Aktiva und Passiva auf den Komparenten als einziger

Eigentümer sämtlicher Anteile andurch übertragen werden, welcher alle Schulden der aufgelösten Gesellschaft beglichen
hat und sich verpflichtet, für alle, bis jetzt nicht bekannten Verbindlichkeiten persönlich zu haften;

die Gesellschaft als liquidiert zu betrachten ist;
dem Geschäftsführer vollumfängliche Entlastung für die Ausübung seines Mandates gewährt wird;
die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren am Gesellschaftssitz verwahrt werden;
Herr Wolfgang STRATMANN sich verpflichtet, die Kosten dieser Urkunde die sich auf ungefähr 1.040,-€ belaufen,

zu übernehmen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Hesperange, Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument dem Komparenten, welcher dem Notar mit seinem Familien- und Vornamen, Wohnsitz und

Familienstand bekannt ist, vorgelesen und erklärt wurde, hat dieser es zusammen mit dem amtierenden Notar unterzeichnet.

Signé: STRATMANN, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 août 2015. Relation: 1LAC/2015/25020. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft zwecks Hinterlegung bei dem Handels-und Gesell-

schaftsregister erteilt.

Hesperange, den 14. August 2015.

Référence de publication: 2015140686/41.
(150152922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Digital Services XVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.750,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 186.480.

Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Monsieur Martin TWELLMEYER a démissionné de son

mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 27 mai 2015.

Il ressort d'une deuxième lettre de démission adressée à la Société que Monsieur Robert REBHOLZ a démissionné de

son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 27 mai 2015.

Il ressort d'une troisième lettre de démission adressée à la Société que Monsieur David FUCHS a démissionné de son

mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 29 mai 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2015.

Digital Services XVII S.à r.l.

Référence de publication: 2015140734/17.
(150153292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Bourgueil International, Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 34, rue Albert Ier.

R.C.S. Luxembourg B 60.885.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2014 tenue le 2 juin 2015 à

<i>14.00 heures

<i>Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur - délégué et du commissaire

aux comptes, à savoir:

<i>administrateurs:

- Michel BOURKEL, adresse professionnelle 34, rue Albert 1 

er

 , L-1117 Luxembourg;

- Alexandre VANCHERI, adresse professionnelle 34, rue Albert 1 

er

 , L-1117 Luxembourg;

- Anique BOURKEL, adresse professionnelle 34, rue Albert 1 

er

 , L-1117 Luxembourg;

132153

L

U X E M B O U R G

<i>administrateur-délégué:

- Michel BOURKEL, adresse professionnelle 34, rue Albert 1 

er

 , L-1117 Luxembourg;

<i>commissaire aux comptes:

- WILBUR ASSOCIATES LTD, Union Court Building, Elizabeth Avenue &amp; Shirley Street S-E2, Nassau, Bahamas,

N-8188, IBC 185200;

qui tous acceptent, pour l'exercice 2015 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle à être tenue en 2016.
Référence de publication: 2015140672/22.
(150153594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

CRH Cities Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 198.290.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015142030/11.
(150155249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Mistral Partners 1 JV SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 199.370.

EXTRAIT

1/ La Société, Mistral Partners 1 JV SCSp, une société en commandite spéciale, a été constituée par acte sous seing

privé signé en date du 14 août 2015 pour une durée illimitée, ayant son siège social au 2, rue Jean Bertholet, L-1233
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il/ Il résulte du contrat social que l'objet social de la Société s'inscrit comme suit:
La Société peut réaliser (a) toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et la détention

de biens immobiliers (les Biens Immobiliers) et à la prise de participations dans (i) des entreprises (sous quelque forme
que ce soit) qui peuvent, conformément à leurs documents constitutifs, acquérir et détenir exclusivement des biens immo-
biliers et d'autres actifs nécessaires à la gestion de tels biens immobiliers (les Sociétés Immobilières) et (ii) des sociétés de
détention de portefeuille immobilier qui sont définies ici comme des entités dont l'objet social, conformément à leurs
documents constitutifs, est l'acquisition et la détention indirecte des biens immobiliers et autres actifs nécessaires à la
gestion de tels biens immobiliers, par le biais de l'acquisition et la prise de participations dans d'autres entités dont l'objet
social est limité de la même façon comme décrit aux points (i) et (ii) ci-dessus (les Sociétés de Détention de Portefeuille
Immobilier), ainsi que (b) l'administration, la gestion, le contrôle, le développement et la cession des Biens Immobiliers et
des participations dans les Sociétés Immobilières et les Sociétés de Détention de Portefeuille Immobilier.

Dans le cadre des objets indiqués ci-dessus, la Société peut apporter tout concours (par voie de prêts, avances, garanties,

sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière,

prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations qui se rattachent directement ou indi-
rectement à son objet social indiqué ci-dessus ou qui favorisent son développement ou son extension.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, unique-

ment par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts,
convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie
de ses avoirs.

Ill/ Il résulte du contrat social que la société suivante a été nommée en tant qu'associé commandité assurant les pouvoirs

de gérance de la Société pour une durée illimitée:

- Mistral Partners 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et existante selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège sociale au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190156.

Son pouvoir est inscrit comme suit:

132154

L

U X E M B O U R G

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son associé commandité représenté par ses

signataires dûment autorisés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, 14 août 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2015140308/50.
(150152339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

C.C.Associates, Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 34, rue Albert Ier.

R.C.S. Luxembourg B 66.107.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2014 tenue à 08,00 heures

<i>le 2 juin 2015

<i>Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux

comptes, à savoir:

<i>- administrateurs:

* Mme Bourkel Anique, 34, rue Albert 1 

er

 , L-1117 Luxembourg;

* M. Bourkel Michel, 34, rue Albert 1 

er

 , L-1117 Luxembourg;

* M. Vancheri Alexandre, 34, rue Albert 1 

er

 , L-1117 Luxembourg;

<i>- administrateur-délégué:

* M. Bourkel Michel, 34, rue Albert 1 

er

 , L-1117 Luxembourg;

<i>- commissaire aux comptes:

* Wilbur Associates Ltd, , IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue &amp; Shirley Street n°S-E2, Nassau,

Bahamas, N-8188;

qui tous acceptent, pour l'année 2015 et jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2016;
Référence de publication: 2015140676/22.
(150153464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Empyreum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4563 Differdange, 5, Z.A.C. Haneboesch II.

R.C.S. Luxembourg B 90.813.

L’an deux mille quinze, le huit août.
Pardevant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur René Yvon Jean SCHOMER, administrateur de société, né à Differdange, le 31 août 1955 (matricule 1955

0831 13118),

2.- Madame Maria HOFFMANN, administratrice de société, née à Illingen (Allemagne), le 18 août 1956 (matricule

1956 0818 56724), demeurant ensemble à L-4577 Differdange, 51, Cité Henri Grey.

Lesquels associés déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée EMPYREUM

S.à r.l. (Matricule 2003 2400 184) avec siège social à L-4577 Differdange, 51, Cité Henri Grey, constituée suivant acte
reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 17 janvier 2003,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 204, du 26 février 2003.
Lesquels associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués

et dont ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour au préalable et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:

1.- L’assemblée générale décide de transférer le siège social à Niederkorn.

132155

L

U X E M B O U R G

2.- Suite à la résolution qui précède le 1 

er

 alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Le siège social est établi dans la Commune de Differdange. (…)»
3.- L’assemblée générale décide de fixer l’adresse du siège social à L-4563 Differdange, 5, Z.A.C. Haneboesch II.
Plus rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais et charges en rapport avec le présent acte resteront à charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Differdange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états ou demeures,

ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Schomer, Hoffmann, Schuman.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 août 2015. Relation: EAC / 2015 / 18943. Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Differdange, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140120/38.
(150152484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Gama Lettrage et Designs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8057 Bertrange, 17B, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 147.787.

L'an deux mil quinze, le quatre août.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,

Ont comparu:

1. - Monsieur Gabriel DE CONTI, employé, né à Luxembourg, le 2 septembre 1977, demeurant à L-1739 Luxembourg,

13, rue Fernand d’Huart,

2. - Monsieur Marc MERSCH, employé, né à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 1981, demeurant à L-8361 Goetzingen,

21, rue Principale.

Lesquels comparants ont exposé au notaire:
Que la société à responsabilité limitée Gama Lettrage et Designs, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1321

Luxembourg, 235, rue de Cessange, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire alors de résidence
à Luxembourg, agissant en remplacement du notaire instrumentant empêché resté dépositaire de la minute, en date du 23
juillet 2009, publié au Mémorial C, numéro 1807 du 18 septembre 2009, modifié suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 30 novembre 2011, publié audit Mémorial C, numéro 116 du 14 janvier 2012.

Qu'elle est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147 787,
Qu'elle a un capital social de 12.500.- € divisé en 100 parts sociales de 125.- € chacune,
Que les comparants sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital de la société «Gama Lettrage et Designs

S.à r.l.» en vertu des statuts publiés comme prédit.

Ensuite les comparants prénommés, représentant l’intégralité du capital social de la société, se réunissant en assemblée

générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, ont requis le notaire instrumentant d'acter leur
résolution prise suivante:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de L-1321 Luxembourg, 235, rue de Cessange à L-8057

Bertrange, 17B, rue du Chemin de Fer, et de modifier en conséquence l’article 2 alinéa premier des statuts comme suit:

« Art. 2. (alinéa 1). Le siège social de la société est établi dans la commune de Bertrange.»

<i>Deuxième résolution

Les associés prennent acte des nouvelles adresses des gérants, à savoir:
- Monsieur Gabriel DE CONTI, préqualifié, demeurant à L-1739 Luxembourg, 13, rue Fernand d’Huart,
- Monsieur Marc MERSCH, préqualifié, demeurant à L-8361 Goetzingen, 21, rue Principale.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

132156

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à

sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 1.000.-€.

Fait et passé en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: DE CONTI, MERSCH, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 août 2015. Relation: 1LAC/2015/25023. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140156/48.
(150152759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Euro Logistics &amp; Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 110.133.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le six août.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social

à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg
sous le numéro B 49308,

ici représentée par Madame Cristiana VALENT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une

procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare et requière le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1.- Que la société anonyme "EURO LOGISTICS &amp; TRADING S.A.", régie par le droit luxembourgeois, avec siège

social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 110133, (ci-après nommée la “Société”), a été constituée suivant acte par Maître Jean
SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 août 2005, publié au Mémorial C numéro 36 du 6 janvier
2006.

2.- Que le capital social de la Société est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), représenté par trois cent cinquante

(350) actions d'une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.

3.- Que l'actionnaire unique est seul propriétaire de toutes les actions de la Société.
4.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5.- Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter

et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre
en exécution les dispositions du présent acte.

6.- Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif

présent et futur de la société dissoute.

7.- Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la

société indiqué au point 6.

8.- Que la liquidation de la Société est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.
9.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, président et au commissaire aux comptes de la société

dissoute pour l'exécution de leur mandat.

10.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société

à L-2522 Luxembourg, 6, Rue Guillaume Schneider.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à

raison de cet acte, est dès lors évalué à mille euros

132157

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 août 2015. Relation GAC/2015/6892. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015140783/49.
(150153634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 217.345.436,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 129.314.

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 10 juillet 2015, l'associé de la Société a nommé Aidan Clare en tant que nouveau gérant

de la avec effet au 20 juillet 2015 pour une durée indéterminée;

de sorte que le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Stefan Lambert, né le 8 janvier 1964 à Trêves en Allemagne, gérant,
avec adresse professionnelle à 59, rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Membre du Conseil de Gérance

Dr. Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1962 à Constance en Allemagne,
gérant, avec adresse professionnelle au 59, rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Membre du Conseil de Gérance

Aidan Clare, né le 14 juillet 1966 à Dublin en Irelande, gérant,
avec adresse professionnelle au 2 The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey, KT13 ONY, Royaume-Uni

Membre du Conseil de Gérance

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Stefan Lambert
<i>Gérant

Référence de publication: 2015140600/25.
(150153656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Euro Pneus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3321 Berchem, 56, rue Hans Adam.

R.C.S. Luxembourg B 49.728.

DISSOLUTION

L'an deux mil quinze, le vingt-neuf juillet.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

- Monsieur Andrea FAUZZI, retraité, né à Noci (Italie), le 19 juillet 1960, demeurant à L-3321 Berchem, 56, rue Hans

Adam,

Lequel comparant, a exposé au notaire instrumentant et l'a prié d'acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée «EURO PNEUS S.à r.l.» établie et ayant son siège social à L-3321 Berchem, 56,

rue Hans Adam, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 49.728 (ci-après la
«Société»), a été constituée sous la dénomination de «CONMAC S.à r.l.» suivant acte reçu par le notaire Camille HEL-
LINCKX, alors de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 151 de 1995, page 7203, et dont les statuts ont été modifiés une unique fois suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 4 octobre 2013, publié audit Mémorial C, numéro 2980 du 26 novembre 2013.

Que la Société a un capital social de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68

EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune, en-
tièrement libérées;

132158

L

U X E M B O U R G

Que le comparant est devenu le seul propriétaire de la totalité des parts sociales de la société «EURO PNEUS S.à r.l.»

en vertu d’une cession de parts sous seing privé datée du 11 septembre 2013, dont une copie conforme est restée, après
signature «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au prédit acte du 4 octobre 2013, pour être
enregistrée avec lui.

Ensuite le comparant agissant comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a décidé de dissoudre la

société «EURO PNEUS S.à r.l.», avec effet immédiat.

Qu'il déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société, celle-ci ayant cessé toute activité, et en connaître

parfaitement la situation financière;

Que la Société ne possède pas d'immeuble ni de part(s) d'immeuble(s);
En sa qualité de liquidateur de la Société, il déclare que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il se

trouve investi de tout l'actif et s'engage expressément à prendre en charge tout passif pouvant éventuellement encore exister
à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée au gérant pour son mandat jusqu'à ce jour.
Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la Société.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la Société.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: FAUZZI, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/24126. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140784/48.
(150152936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Duvessa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 193.436.

L'an deux mille quinze, le sept juillet;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

«STC International Limited», une société constituée et régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège

social à GTS Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au registre du BVI Business Companies Act
2004 sous le numéro 1273,

ici représentée par Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la

mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparant, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “Duvessa S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 43,

boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
193436, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 décembre 2014, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 369 du 11 février 2015;

- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'"Associée Unique") de la Société et qu'elle a pris, par sa

mandataire, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'Associée Unique décide de changer l'année sociale de la Société, de sorte qu'elle courra désormais du 1 

er

 juillet de

chaque année au 30 juin de l'année suivante et de modifier subséquemment les articles 16, 17 et 14 des statuts afin de leur
donner la teneur suivante:

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 juillet de chaque année et se termine le 30 juin

de l'année suivante."

132159

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 30 juin, les comptes de la Société sont établis et suivant le cas, le gérant

ou le conseil de gérance, dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société."

Art. 14. Assemblées générales des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se

tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation
à l'assemblée, le dernier vendredi du mois de novembre à quatorze heures."

<i>Deuxième résolution

L'Associée unique déclare en outre que:
- l'année sociale qui a débuté le 17 décembre 2014, s'est terminée exceptionnellement le 30 juin 2015.

- l'exercice social qui a débuté le 1 

er

 juillet 2015 se terminera le 30 juin 2016.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A.UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 juillet 2015. 2LAC/2015/15467. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 23 juillet 2015.

Référence de publication: 2015140738/51.
(150153635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Ersel Gestion Internationale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 17, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 30.350.

<i>Extrait rectificatif des résolutions prises lors du Conseil d'Administration en date du 17 juin 2015 (déposées le 19 juin

<i>2015 sous la référence L150106597)

Les pouvoirs de Monsieur Henri Ninove en qualité de délégué à la gestion journalière sont modifiés comme suit:
Pouvoir de signer seul:
- tout contrat concernant l'activité de la Société ou de ses fonds (Globersel, Leadersel, Systematica, Ersel Sicav, Value

SIF), tels que ISDA, CSA, contrats de gestion déléguée, de distribution, de rebate, d'engagement d'auditeur et tout autre
contrat pour la Société ou ses fonds, pour n'importe quel type d'opération, y compris achat, vente de titre ou de fonds, spot,
à terme ou dérivé;

- ouvertures de compte, approuvé par le Conseil d'Administration de la Société, pour la Société ou ses fonds;
- tout acte de la gestion quotidienne de la Société ou de ses fonds, tels que déclarations fiscales, communications aux

autorités fiscales, de contrôle ou autre;

- tout paiement pour le compte de la Société ou de ses fonds (tels que commissions, factures) jusqu'à 3.000 EUR.
Pouvoir de signer avec un administrateur:
Tout paiement au-dessus de 3.000 EUR.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Ersel Gestion Internationale SA
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2015140755/25.
(150153673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

132160

L

U X E M B O U R G

EuroPRISA Lombard Street Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 110.926.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 12 août 2015 que les associés de la Société ACCA

Privatstiftung et Anonymos Privatstiftung ont chacun transféré l'intégralité des trente (30) parts sociales qu'ils détenaient
dans le capital social de la Société à EuroPRISA Luxembourg Holding Company P S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2, Boulevard de la Foire, L - 1528 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B113414;

Suite à ce transfert, EuroPRISA Luxembourg Holding Company P S.à r.l. détient désormais trois cent vingt (320) parts

sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140769/18.
(150152969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Highbridge Aiguilles Rouges Lux Sàrl II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 181.511.

L'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Démission du gérant de catégorie B suivant avec effet au 31 juillet 2015:
Mr Johannes Laurens de Zwart
2. Nomination du nouveau gérant de catégorie B suivant avec effet au 1 

er

 août 2015 pour une durée indéterminée:

Robert Jan Schol, né le 1 

er

 août 1959 à Delft aux Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Highbridge Aiguilles Rouges Lux Sàrl II
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015140863/18.
(150153638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Harmorlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 158.897.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 1 

er

 juin 2015 a renouvelé le mandat de l'administrateur unique.

- Monsieur Marie-Dominique ORBAN de XIVRY, Administrateur, chef d'entreprise, rue Albert 1 

er

 , 55, B-1490 Court-

Saint-Etienne, Belgique.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
L'assemblée générale du 1 

er

 juin 2015 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2015.

<i>Pour HARMORLUX S.A.
Société anonyme

Référence de publication: 2015140868/18.
(150153144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

132161

L

U X E M B O U R G

Harmony Multi-Manager Funds SIF-SICAV, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -

Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 162.046.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 14 août 2015:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide:
- le renouvellement du mandat de KPMG Luxembourg Société Coopérative («Réviseur d'Entreprises agréé») en tant

que Réviseur du Fonds pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2016 et qui approuvera les comptes annuels de l'exercice social se terminant le 31 Décembre 2015.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire,
Le Réviseur d'Entreprises agréé est:
- KPMG Luxembourg Société Coopérative, ayant son siège social à 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2015.

Référence de publication: 2015140867/18.
(150153416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

HPS-GIM Credit Master Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 193.488.

Les décisions suivantes ont été prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 14 août 2015:
- acceptation de la démission de Monsieur Johannes Laurens de Zwart en tant que gérant de la Société avec effet rétroactif

au 31 juillet 2015;

- nomination, avec effet rétroactif au 1 

er

 août 2015, en tant que nouveau gérant de la Société pour une durée indéterminée,

de Monsieur Robert Jan Schol, né le 1 

er

 août 1959 à Delft (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- confirmation que le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé des administrateurs suivants:
* Monsieur Robert Jan Schol;
* Monsieur Faith Rosenfeld; and
* Monsieur Fabian Sires,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

<i>Pour la Société
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Dûment autorisé

Référence de publication: 2015140881/24.
(150153512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

IRAF Heidi Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 180.987.

In the year two thousand and fifteen, on the third August.
Before the undersigned, Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. “INFRARED ACTIVE REAL ESTATE III (No. 2) L.P.”, a limited partnership formed under the English Limited

Partnerships  Act  1907  Regency  Court,  Glategny  Esplanade,  GY1  1WW  St  Peter  Port,  Guernsey,  registered  with  the
Guernsey Trade Register under the number LP2093, duly represented by its general partner, “INFRARED ACTIVE REAL
ESTATE III GENERAL PARTNER LLP”, a limited liability company incorporated and existing under the laws of United

132162

L

U X E M B O U R G

Kingdom having its registered office is at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom, and registered with
the Companies’ Register of England and Wales under the number OC384542, duly represented by its managing member,
INFRARED CAPITAL PARTNERS (HOLDCO) LIMITED;

2.  “IRAF  HEIDI  (GUERNSEY)  LIMITED”,  a  limited  company  formed  pursuant  to  section  20  of  The  Companies

(Guernsey)  Law  2008  having  its  registered  office  at  Regency  Court,  Glategny  Esplanade,  GY1  1WW,  St  Peter  Port,
Guernsey, registered with the Guernsey Trade Register under the number 59139.

All of them here represented by Mr. Thomas MATHIEU, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of “ad hoc” proxies given under private seal.

The said proxies, signed “ne varietur” by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are the sole shareholders of “IRAF HEIDI HOLDINGS”, a “société à responsabilité limitée”,

established and having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number
180.987), incorporated on 14 October 2013 by a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, published
in the Mémorial C N°3076 of 4 December 2013 (hereafter the “Company”).

The appearing parties, represented as state above, representing the whole corporate capital require the notary to act the

following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to proceed to the dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as of today.

<i>Second resolution

The shareholders resolve to appoint as sole liquidator of the Company: IRAF III LIMITED, a private limited company

incorporated nder the laws of the United kingdom, having its registered office at 12 Charles II Street, London SW1Y 4QU,
registered with the Companies’ Register of England and Wales under the number 9709017, duly represented by its directors
Mr Tim THORP and Mr Chris GILL (hereafter the “Liquidator”).

<i>Third resolution

The shareholders resolve to confer the following powers to the Liquidator:
- The Liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated laws

on commercial companies as amended.

- The Liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of

Shareholders if the latter is required.

- The Liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The Liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-

mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxy holder.

Out of the net proceeds of the liquidation, the Liquidator is authorised and empowered to make at any time, in one port

or in several ports, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the Luxembourg
Company Act.

<i>Fourth resolution

The shareholders resolve to grant full discharge to the managers of the Company for the execution of their mandate up

to this date.

Nothing else being on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same parties and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy-holder of the parties appearing, known to the notary by his surname, first

name, civil status and residence, said person signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le trois août.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. “INFRARED ACTIVE REAL ESTATE III (No. 2) L.P.”, un “limited partnership“, formé sous “the English Limited

Partnerships Act 1907” Regency Court, Glategny Esplanade, GY1 1WW St Peter Port, Guernsey, inscrit au Registre de
commerce de Guernsey sour le numéro LP2093, dûment représenté par son ‘general partner’, “INFRARED ACTIVE REAL
ESTATE III GENERAL PARTNER LLP”, a ‘limited liability company’, ayant son siege social au 12, Charles II Street,

132163

L

U X E M B O U R G

Londres SW1Y 4QU, Royaume Uni, immatriculée au Regsitre des Sociétés d’Angleterre et pays de Galles sous le numéro
OC384542, dûment représenté par son ‘managing member’, “INFRARED CAPITAL PARTNERS (HOLDCO) LIMI-
TED”;

2. “ IRAF HEIDI (GUERNSEY) LIMITED”, un “limited company“, formé “pursuant to section 20 of the Companies

(Guernsey) Law 2008”, ayant son siege social au Regency Court, Glategny Esplanade, GY1 1WW, St Peter Port, Guernsey,
inscrite auprès du Registre des Sociétés de Guernsey sous le numéro 59139.

Tous ici dûment représentés par Monsieur Thomas MATHIEU, employé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu de procurations «ad hoc» données sous seing privé.

Les procurations signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes sont les seuls associés de «IRAF HEIDI HOLDINGS», une société à responsabilité limitée,

établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 180.987),
constituée en date du 14 octobre 2013 suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°3076 du 4 décembre 2013 (ci-après la «Société»).

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire

instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce

jour.

<i>Seconde résolution

IRAF III LIMITED, une «private limited company» constituée suivant les lois du Royaume uni, ayant son siège social

au 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, immatriculée auprès du Registre de Commerce d’Angleterre et Pays de Galles
sous le numéro 970917, dûment représentée par ses administrateurs Mr Tim THORP et Mr Chris GILL (ci-après le «Li-
quidateur»).

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’investir le Liquidateur des pouvoirs suivants:
- le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales, telles que modifiées.

- le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le Liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
- le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.

Des bénéfices nets de la liquidation, le Liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois,

toute distribution en espèces qu’il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise con-
cernant les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident d’accorder pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l’exécution de leur mandat

respectif jusqu’à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes
parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataitre des parties comparantes, connu du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Mathieu, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 août 2015. Relation: EAC/2015/18340. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Amédé SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 5 août 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015142190/120.
(150154467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

132164

L

U X E M B O U R G

Esyodis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 2, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 156.235.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015142096/11.
(150155412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Art Jardin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 7, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 169.984.

Les statuts coordonnés ont été dûment déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Paul MEYERS
<i>Le notaire

Référence de publication: 2015142625/11.
(150156151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

CGI Information Systems and Management Consultants II Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activités de Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 154.815.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015142694/11.
(150155981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

CGI Information Systems and Management Consultants III Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité de Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 171.407.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015142696/11.
(150155938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

Al Avocado &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 181.510.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 20 août 2015.

Référence de publication: 2015142605/10.
(150155478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

132165

L

U X E M B O U R G

Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 195.167.

In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of the month of July.
Before Maître Leonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement

of Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Logicor Europe Holdings II S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twenty-five thousand Euros (EUR 25,000) and registered with the Registre de Commerce et des
Sociétés of Luxembourg under number B 181.528 (the “Sole Shareholder”),

represented by Maître Ségolène Le Marec, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 3

th

 August 2015 which proxy shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder

and the undersigned notary,

being the Sole Shareholder of Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability

company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 195.167 (the "Company"), incorporated
on  2  March  2015  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Cosita  DELVAUX,  notary  residing  in  Luxembourg,  Grand  Duchy  of
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 20 April 2015,
number 1036.

The articles of association of the Company have never been amended.
The appearing party, represented as above stated declared and requested the notary to record as follows:
A. The Sole Shareholder holds all the five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital

is represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.

B. The items on which resolutions are to be taken are as follows:
1) creation of two classes of shares in the Company, namely class A shares and class B shares, and determination of the

rights and obligations thereof by amending and restating the articles of association of the Company as set forth further to
item 4) of the agenda.

2) reclassification of all the five hundred (500) issued shares in the Company as five hundred (500) class A shares.
3) increase of the issued share capital by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) from its current

amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) by the issue of
five hundred (500) new class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) (the “New Shares”) and
a total subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) (the “Subscription Price”); subscription to
the New Shares by the Sole Shareholder and payment of the Subscription Price in cash.

4) consequential amendment and restatement of the articles of association of the Company to reflect the resolutions on

the items above.

Thereafter the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to create two classes of shares in the Company, namely class A shares and class B shares,

and to determine the rights and obligations thereof by amending and restating the articles of association of the Company
as set forth further to item 4) of the agenda.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to reclassify all the five hundred (500) issued shares in the Company as five hundred

(500) class A shares.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital by an amount of twelve thousand five hundred Euro

(EUR 12,500) from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to twenty-five thousand Euro
(EUR 25,000) by the issue of five hundred (500) new class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25) (the “New Shares”) and a total subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) (the “Subscription
Price”).

132166

L

U X E M B O U R G

The New Shares have been subscribed and fully paid in by way of a contribution in cash of twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500) by the Sole Shareholder pursuant to proxy and subscription forms (copies of which shall remain attached
to the present deed to be registered therewith).

Proof of the existence and the amount of the Subscription Price, blocked in an account of the Company, has been given

to the notary.

<i>Fourth resolution

As  a  consequence  of  the  preceding  resolutions,  the  Sole  Shareholder  resolved  to  amend  and  restate  the  articles  of

association of the Company to reflect the resolutions on the items above.

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Ferrari Logistics

Pledgeco S.à r.l.” (the “Company”) between the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect

participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance

money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case

may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twenty five thousand Euros (EUR 25,000)

represented by (i) five hundred (500) shares of class A of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each, and (ii)
five hundred (500) shares of class B of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each.

132167

L

U X E M B O U R G

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.

Each class of shares shall be issued in connection with the acquisition or making by the Company of a specific investment

or investment portfolio directly or indirectly (each a "Specific Investment"), except as otherwise specified herein. The
subscription price paid to the Company upon the issuance of shares of a particular class (including for the avoidance of
doubt any share premium) (the "Subscription Price"), net of all costs payable by the Company in connection with such
issuance including, but not limited to, capital duty, notarial fees and publication costs ("Issuance Costs"), shall be invested
directly or indirectly in one and the same Specific Investment.

The Specific Investment for Class A is the Class A Portfolio.
The Specific Investment for Class B is the Class B Portfolio.
In relation to each Specific Investment, the sole manager, or as the case may be, the board of managers will, in the

internal accounts of the Company, establish a separate compartment of assets and liabilities of the Company in the following
manner:

- the Subscription Price of the relevant class of shares, the payment to share premium account, and the proceeds of any

loans, preferred equity certificates, debt or other instruments convertible or not which may from time to time be granted
to, or issued by, the Company by or to its shareholder(s) in connection with the relevant Specific Investment, as well as
assets acquired with such funds contributed to or borrowed by the Company, in each case shall be applied in the internal
books of the Company to the compartment established for such Specific Investment;

- any income or proceeds earned by the Company on, or any asset derived from, the assets allocated to a compartment

shall be allocated to that compartment;

- any liability, costs and expenses (including provisions) relating to assets allocated to a compartment or to any action

taken in connection with a compartment or an asset of a particular compartment or in connection with the issuance of shares
or other instruments of the particular class (such as Issuance Costs) as well as all administration expenses, tax liabilities
and other costs and expenses of the Company attributable to the relevant Specific Investment or the operation or adminis-
tration of that compartment shall be allocated to that compartment;

- in the case where any liability or expense of the Company cannot be considered as being attributable solely to a

particular compartment, such liability or expense shall be allocated between all the existing compartments pro rata to the
Net Assets (as defined below) of each compartment or pro rata to the relevant compartments to which the liability or expense
relates;

- any distributions or payments (including payments of the price payable by the Company for shares of the relevant class

repurchased by it) made to shareholders in respect of a compartment shall reduce the Net Assets (as defined below) of that
compartment;

- the net assets of each compartment (the "Net Assets") will be equal to the sum of the value of the Specific Investment

of that compartment and all other assets attributable to that compartment in accordance with these articles of association
less all the liabilities, costs and expenses allocated to that compartment in accordance with these articles of association.

For the avoidance of doubt, any reference to the Net Assets in these articles of association may be construed as a reference

to the Net Assets as calculated for any Specific Investment allocated to a specific class of shares in the compartment created
to that purpose in the internal accounts of the Company.

Any share premium paid in respect of a specific class (or sub-class) of shares upon their issuance shall be allocated to

a share premium account corresponding to that specific class (or sub-class) of shares of the Company. Any payment or
contribution of any kind to any share premium account established in accordance with Luxembourg law or accounting
regulations shall be specified as to which class of shares (or sub-class) it relates, the sole manager or, as the case may be,
the board of managers, having the power to confirm any allocation to a specific class (or sub-class) of shares if this has not
been specified otherwise. Any available share premium shall be distributable. In addition, the economic rights of share-
holders may be governed by an agreement between the shareholders. To the extent there are any inconsistencies between
the provisions of such agreement and these articles of association, the principle set out in the agreement between the
shareholders in relation to the economic rights shall prevail.

Art. 6. Cancellation of an entire class of shares and reduction of share capital. The share capital of the Company may

be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire class of shares through
the repurchase and cancellation of all the shares in issue in the relevant class by approval at the general meeting of share-
holders resolving at the quorum and majorities provided for the amendment of the articles of association.

In case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more class of shares, the

holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the
Cancellation Value per Share (as defined below) for each share of the relevant class held by them and cancelled.

The board of managers shall, in case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a

class of shares, calculate the Class Available Amount for the repurchased class (always subject to the amount of available
profits, premium and reserves of the Company) on the basis of the interim accounts of the Company and interim internal

132168

L

U X E M B O U R G

accounts relating to the relevant class which shall be prepared on the basis set out in Article 5, each time not older than
eight (8) days (together, the “Interim Accounts”).

“Class Available Amount” means the total amount of net profits, available reserves and premium of the Company

(including carried forward profits) relating to the Specific Investment to which the relevant class of shares belongs (i) plus
the amount of the share capital reduction relating to the class of shares repurchased (and if any the amount equal to the
decrease of the legal reserve relating to the reduction of share capital in relation to such class) but (ii) less any Investment
Losses of that class (including carried forward losses) and (iii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of the articles of association each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the
avoidance of doubt, any double counting), so that:

AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Class Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled
L = Investment Losses
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles of association.
“Class A Portfolio”, means the investment by way of units, premium account, loans, preferred equity certificates, or

other instruments, convertible or not, or otherwise in the Italian fund to be formed to invest in “Project Ferrari” (and the
underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly
or indirectly the project Ferrari, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other
projects and especially project Scorpion.

“Class B Portfolio” means the investment by way of units, premium account, loans, or other instruments, convertible

or not, or otherwise in the Italian Fund to be formed to invest in “Project Scorpion”, (and the underlying assets, subsidiaries
and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the portfolio
of project Scorpion, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and
especially project Ferrari.

“Investment Losses” means any losses (including carry forward losses relating to the relevant Specific Investment) and

any costs, charges or expenses related to the relevant Specific Investment (including repayment by the Company of any
debt incurred to manage the respective Specific Investment), and an amount corresponding to the pro rata portion (calculated
of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by the board of managers) and the Company's non-
recoverable losses. The “Cancellation Value per Share” shall be calculated by dividing the Class Cancellation Amount by
the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

The “Class Cancellation Amount” shall be an amount determined by the sole manager or, as the case may be, the board

of managers and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the Interim Accounts. Subject always to
the amount of available net profits, reserves and premium of the Company, the Class Cancellation Amount for the class of
shares to be repurchased and cancelled shall be the Class Available Amount unless otherwise resolved by the general
meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the articles of association provided however that the
Class Cancellation Amount shall never be higher than the Class Available Amount and provided further that the Class
Cancellation Amount shall never be greater than the total amount of available net profits, reserves and premium of the
Company.

Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class, the Cancellation Value per Share will become

due and payable by the Company.

Art. 7. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent (75%)
of the Company's share capital.

Art. 8. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business

of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers, including specific powers given
in specific provisions of these articles of association.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to

act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed

132169

L

U X E M B O U R G

for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,

by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 9. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability”
and “expenses” shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the

board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.

Art. 10. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns (regardless of class) and may validly act at any meeting of shareholders through a
special proxy.

Art. 11. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting

132170

L

U X E M B O U R G

of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in

the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in  the  register  of  shareholders  held  by  the  Company  at  least  eight  (8)  days  before  the  proposed  effective  date  of  the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions  (or  subject  to  the  satisfaction  of  the  majority  requirements,  on  the  date  set  out  therein).  Unanimous  written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than forty (40) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 12. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December

2015.

Art. 13. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the sole

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 14. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on one or several classes of shares on the basis of statements of

accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the
last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law (regardless of the Investment Net Income of
a class of shares). Distribution to a class shall only be made out of the Investment Net Income related to that class (subject
to the above).

“Investment Net Income” means any income last accounting year increased by profits carried forward and distribute

return of any total or partial disposal of the relevant Specific Investment (disposal meaning through transfers and contri-
butions of any kind) as well as any dividends or other distributions, interest, yield, financing margin, repayment of principal
or other income or return deriving from the relevant Specific Investment and assets and reserve funds received by or
attributable to the Company in respect of the issue of the relevant class of shares such as the share premium or any amounts
of profit (related to the relevant Specific Investment(s)) carried forward after deducting any costs, charges or expenses
related to the relevant Specific Investment (including repayment by the Company of any debt incurred to manage the
respective Specific Investment), and an amount corresponding to the pro rata portion calculated of the Company's overhead
expenses  (assessed  fairly  but  irrevocably  by  the  board  of  managers  or  the  sole  manager  as  the  case  may  be)  and  the
Company's non-recoverable losses.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders,

but only to the shareholders of the class to which this share premium relates to. The general meeting of shareholders may
decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 15. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Upon liquidation of the Company the liquidation proceeds of each class shall be the amount to which the class is entitled

as  per  the  relevant  Specific  Investment  if  applicable.  Each  class  of  shares  shall  be  entitled  to  proceeds  of  liquidation
determined as follows in relation to the relevant Specific Investment to which the class relates:

First all debts and liabilities of the Company (regardless of Specific Investment) shall be paid. Such debts or liabilities

shall be attributed to the class of shares to which they specifically belong (i.e. because they relate to the relevant Specific
Investment for that class) or, if that is not possible, distributed rateably among all classes of shares in proportion of the
issued share capital of the Company which they represent.

132171

L

U X E M B O U R G

Thereafter the relevant amount of liabilities for each class of shares shown in the separate category for the Specific

Investment to which they relate shall be set against the assets attributable to the relevant class including in particular the
Specific Investment of that class and any reserve funds attributable to such class. Assets not attributable to a specific class
shall be divided pro rata to all classes of shares.

To the extent that the amount so calculated for any class shall be negative, such class shall not be entitled to any liquidation

proceeds. The relevant negative amount shall be allocated rateably among all classes of shares which have a positive amount
up such positive amount. Any surplus remaining within a specific class of shares (the "Class Surplus") shall be distributed
to the relevant holders of such class of shares.

Art. 16. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies,

as amended; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at EUR 2,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above

appearing persons the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Englischen Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am vierten Tag des Monats August.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Leonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

in Vertretung für Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

Logicor Europe Holdings II S.à r.l., société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxembur-

gischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital fünfundzwanzigtau-
send Euro (EUR 25.000) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg, unter der
Nummer B 181.528 (der „Alleinige Gesellschafter“),

hier vertreten durch Maître Ségolène Le Marec, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Voll-

macht ausgestellt am 3. August 2015, welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt wird nachdem sie ne varietur durch den
Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde,

als Alleiniger Gesellschafter der Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft

mit  beschränkter  Haftung)  luxemburgischen  Rechts  mit  Sitz  in  2-4,  rue  Eugène  Ruppert,  L-2453  Luxembourg,  deren
Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen im Registre de Commerce et
des Sociétés in Luxemburg unter Nummer B 195.167 (die „Gesellschaft“), gegründet am 2. März 2015 gemäß Urkunde
aufgenommen durch Maître Cosita DELVAUX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlich am 20. April 2015 im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“), Nummer 1036.

Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nie abgeändert.
Der Erschienene gibt, in Ausübung seines obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden

Notar folgendes zu beurkunden:

A. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hält alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Ge-

sellschaftsanteile, sodass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und wirksam über alle Punkte der Tagesordnung
entschieden werden kann.

B. Die Punkte, über die Beschlüsse getroffen werden sollen, sind die Folgenden:
1) Gründung von zwei Anteilsklassen der Gesellschaft, nämlich Klasse A Anteile und Klasse B Anteile, und Bestimmung

deren Rechte und Pflichten durch die Abänderung und Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft, wie in Punkt 4 der
Agenda vorgesehen.

2) Umbenennung aller fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftsanteile in fünfhundert (500)

Klasse A Anteile.

3) Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapital in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) von dem

aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) auf fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25,000) durch
Ausgabe von fünfhundert (500) neuen Anteilen der Klasse B mit einem Nominalwert in Höhe von fünfundzwanzig Euro
(EUR 25) (die „Neuen Anteile“) und für einen Gesamtzeichnungspreis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500)

132172

L

U X E M B O U R G

(der „Zeichnungspreis“); Zeichnung der Neuen Anteile durch den Alleinigen Gesellschafter und Zahlung des Zeichnungs-
preises in Bar.

4) Die daraus folgende Abänderung und Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft um die Beschlüsse über die

obengenannten Punkte widerzuspiegeln.

Danach wurden die folgenden Beschlüsse vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen zwei Anteilsklassen der Gesellschaft, nämlich Klasse A Anteile und Klasse

B Anteile, zu gründen, und die daraus hervorgehenden Rechte und Pflichten durch die Abänderung und Neuformulierung
der Satzung der Gesellschaft zu bestimmen, wie in Punkt 4 der Agenda vorgesehen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschafts-

anteile in fünfhundert (500) Klasse A Anteile umzubenennen.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen das Gesellschaftskapital in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR

12,500) von dem aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) auf fünfundzwanzigtausend Euro
(EUR 25,000) zu erhöhen, durch die Ausgabe von insgesamt fünfhundert (500) neuen Anteilen der Klasse B mit einem
Nominalwert  von  je  fünfundzwanzig  Euro  (EUR  25)  (die  „Neuen  Anteile“)  und  einem  Zeichnungspreis  in  Höhe  von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) (der „Zeichnungspreis“). Die Neuen Anteile sind in bar in Höhe von dem
aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) gezeichnet und völlig bezahlt worden durch den Al-
leinigen Gesellschafter laut Bevollmächtigungen und Zeichnungsformular (deren Kopien mit dieser Urkunde eingetragen
werden soll).

Ein Beweis über die Existenz und den Betrag des Zeichnungspreises, in einem Sperrkonto der Gesellschaft beinhaltet,

wurde vor dem Notar gezeigt.

<i>Vierter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat folglich beschlossen die Satzung der Gesellschaft abzuändern und neu zu formulieren,

um die oben genannten Beschlüsse widerzuspiegeln.

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

"Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise sowie die Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direktem oder indirektem Erwerb von Grundbesitz,

Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann garantieren, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder

indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder
anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-

geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzen oder Regulierungsmaßnahmen, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

132173

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-

denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,

durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfundzwanzig-

tausend Euro (EUR 25.000), eingeteilt in (i) fünfhundert Klasse A (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je
fünfundzwanzig  Euro  (EUR  25)  und  (ii)  fünfhundert  Klasse  B  (500)  Gesellschaftsanteile  mit  einem  Nennwert  von  je
fünfundzwanzig Euro (EUR 25).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung

vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann ihre anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Jede Anteilsklasse wird in Verbindung mit dem Erwerb oder der Durchführung eines spezifischen direkten oder indi-

rekten Investments ausgegeben (jedes ein „Spezifisches Investment“), soweit hiernach nicht anders angegeben. Der, der
Gesellschaft gezahlte Zeichnungspreis bei der Ausgabe der Anteile (um Zweifel zu vermeiden einschließlich jedes An-
teilsprämien) (der „Zeichnungspreis“), abzüglich aller durch die Gesellschaft, bezüglich der Anteilsausgabe, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf, Gesellschaftssteuer, Notargebühren und Veröffentlichungskosten („Emissionskosten“) zu zah-
lenden Kosten, soll direkt oder indirekt in ein und demselben Spezifischen Investment investiert werden.

Das Spezifische Investment bezüglich Klasse A bezieht sich auf Klasse A Portfolio.
Das Spezifische Investment bezüglich Klasse B bezieht sich auf Klasse B Portfolio.
In Bezug auf jedes Spezifische Investment wird der alleinige Geschäftsführer, beziehungsweise die Geschäftsführung,

in der Buchführung der Gesellschaft wie folgt eine separate Abteilung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf-
stellen:

- Der Zeichnungspreis der relevanten Anteilsklasse, die Zahlung ins Anteilsprämienkonto, Erlöse aus Gesellschafter-

darlehen, Preferred Equity Certificates, Schulden oder andere Instrumente, wandelbar oder nicht, welche von Zeit zu Zeit
der Gesellschaft gewährt, oder durch die Gesellschaft gewährt werden, von oder an ihre(n) Anteilsinhabe(r), in Verbindung
mit dem relevanten Spezifischen Investment, sowie Vermögenswerte welche mit solchen Mitteln der Gesellschaft beige-
tragen  oder  von  ihr  geliehen  wurden,  sollen  in  der  Buchhaltung  der  Gesellschaft  der,  des  spezifischen  Investments
zugeteilten separaten Abteilung, angewendet werden;

- Alle Einkommen oder Einlöse welche die Gesellschaft verdient, oder irgendwelche Vermögenswerte, abgeleitet von

den Vermögenswerten die einer separaten Abteilung der Buchführung zugeteilt sind, werden dieser separaten Abteilung
zugeteilt;

- Jegliche Verbindlichkeit, Kosten und Ausgaben (einschließlich Provisionen) bezüglich der Vermögenswerte die einer

separaten Abteilung zugerechnet werden, oder jeglicher in Verbindung mit einer separaten Abteilung oder einem Vermö-
genswertes  einer  separaten  Abteilung,  oder  in  Verbindung  mit  der  Ausgabe  von  Gesellschaftsanteilen  oder  anderer
Instrumente der betroffenen Klasse (z.B. Emissionskosten), getroffenen Handlung, sowie alle administrativen Kosten,
Steuerverpflichtungen und andere Kosten und Ausgaben der Gesellschaft welche dem relevanten Spezifischen Investment
zugerechnet werden können, oder die Durchführung und Verwaltung dieser Abteilung, sollen dieser separaten Abteilung
zugerechnet werden;

- Im Falle von Verbindlichkeit oder Aufwendung der Gesellschaft welche nicht einer separaten Abteilung zugerechnet

werden können, wird diese Verbindlichkeit oder Aufwendung pro rata zu den Nettovermögenswerten (wie hierfolgt defi-
niert) jeder separaten Abteilung zwischen den existierenden Abteilungen oder pro rata zwischen den relevanten Abteilungen
auf welche diese Verbindlichkeit oder Aufwendung fällt aufgeteilt;

132174

L

U X E M B O U R G

- Jedwede Ausschüttungen oder Auszahlungen (einschließlich Zahlungen welche im Falle eines Anteilsrückkaufs durch

die Gesellschaft fällig werden würden) an die Gesellschafter bezüglich einer Abteilung sollen die Nettovermögenswerte
(wie hierfolgt definiert) dieser Abteilung mindern;

- Die Nettovermögenswerte jeder Abteilung („Nettovermögenswerte“) entsprechen der Summe des Wertes des spezi-

fischen Investments dieser Abteilung und aller weiteren Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, Kosten und
Ausgaben welche gemäß dieser Satzung dieser Abteilung zugerechnet werden können

Zur Vermeidung jeglicher Zweifel, soll jeder Bezug auf die Nettovermögenswerte in dieser Satzung so verstanden

werden, dass er die berechneten Nettovermögenswerte der Spezifischen Investments die auf eine spezifische Anteilsklasse
zugeteilt sind in der eigens dafür geschaffenen Abteilung der Geschäftsbücher der Gesellschaft zusammengefasst werden,
umfasst.

Jedwedes Anteilsprämien welches in Bezug auf die Ausgabe einer spezifischen Anteilsklasse (oder Anteilsunterklasse)

eingezahlt wurde, wird auf das Anteilsprämienkonto eingezahlt welches der spezifischen Anteilsklasse (oder Anteilsun-
terklasse) der Gesellschaft entspricht. Bezüglich jeglicher Zahlung oder Einzahlung in eines der Anteilsprämienkonto,
welche in Übereinstimmung mit luxemburgischem Gesetz sowie Rechnungslegungsvorschriften getätigt wird, soll festlegt
werden, auf welche Anteilsklasse (oder Anteilsunterklasse) sie sich bezieht. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise
die Geschäftsführung, haben die Befugnis jede Einzahlung an eine Spezifische Anteilsklasse (oder Anteilsunterklasse) zu
bestätigen falls nicht anders angegeben. Jede verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden. Außerdem können die
Vermögensrechte der Gesellschafter durch einen privatschriftlichen Vertrag zwischen den Gesellschafter geregelt werden.
Insofern es Unstimmigkeiten zwischen den Bestimmungen dieses Vertrags und der Satzung der Gesellschaft gibt, so sind
die in einem solchen Vertrag dargelegten Grundsätze bezüglich der Vermögenswerte, maßgebend.

Art. 6. Annullierung einer gesamten Anteilsklasse und Herabsetzung des Stammkapitals. Das Gesellschaftskapital der

Gesellschaft kann durch die Annullierung von Anteilen herabgesetzt werden, einschließlich der Annullierung einer oder
mehrerer Anteilsklassen durch den Rückkauf und die Annullierung aller ausgegebenen Anteile bezüglich der relevanten
Anteilsklasse, durch Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit dem Quorum und der Mehrheit welche für eine
Änderung der Satzung nötig wären.

Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapital durch den Rückkauf und die Annullierung einer oder mehrerer

Anteilsklassen sollen die Anteilsinhaber der rückgekauften und annullierten Anteile einen Betrag entsprechend des An-
nullierungswert pro Anteil (wie hierfolgt definiert) der relevanten Anteilsklasse, welchen sie hielten und welcher annulliert
wurde, von der Gesellschaften erhalten.

Die Geschäftsführung soll im Falle einer Herabsetzung des Grundkapitals durch den Rückkauf und die Annullierung

einer Anteilsklasse, den Klassenausschüttfähigen Betrag für die rückgekaufte Klasse berechnen (immer abhängig von der
Summe der verfügbaren Gewinne, Agio und Reserven der Gesellschaft) anhand des Zwischenabschlusses der Gesellschaft
sowie des internen Zwischenabschlusses bezüglich der relevanten Klasse welcher gemäß Artikel 5 angefertigt werden soll,
jeweils nicht älter als acht (8) Tage (zusammen die „Zwischenabschlüsse“).

„Klassenausschüttfähiger Betrag“ bedeutet die Gesamtsumme der Nettogewinne, verfügbaren Reserven sowie Anteils-

prämie der Gesellschaft (einschließlich Gewinnvortrag) betreffend das Spezifische Investment zu welcher die relevante
Anteilsklasse gehört (i) zuzüglich des Betrages der Herabsetzung des Stammkapitals betreffend der zurückgekauften An-
teilsklasse (und etwaiger Verringerung der gesetzlichen Reserven betreffend die Reduzierung des Stammkapitals bezüglich
der betroffenen Anteilsklasse) aber (ii) abzüglich etwaiger Anlageverluste betreffend diese Klasse (zuzüglich Verlustvor-
trägen) und (iii) abzüglich etwaiger Summen welche gemäß Gesetz oder Satzung in Reserve(n) eingebracht werden müssen,
jeweils in den entsprechenden Zwischenabschlüssen aufgeführt (ohne, um jeden Zweifel auszuschließen, Doppelzählung),
sodass:

AA = (NP + P + CR) - (L + R)
Womit:
AA = Klassenausschüttfähiger Betrag
NP = Gesamtheit aller Nettoerträge (einschließlich jeglicher Gewinnvorträge)
P = jede freie ausschüttbare Anteilsprämie und andere freie ausschüttbare Rücklage
CR = der Herabsetzung des Gesellschaftskapitals und die Herabsetzung der gesetzlichen Rücklagen bezüglich der zu

annullierende Klasse

L = Anlageverluste
LR  =  jegliche  in  die  Rücklagen  einzuzahlende  Summen  gemäß  den  Bestimmungen  des  Gesetzes  oder  der  Gesell-

schaftssatzung.

„Klasse A Portfolio“ bedeutet das Investment durch Anteile, Prämienkonto, Darlehen, Preferred Equity Certificates

oder andere Instrumente, wandelbar oder nicht, oder in dem Italienischen Fonds, der gegründet wird, um „Project Ferrari“
zu finanzieren (und die Basiswerte, Filialen und juristische Personen), aber nur für die gezeichneten oder erworbenen
Instrumente bezüglich direkter oder indirekter Finanzierung des Projects Ferrari, mit Ausnahme von Instrumenten ge-
zeichnet oder erworben bezüglich anderer Projekte und besonders Project Scorpion.

„Klasse B Portfolio“ bedeutet das Investment durch Anteile, Anteilsprämienkonto, Darlehen, oder andere Instrumente,

wandelbar oder nicht, oder auf anderem Wege in dem Italienischen Fonds, der gegründet wird, um „Project Scorpion“ zu

132175

L

U X E M B O U R G

finanzieren (und die Basiswerte, Filialen und juristische Personen), aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instru-
menten bezüglich direkter oder indirekter Finanzierung des Projects Scorpion, mit Ausnahme von Instrumente gezeichnet
oder erworben bezüglich anderer Projekte und besonders Project Ferrari.

„Anlageverluste“ bezeichnet etwaige Verluste (einschließlich Verlustvorträge bezüglich des relevanten Spezifischen

Investments) sowie etwaige Kosten, Gebühren und Ausgaben betreffend das Spezifische Investment (einschließlich der
Rückzahlung  durch  die  Gesellschaft  jedweder  Schulden  welche  in  Folge  der  Verwaltung  des  relevanten  Spezifischen
Investments aufgetreten sind), und einen Betrag in Höhe des pro rata Teils berechnet an den allgemeinen Geschäftskosten
(fair aber unwiderruflich festgesetzt von der Geschäftsführung) und nicht erstattungsfähiger Verluste der Gesellschaft. Um
den „Anteilsannullierungswert pro Anteil“ zu berechnen wird der Annullierungsbetrag der Anteilsklasse durch die Anzahl
der ausgegebenen Anteile der betroffenen Anteilsklasse, welche zurückgekauft und annulliert werden, geteilt.

Der „Annullierungsbetrag der Anteilsklasse“ wird vom alleinigen Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsfüh-

rung bestimmt und von der Gesellschafterversammlung auf Basis des Zwischenberichts genehmigt. Immer vorbehaltlich
der Summe der verfügbaren Nettogewinne, Reserven oder Anteilsprämie der Gesellschaft, wird der Annullierungsbetrag
der Anteilsklasse für die zurückzukaufende und annullierende Anteilsklasse, der Klassenausschüttfähige Betrag sein, sofern
nicht anderweitig durch die Gesellschafterversammlung in der Art und Weise bestimmt wie für eine Änderung der Satzung
vorgesehen, vorausgesetzt dass der Annullierungsbetrag der Anteilsklasse nie höher sein soll als der Klassenausschüttfähige
Betrag und ferner, dass der Annullierungsbetrag der Anteilsklasse nie höher sein soll als die Gesamtsumme der verfügbaren
Nettogewinne, Reserven und Anteilsprämie der Gesellschaft. Bei Rückkauf und Annullierung der Anteile einer relevanten
Klasse, wird der Anteilsannullierungswert durch die Gesellschaft fällig und zahlbar.

Art. 7. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht

anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 8. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die

keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichensten Befugnissen aus-

gestattet, die Geschäfte der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich  des  Geschäftsführers  beziehungsweise  der  Geschäftsführung,  einschließlich  spezifische  Befugnissen
welche gemäß spezifischen Auflagen der Satzung eingebracht würden.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichensten Befugnisse

um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und

abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der

Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,

von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per

132176

L

U X E M B O U R G

ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen

Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 9. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder

leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig Eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-

schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die  Rechte  zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.

Art. 10. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 11. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage

vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens  acht  (8)  Tage  bevor  der  Beschluss  wirksam  werden  soll,  an  alle  Gesellschafter  an  ihre  im  Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche

132177

L

U X E M B O U R G

Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als vierzig (40) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 12. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres mit

Aufnahme vom ersten Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31.December 2015
endet.

Art. 13. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 14. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die  Gesellschafter  können  auf  der  Grundlage  eines  von  dem  alleinigen  Geschäftsführer,  beziehungsweise  der  Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf (trotz
des Investment Überschusses einer Anteilsklasse). Gewinnausschüttung in einer Klasse soll nur durch Investment Über-
schuss bezüglich dieser Klasse erlaubt werden (mit Vorbehalt des Obenerwähnten).

„Investment Überschuss“ umfasst jegliches Einkommen des letzten Geschäftsjahres zuzüglich Gewinnvorträge und

ausgeschüttet Rückgabe jeglicher teilweisen oder kompletten Veräußerung bezüglich relevante Spezifische Investment
(Veräußerung bedeutet Transfers sowie Einlagen jeder Art) sowie jegliche Dividenden und andere Ausschüttungen, Zinsen,
Renditen, Tilgungszahlungen, oder anderes Einkommen und Erträge welche vom relevanten Spezifischen Investment,
sowie Vermögenswerten und Reserven welche die Gesellschaft bekommen hat beziehungsweise ihr zugerechnet werden
können hinsichtlich der Ausgabe der relevanten Anteilsklassen wie beispielsweise das Agio oder jedwede Gewinne (be-
treffend das relevante Investment(s)), vorgetragen, ableiten lassen; abzüglich jeder Kosten, Gebühren und Ausgaben im
Zusammenhang mit dem relevanten Spezifischen Investment (einschließlich Rückzahlungen der Gesellschaft jedweder im
Zusammenhang mit der Verwaltung der relevanten Spezifischen Investments), und einen Betrag in Höhe des pro rata Teils
berechnet an den allgemeinen Geschäftskosten (fair aber unwiderruflich festgesetzt vom alleinigen Geschäftsführer be-
ziehungsweise der Geschäftsführung) und nicht erstattungsfähiger Verluste der Gesellschaft.

Der Kontostand kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, das Anteilsprämienkonto den Anteilsinhaber auszuschütten, aber

nur zu dessen Anteilsinhaber der angehörigen Klasse des Anteilsprämienkontos. Die Gesellschafterversammlung kann
beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche Rücklage zu übertragen.

Art. 15. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.

Bei Auflösung der Gesellschaft umfasst der Liquidationserlös jeder Klasse, die Summe welche dieser Klasse bezüglich

des relevanten Spezifischen Investments gegebenenfalls zusteht. Jede Anteilsklasse ist am Liquidationserlös berechtigt,
festgelegt anhand des relevanten Spezifischen Investments auf welches sich die Klasse bezieht.

Erstens werden alle Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft (unabhängig eines Spezifischen Investments) ge-

zahlt. Solche Schulden und Verpflichtungen werden der Anteilsklasse zugerechnet welcher sie angehören (z.B. weil sie in
Zusammenhang mit dem relevanten Spezifischen Investment dieser Klasse stehen) oder, sollte dies nicht umsetzbar sein,
proportional zwischen allen Anteilsklassen, zum Anteil des Gesellschaftskapital welches sie vertreten.

Anschließend werden alle relevanten Verpflichtungen bezüglich jeder Anteilsklasse, welche in separaten Kategorien

der Spezifischen Investments angezeigt werden, den Vermögensanlagen welche der spezifischen Klasse insbesondere dem
Spezifischen Investment dieser Klasse sowie jeglicher Reserven die dieser Klasse angerechnet werden können, entgegen-
gesetzt. Vermögenswerte welche keiner spezifischen Klasse zugerechnet werden können, werden pro rata zwischen allen
Anteilsklassen aufgeteilt.

In dem Maß, dass die so bestimmte Summe für eine Klasse negativ sein sollte, wird diese Klasse kein Anspruch auf

jeglichen  Liquidationserlös  haben.  Die  relevante  Negativsumme,  wird  unter  allen  Anteilsklassen  welche  eine  positive

132178

L

U X E M B O U R G

Summe aufweisen können anteilig aufgeteilt bis zu dieser positiven Summe. Jeder innerhalb einer Klasse von Anteilen
verbleibende Überschuss (der „Klassenüberschuss“) wird unter den Anteilsinhabern dieser relevanten Anteilsklasse aus-
geschüttet.

Art. 16. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179

(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

Art. 17. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich

nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass

dieser Akte entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher der deutschen und englischen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass, auf An-

frage der erschienenen Partei, vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung,  und  dass,  im  Falle  einer  Abweichung  zwischen  dem  englischen  und  dem  deutschen  Text,  die  englische
Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei, hat dieser mit dem

amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: S. LE MAREC, L. GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 août 2015. Relation: 1LAC/2015/25127. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18. August 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015140793/770.
(150153233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Nordic Estate Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte neuve.

R.C.S. Luxembourg B 119.679.

DISSOLUTION

In the year two thousand fifteen,
on the thirteenth day of the month of August.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

Mrs Alessia ARCARI, employee, residing professionally at 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg,
acting in her capacity as a special proxy holder of:
Mr Lars VESTERGAARD, director, born in Århus (Denmark), on 19 May 1964, residing The Mount 11, Roedean Way,

Brighton BN 5RJ (United Kingdom),

pursuant to a proxy given to her under private seal dated Brighton (United Kingdom), 31 July 2015,
which proxy, after being signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain attached to present deed for registration purposes,

here after referred to as "the principal",
The same party declared and requested the notary to act:
I.- That the company “NORDIC ESTATE CAPITAL S.à r.l.” (the “Company”), a “société à responsabilité limitée”,

established and having its registered office at 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, registered with the
“Registre de Commerce et des Sociétés” in Luxembourg, section B number 119 679, has been incorporated under Luxem-
bourg Law, pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary on 22 September 2006, published in the Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”), on 14 November 2006, under number 2118 and page 101642.

The Articles of Association of said Company have never been amended since its date of incorporation.
II.- That the subscribed capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12’500.- EUR) divided

into five hundred (500) shares having each a nominal value of twenty-five euro (25.- EUR) all fully paid up.

III.- That the principal has become successively sole owner of all the shares of said Company.

132179

L

U X E M B O U R G

IV.- That the principal, being sole partner of the Company “NORDIC ESTATE CAPITAL, S.à r.l.”, has decided to

proceed immediately to the dissolution of said Company.

V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the

Company and declares as such to approve the interim balance sheet of the Company as of 21 July 2015.

VI.- That the principal, as well in its activity as liquidator of the Company, declares that the business activity of the

Company has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company
committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company as well as to be personally
charged with any presently unknown liability.

VII.- That the principal fully grants discharge to the current manager(s) of the dissolved Company, for the due perfor-

mance of his(their) duties up to this date.

VIII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at its former address being:

11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

IX.- That the principal commits itself to pay the cost of the present deed.
X.- That the Company’s register of shareholders is cancelled in the presence of the undersigned notary.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the proxy holder of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same proxy
holder and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read to the proxy holder of the appearing party said proxy holder signed together with

Us the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze,
le treize août.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Madame Alessia ARCARI, employée privée, demeurant professionnellement au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227

Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:
Monsieur Lars VESTERGAARD, directeur, né à Århus (Danemark), le 19 mai 1964, demeurant à The Mount 11,

Roedean Way, Brighton BN 5RJ (Royaume-Uni),

en vertu d’une procuration lui donnée sous seing privé datée Brighton (Royaume-Uni), du 31 juillet 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement,

ci-après dénommée «le mandant».
Laquelle partie comparante, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:
I.- Que la société «NORDIC ESTATE CAPITAL, S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie

et ayant son siège social au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 119 679, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte
notarié dressé par le notaire soussigné en date du 22 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial»), en date du 14 novembre 2006, sous le numéro 2118 et page 101642.

Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis sa création.
II.- Que le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12'500.- EUR) divisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, chaque part sociale étant intégralement
libérée.

III.- Que le mandant est devenu successivement seul et unique propriétaire de toutes les parts sociales de ladite Société.
IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la société «NORDIC ESTATE CAPITAL, S.à r.l.», a décidé de procéder

à la dissolution immédiate de ladite Société.

V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et déclare

ainsi approuver les comptes intérimaires de la Société arrêtés au 31 juillet 2015.

VI.- Que le mandant, de même en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui,

en tant qu'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation
inconnue à l'heure actuelle.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée au(x) gérant(s) de la Société dissoute pour l'exécution de son(leur)

mandat jusqu'à ce jour.

132180

L

U X E M B O U R G

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancienne adresse de la

Société, étant celle du 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

IX.- Que le mandant s’engage personnellement à régler tous les frais résultant du présent acte.
X.- Que le registre des associés nominatifs de la Société est annulé en présence du notaire instrumentant.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire de la

partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: A. ARCARI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 août 2015. Relation: EAC/2015/19228. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015142968/100.
(150155503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

Patron Noosa Devco (Bath) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 181.430.

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, as pro-

xyholder on behalf of Patron Noosa Propco (Bath) S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having
its registered office at L-2310 Luxembourg, 6 avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 187.262), being the sole shareholder
of Patron Noosa Devco (Bath) S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered office at
L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 181.430), incorporated pursuant to a deed of Maître Martine
SCHAEFFER, prenamed, dated October 23 

rd

 , 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

number 3151 dated December 11 

th

 , 2013, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of Maître Martine

Schaeffer, prenamed, on October 1 

st

 , 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number

3402 dated November 14 

th

 , 2014.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. All the shares being represented, the decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
- Modification of the company year of the Company;
- Amendment of Article 14 and of the first paragraph of Article 15 of the articles of association.
After deliberation the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

It is resolved to modify the company year of the Company so that it starts on the 18 

th

 day of August of each year and

ends on the 17 

th

 day of August of the following year.

The company year started on January 1 

st

 , 2015 shall end on August 17 

th

 , 2015.

<i>Second resolution

It is therefore resolved to amend Article 14 of the articles of associations so that it reads as follows:

“ Art. 14. The Company's year starts on August 18 

th

 of each year and ends on August 17 

th

 of the following year”.

It is furthermore resolved to amend the first paragraph of Article 15 of the articles of associations so that it reads as

follows:

“ Art. 15. Each year, with reference to August 17 

th

 , the Company's accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities”.

132181

L

U X E M B O U R G

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto, the

present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-sept août.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame  Isabel  DIAS,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  L-1750  Luxembourg,  74,  avenue  Victor

Hugo, agissant en vertu d'une procuration de Patron Noosa Propco (Bath) S.à r.l., une société de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 187.262), étant l'associé unique de
Patron Noosa Devco (Bath) S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2310
Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B181.430), constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer,
susnommée, en date du 23 Octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3151 du 11
décembre 2013 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, susnom-
mée, en date du 1 

er

 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3402 du 14 novembre

2014.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d'acter que:
1. Toutes les parts sociales étant représentées, les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points à l'ordre

du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
- Modification de l'exercice social de la Société
- Modification de l'article 14 et du premier alinéa de l'article 15 des statuts.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l'exercice social de la Société pour qu'il commence le 18 août de chaque année et se termine le

17 août de l'année suivante. L'année sociale ayant commencé le 1 

er

 janvier 2015 se terminera le 17 août 2015.

<i>Deuxième résolution

Il est par conséquent décidé de modifier l'article 14 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 18 août de chaque année et se termine le 17 août de l'année suivante.»
Il est en outre décidé de modifier le premier alinéa de l'article 15 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 15. Chaque année, au 17 août, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 août 2015. 2LAC/2015/18903. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Yvette Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2015.

Référence de publication: 2015142999/87.
(150155700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

132182

L

U X E M B O U R G

Patron Noosa Devco (Lane End) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 169.096.

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, as pro-

xyholder on behalf of Patron Noosa Propco (Lane End) S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at L-2310 Luxembourg, 6 avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 190.947), being the sole sha-
reholder of Patron Noosa Devco (Lane End) S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered
office at L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 169.096), incorporated pursuant to a deed of Maître
Martine SCHAEFFER, prenamed, dated May 23 

rd

 , 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions number 1648 dated June 29 

th

 , 2012, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of Maître Martine

Schaeffer, prenamed, on October 2 

nd

 , 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number

3444 dated November 18 

th

 , 2014.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. All the shares being represented, the decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
- Modification of the company year of the Company;
- Amendment of Article 14 and of the first paragraph of Article 15 of the articles of association.
After deliberation the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

It is resolved to modify the company year of the Company so that it starts on the 18 

th

 day of August of each year and

ends on the 17 

th

 day of August of the following year.

The company year started on January 1 

st

 , 2015 shall end on August 17 

th

 , 2015.

<i>Second resolution

It is therefore resolved to amend Article 14 of the articles of associations so that it reads as follows:

“ Art. 14. The Company's year starts on August 18 

th

 of each year and ends on August 17 

th

 of the following year”.

It is furthermore resolved to amend the first paragraph of Article 15 of the articles of associations so that it reads as

follows:

“ Art. 15. Each year, with reference to August 17 

th

 , the Company's accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities”.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto, the

present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-sept août.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame  Isabel  DIAS,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  L-1750  Luxembourg,  74,  avenue  Victor

Hugo, agissant en vertu d'une procuration de Patron Noosa Propco (Lane End) S.à r.l., une société de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 190.947), étant l'associé unique de
Patron Noosa Devco (Lane End) S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2310
Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B169.096), constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer,

132183

L

U X E M B O U R G

susnommée, en date du 23 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1648 du 29 juin 2012
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, susnommée, en date du
2 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3444 du 18 novembre 2014.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d'acter que:
1. Toutes les parts sociales étant représentées, les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points à l'ordre

du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
- Modification de l'exercice social de la Société
- Modification de l'article 14 et du premier alinéa de l'article 15 des statuts.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l'exercice social de la Société pour qu'il commence le 18 août de chaque année et se termine le

17 août de l'année suivante.

L'année sociale ayant commencé le 1 

er

 janvier 2015 se terminera le 17 août 2015.

<i>Deuxième résolution

Il est par conséquent décidé de modifier l'article 14 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 18 août de chaque année et se termine le 17 août de l'année suivante.»
Il est en outre décidé de modifier le premier alinéa de l'article 15 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 15. Chaque année, au 17 août, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 août 2015. 2LAC/2015/18906. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Yvette Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2015.

Référence de publication: 2015143002/87.
(150155734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

Patron Noosa Devco (Earley) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 177.593.

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, as pro-

xyholder on behalf of Patron Noosa Propco (Earley) S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having
its registered office at L-2310 Luxembourg, 6 avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 164.333), being the sole shareholder
of Patron Noosa Devco (Earley) S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered office at
L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 177.593), incorporated pursuant to a deed of Maître Martine
SCHAEFFER, prenamed, dated May 16 

th

 , 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

number 1718 dated July 17 

th

 , 2013, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of Maître Martine

Schaeffer, prenamed, on October 1 

st

 , 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number

3424 dated November 17 

th

 , 2014.

132184

L

U X E M B O U R G

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. All the shares being represented, the decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
- Modification of the company year of the Company;
- Amendment of Article 14 and of the first paragraph of Article 15 of the articles of association.
After deliberation the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

It is resolved to modify the company year of the Company so that it starts on the 18 

th

 day of August of each year and

ends on the 17 

th

 day of August of the following year.

The company year started on January 1 

st

 , 2015 shall end on August 17 

th

 , 2015.

<i>Second resolution

It is therefore resolved to amend Article 14 of the articles of associations so that it reads as follows:

“ Art. 14. The Company's year starts on August 18 

th

 of each year and ends on August 17 

th

 of the following year”.

It is furthermore resolved to amend the first paragraph of Article 15 of the articles of associations so that it reads as

follows:

“ Art. 15. Each year, with reference to August 17 

th

 , the Company's accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities”.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto, the

present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-sept août.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame  Isabel  DIAS,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  L-1750  Luxembourg,  74,  avenue  Victor

Hugo, agissant en vertu d'une procuration de Patron Noosa Propco (Earley) S.à r.l., une société de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 164.333), étant l'associé unique de
Patron Noosa Devco (Earley) S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2310
Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B177.593), constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer,
susnommée, en date du 16 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1718 du 17 juillet
2013 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, susnommée, en date
du 1 

er

 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3424 du 17 novembre 2014.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d'acter que:
1. Toutes les parts sociales étant représentées, les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points à l'ordre

du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
- Modification de l'exercice social de la Société
- Modification de l'article 14 et du premier alinéa de l'article 15 des statuts.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l'exercice social de la Société pour qu'il commence le 18 août de chaque année et se termine le

17 août de l'année suivante.

L'année sociale ayant commencé le 1 

er

 janvier 2015 se terminera le 17 août 2015.

<i>Deuxième résolution

Il est par conséquent décidé de modifier l'article 14 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

132185

L

U X E M B O U R G

« Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 18 août de chaque année et se termine le 17 août de l'année suivante.»
Il est en outre décidé de modifier le premier alinéa de l'article 15 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 15. Chaque année, au 17 août, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 août 2015. 2LAC/2015/18905. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Yvette Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2015.

Référence de publication: 2015143001/87.
(150155735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

PALLINGHURST CONSOLIDATED (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 129.141.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015143022/14.
(150155500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

Patron Noosa Devco (Bournville) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 190.226.

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, as pro-

xyholder on behalf of Patron Noosa Propco (Bournville) S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at L-2310 Luxembourg, 6 avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 187.263), being the sole sha-
reholder of Patron Noosa Devco (Bournville) S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered
office at L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 190.226), incorporated pursuant to a deed of Maître
Martine SCHAEFFER, prenamed, dated September 5 

th

 , 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations number 3134 dated October 28 

th

 , 2014, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of

Maître Martine Schaeffer, prenamed, on October 1 

st

 , 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations number 3424 dated November 17 

th

 , 2014.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. All the shares being represented, the decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:

132186

L

U X E M B O U R G

- Modification of the company year of the Company;
- Amendment of Article 14 and of the first paragraph of Article 15 of the articles of association.
After deliberation the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

It is resolved to modify the company year of the Company so that it starts on the 18 

th

 day of August of each year and

ends on the 17 

th

 day of August of the following year.

The company year started on January 1 

st

 , 2015 shall end on August 17 

th

 , 2015.

<i>Second resolution

It is therefore resolved to amend Article 14 of the articles of associations so that it reads as follows:

“ Art. 14. The Company's year starts on August 18 

th

 of each year and ends on August 17 

th

 of the following year”.

It is furthermore resolved to amend the first paragraph of Article 15 of the articles of associations so that it reads as

follows:

“ Art. 15. Each year, with reference to August 17 

th

 , the Company's accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities”.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto, the

present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-sept août.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame  Isabel  DIAS,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  L-1750  Luxembourg,  74,  avenue  Victor

Hugo, agissant en vertu d'une procuration de Patron Noosa Propco (Bournville) S.à r.l., une société de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 187.263), étant l'associé unique de
Patron Noosa Devco (Bournville) S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2310
Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B190.226), constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer,
susnommée, en date du 5 septembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3134 du 28
octobre 2014 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, susnommée,
en date du 1 

er

 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3424 du 17 novembre 2014.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d'acter que:
1. Toutes les parts sociales étant représentées, les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points à l'ordre

du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
- Modification de l'exercice social de la Société
- Modification de l'article 14 et du premier alinéa de l'article 15 des statuts.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l'exercice social de la Société pour qu'il commence le 18 août de chaque année et se termine le

17 août de l'année suivante.

L'année sociale ayant commencé le 1 

er

 janvier 2015 se terminera le 17 août 2015.

<i>Deuxième résolution

Il est par conséquent décidé de modifier l'article 14 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 18 août de chaque année et se termine le 17 août de l'année suivante.»
Il est en outre décidé de modifier le premier alinéa de l'article 15 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

132187

L

U X E M B O U R G

« Art. 15. Chaque année, au 17 août, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 août 2015. 2LAC/2015/18904. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Yvette Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2015.

Référence de publication: 2015143000/87.
(150155699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

Fiduciaire Socofisc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 49.547.

<i>Résolution du conseil d'administration

Les administrateurs confirment l'adresse professionnelle du délégué à la gestion journalière, Monsieur Rainer ERZ,

actuellement comme suit:

- L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves

Norbert Ebsen / Helena Rösch
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015140807/13.
(150153199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Patron Noosa Devco (Solihull) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 164.362.

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, as pro-

xyholder on behalf of Patron Noosa Propco (Solihull) S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at L-2310 Luxembourg, 6 avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 179.134), being the sole sha-
reholder of Patron Noosa Devco (Solihull) S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered
office at L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 164.362), incorporated pursuant to a deed of Maître
Martine SCHAEFFER, prenamed, dated October 21 

st

 , 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-

sociations number 3056 dated December 13 

th

 , 2011, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of

Maître Martine Schaeffer, prenamed, on October 2 

nd

 , 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations number 3394 dated November 14 

th

 , 2014.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. All the shares being represented, the decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
- Modification of the company year of the Company;
- Amendment of Article 14 and of the first paragraph of Article 15 of the articles of association.
After deliberation the following resolutions were unanimously taken:

132188

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

It is resolved to modify the company year of the Company so that it starts on the 18 

th

 day of August of each year and

ends on the 17 

th

 day of August of the following year.

The company year started on January 1 

st

 , 2015 shall end on August 17 

th

 , 2015.

<i>Second resolution

It is therefore resolved to amend Article 14 of the articles of associations so that it reads as follows:

“ Art. 14. The Company's year starts on August 18 

th

 of each year and ends on August 17 

th

 of the following year”.

It is furthermore resolved to amend the first paragraph of Article 15 of the articles of associations so that it reads as

follows:

“ Art. 15. Each year, with reference to August 17 

th

 , the Company's accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities”.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto, the

present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-sept août.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame  Isabel  DIAS,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  L-1750  Luxembourg,  74,  avenue  Victor

Hugo, agissant en vertu d'une procuration de Patron Noosa Propco (Solihull) S.à r.l., une société de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 179.134), étant l'associé unique de
Patron Noosa Devco (Solihull) S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2310
Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B164.362), constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer,
susnommée, en date du 21 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3056 du 13
décembre 2011 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, susnom-
mée, en date du 2 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3394 du 14 novembre 2014.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d'acter que:
1. Toutes les parts sociales étant représentées, les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points à l'ordre

du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
- Modification de l'exercice social de la Société
- Modification de l'article 14 et du premier alinéa de l'article 15 des statuts.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l'exercice social de la Société pour qu'il commence le 18 août de chaque année et se termine le

17 août de l'année suivante.

L'année sociale ayant commencé le 1 

er

 janvier 2015 se terminera le 17 août 2015.

<i>Deuxième résolution

Il est par conséquent décidé de modifier l'article 14 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 18 août de chaque année et se termine le 17 août de l'année suivante.»
Il est en outre décidé de modifier le premier alinéa de l'article 15 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 15. Chaque année, au 17 août, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

132189

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 août 2015. 2LAC/2015/18909. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

<i>Le Receveur ff. (signé): Yvette THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2015.

Référence de publication: 2015143005/87.
(150155525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

Patron Noosa Devco (Newbury) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 179.168.

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, as pro-

xyholder on behalf of Patron Noosa Propco (Newbury) S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at L-2310 Luxembourg, 6 avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 190.232), being the sole sha-
reholder of Patron Noosa Devco (Newbury) S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered
office at L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 179.168), incorporated pursuant to a deed of Maître
Martine SCHAEFFER, prenamed, dated July 16 

th

 , 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

number 2353 dated September 24 

th

 , 2014, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of Maître Martine

Schaeffer, prenamed, on October 2 

nd

 , 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number

3393 dated November 14 

th

 , 2014.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. All the shares being represented, the decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
- Modification of the company year of the Company;
- Amendment of Article 14 and of the first paragraph of Article 15 of the articles of association.
After deliberation the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

It is resolved to modify the company year of the Company so that it starts on the 18 

th

 day of August of each year and

ends on the 17 

th

 day of August of the following year.

The company year started on January 1 

st

 , 2015 shall end on August 17 

th

 , 2015.

<i>Second resolution

It is therefore resolved to amend Article 14 of the articles of associations so that it reads as follows:

“ Art. 14. The Company's year starts on August 18 

th

 of each year and ends on August 17 

th

 of the following year”.

It is furthermore resolved to amend the first paragraph of Article 15 of the articles of associations so that it reads as

follows:

“ Art. 15. Each year, with reference to August 17 

th

 , the Company's accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities”.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

132190

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto, the

present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-sept août.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame  Isabel  DIAS,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  L-1750  Luxembourg,  74,  avenue  Victor

Hugo, agissant en vertu d'une procuration de Patron Noosa Propco (Newbury) S.à r.l., une société de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B 190.232), étant l'associé unique de
Patron Noosa Devco (Newbury) S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2310
Luxembourg, 6, avenue Pasteur (RCS Luxembourg B179.168), constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer,
susnommée, en date du 16 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2353 du 24 septembre
2013 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, susnommée, en date
du 2 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3393 du 14 novembre 2014.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d'acter que:
1. Toutes les parts sociales étant représentées, les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points à l'ordre

du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
- Modification de l'exercice social de la Société
- Modification de l'article 14 et du premier alinéa de l'article 15 des statuts.
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l'exercice social de la Société pour qu'il commence le 18 août de chaque année et se termine le

17 août de l'année suivante.

L'année sociale ayant commencé le 1 

er

 janvier 2015 se terminera le 17 août 2015.

<i>Deuxième résolution

Il est par conséquent décidé de modifier l'article 14 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 18 août de chaque année et se termine le 17 août de l'année suivante.»
Il est en outre décidé de modifier le premier alinéa de l'article 15 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 15. Chaque année, au 17 août, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 août 2015. 2LAC/2015/18908. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

<i>Le Receveur ff. (signé): Yvette THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2015.

Référence de publication: 2015143004/87.
(150155526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2015.

132191

L

U X E M B O U R G

Vidar Crewing Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 191.794.

L'an deux mil quinze, le trois août.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Sophie Mathot, employée privée en l’étude du notaire soussigné, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés

en vertu de l’acte numéro 48.783 du répertoire du notaire soussigné,

Lequel comparant a exposé ce qui suit:
En date du 6 novembre 2014, le notaire soussigné a reçu sous le numéro 48.783 de son répertoire, l’acte constitutif de

VIDAR CREWING LUXEMBOURG SA, société anonyme, ayant son siège social à L-8399 Windhof, 11, route des Trois
Cantons, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 191.794 (la
Société).

Ledit acte a été enregistré le 7 novembre 2014 sous les références LAC / 2014 / 52274, déposé auprès du registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg le 14 novembre 2014 sous les références L140202484 et publié au Mémorial C
du 8 décembre 2014 numéro 3771.

Le comparant prend acte que l’actionnaire unique a décidé à l’issue dudit acte de nommer un commissaire aux comptes /

statutory auditor, alors qu'en vue de se conformer aux exigences du groupe dont fait partie la Société, les comptes devraient
être contrôlés par un réviseur d’entreprises agréé et que partant la nomination d’un commissaire aux comptes n’est pas
nécessaire.

Par la présente, le comparant, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés comme indiqué ci-avant requiert

la rectification comme suit:

Versions initiales française et anglaise à modifier

4. La personne suivante est nommée en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour une période prenant fin

à l’issue de la tenue de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2016:

La société Deloitte Audit s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf, RCSL B

67.895.

4. The following is appointed as statutory auditor for a period ending upon the holding of the annual meeting of share-

holders to be held in 2016.

Deloitte Audit s.à.r.l., having its registered office in L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf, registered with the

Register of Companies of Luxembourg under number B 67.895

Versions française et anglaise qui remplacent les versions initiales

4. La personne suivante est nommée en qualité de réviseur d’entreprises agréé pour une période prenant fin à l’issue de

la tenue de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2016:

La société Deloitte Audit s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf, RCSL B

67.895.

4. The following is appointed as auditor (réviseur d’entreprises agréé) for a period ending upon the holding of the annual

meeting of shareholders to be held in 2016.

Deloitte Audit s.à r.l., having its registered office in L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf, registered with the

Register of Companies of Luxembourg under number B 67.895

Le reste de l'acte demeurant inchangé.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg,
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, celui-

ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie Mathot, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 5 août 2015. LAC1 / 2015 / 25185. Reçu 12.-€.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140534/53.
(150152463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

132192


Document Outline

AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l.

Addivant Luxembourg Holdings

Al Avocado &amp; Cy S.C.A.

ARM Holdings

Art Jardin S.à r.l.

Bâloise Vie Luxembourg S.A.

Bourgueil International

Cafor Holding S.A.

C.C.Associates

CCE Holdings (Luxembourg)

CGI Information Systems and Management Consultants III Luxembourg Sàrl

CGI Information Systems and Management Consultants II Luxembourg Sàrl

CH3 Capital S.à r.l.

Clarenville CDO S.A.

Clouse S.A.

Compagnie Ingénierie Financière (Luxembourg) S.A.

Composites GO S.à r.l.

CRH Cities Luxembourg Sàrl

Digital Services XVII S.à r.l.

Duvessa S.à r.l.

Empyreum S.à r.l.

Ersel Gestion Internationale S.A.

Esyodis S.A.

Euro Logistics &amp; Trading S.A.

Euro Pneus S.à r.l.

EuroPRISA Lombard Street Acquisition S.à r.l.

Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l.

Fiduciaire Socofisc S.A.

Fifteen Episcia S.A.

Fifteen Red Pine S.A.

Gama Lettrage et Designs S.à r.l.

Harmony Multi-Manager Funds SIF-SICAV

Harmorlux S.A.

Highbridge Aiguilles Rouges Lux Sàrl II

HPS-GIM Credit Master Lux S.à r.l.

IRAF Heidi Holdings

Mistral Partners 1 JV SCSp

MPIT 1 JV SCSp

Nordic Estate Capital S.à r.l.

PALLINGHURST CONSOLIDATED (Lux) S.à r.l.

Patron Noosa Devco (Bath) S.à r.l.

Patron Noosa Devco (Bournville) S.à r.l.

Patron Noosa Devco (Earley) S.à r.l.

Patron Noosa Devco (Lane End) S.à r.l.

Patron Noosa Devco (Newbury) S.à r.l.

Patron Noosa Devco (Solihull) S.à r.l.

Thor Crewing Luxembourg S.A.

Vidar Crewing Luxembourg S.A.