logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2718

2 octobre 2015

SOMMAIRE

Abensberg Acquisition S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

130418

Agacom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130418

Benelux Partners Investholding S.A.  . . . . . . . .

130451

Brookstar A Note JV CO S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

130418

Brookstar Investments Lux S.à r.l.  . . . . . . . . .

130444

Crystal Pumpkin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130464

Firewall Management MIP S.A. . . . . . . . . . . . .

130452

Garibaldi GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130425

Global Restaurant Investments S.à r.l.  . . . . . .

130434

Happy Family I S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130451

Hassium Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

130426

Imexal S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130419

Immo-Contrat S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130422

J. A. Restauration S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

130422

Jet Financial Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130420

JTC Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

130420

KG Far East (Luxembourg) Sàrl  . . . . . . . . . . .

130419

Landericus Holding Limited S.à r.l.  . . . . . . . .

130421

Landericus Property Alpha S.à r.l.  . . . . . . . . .

130422

Le Battant Dormant S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

130422

Les Bains d'Aphrodite S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

130419

Les Bains d'Aphrodite S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

130421

Les Bains d'Aphrodite S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

130420

Librairie Française  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130423

Loëndal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130424

Losca International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

130423

Lululemon LU Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

130423

Mainstream Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

130423

Management Associates S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

130418

Maxis Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130424

Medliner S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130425

Mira SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130425

OCM Luxembourg Serviced Apartments Hol-

dings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130445

Papier Franzen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130424

Picard Bondco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130419

Picard Bondco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130419

Precious Metals & Commodities Trading S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130421

Prime Credit 7 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130423

Prime Credit 9 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130421

Rigel International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130424

Robor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130418

Sandton Holdings III (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130426

Semper Veritas Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

130425

Socolem S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130426

Stiletto Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130464

THS Kingsway Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130420

Victoria Lux Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

130425

VPB-Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130463

VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A. . . . . . .

130463

130417

L

U X E M B O U R G

Agacom, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63, route de Dudelange.

R.C.S. Luxembourg B 84.928.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015139376/9.
(150151835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2015.

Management Associates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 139.770.

Le Bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/05/2015.

Signature.

Référence de publication: 2015138315/10.
(150150522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.

Abensberg Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 186.917.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015138622/10.
(150150954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2015.

Brookstar A Note JV CO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Brookstar A Note JV Co S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015139993/11.
(150152286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Robor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 134.133.

Les comptes annuels au 30.06.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2015.

<i>Pour: ROBOR S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015141083/14.
(150153409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

130418

L

U X E M B O U R G

Imexal S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1527 Luxembourg, 54, rue Maréchal Foch.

R.C.S. Luxembourg B 17.264.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015140223/9.
(150152335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

KG Far East (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 320.077.350,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 149.409.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140252/10.
(150152493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Les Bains d'Aphrodite S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 41, boulevard du Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 103.100.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015140261/10.
(150152297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Picard Bondco, Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 154.899.

Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015141030/12.
(150153018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Picard Bondco, Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.642.097,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 154.899.

Les comptes annuels consolidés au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015141031/13.
(150153208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

130419

L

U X E M B O U R G

Les Bains d'Aphrodite S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 41, boulevard du Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 103.100.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015140262/10.
(150152298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

THS Kingsway Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 177.534.

Le Bilan au 31 mars 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140255/10.
(150152330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Jet Financial Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 171.837.

Les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

JET FINANCIAL SERVICES
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2015140244/13.
(150152864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

JTC Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.509,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 197.406.

<i>Extrait des résolutions des associés de la Société

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 13 août 2015 qui ont été acceptées:
- la démission de Mme Miranda Lansdowne en tant que gérant de la Société;
- la démission de Mme Pamela Valasuo en tant que gérant de la Société;
- la nomination de Mr Eric Biren né le 14 Juin 1969 à Bruxelles, Belgique, résidant professionnellement au 68-70

Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet à la date de l'assemblée générale
tenue le 13 août 2015;

- la nomination de Mr Vincent Goy né le 16 Juin 1955 à Dudelange, Luxembourg, résidant professionnellement au 68-70

Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet à la date de l'assemblée générale
tenue le 13 août 2015;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2015.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015140246/21.
(150152217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

130420

L

U X E M B O U R G

Les Bains d'Aphrodite S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 41, boulevard du Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 103.100.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015140263/10.
(150152299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Prime Credit 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 190.097.

Les comptes annuels de la Société pour la période du 8 septembre 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Duncan Smith
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015140371/13.
(150152856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Landericus Holding Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 135.164.

EXTRAIT

La nouvelle adresse de Monsieur Andrew MC KEON, Gérant de classe A de la Société est la suivante:
Two Pancras Square, King's Cross, Londres N1C 4AG, (Royaume-Uni).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2015140273/14.
(150152785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Precious Metals &amp; Commodities Trading S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel.

R.C.S. Luxembourg B 94.596.

EXTRAIT

Par la présente nous vous informons que
- La société TRIPLE A CONSULTING S.A. No RCS B61417 avec siège social au 2a rue Denis Netgen L-3858 Schif-

flange a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société Precious Metals &amp; Commodities Trading S.A. à
la date du 14/08/2015

- Alain VASSEUR né le 24/04/1958 à Dudelange, Luxembourg, résidant à L-8277 Holzem 3 rue de Mamer a démissionné

en tant qu'administrateur de la société Precious Metals &amp; Commodities Trading S.A. à la date du 14/08/2015

Le 14 août 2015.

Certifié sincère et conforme
Triple A Consulting

Référence de publication: 2015140368/17.
(150152800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

130421

L

U X E M B O U R G

Immo-Contrat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 37, rue des Etats-Unis.

R.C.S. Luxembourg B 28.058.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015140224/9.
(150152581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Le Battant Dormant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 189.695.

EXTRAIT

Madame Sylvie MARTIN démissionne de ses fonctions d'administrateur et de directeur à la gestion journalière, avec

effet au 30 mars 2015, de la société Le Battant Dormant S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015140259/11.
(150152437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Landericus Property Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 135.165.

EXTRAIT

La nouvelle adresse de Monsieur Andrew MC KEON, Gérant de classe A de la Société est la suivante:
Two Pancras Square, King's Cross, Londres N1C 4AG, (Royaume-Uni).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2015140274/14.
(150152784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

J. A. Restauration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 20, rue d'Audun.

R.C.S. Luxembourg B 191.122.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2015

<i>Première résolution

Est nommé comme gérant unique de la société, Monsieur MAIA FIGUEIRAS Antonio Marcelino, né le 15 décembre

1967 à Coimbra (P), demeurant à L-4018 Esch-sur-Alzette, 20, Rue d'Audun.

en remplacement de Monsieur DA SILVA RODRIGUES CRUZ Joao, gérant, né le 17 octobre 1960 à Parada de Bouro

(P), demeurant à L-2561 Luxembourg, 77, rue de Strasbourg.

<i>Deuxième résolution

Est  révoqué  comme  gérant  administratif  de  la  société,  Monsieur  MAIA  FIGUEIRAS  Antonio  Marcelino,  né  le  15

décembre 1967 à Coimbra (P), demeurant à L-4018 Esch-sur-Alzette, 20, Rue d'Audun.

La société sera valablement engagée par la seule signature du gérant unique.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 2015.

COMPTABILITE STC
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015140239/20.
(150152623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

130422

L

U X E M B O U R G

Lululemon LU Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 47.501,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 170.553.

Les comptes annuels au 31 janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140267/10.
(150152492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Librairie Française, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 13.350.

Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015140284/10.
(150152404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Mainstream Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 169.617.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015140301/10.
(150152512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Losca International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 131.097.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 Août 2015.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015140288/11.
(150152821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Prime Credit 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 185.920.

Les comptes annuels de la Société pour la période du 26 mars 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Duncan Smith
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015140370/13.
(150152754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

130423

L

U X E M B O U R G

Loëndal, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 101.731.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015140287/9.
(150152162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Maxis Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.665.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2015140305/10.
(150152426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Rigel International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.198.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 juillet 2015

Les mandats des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée

générale statuant sur l'exercice clos au 30 juin 2017 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

Mme Marina Padalino, demeurant professionnellement 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, président;
M. Cédric Finazzi, demeurant professionnellement 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, administrateur;
CL Management S.A., ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RIGEL INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2015140424/18.
(150152700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Papier Franzen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 112.697.

<i>Gesellschafterbeschluss der Firma Papier Franzen Sàrl

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und

beschließen folgendes:

1.
Die Adresse der Teilhaberin und Geschäftsführerin Heike Franzen wird abgeändert wie folgt:
Aulstraße 12, D-54290 Trier
2.
Die Adresse des Teilhabers Michael Franzen wird abgeändert wie folgt:
Fürstenhofenstraße 25, D-54329 Konz-Niedermennig

Niederanven, den 17. August 2015.

Référence de publication: 2015140381/17.
(150152761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

130424

L

U X E M B O U R G

Mira SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 59.887.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015140320/9.
(150152332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Medliner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 139.674.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015140315/10.
(150152526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Garibaldi GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 104.785.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2015138921/10.
(150151220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2015.

Semper Veritas Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.518.327,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 179.314.

Le bilan de la société au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015140436/12.
(150152737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Victoria Lux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 95.581.

1. Mme Karoline WILLOT a démissionné de son mandat de gérante.
2. Mme Virginie DECONINCK a démissionné de son mandat de gérante.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour VICTORIA LUX INVEST S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015140532/13.
(150152753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

130425

L

U X E M B O U R G

Sandton Holdings III (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 184.128.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015139789/11.
(150151686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2015.

Socolem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 188.082.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
Nico Patteet / K. Van Huynegem
<i>Administrateur – délégué / Administrateur – délégué

Référence de publication: 2015139801/13.
(150151476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2015.

Hassium Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 199.249.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of the month of July.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BRE/Europe 8NQ S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 195.188,

represented by Maître Ségolène Le Marec, maître en droit, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy

which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company Hassium Investment S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Hassium Investment

S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

130426

L

U X E M B O U R G

The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream), grant security interests, grant loans

or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group
of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance

money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case

may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500)

represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business

of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to

act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

130427

L

U X E M B O U R G

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,

by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the

board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal

to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

130428

L

U X E M B O U R G

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in

the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in  the  register  of  shareholders  held  by  the  Company  at  least  eight  (8)  days  before  the  proposed  effective  date  of  the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions  (or  subject  to  the  satisfaction  of  the  majority  requirements,  on  the  date  set  out  therein).  Unanimous  written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December

2015.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies;

in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December 2015.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:

Subscriber

Number

of shares

Subscription

price (EUR)

BRE/Europe 8NQ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 EUR 12,500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 EUR 12,500

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

130429

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles

of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:

- BRE/Management 8 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at

35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under number B 195.140.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,

the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English
language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreißigsten Tag des Monats Juli,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen,

BRE/Europe 8NQ S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen

Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500) beträgt, und eingetragen ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxemburg unter der Nummer B
195.188,

hier vertreten durch Frau Ségolène Le Marec, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer pri-

vatschriftlichen  Vollmacht  welche  vorliegender  Urkunde  beigefügt  ist  um  mit  dieser  bei  der  Registrierungsbehörde
eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) Hassium Investment S.à r.l. wie folgt zu
beurkunden.

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

„Hassium Investment S.à r.l.“ (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gege-
benenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch
die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,

Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream und sidestream Bürgschaften), Sicherheiten leisten,

Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die
zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-

geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und

130430

L

U X E M B O U R G

alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-

denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,

durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-

hundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung

vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht

anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die

keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-

gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführungdie weitestreichenden Befugnisse um

in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und

abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der

Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten

130431

L

U X E M B O U R G

werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,

von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen

Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder

leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-

schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die  Rechte  zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

130432

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage

vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens  acht  (8)  Tage  bevor  der  Beschluss  wirksam  werden  soll,  an  alle  Gesellschafter  an  ihre  im  Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember

eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember
2015 enden.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die  Gesellschafter  können  auf  der  Grundlage  eines  von  dem  alleinigen  Geschäftsführer,  beziehungsweise  der  Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet

werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179

(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich

nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2015 enden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt

in bar eingezahlt und gezeichnet:

130433

L

U X E M B O U R G

Einzahler

Zahl der

Geschäftsanteile

Einzahlungspreis

(EUR)

BRE/Europe 8NQ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12.500

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12.500

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.

<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der

Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:

- BRE/Management 8 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue

Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer
B 195.140.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen

Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-

schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach

Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: S. LE MAREC, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 août 2015. Relation: 1LAC/2015/24624. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. August 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015138194/453.
(150149896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.

Global Restaurant Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 199.290.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of August.
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

Mediterra Capital Partners I, LP, registered as a limited partnership in England, under the limited Partnerships Act 1907

with number LP014244, whose principal place of business is at Heritage Hall, PO Box 225, Le Marchant Street, St Peter
Port, Guernsey GY1 4HY, acting through its general partner Mediterra Capital Partners GP, LP, registered with the Registrar
of Limited Partnerships at Companies House in Edinburgh under number 8498, the latter acting in turn through its general
partner Mediterra Capital Management Limited, registered with the Guernsey Registry under number 52755,

hereby duly represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally at Pétange,

Grand-Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the “Articles”) of a “société à responsabilité limitée” which such party declares to incorporate.

130434

L

U X E M B O U R G

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed

by the present articles of Association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December
1992 on “sociétés à responsabilité limitée” (the “Commercial Companies Law”).

Art. 2. The Company's name is “Global Restaurant Investments S.à r.l.”.

Art. 3. The Company's purpose is:
(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Lu-

xembourg or foreign companies or enterprises;

(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way

any securities, rights, patents and licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem
fit;

(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the

Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company or natural person which

belong to the same group of companies than the Company (the “Affiliates”) or any manager/director of the Affiliates, any
assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case, even in favor of third-party lender of Affiliates);

(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed;
(7) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment

of the above objects or any of them.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers

or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case
may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of
the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings
of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Shares

Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros), represented by 12,500

(twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1,- (one Euro) each.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary

general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for
amendment of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his/her/its

shareholding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

130435

L

U X E M B O U R G

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three quarter of

the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders

or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital or
of the class of shares concerned represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requi-
rements of the Law or of Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and by one or several category B manager
(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and his/her/their

remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken at the majority rules set forth in
article 16 of the Articles, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be
modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove

and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole

shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the case
may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with
the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one category A manager and one category B manager.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/her/his powers

for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration

(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/her/their agency.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a

casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

130436

L

U X E M B O U R G

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his/her/its proxy.

A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, video-conference, or any other suitable tele-

communication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, including

at least one category A manager and one category B manager.

Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly

represented thereto provided that at least one category A manager and one category B manager approved these resolutions.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed
by the chairman or one category A manager and one category B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a managers'

meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having

the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other

suitable telecommunication means.

Art. 14. Any manager does not contract in his/her/its function any personal obligation concerning the commitments

regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the
execution of his/her/its mandate.

General meetings of shareholders

Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing
or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall
vote in writing.

If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the

shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the
closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg
at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the board

of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than the half of
the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the
notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken in

so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or

consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the
portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at

a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole share-

holder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

130437

L

U X E M B O U R G

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on 1 

st

 January and closes on 31 

st

 December.

Art. 18. Each year, as of 31 

st

 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up

the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor
(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,

which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen) days

preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the Company

Art. 20. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to one

or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by

a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the holding of
the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register

are  met,  the  Company  shall  have  its  annual  accounts  audited  by  one  or  more  approved  qualified  auditors  (“réviseurs
d'entreprises agréés”) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst
the qualified auditors (“réviseurs d'entreprises agréés”) registered in the Financial Sector Supervisory Commission (“Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier”)'s public register.

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms
and conditions of his/her/its/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as

decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one
tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case

may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold,
as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,

or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may
be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts
prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the
last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the sole

shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters

of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of liqui-
dation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When  the  liquidation  of  the  Company  is  closed,  the  liquidation  proceeds  of  the  Company  will  be  allocated  to  the

shareholders proportionally to the shares they hold.

130438

L

U X E M B O U R G

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 

st

 December 2015.

<i>Subscription - Payment

The appearing party hereby declares to subscribe to the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares issued by the

Company

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros)

is at the disposal of the Company.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about 1,500.- euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the company, representing the entirety of

the subscribed capital, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers:
- Ahmet Faralyali, residing professionally at Adali Fettah Sk. No:18, Arnavutköy - Besiktas/ Istanbul Turkey, category

A manager;

- Didem Batum, residing professionally at 40, avenue Monterey, L- 2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

category B manager; and

- Bérénice Kunnari, residing professionally at 40, avenue Monterey, L- 2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-

bourg, category B manager.

The managers shall serve for an undetermined duration.
According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager

and one category B manager.

2) The Company shall have its registered office at 40, avenue Monterey, L- 2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-

xembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned

appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the latter signed with us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte précédent

L'an deux mille quinze, le cinquième jour d'août.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg soussigné.

Comparaît:

Mediterra Capital Partners I, LP, immatriculée en tant que société en commandite en Angleterre, sous la loi de 1907 sur

les sociétés en commandite (the “limited Partnerships Act 1907”) sous le numéro LP014244, ayant son centre principal
d'activité sis à Heritage Hall, PO Box 225, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey GY1 4HY, agissant par l'intermé-
diaire  de  son  associé  commandité  Mediterra  Capital  Partners  GP,  LP,  immatriculé  auprès  du  registre  des  sociétés
(Companies House) à Edimbourg sous le numéro 8498, ce dernier agissant à son tour par l'intermédiaire de son associé
commandité Mediterra Capital Management Limited immatriculé auprès du Registre de Guernsey sous le numéro 52755,

ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Pétange,

Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeureront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire instrumentant de dresser les statuts suivants (les

«Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

130439

L

U X E M B O U R G

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué une société à responsabilité limitée (la «Société»), régis par les présents statuts (les «Statuts»)

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à
responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

Art. 2. La dénomination de la société est “Global Restaurant Investments S.à r.l.”.

Art. 3. L'objet de la Société est:
1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;

2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et

de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts,
comme la Société le jugera utile;

3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que

la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;

4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
5) D'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute

société ou personne physique appartenant au même groupe de sociétés que celui de la Société (les «Sociétés Affiliées»),
ou à tout gérant/administrateur des Sociétés Affiliées, tout concours, prêts, avances ou garanties (dans ce dernier cas, même
en faveur d'un prêteur tiers des Sociétés Affiliées);

6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme

empruntée; et

7) De manière générale faire toute chose apparaissant à la société comme étant favorable à l'accomplissement de l'objet

de la société, tel que susmentionné.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec

les secteurs pré-décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. La société a son siège social dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou

par le gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par

décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions
requises pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la com-
munication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provi-
soire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera
luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou
par le gérant unique (selon le cas) de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de
son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des
assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros), représenté par 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.

Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale

extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décision et chaque associé a un nombre

de droit de vote proportionnel aux nombre de part qu'il détient.

130440

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune  cession  de  parts  sociales  entre  vifs  à  un  tiers  non-associé  ne  peut  être  effectuée  sans  l'agrément  donné  en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique

(selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été proposé à
chaque associé de la même classe en proportion de leur participation dans le capital social ou de la classe de parts sociales
concernée représentés par leurs parts sociales.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues des
réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément
aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance composé d'au moins un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le
(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés de la société.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désignés en tant que gérant(s) de catégorie A ou gérant(s) de catégorie B et sa/leur

rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise selon les règles de majorité mentionnées
à l'article 16 des Statuts, ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être
modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

Le(s) gérant(s) peut/peuvent être révoqué(s) ou remplacé(s) ad nutum à tout moment avec ou sans justification par une

résolution de l'assemblée générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) par

la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir en

toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec l'objet
social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs

pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant
(s) de la Société.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (s'il

y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité de voix, aura un vote prépondérant.

Le président présidera toutes réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance sera
présidé par un gérant présent et nommé dans cette intention. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas né-
cessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de
l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)

jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la
réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens

électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques

ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les  réunions  du  conseil  de  gérance  se  tiendront  valablement  sans  convocation  si  tous  les  gérants  sont  présents  ou

représentés.

130441

L

U X E M B O U R G

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé

précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant de la Société peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de com-
muniquer à un même moment.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou

représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés,

incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par 1 (un)

gérant de catégorie A et 1 (un) gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le
président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant

le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques ou

tout autre moyen de communication approprié.

Art. 14. Tout gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Assemblée générale des associés

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé
émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des

associés. Dans ce cas, 1 (une) assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du
dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à l'heure
et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et les résolutions écrites des associés sont proposées

par le conseil de gérance, ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée

à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la con-
vocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre

du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme,

télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié, un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement

adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont

immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la
majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale

extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique

et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

130442

L

U X E M B O U R G

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui

contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du/des gérant(s), du/des commissaire(s) (s'il en existe) et du/des associé(s) envers la
Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes

qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de

profits et pertes.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)

jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la Société

Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs

commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale

annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé

(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon
le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'approbation des comptes
annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés seront atteints,

la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommés par
l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les membres inscrits au registre public des
réviseurs d'entreprises agréés tenu par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé peut/peuvent

être nommé(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat/s.

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pourcent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel

qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais seront à nouveau obligatoire si la réserve légale redevient inférieure à ce seuil
de dix pourcent.

L'assemblée des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment

qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au prorata de leur
participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou le gérant

unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, desquels
il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne
peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et
des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des
Statuts.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé

unique (selon le cas) peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.

Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts du

capital social, devra désigner un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) et déterminer la méthode
de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs ainsi que leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata des parts sociales qu'ils détien-

nent.

130443

L

U X E M B O U R G

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2015.

<i>Libérations - Apports

La partie comparante déclare par la présente souscrire aux 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales émises par la

Société.

Les parts sociales ont été entièrement payés en numéraire de telle sorte que la somme de EUR 12,500 (douze mille cinq

cent Euros) est à disposition de la Société.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élèvent à environ 1.500,- euros.

<i>Décisions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital souscrit, a pris les

résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants:
- Ahmet Faralyali, résidant professionnellement à Adali Fettah Sk. No:18, Arnavutköy - Besiktas/ Istanbul Turkey,

gérant de catégorie A;

- Didem Batum, résidant professionnellement au 40, avenue Monterey, L- 2163 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-

xembourg, gérant de catégorie B; et

- Bérénice Kunnari, résidant professionnellement au 40, avenue Monterey, L- 2163 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, gérant de catégorie B.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article 12 des statuts, la Société est engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et

d'un gérant de catégorie B.

2) Le siège social de la Société est établi au 40, avenue Monterey, L- 2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente, le présent acte

de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour fixé au début de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 août 2015. Relation: EAC/2015/18558. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015138931/543.
(150150725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2015.

Brookstar Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 181.439.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Brookstar Investments Lux S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015139994/11.
(150152291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

130444

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg Serviced Apartments Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 173.382.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth of July.
before Us, Maître Jean SECKLER, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of OCM Luxembourg Serviced Apartments Holdings

S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg and a share capital in an amount of EUR 188,678.-, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 173.382, incorporated on October 26, 2012 pursuant to a deed enacted by
Maître Jean Seckler, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 181, page 8658, of January 24, 2013 (the Company).

The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on March 9, 2015, pursuant

to a deed of Maître Francis Kesseler, notary then residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1296, page 62190, of May 19, 2015.

There appeared:

1. OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 159.343 and having a share capital amounting to
EUR 1,127,300.- (EPF III),

hereby represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, professionally residing in Junglinster, by virtue of a proxy given

under private seal;

2. Max Daniel Thorne, born on August 10, 1967 in Walton in Thames and having his address at Wispington House,

Worster Road, Cookham, Maidenhead, Berkshire, SL6 9JG, United Kingdom (Max),

hereby represented by Henri DA CRUZ, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;
3. Simon John Scott, born on September 3, 1972 in Folkestone and having his address at Heybourne, Stonefield Road,

Naphill, Bucks, HP14 4SP, United Kingdom (Simon),

hereby represented by Henri DA CRUZ, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
4. David Freed, born on 11 March 1954, in Cardiff, residing professionally at 6 

th

 Floor, Embassy House, Queens Avenue,

Clifton, Bristol, BS8 1SB (David),

hereby represented by Henri DA CRUZ, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
5. Lesley Freed, born on 14 December 1951, in Cardiff, residing professionally at 6 

th

 Floor, Embassy House, Queens

Avenue, Clifton, Bristol, BS8 1SB (Lesley),

hereby represented by Henri DA CRUZ, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
6. Stephen Hanton, born on 25 August 1958 in Cardiff, residing professionally at 6 

th

 Floor, Embassy House, Queens

Avenue, Clifton, Bristol, BS8 1SB (Stephen),

hereby represented by Henri DA CRUZ, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
7. Tower Pension Trustees Limited, a limited company incorporated under the laws of England and Wales, having its

registered office at 3 Temple Quay, Temple Back East, Bristol, BS1 6DZ, United Kingdom and registered with the Com-
panies House under the number 2178783 (Tower Pension, and together with EPF III, Max, Simon, David, Lesley and
Stephen, the Shareholders),

hereby represented by Henri DA CRUZ, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that:
I. The (i) one hundred and seventy-nine thousand nine hundred and sixty-one (179,961) class A ordinary shares, (ii)

eight thousand five hundred and fifteen (8,515) class B ordinary shares, (iii) two (2) class C ordinary shares and (iv) two
hundred (200) MIP ordinary shares, all in registered form with a nominal value one euro (EUR 1.-) each, representing the
entire share capital of the Company of an amount of one hundred and eighty-eight thousand six hundred and seventy-eight
euro (EUR 188,678.-) are duly represented at the present Meeting which is consequently regularly constituted and may
deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notice;

130445

L

U X E M B O U R G

2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of thirty-four thousand two hundred and fifty-seven euro

(EUR 34,257.-) so as to bring it from its present amount of one hundred and eighty-eight thousand six hundred and seventy-
eight euro (EUR 188,678), represented by (i) one hundred and seventy-nine thousand nine hundred and sixty-one (179,961)
class A ordinary shares (the A Shares), (ii) eight thousand five hundred and fifteen (8,515) class B ordinary shares (the B
Shares), (iii) two (2) class C ordinary shares (the C Shares) and (iv) two hundred (200) MIP shares (the MIP Shares), to
an amount of one hundred and fifty-four thousand four hundred and twenty-one euro (EUR 154,421.-), by way of the
redemption and cancellation of (i) thirty-two thousand seven hundred and fifty-four (32,754) A Shares held by EPF III, (ii)
six hundred and forty-nine (649) B Shares held by David, (iii) six hundred and forty-nine (649) B Shares held by Lesley,
and (iv) two hundred and five (205) B Shares held by Stephen, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all in
registered form, by way of repayment to the redeemed shareholders;

3. Suppression of the nominal value of (i) one hundred and forty-seven thousand two hundred and seven (147,207) A

Shares, (ii) seven thousand and twelve (7,012) B Shares, (iii) two (2) C Shares and (iv) two hundred (200) MIP Shares,
representing the entire share capital of the Company of an amount of one hundred and fifty-four thousand four hundred
and twenty-one euro (EUR 154,421.-);

4. Change of the functional currency of the Company from euro (EUR) to British Pound Sterling (GBP), and subsequent

conversion of the amount of share capital of the Company from its present amount of one hundred and fifty-four thousand
four hundred and twenty-one euro (EUR 154,421.-) to one hundred and eight thousand nine hundred and thirteen British
Pound Sterling and thirteen penny (GBP 108,913.13.-) at the EUR/GBP exchange rate published by the European Central
Bank on July 30, 2015 according to which one euro (EUR 1.-) corresponds to zero point seven zero five three British Pound
Sterling (GBP 0.7053.-), represented by (i) one hundred and forty-seven thousand two hundred and seven (147,207) A
Shares, (ii) seven thousand and twelve (7,012) B Shares, (iii) two (2) C Shares and (iv) two hundred (200) MIP Shares,
without designation of nominal value;

5. Creation of a nominal value of one penny (GBP 0.01.-) by share of the Company, so that the share capital of the

Company be represented by (i) ten million three hundred and eighty-two thousand five hundred and nine (10,382,509) A
Shares, (ii) four hundred and ninety-four thousand five hundred and fifty-six (494,556) B Shares, (iii) one hundred and
forty-two (142) C Shares and (iv) fourteen thousand one hundred and six (14,106) MIP Shares, having a nominal value of
one penny (GBP 0.01.-) each, and an aggregate nominal value of one hundred and eight thousand nine hundred and thirteen
British Pound Sterling and thirteen penny (GBP 108,913.13.-);

6. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the share capital decrease adopted under item

2. and the change of nominal value adopted under item 4;

7. Subsequent amendment of article 6.25 of the Articles;
8. Subsequent amendment of the following definitions in the Articles: “A Share”, “B Share”, “C Share”, and “MIP

Share”;

9. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any employee and/or manager of the Company and to any lawyer and/or employee of Stibbe Avocats in Luxem-
bourg, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the cancellation of the shares in the shareholders'
register of the Company; and

10. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholders, have requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices require-

ment, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of thirty-four thousand two hundred

and fifty-seven euro (EUR 34,257.-) so as to bring it from its present amount of one hundred and eighty-eight thousand six
hundred and seventy-eight euro (EUR 188,678.-), represented by (i) one hundred and seventy-nine thousand nine hundred
and sixty-one (179,961) class A ordinary shares (the A Shares), (ii) eight thousand five hundred and fifteen (8,515) class
B ordinary shares (the B Shares), (iii) two (2) class C ordinary shares (the C Shares) and (iv) two hundred (200) MIP shares
(the MIP Shares), to an amount of one hundred and fifty-four thousand four hundred and twenty-one euro (EUR 154,421.-),
by way of the redemption and cancellation of (i) thirty-two thousand seven hundred and fifty-four (32,754) A Shares held
by EPF III, (ii) six hundred and forty-nine (649) B Shares held by David, (iii) six hundred and forty-nine (649) B Shares
held by Lesley, and (iv) two hundred and five (205) B Shares held by Stephen, having a nominal value of one euro (EUR
1.-) each, all in registered form, by way of repayment in cash to the relevant shareholders.

After the decrease of the share capital of the Company, the shareholding of the Company shall be constituted as follows:
- EPF III holds one hundred and forty-seven thousand two hundred and seven (147,207) A Shares;
- Max holds (i) one (1) C Share and (ii) one hundred (100) MIP Shares;

130446

L

U X E M B O U R G

- Simon holds (i) one (1) C Share and (ii) one hundred (100) MIP Shares;
- David holds two thousand nine hundred and twenty (2,920) B Shares;
- Lesley holds two thousand nine hundred and twenty (2,920) B Shares;
- Stephen holds nine hundred and twenty-five (925) B Shares; and
- Tower Pension holds two hundred and forty-seven (247) B Shares.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to suppress the nominal value of (i) one hundred and forty-seven thousand two hundred and seven

(147,207) A Shares, (ii) seven thousand and twelve (7,012) B Shares, (iii) two (2) C Shares and (iv) two hundred (200)
MIP Shares, representing the entire share capital of the Company of an amount of one hundred and fifty-four thousand four
hundred and twenty-one euro (EUR 154,421.-).

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves:
(i) to change the functional currency of the Company from euro (EUR) to British Pound Sterling (GBP) with immediate

effect; and

(ii) to subsequently convert the amount of share capital of the Company from its present amount of one hundred and

fifty-four thousand four hundred and twenty-one euro (EUR 154,421.-) to one hundred and eight thousand nine hundred
and thirteen British Pound Sterling and thirteen penny (GBP 108,913.13.-) at the EUR/GBP exchange rate published by
the European Central Bank on July 30, 2015 according to which one euro (EUR 1.-) corresponds to zero point seven zero
five three British Pound Sterling (GBP 0.7053.-), represented by (i) one hundred and forty-seven thousand two hundred
and seven (147,207) A Shares, (ii) seven thousand and twelve (7,012) B Shares, (iii) two (2) C Shares and (iv) two hundred
(200) MIP Shares, without designation of nominal value.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to create a nominal value of one penny (GBP 0.01.-) by share of the Company, so that the share

capital of the Company be represented by (i) ten million three hundred and eighty-two thousand five hundred and nine
(10,382,509) A Shares, (ii) four hundred and ninety-four thousand five hundred and fifty-six (494,556) B Shares, (iii) one
hundred and forty-two (142) C Shares and (iv) fourteen thousand one hundred and six(14,106) MIP Shares, having a
nominal value of one penny (GBP 0.01.-) each, and an aggregate nominal value of one hundred and eight thousand nine
hundred and thirteen British Pound Sterling and thirteen penny (GBP 108,913.13.-).

<i>Sixth resolution

The Meeting subsequently unanimously resolves to amend article 5.1 of the Articles, which shall henceforth read as

follows:

“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at one hundred and eight thousand nine hundred and thirteen British

Pound Sterling and thirteen penny (GBP 108,913.13.-) represented by (i) ten million three hundred and eighty-two thousand
five  hundred  and  nine  (10,382,509)  A  Shares,  (ii)  four  hundred  and  ninety-four  thousand  five  hundred  and  fifty-six
(494,556) B Shares, (iii) one hundred and forty-two (142) C Shares and (iv) fourteen thousand one hundred and six(14,106)
MIP Shares, all in registered form with a nominal value one penny (GBP 0.01.-) each, all subscribed and fully paid-up.”

<i>Seventh resolution

The Meeting unanimously resolves to amend article 6.25 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ 6.25. If a B Shareholder (except David Freed, Lesley Freed and Stephen Hanton, to the extent they hold any B Shares,

and for which the Articles 6.25 to and including 6.27 shall not be applicable) becomes a Leaver the Company may by
written notice to the relevant Leaver at any point after the relevant Cessation Date elect that the Company shall purchase
(or as it shall direct a third party may purchase) any or all of the Leaver's B Shares (“B Shareholder's Shares”).”

<i>Eighth resolution

The Meeting unanimously resolves to amend the following definitions in the Articles: “A Share”, “B Share”, “C Share”,

and “MIP Share”, which shall henceforth read as follows:

- "A Share" means the class 'A' ordinary shares of one penny (GBP 0.01.-) each in the capital of the Company;
- "B Share" means a class 'B' ordinary share of one penny (GBP 0.01.-) each in the capital of the Company;
- "C Share" means a class 'C' ordinary share of one penny (GBP 0.01.-) each in the capital of the Company;
- "MIP Shares" means a MIP share of one penny (GBP 0.01.-) each in the capital of the Company.

<i>Ninth resolution

The Meeting unanimously resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the currency

change and the share capital decrease and to empower and authorize any employee and/or manager of the Company and

130447

L

U X E M B O U R G

to any lawyer and/or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg, each acting individually, to proceed on behalf of the
Company, with the registration of the currency change and the share capital decrease in the register of shareholders of the
Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred (EUR
1,300.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, said proxyholders signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le trente juin.
Par-devant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg;

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de OCM Luxembourg Serviced Apartments Holdings

S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 26A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg et un capital social de 188.678 EUR, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 173.382, constituée le 26 octobre 2012 suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire
de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 181, page 8658, en date du 24 janvier 2013 (la Société).

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 9 mars 2015 suivant un acte de Maître

Francis Kesseler, notaire résidant alors à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1296, page 62190, du 19 mai 2015.

ONT COMPARU:

1. OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois ayant son

siège social situé au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 159.343, et ayant un capital social de 1.127.300 EUR (EPF III),

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé;

2. Max Daniel Thorne, né le 10 août 1967 à Walton (Thames), et ayant son adresse à Wispington House, Worster Road,

Cookham, Maidenhead, Berkshire, SL6 9JG, Royaume-Uni (Max),

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
3. Simon John Scott, né le 3 septembre 1972 à Folkestone et ayant son adresse à Heybourne, Stonefield Road, Naphill,

Bucks, HP14 4SP, Royaume-Uni (Simon),

ici représenté par Monsieur Henri DA CRUZ, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
4. David Freed, né le 11 mars 1954 à Cardiff, ayant son adresse professionnelle au 6 

ème

 étage, Embassy House, Queens

Avenue, Clifton, Bristol, BS8 1SB (David),

ici représenté par Monsieur Henri DA CRUZ, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
5. Lesley Freed, née le 14 décembre 1951 à Cardiff, ayant son adresse professionnelle au 6 

ème

 étage, Embassy House,

Queens Avenue, Clifton, Bristol, BS8 1SB (Lesley),

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
6. Stephen Hanton, né le 25 août 1958 à Cardiff, ayant son adresse professionnelle au 6 

ème

 étage, Embassy House,

Queens Avenue, Clifton, Bristol, BS8 1SB (Stephen),

ici représenté par Monsieur Henri DA CRUZ, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
7. Tower Pension Trustees Limited, une société constituée sous le droit d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son

adresse à 3 Temple Quay, Temple Back East, Bristol, BS1 6DZ, Royaume-Uni et immatriculée auprès de Companies House
sous le numéro 2178783 (Tower Pension, et avec EPF III, Max, Simon, David, Lesley and Stephen, les Associés),

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

130448

L

U X E M B O U R G

Lesdites  procurations,  après  avoir  été  signées  "ne  varietur"  par  le  mandataire  des  parties  comparantes  et  le  notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont prié le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les (i) cent soixante-dix-neuf mille neuf cent soixante-et-une (179.961) parts sociales ordinaires de classe A, (ii) huit

mille cinq cent quinze (8.515) parts sociales ordinaires de classe B, (iii) deux (2) parts sociales ordinaires de classe C, et
(iv) deux cents (200) parts sociales ordinaires MIP, toute sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un euro (1
EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-huit mille six cent
soixante-dix-huit euros (188.678 EUR), sont dûment représentées à la présente Assemblée, laquelle est régulièrement
constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour ci-après reproduits.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de trente-quatre mille deux cent cinquante-sept euros (34.257

EUR), afin de le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-dix-huit euros (188.678
EUR), représenté par (i) cent soixante-dix-neuf mille neuf cent soixante-et-une (179.961) parts sociales ordinaires de classe
A (les Parts Sociales A), (ii) huit mille cinq cent quinze (8,515) parts sociales ordinaires de classe B (les Parts Sociales B),
(iii) deux (2) parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales C), et (iv) deux cents (200) parts sociales ordinaires
MIP (les Parts Sociales MIP), à un montant de cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-et-un euros (154.421 EUR),
par le rachat et l'annulation de (i) trente-deux mille sept cent cinquante-quatre (32.754) Parts Sociales A détenues par EPF
III, (ii) six cent quarante-neuf (649) Parts Sociales B détenues par David, (iii) six cent quarante-neuf (649) Parts Sociales
B détenues par Lesley et (iv) deux cent cinq (205) Parts Sociales B détenues par Stephen, ayant une valeur nominale de un
euro (1 EUR) chacune, toute sous forme nominative, par repaiement aux associés concernés;

3. Suppression de la valeur nominale des (i) cent quarante-sept mille deux cent sept (147.207) Parts Sociales A, (ii) sept

mille  douze  (7.012)  Parts  Sociales  B,  (iii)  deux  (2)  Parts  Sociales  C  et  (iv)  deux  cents  (200)  Parts  Sociales  MIP,  qui
représentent la totalité du capital cial de la Société d'un montant de cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-et-un
euros (EUR 154.421);

4. Changement de la devise fonctionnelle de la Société d'euro (EUR) en livres sterling (GBP) et conversion subséquente

du montant du capital social de la Société de son montant actuel de cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-et-un
euros (154.421 EUR) à cent huit mille neuf cent treize livres sterling et douze pence (GBP 108.913,13.-) au taux de change
officiel EUR/GBP publié par la Banque Centrale Européenne à la date du 30 juin 2015 selon lequel un euro (EUR 1)
équivaut à zéro virgule sept zéro cinq trois de livres sterling (GBP 0,7053.-), représenté par (i) cent quarante-sept mille
deux cent sept (147.207) Parts Sociales A, (ii) sept mille douze (7.012) Parts Sociales B, (iii) deux (2) Parts Sociales C et
(iv) deux cent (200) Parts Sociales MIP, sans valeur nominale;

5. Création d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) par part sociale de la Société, de sorte que le capital social de

la Société soit représenté par (i) dix million trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cent neuf (10.382.509) Parts Sociales
A, (ii) quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinquante-six (494.556) Parts Sociales B, (iii) cent quarante-deux
(142) Parts Sociales C et (iv) quatorze mille cent six (14.106) Parts Sociales MIP, ayant une valeur nominale d'un penny
(GBP 0,01) chacune et une valeur nominale totale de cent huit mille neuf cent treize livres sterling et treize pence (GBP
108.913,13);

6. Modification ultérieure de l'article 5.1. des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital indiquée au

point 2 et la conversion de la valeur nominale indiquée au point 4;

7. Modification ultérieure de l'article 6.25. des Statuts;
8. Modification ultérieure des définitions suivantes dans les Statuts: «Part Sociale A», «Part Sociale B», «Part Sociale

C» et «Part Sociale MIP»;

9. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat et/ou employé de Stibbe Avocats au Luxembourg, chacun agissant
individuellement, pour procéder au nom et pour le compte de la Société à l'annulation des parts sociales dans le registre
des associés de la Société; et

10. Divers.
Par conséquent, les parties présentes, agissant par l'intermédiaire de leur représentant, ont requis le notaire instrumentant

d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les

Associés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de trente-quatre mille deux cent cinquante-

sept euros (34.257 EUR), afin de le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-dix-huit

130449

L

U X E M B O U R G

euros (188.678 EUR), représenté par (i) cent soixante-dix-neuf mille neuf cent soixante-et-une (179.961) parts sociales
ordinaires de classe A (les Parts Sociales A), (ii) huit mille cinq cent quinze (8,515) parts sociales ordinaires de classe B
(les Parts Sociales B), (iii) deux (2) parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales C), et (iv) deux cents (200)
parts sociales ordinaires MIP (les Parts Sociales MIP), à un montant de cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-et-
un euros (154.421 EUR), par le rachat et l'annulation de (i) trente-deux mille sept cent cinquante-quatre (32.754) Parts
Sociales A détenues par EPF III, (ii) six cent quarante-neuf (649) Parts Sociales B détenues par David, (iii) six cent quarante-
neuf (649) Parts Sociales B détenues par Lesley et (iv) deux cent cinq (205) Parts Sociales B détenues par Stephen, ayant
une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune, toute sous forme nominative, par repaiement en liquide aux associés
concernés.

Suite à la réduction du capital social de la Société, l'actionnariat de la Société se compose comme suit:
- EPF III détient cent quarante-sept mille deux cent sept (147.207) Parts Sociales A;
- Max détient (i) one (1) Parts Sociales de Classe C et (ii) cent (100) Parts Sociales MIP;
- Simon détient (i) one (1) Parts Sociales de Classe C et (ii) cent (100) Parts Sociales MIP;
- David détient deux mille neuf cent vingt (2.920) Parts Sociales B;
- Lesley détient deux mille neuf cent vingt (2.920) Parts Sociales B;
- Stephen détient neuf cent vingt-cinq (925) Parts Sociales B; et
- Tower Pension détient deux cent quarante-sept (247) Parts Sociales B.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des i) cent quarante-sept mille deux cent sept (147.207) Parts

Sociales A, (ii) sept mille douze (7.012) Parts Sociales B, (iii) deux (2) Parts Sociales C et (iv) deux cents (200) Parts
Sociales MIP, qui représentent la totalité du capital social de la Société d'un montant de cent cinquante-quatre mille quatre
cent vingt-et-un euros (EUR 154.421).

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide:
(i) de modifier la devise fonctionnelle de la Société d'euro (EUR) en livres sterling (GBP) avec effet immédiat; et
(ii) de convertir ensuite le montant du capital social de la Société de son montant actuel de ent cinquante-quatre mille

quatre  cent  vingt-et-un  euros  (154.421  EUR)  à  cent  huit  mille  neuf  cent  treize  livres  sterling  et  treize  pence  (GBP
108.913,13.-) au taux de change officiel EUR/GBP publié par la Banque Centrale Européenne à la date du 30 juin 2015
selon lequel un euro (EUR 1) équivaut à zéro virgule sept zéro cinq trois de livres sterling (GBP 0,7053.-), représenté par
(i) cent quarante-sept mille deux cent sept (147.207) Parts Sociales A, (ii) sept mille douze (7.012) Parts Sociales B, (iii)
deux (2) Parts Sociales C et (iv) deux cent (200) Parts Sociales MIP, sans valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de créer une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) par part sociale de la Société, de sorte que le

capital social de la Société soit représenté (i) dix million trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cent neuf (10.382.509)
Parts Sociales A, (ii) quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinquante-six (494.556) Parts Sociales B, (iii) cent
quarante-deux (142) Parts Sociales C et (iv) quatorze mille cent six (14.106) Parts Sociales MIP, ayant une valeur nominale
d'un penny (GBP 0,01) chacune et une valeur nominale totale de cent huit mille neuf cent treize livres sterling et treize
pence (GBP 108.913,13).

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide unanimement de modifier l'article 5.1. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à cent huit mille neuf cent treize livres sterling et treize pence (GBP

108.913,13), représenté par (i) dix million trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cent neuf (10.382.509) Parts Sociales A,
(ii) quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinquante-six (494.556) Parts Sociales B, (iii) cent quarante-deux
(142) Parts Sociales C et (iv) quatorze mille cent six (14.106) Parts Sociales MIP, toutes sous forme nominative d'une
valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide unanimement de modifier l'article 6.25 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« 6.25. Si un Associé B (à l'exception de David Freed, Lesley Freed et Stephen Hanton, pour autant qu'ils détiennent

des Parts Sociales de Classe B, pour lesquels les articles 6.25 à 6.27 inclus ne s'appliquent pas) devient un Sortant la Société
peut par notification écrite au Sortant concerné à tout moment après la Date de Cessation en question choisir que la Société
achètera (ou selon qu'elle ordonnera à un tiers de pouvoir racheter) la totalité ou une partie des Parts Sociales du Sortant
B ("Parts Sociales de l'Associé B").»

130450

L

U X E M B O U R G

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide unanimement de modifier les définitions suivantes dans les Statuts: «Part Sociale A», «Part Sociale

B», «Part Sociale C» et «Part Sociale MIP», qui auront désormais la teneur suivante:

- «Part Sociale A» désigne toute part sociale ordinaire de classe «A» d'une valeur d'un penny (GBP 0,01) chacune dans

le capital de la Société;

- «Part Sociale B» désigne toute part sociale ordinaire de classe «B» d'une valeur d'un penny (GBP 0,01) chacune dans

le capital de la Société;

- «Part Sociale C» désigne toute part sociale ordinaire de classe «C» d'une valeur d'un penny (GBP 0,01) chacune dans

le capital de la Société;

- «Parts Sociales MIP» désigne une part sociale MIP d'une valeur d'un penny (GBP 0,01) chacune dans le capital de la

Société.

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée décide unanimement de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter le changement de

devise et la diminution du capital social et autoriser tout gérant et/ou employé de la Société et à tout avocat et/ou employé
de Stibbe Avocats à Luxembourg agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription du
changement de la devise et de la diminution du capital social dans le registre des associés de la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, la Séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre la version anglaise et la
version française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire

instrumentant, le présent acte original.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 août 2015. Relation GAC/2015/6760. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015138357/361.
(150150302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.

Happy Family I S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 151.121.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015140190/9.
(150152618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Benelux Partners Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 60.695.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140003/10.
(150152470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

130451

L

U X E M B O U R G

Firewall Management MIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 191.637.

In the year two thousand and fifteen, on the sixth of the month of August,
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

the extraordinary general meeting of shareholders of Firewall Management MIP, S.A. (hereinafter the “Company”), a

société anonyme, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Company and Trade Register under number B 191.637 incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard
Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 November 2014, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on 3 December 2014. The articles of association have been last amended on 29 January
2015 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on
17 March 2015 under number 726.

The meeting was opened with Alexander Olliges, professionally residing in Luxembourg in the chair.
The chairman appointed as secretary Diana Toth and the meeting elected Julia Szafranska as scrutineer, professionally

residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to

record the following:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present or the proxholder of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

II. It appears from the above-mentioned attendance list, that all one hundred three million six hundred eleven thousand

five hundred sixty (103,611,560) shares representing one hundred per cent (100 %) of the share capital of the Company,
are duly represented at the present meeting.

III. The shareholders represented waiving any convening formalities; the present meeting is thus regularly constituted

and may validly deliberate on all the items on the agenda.

IV. The agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the Company's share capital by an amount of three hundred thirty euro sixty-five euro cents (EUR 330.65)

so as to raise it from its current amount of one hundred three thousand six hundred eleven euro fifty-six euro cents (EUR
103,611.56)  up  to  one  hundred  three  thousand  nine  hundred  forty-two  euro  twenty-one  euro  cents  (EUR  103,942.21)
through the issuance of three hundred thirty thousand six hundred fifty (330,650) shares divided into thirty-three thousand
sixty-five (33,065) class B1 redeemable shares (the “Class B1 Shares”), thirty-three thousand sixty-five (33,065) class B2
redeemable shares (the “Class B2 Shares”), thirty-three thousand sixty-five (33,065) class B3 redeemable shares (the “Class
B3 Shares”), thirty-three thousand sixty-five (33,065) class B4 redeemable shares (the “Class B4 Shares”), thirty-three
thousand sixty-five (33,065) class B5 redeemable shares (the “Class B5 Shares”), thirty-three thousand sixty-five (33,065)
class B6 redeemable shares (the “Class B6 Shares”), thirty-three thousand sixty-five (33,065) class B7 redeemable shares
(the “Class B7 Shares”), thirty-three thousand sixty-five (33,065) class B8 redeemable shares (the “Class B8 Shares”),
thirty-three thousand sixty-five (33,065) class B9 redeemable shares (the “Class B9 Shares”), and thirty-three thousand
sixty-five (33,065) class B10 redeemable shares (the “Class B10 Shares”) with a nominal value of one tenth of a euro cent
(EUR 0,001) each.

2. Subsequent amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth

read as follows:

“ 5.1. The Company's share capital is set at one hundred three thousand nine hundred forty-two euro twenty-one euro

cents  (EUR  103,942.21)  represented  by  one  hundred  three  million  nine  hundred  forty-two  thousand  two  hundred  ten
(103,942,210) shares having nominal value of one tenth of a cent (EUR 0.001) split as follows:

(a) one hundred million (100,000,000) A shares (the “A Shares”);
(b) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B1 redeemable shares (the “Class B1

Shares”);

(c) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B2 redeemable shares (the “Class B2

Shares”);

130452

L

U X E M B O U R G

(d) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B3 redeemable shares (the “Class B3

Shares”);

(e) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B4 redeemable shares (the “Class B4

Shares”);

(f) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B5 redeemable shares (the “Class B5

Shares”);

(g) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B6 redeemable shares (the “Class B6

Shares”);

(h) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B7 redeemable shares (the “Class B7

Shares”);

(i) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B8 redeemable shares (the “Class B8

Shares”);

(j) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B9 redeemable shares (the “Class B9

Shares”); and

(k) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B10 redeemable shares (the “Class B10

Shares”) (the Class B10 Shares together with Class B1 Shares, Class B2 Shares, Class B3 Shares, Class B4 Shares, Class
B5 Shares, Class B6 Shares, Class B7 Shares, Class B8 Shares, Class B9 Shares, are collectively called the “Classes”).”

3. Miscellaneous.
The general meeting of shareholders has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company's share capital by an amount of three hundred

thirty euro sixty-five euro cents (EUR 330.65) so as to raise it from its current amount of one hundred three thousand six
hundred eleven euro and fifty-six euro cents (EUR 103,611.56) up to one hundred three thousand nine hundred forty-two
euro twenty-one euro cents (EUR 103,942.21) through the issuance of three hundred thirty thousand six hundred fifty
(330,650) shares divided into thirty-three thousand sixty-five (33,065) Class B1 Shares, thirty-three thousand sixty-five
(33,065)  Class  B2  Shares,  thirty-three  thousand  sixty-five  (33,065)  Class  B3  Shares,  thirty-three  thousand  sixty-five
(33,065)  Class  B4  Shares,  thirty-three  thousand  sixty-five  (33,065)  Class  B5  Shares,  thirty-three  thousand  sixty-five
(33,065)  Class  B6  Shares,  thirty-three  thousand  sixty-five  (33,065)  Class  B7  Shares,  thirty-three  thousand  sixty-five
(33,065) Class B8 Shares, thirty-three thousand sixty-five (33,065) Class B9 Shares, and thirty-three thousand sixty-five
(33,065) Class B10 Shares with a nominal value of one tenth of a euro cent (0,001) each (the “New Shares”).

<i>Subscription - Payment

The three hundred thirty thousand six hundred fifty (330,650) New Shares have been subscribed as follows:
1) Firewall Investments S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 191.622,

has subscribed ninety-six thousand ninety (96,090) New Shares subdivided as follows:
a) nine thousand six hundred nine (9,609) Class B1 Shares;
b) nine thousand six hundred nine (9,609) Class B2 Shares;
c) nine thousand six hundred nine (9,609) Class B3 Shares;
d) nine thousand six hundred nine (9,609) Class B4 Shares;
e) nine thousand six hundred nine (9,609) Class B5 Shares;
f) nine thousand six hundred nine (9,609) Class B6 Shares;
g) nine thousand six hundred nine (9,609) Class B7 Shares;
h) nine thousand six hundred nine (9,609) Class B8 Shares;
i) nine thousand six hundred nine (9,609) Class B9 Shares; and
j) nine thousand six hundred nine (9,609) Class B10 Shares,
for the price of ninety-six thousand eight hundred ninety-six euro twenty-three euro cents (EUR 96,896.23).
All shares were fully paid up by way of a contribution in kind consisting of receivable held by Firewall Investments

S.A., aforementioned, against the Company in the aggregate amount of ninety-six thousand eight hundred ninety-six euro
twenty-three euro cents (EUR 96,896.23).

The value of such contribution results from a report issued by Ernst &amp; Young Luxembourg S.A., a public limited liability

company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 88019, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé).

The conclusion of the report is the following: “Based on the work performed and described above, nothing has come to

our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and

130453

L

U X E M B O U R G

nominal value to the 96,090 new shares with a nominal value of EUR 0.001 each to be issued with total related share
premium of 96,800.14, hence total consideration amounting to EUR 96,896.23”.

The above mentioned report after having been initialled by the notary and the proxyholder of the appearing parties will

remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Proof of the existence of the above-referred receivable has been produced to the undersigned notary.
2) Pentera Trustees Limited as trustee of The Siveytal Trust, a trust set up in Jersey, having its registered address at PO

Box 79, 26 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 8PS, and registered with the Jersey Financial Services Commission Companies
Registry under number 91413, has subscribed fifty-five thousand eight hundred (55,800) New Shares subdivided as follows:

a) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B1 Shares;
b) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B2 Shares;
c) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B3 Shares;
d) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B4 Shares;
e) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B5 Shares;
f) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B6 Shares;
g) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B7 Shares;
h) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B8 Shares;
i) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B9 Shares; and
j) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B10 Shares
for the price of fifty-six thousand seven hundred sixty-one euro eighty-seven euro cents (EUR 56,761.87).
3) Peter Cohen, professionally residing at 12 Castle Street, St Helier, Jersey, JE2 3RT, has subscribed fifty-five thousand

eight hundred (55,800) New Shares subdivided as follows:

a) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B1 Shares;
b) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B2 Shares;
c) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B3 Shares;
d) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B4 Shares;
e) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B5 Shares;
f) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B6 Shares;
g) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B7 Shares;
h) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B8 Shares;
i) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B9 Shares; and
j) five thousand five hundred eighty (5,580) Class B10 Shares
for the price of fifty-six thousand seven hundred sixty-one euro eighty-seven euro cents (EUR 56,761.87).
4) Jonathan Ben-David, professionally residing at 12 Castle Street, St Helier, Jersey, JE2 3RT, has subscribed twenty-

five thousand eight hundred forty (25,840) New Shares subdivided as follows:

a) two thousand five hundred eighty-four (2,584) Class B1 Shares;
b) two thousand five hundred eighty-four (2,584) Class B2 Shares;
c) two thousand five hundred eighty-four (2,584) Class B3 Shares;
d) two thousand five hundred eighty-four (2,584) Class B4 Shares;
e) two thousand five hundred eighty-four (2,584) Class B5 Shares;
f) two thousand five hundred eighty-four (2,584) Class B6 Shares;
g) two thousand five hundred eighty-four (2,584) Class B7 Shares;
h) two thousand five hundred eighty-four (2,584) Class B8 Shares;
i) two thousand five hundred eighty-four (2,584) Class B9 Shares; and
j) two thousand five hundred eighty-four (2,584) Class B10 Shares
for the price of twenty-six thousand two hundred seventy-eight euro sixty-four euro cents (EUR 26,278.64).
5) Robert Bell, professionally residing at 12 Castle Street, St Helier, Jersey, JE2 3RT, has subscribed twenty-six thousand

eight hundred sixty (26,860) New Shares subdivided as follows:

a) two thousand six hundred eighty-six (2,686) Class B1 Shares;
b) two thousand six hundred eighty-six (2,686) Class B2 Shares;
c) two thousand six hundred eighty-six (2,686) Class B3 Shares;
d) two thousand six hundred eighty-six (2,686) Class B4 Shares;
e) two thousand six hundred eighty-six (2,686) Class B5 Shares;
f) two thousand six hundred eighty-six (2,686) Class B6 Shares;
g) two thousand six hundred eighty-six (2,686) Class B7 Shares;

130454

L

U X E M B O U R G

h) two thousand six hundred eighty-six (2,686) Class B8 Shares;
i) two thousand six hundred eighty-six (2,686) Class B9 Shares; and
j) two thousand six hundred eighty-six (2,686) Class B10 Shares
for the price of twenty-seven thousand three hundred twenty-nine euro seventy-nine euro cents (EUR 27,329.79).
6) John Dundon, residing professionally at 52 the Leasowe, Lichfield, Staffordshire WS13 7HA, has subscribed sixteen

thousand five hundred thirty (16,530) New Shares subdivided as follows:

a) one thousand six hundred fifty-three (1,653) Class B1 Shares;
b) one thousand six hundred fifty-three (1,653) Class B2 Shares;
c) one thousand six hundred fifty-three (1,653) Class B3 Shares;
d) one thousand six hundred fifty-three (1,653) Class B4 Shares;
e) one thousand six hundred fifty-three (1,653) Class B5 Shares;
f) one thousand six hundred fifty-three (1,653) Class B6 Shares;
g) one thousand six hundred fifty-three (1,653) Class B7 Shares;
h) one thousand six hundred fifty-three (1,653) Class B8 Shares;
i) one thousand six hundred fifty-three (1,653) Class B9 Shares; and
j) one thousand six hundred fifty-three (1,653) Class B10 Shares
for the price of fifteen thousand six hundred seventy-one euro twenty-four euro cents (EUR 15,671.24).
7) Christopher Routledge, professionally residing at 15 Lakewood Road, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire SO53

1ER, has subscribed four thousand one hundred thirty (4,130) New Shares subdivided as follows:

a) four hundred thirteen (413) Class B1 Shares;
b) four hundred thirteen (413) Class B2 Shares;
c) four hundred thirteen (413) Class B3 Shares;
d) four hundred thirteen (413) Class B4 Shares;
e) four hundred thirteen (413) Class B5 Shares;
f) four hundred thirteen (413) Class B6 Shares;
g) four hundred thirteen (413) Class B7 Shares;
h) four hundred thirteen (413) Class B8 Shares;
i) four hundred thirteen (413) Class B9 Shares; and
j) four hundred thirteen (413) Class B10 Shares
for the price of three thousand nine hundred seventeen euro eighty-one euro cents (EUR 3,917.81).
8) John Murphy, residing professionally at 10 Maple Grove, Lichfield, Staffordshire WS14 9XB, has subscribed twelve

thousand four hundred (12,400) New Shares subdivided as follows:

a) one thousand two hundred forty (1,240) Class B1 Shares;
b) one thousand two hundred forty (1,240) Class B2 Shares;
c) one thousand two hundred forty (1,240) Class B3 Shares;
d) one thousand two hundred forty (1,240) Class B4 Shares;
e) one thousand two hundred forty (1,240) Class B5 Shares;
f) one thousand two hundred forty (1,240) Class B6 Shares;
g) one thousand two hundred forty (1,240) Class B7 Shares;
h) one thousand two hundred forty (1,240) Class B8 Shares;
i) one thousand two hundred forty (1,240) Class B9 Shares; and
j) one thousand two hundred forty (1,240) Class B10 Shares
for the price of eleven thousand seven hundred fifty-three euro and forty-three euro cents (EUR 11,753.43).
9) Kevin Matthews, residing professionally at 5 Denton Drive, Marston, Moretaine, Bedforshire MK43 0NA, has sub-

scribed twelve thousand four hundred (12,400) New Shares subdivided as follows:

a) one thousand two hundred forty (1,240) Class B1 Shares;
b) one thousand two hundred forty (1,240) Class B2 Shares;
c) one thousand two hundred forty (1,240) Class B3 Shares;
d) one thousand two hundred forty (1,240) Class B4 Shares;
e) one thousand two hundred forty (1,240) Class B5 Shares;
f) one thousand two hundred forty (1,240) Class B6 Shares;
g) one thousand two hundred forty (1,240) Class B7 Shares;
h) one thousand two hundred forty (1,240)Class B8 Shares;

130455

L

U X E M B O U R G

i) one thousand two hundred forty (1,240) Class B9 Shares; and
j) one thousand two hundred forty (1,240) Class B10 Shares
for the price of eleven thousand seven hundred fifty-three euro and forty-three euro cents (EUR 11,753.43).
10) Gregory Pritchett, professionally residing at 5 Denton Drive, Marston, Moretaine, Bedfordshire MK43 0NA, has

subscribed twelve thousand four hundred (12,400) New Shares subdivided as follows:

a) one thousand two hundred forty (1,240) Class B1 Shares;
b) one thousand two hundred forty (1,240) Class B2 Shares;
c) one thousand two hundred forty (1,240) Class B3 Shares;
d) one thousand two hundred forty (1,240) Class B4 Shares;
e) one thousand two hundred forty (1,240) Class B5 Shares;
f) one thousand two hundred forty (1,240) Class B6 Shares;
g) one thousand two hundred forty (1,240) Class B7 Shares;
h) one thousand two hundred forty (1,240)Class B8 Shares;
i) one thousand two hundred forty (1,240) Class B9 Shares; and
j) one thousand two hundred forty (1,240) Class B10 Shares
for the price of eleven thousand seven hundred fifty-three euro and forty-three euro cents (EUR 11,753.43).
11) Mark Cross, professionally residing at 2 Walshaw Brook Close, Walshaw, Bury, BL8 3TB, has subscribed six

thousand two hundred (6,200) New Shares subdivided as follows:

a) six hundred twenty (620) Class B1 Shares;
b) six hundred twenty (620) Class B2 Shares;
c) six hundred twenty (620) Class B3 Shares;
d) six hundred twenty (620) Class B4 Shares;
e) six hundred twenty (620) Class B5 Shares;
f) six hundred twenty (620) Class B6 Shares;
g) six hundred twenty (620) Class B7 Shares;
h) six hundred twenty (620) Class B8 Shares;
i) six hundred twenty (620) Class B9 Shares; and
j) six hundred twenty (620) Class B10 Shares
for the price of five thousand eight hundred seventy-six euro seventy-two euro cents (EUR 5,876.72).
12) Matt Hemming, professionally residing at 7 Eastdown Gardens, Weymouth, Dorset, DT3 6QP, has subscribed six

thousand two hundred (6,200) New Shares subdivided as follows:

a) six hundred twenty (620) Class B1 Shares;
b) six hundred twenty (620) Class B2 Shares;
c) six hundred twenty (620) Class B3 Shares;
d) six hundred twenty (620) Class B4 Shares;
e) six hundred twenty (620) Class B5 Shares;
f) six hundred twenty (620 Class B6 Shares;
g) six hundred twenty (620) Class B7 Shares;
h) six hundred twenty (620) Class B8 Shares;
i) six hundred twenty (620) Class B9 Shares; and
j) six hundred twenty (620) Class B10 Shares
for the price of five thousand eight hundred seventy-six euro seventy-two euro cents (EUR 5,876.72).
The aggregate number of two hundred thirty-four thousand five hundred sixty (234,560) New Shares so subscribed by

the parties under point 2 to 12 above have been fully paid up by a contribution in cash consisting of two hundred thirty-
three thousand seven hundred thirty-four euro ninety four euro cents (EUR 233,734.94). The amount of two hundred thirty-
three thousand seven hundred thirty-four euro ninety four euro cents (EUR 233,734.94) is as of now available to the
Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of three hundred thirty thousand six hundred thirty-one euro seventeen euro cents

(EUR 330,631.17) shall be contributed for a total amount of three hundred thirty euro sixty-five euro cents (EUR 330.65)
to the share capital of the Company and for a total amount of three hundred thirty thousand three hundred euro fifty-two
euro cents (EUR 330,300.52) to the share premium account of the Company.

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 5 paragraph 1 the articles of association of the Company,

which shall now be read as follows:

130456

L

U X E M B O U R G

5.1. The Company's share capital is set at one hundred three thousand nine hundred forty-two euro twenty-one euro

cents  (EUR  103,942.21)  represented  by  one  hundred  three  million  nine  hundred  forty-two  thousand  two  hundred  ten
(103,942,210) shares having nominal value of one tenth of a cent (EUR 0.001) split as follows:

(a) one hundred million (100,000,000) A shares (the “A Shares”);
(b) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B1 redeemable shares (the “Class B1

Shares”);

(c) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B2 redeemable shares (the “Class B2

Shares”);

(d) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B3 redeemable shares (the “Class B3

Shares”);

(e) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B4 redeemable shares (the “Class B4

Shares”);

(f) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B5 redeemable shares (the “Class B5

Shares”);

(g) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B6 redeemable shares (the “Class B6

Shares”);

(h) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B7 redeemable shares (the “Class B7

Shares”);

(i) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B8 redeemable shares (the “Class B8

Shares”);

(j) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B9 redeemable shares (the “Class B9

Shares”); and

(k) three hundred ninety-four thousand two hundred twenty-one (394,221) class B10 redeemable shares (the “Class B10

Shares”) (the Class B10 Shares together with Class B1 Shares, Class B2 Shares, Class B3 Shares, Class B4 Shares, Class
B5 Shares, Class B6 Shares, Class B7 Shares, Class B8 Shares, Class B9 Shares, are collectively called the “Classes”).”

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at one thousand eight hundred euro (EUR 1,800,-).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am sechsten August.
Vor uns, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,
wurde eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Firewall Management MIP, S.A. (die „Gesellschaft”)

abgehalten, einer Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, einge-
tragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 191.637, gegründet am 6. November 2014
gemäß einer Urkunde des Notars Maître Edouard Delosch, welche am 3. Dezember 2014 im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt geändert am 29. Januar 2015
gemäß einer Urkunde des Notars Maître Edouard Delosch, welche am 17. März 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nr. 726, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Alexander Olliges, geschäftsansässig in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft Diana Toth zur Schriftführerin und die Versammlung wählt Julia Szafranska, geschäftsansässig

in Luxemburg, zur Stimmzählerin.

Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Rates der Versammlung erklärt und ersucht der Vorsitzende den

unterzeichnenden Notar, Folgendes aufzunehmen:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien

erscheinen auf einer Anwesenheitsliste, die von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Akti-
onäre, vom Rat der Versammlung und von dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet und der vorliegenden Urkunde
beigefügt werden, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur paraphiert wurden, werden der

vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

130457

L

U X E M B O U R G

II. Aus der oben erwähnten Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle einhundertdrei Millionen sechshundertelftausend-

fünfhundertsechzig (103.611.560) Aktien, welche einhundert Prozent (100 %) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft
repräsentieren, ordnungsgemäß auf der Versammlung vertreten sind.

III.  Die  vertretenen  Aktionäre  haben  auf  jegliche  Ladungsformalitäten  verzichtet;  die  Versammlung  ist  somit  ord-

nungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Punkte der Tagesordnung beraten.

IV. Die Tagesordnung dieser Versammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einhundertdreitausendsechs-

hundertelf Euro und sechsundfünfzig Cent (EUR 103.611,56) um einen Betrag von dreihundertdreißig Euro und fünfund-
sechzig Cent (EUR 330,65), auf einhundertdreitausendneunhundertzweiundvierzig Euro und einundzwanzig Cent (EUR
103.942,21) durch Ausgabe von dreihundertdreißigtausendsechshundertfünfzig (330.650) Aktien, unterteilt in dreiundd-
reißigtausendfünfundsechzig (33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B1 („Klasse B1 Aktien“), dreiunddreißigtausend-
fünfundsechzig (33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B2 („Klasse B2 Aktien“), dreiunddreißigtausendfünfundsechzig
(33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B3 („Klasse B3 Aktien“), dreiunddreißigtausendfünfundsechzig (33.065) rück-
nehmbare  Aktien  der  Klasse  B4  („Klasse  B4  Aktien“),  dreiunddreißigtausendfünfundsechzig  (33.065)  rücknehmbare
Aktien  der  Klasse  B5  („Klasse  B5  Aktien“),  dreiunddreißigtausendfünfundsechzig  (33.065)  rücknehmbare  Aktien  der
Klasse  B6  („Klasse  B6  Aktien“),  dreiunddreißigtausendfünfundsechzig  (33.065)  rücknehmbare  Aktien  der  Klasse  B7
(„Klasse B7 Aktien“), dreiunddreißigtausendfünfundsechzig (33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B8 („Klasse B8
Aktien“), dreiunddreißigtausendfünfundsechzig (33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B9 („Klasse B9 Aktien“) und
dreiunddreißigtausendfünfundsechzig (33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B10 („Klasse B10 Aktien“) mit einem
Nominalwert von je einem Zehntel Cent (EUR 0,001).

2. Anschließende Änderung des Artikels 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lauten

soll:

“ 5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertdreitausendneunhundertzweiundvierzig Euro und einundzwanzig Cent

(EUR  103.942,21),  bestehend  aus  einhundertdrei  Millionen  neunhundertzweiundvierzigtausendzweihundertzehn
(103.942.210) Aktien mit einem Nominalwert von einem Zehntel Cent (EUR 0,001) und unterteilen sich wie folgt:

(a) einhundert Millionen (100.000.000) A Aktien (die “A Aktien”);
(b)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinun  dzwanzig  (394.221)  Klasse  B1  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B1 Aktien”);

(c)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinun  dzwanzig  (394.221)  Klasse  B2  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B2 Aktien”);

(d)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinun  dzwanzig  (394.221)  Klasse  B3  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B3 Aktien”);

(e)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinun  dzwanzig  (394.221)  Klasse  B4  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B4 Aktien”);

(f)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinund  zwanzig  (394.221)  Klasse  B5  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B5 Aktien”);

(g)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinun  dzwanzig  (394.221)  Klasse  B6  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B6 Aktien”);

(h)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinun  dzwanzig  (394.221)  Klasse  B7  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B7 Aktien”);

(i)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinund  zwanzig  (394.221)  Klasse  B8  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B8 Aktien”);

(j)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinund  zwanzig  (394.221)  Klasse  B9  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B9 Aktien”); und

(k)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinun  dzwanzig  (394.221)  Klasse  B10  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B10 Aktien”) (die Klasse B10 Aktien zusammen mit den Klasse B1 Aktien, Klasse B2 Aktien, Klasse B3 Aktien,
Klasse B4 Aktien, Klasse B5 Aktien, Klasse B6 Aktien, Klasse B7 Aktien, Klasse B8 Aktien und Klasse B9 Aktien, werden
kollektiv die „Klassen“ genannt).“

3. Verschiedenes.
Die Hauptversammlung der Aktionäre ersucht den unterzeichnenden Notar, die folgenden Beschlüsse aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen

Betrag von einhundertdreitausendsechshundertelf Euro und sechsundfünfzig Cent (EUR 103.611,56) um einen Betrag von
dreihundertdreißig Euro und fünfundsechzig Cent (EUR 330,65) auf einhundertdreitausendneunhundertzweiundvierzig
Euro  und  einundzwanzig  Cent  (EUR  103.942,21)  durch  Ausgabe  von  dreihundertdreißigtausendsechshundertfünfzig
(330.650) Aktien, unterteilt in dreiunddreißigtausendfünfundsechzig (33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B1 („Klas-

130458

L

U X E M B O U R G

se B1 Aktien“), dreiunddreißigtausendfünfundsechzig (33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B2 („Klasse B2 Aktien“),
dreiunddreißigtausendfünfundsechzig (33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B3 („Klasse B3 Aktien“), dreiunddrei-
ßigtausendfünfundsechzig (33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B4 („Klasse B4 Aktien“), dreiunddreißigtausend-
fünfundsechzig (33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B5 („Klasse B5 Aktien“), dreiunddreißigtausendfünfundsechzig
(33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B6 („Klasse B6 Aktien“), dreiunddreißigtausendfünfundsechzig (33.065) rück-
nehmbare  Aktien  der  Klasse  B7  („Klasse  B7  Aktien“),  dreiunddreißigtausendfünfundsechzig  (33.065)  rücknehmbare
Aktien  der  Klasse  B8  („Klasse  B8  Aktien“),  dreiunddreißigtausendfünfundsechzig  (33.065)  rücknehmbare  Aktien  der
Klasse B9 („Klasse B9 Aktien“) und dreiunddreißigtausendfünfundsechzig (33.065) rücknehmbare Aktien der Klasse B10
(„Klasse B10 Aktien“) mit einem Nominalwert von je einem Zehntel Cent (EUR 0,001) (die „Neuen Aktien“) zu erhöhen.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Die  dreihundertdreißigtausendsechshundertfünfzig  (330.650)  Neuen  Aktien  mit  einem  Nominalwert  von  je  einem

Zehntel Cent (EUR 0,001) wurden wie folgt gezeichnet:

1) Firewall Investments S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend unter dem Recht des

Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, ein-
getragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 191.622,

hat sechsundneunzigtausendneunzig (96.090) Neue Aktien gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:
a) neuntausendsechshundertneun (9.609) Klasse B1 Aktien;
b) neuntausendsechshundertneun (9.609) Klasse B2 Aktien;
c) neuntausendsechshundertneun (9.609) Klasse B3 Aktien;
d) neuntausendsechshundertneun (9.609) Klasse B4 Aktien;
e) neuntausendsechshundertneun (9.609) Klasse B5 Aktien;
f) neuntausendsechshundertneun (9.609) Klasse B6 Aktien;
g) neuntausendsechshundertneun (9.609) Klasse B7 Aktien;
h) neuntausendsechshundertneun (9.609) Klasse B8 Aktien;
i) neuntausendsechshundertneun (9.609) Klasse B9 Aktien; und
j) neuntausendsechshundertneun (9.609) Klasse B10 Aktien,
zu einem Bezugspreis von sechsundneunzigtausendachthundertsechsundneunzig Euro und dreiundzwanzig Cent (EUR

96.896,23).

Sämtliche Aktien wurden vollständig einbezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus einer von Forderung von Firewall

Investments S.A., vorbenannt, gegen die Gesellschaft in einer Höhe von sechsundneunzigtausendachthundertsechsund-
neunzig Euro und dreiundzwanzig Cent (EUR 96.896,23).

Der Wert dieser Einlage geht aus einem Bericht von Ernst &amp; Young Luxembourg S.A., einer Aktiengesellschaft (société

anonmye) gegründet und bestehend unter dem Recht Luxemburgs, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister  unter  der  Nummer  B  88019,  mit  Sitz  in  7,  rue  Gabriel  Lippmann,  L-5365  Munsbach,  Großherzogtum
Luxemburg, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé), hervor.

Die Schlussfolgerung dieses Berichts lautet wie folgt:
„Auf der Grundlage der durchgeführten und oben beschriebenen Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden,

die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens der Anzahl und dem Nominalwert
der 96.090 neuen Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 0,001 entspricht, welche mit einem gesamten verbundenen
Agio von EUR 96.800,14 ausgegeben werden, und demzufolge der Gesamtbetrag EUR 96.896,23 beträgt.“.

Der oben genannte Bericht, der von dem Notar und der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien paraphiert wurde,

verbleibt bei der Urkunde, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Ein Nachweis über die Existenz der oben erwähnten Forderung wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht.
2) Pentera Trustees Limited als Treuhänder von The Siveytal Trust, einem trust, errichtet in Jersey, mit eingetragener

Adresse in PO Box 79, 26 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 8PS, eingetragen im Jersey Financial Services Commission
Companies Registry unter der Nummer 91413, hat fünfundfünfzigtausendachthundert (55.800) Neue Aktien gezeichnet,
die sich wie folgt unterteilen:

a) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B1 Aktien;
b) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B2 Aktien;
c) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B3 Aktien;
d) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B4 Aktien;
e) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B5 Aktien;
f) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B6 Aktien;
g) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B7 Aktien;
h) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B8 Aktien;
i) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B9 Aktien; und

130459

L

U X E M B O U R G

j) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B10 Aktien,
zu einem Bezugspreis von sechsundfünfzigtausendsiebenhunderteinundsechzig Euro und siebenundachtzig Cent (EUR

56.761,87).

3) Peter Cohen, geschäftsansässig in 12 Castle Street, St Helier, Jersey, JE2 3RT, hat fünfundfünfzigtausendachthundert

(55.800) Neue Aktien gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

a) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B1 Aktien;
b) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B2 Aktien;
c) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B3 Aktien;
d) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B4 Aktien;
e) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B5 Aktien;
f) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B6 Aktien;
g) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B7 Aktien;
h) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B8 Aktien;
i) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B9 Aktien; und
j) fünftausendfünfhundertachtzig (5.580) Klasse B10 Aktien,
zu einem Bezugspreis von sechsundfünfzigtausendsiebenhunderteinundsechzig Euro und siebenundachtzig Cent (EUR

56.761,87).

4) Jonathan Ben-David, geschäftsansässig in 12 Castle Street, St Helier, Jersey, JE2 3RT, hat fünfundzwanzigtausen-

dachthundertvierzig (25.840) Neue Aktien gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

a) zweitausendfünfhundertvierundachtzig (2.584) Klasse B1 Aktien;
b) zweitausendfünfhundertvierundachtzig (2.584) Klasse B2 Aktien;
c) zweitausendfünfhundertvierundachtzig (2.584) Klasse B3 Aktien;
d) zweitausendfünfhundertvierundachtzig (2.584) Klasse B4 Aktien;
e) zweitausendfünfhundertvierundachtzig (2.584) Klasse B5 Aktien;
f) zweitausendfünfhundertvierundachtzig (2.584) Klasse B6 Aktien;
g) zweitausendfünfhundertvierundachtzig (2.584) Klasse B7 Aktien;
h) zweitausendfünfhundertvierundachtzig (2.584) Klasse B8 Aktien;
i) zweitausendfünfhundertvierundachtzig (2.584) Klasse B9 Aktien; und
j) zweitausendfünfhundertvierundachtzig (2.584) Klasse B10 Aktien,
zu einem Bezugspreis von sechsundzwanzigtausendzweihundertachtundsiebzig Euro und vierundsechzig Cent (EUR

26.278,64).

5) Robert Bell, geschäftsansässig in 12 Castle Street, St Helier, Jersey, JE2 3RT, hat sechsundzwanzigtausendachthun-

dertsechzig (26.860) Neue Aktien gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

a) zweitausendsechshundertsechsundachtzig (2.686) Klasse B1 Aktien;
b) zweitausendsechshundertsechsundachtzig (2.686) Klasse B2 Aktien;
c) zweitausendsechshundertsechsundachtzig (2.686) Klasse B3 Aktien;
d) zweitausendsechshundertsechsundachtzig (2.686) Klasse B4 Aktien;
e) zweitausendsechshundertsechsundachtzig (2.686) Klasse B5 Aktien;
f) zweitausendsechshundertsechsundachtzig (2.686) Klasse B6 Aktien;
g) zweitausendsechshundertsechsundachtzig (2.686) Klasse B7 Aktien;
h) zweitausendsechshundertsechsundachtzig (2.686) Klasse B8 Aktien;
i) zweitausendsechshundertsechsundachtzig (2.686) Klasse B9 Aktien; und
j) zweitausendsechshundertsechsundachtzig (2.686) Klasse B10 Aktien,
zu einem Bezugspreis von siebenundzwanzigtausenddreihundertneunundzwanzig Euro und neunundsiebzig Cent (EUR

27.329,79).

6) John Dundon, geschäftsansässig in 52 the Leasowe, Lichfield, Staffordshire WS13 7HA, hat sechzehntausendfünf-

hundertdreißig (16.530) Neue Aktien gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

a) eintausendsechshundertdreiundfünfzig (1.653) Klasse B1 Aktien;
b) eintausendsechshundertdreiundfünfzig (1.653) Klasse B2 Aktien;
c) eintausendsechshundertdreiundfünfzig (1.653) Klasse B3 Aktien;
d) eintausendsechshundertdreiundfünfzig (1.653) Klasse B4 Aktien;
e) eintausendsechshundertdreiundfünfzig (1.653) Klasse B5 Aktien;
f) eintausendsechshundertdreiundfünfzig (1.653) Klasse B6 Aktien;
g) eintausendsechshundertdreiundfünfzig (1.653) Klasse B7 Aktien;

130460

L

U X E M B O U R G

h) eintausendsechshundertdreiundfünfzig (1.653) Klasse B8 Aktien;
i) eintausendsechshundertdreiundfünfzig (1.653) Klasse B9 Aktien; und
j) eintausendsechshundertdreiundfünfzig (1.653) Klasse B10 Aktien,
zu  einem  Bezugspreis  von  fünfzehntausendsechshunderteinundsiebzig  Euro  und  vierundzwanzig  Cent  (EUR

15.671,24).

7) Christopher Routledge, geschäftsansässig in 15 Lakewood Road, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 1ER,

hat viertausendeinhundertdreißig (4.130) Neue Aktien gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

a) vierhundertdreizehn (413) Klasse B1 Aktien;
b) vierhundertdreizehn (413) Klasse B2 Aktien;
c) vierhundertdreizehn (413) Klasse B3 Aktien;
d) vierhundertdreizehn (413) Klasse B4 Aktien;
e) vierhundertdreizehn (413) Klasse B5 Aktien;
f) vierhundertdreizehn (413) Klasse B6 Aktien;
g) vierhundertdreizehn (413) Klasse B7 Aktien;
h) vierhundertdreizehn (413) Klasse B8 Aktien;
i) vierhundertdreizehn (413) Klasse B9 Aktien; und
j) vierhundertdreizehn (413) Klasse B10 Aktien,
zu einem Bezugspreis von dreitausendneunhundertsiebzehn Euro und einundachtzig Cent (EUR 3.917,81).
8) John Murphy, geschäftsansässig in 10 Maple Grove, Lichfield, Staffordshire WS14 9XB, hat zwölftausendvierhundert

(12.400) Neue Aktien gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

a) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B1 Aktien;
b) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B2 Aktien;
c) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B3 Aktien;
d) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B4 Aktien;
e) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B5 Aktien;
f) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B6 Aktien;
g) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B7 Aktien;
h) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B8 Aktien;
i) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B9 Aktien; und
j) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B10 Aktien,
zu einem Bezugspreis von elftausendsiebenhundertdreiundfünfzig Euro und dreiundvierzig Cent (EUR 11.753,43).
9) Kevin Matthews, geschäftsansässig in 5 Denton Drive, Marston, Moretaine, Bedfordshire MK43 0NA, hat zwölf-

tausendvierhundert (12.400) Neue Aktien gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

a) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B1 Aktien;
b) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B2 Aktien;
c) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B3 Aktien;
d) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B4 Aktien;
e) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B5 Aktien;
f) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B6 Aktien;
g) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B7 Aktien;
h) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B8 Aktien;
i) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B9 Aktien; und
j) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B10 Aktien,
zu einem Bezugspreis von elftausendsiebenhundertdreiundfünfzig Euro und dreiundvierzig Cent (EUR 11.753,43).
10) Gregory Pritchett, geschäftsansässig in 5 Denton Drive, Marston, Moretaine, Bedfordshire MK43 0NA, hat zwölf-

tausendvierhundert (12.400) Neue Aktien gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

a) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B1 Aktien;
b) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B2 Aktien;
c) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B3 Aktien;
d) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B4 Aktien;
e) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B5 Aktien;
f) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B6 Aktien;
g) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B7 Aktien;
h) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B8 Aktien;

130461

L

U X E M B O U R G

i) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B9 Aktien; und
j) eintausendzweihundertvierzig (1.240) Klasse B10 Aktien,
zu einem Bezugspreis von elftausendsiebenhundertdreiundfünfzig Euro und dreiundvierzig Cent (EUR 11.753,43).
11) Mark Cross, geschäftsansässig in 2 Walshaw Brook Close, Walshaw, Bury, BL8 3TB, hat sechstausendzweihundert

(6.200) Neue Aktien gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

a) sechshundertzwanzig (620) Klasse B1 Aktien;
b) sechshundertzwanzig (620) Klasse B2 Aktien;
c) sechshundertzwanzig (620) Klasse B3 Aktien;
d) sechshundertzwanzig (620) Klasse B4 Aktien;
e) sechshundertzwanzig (620) Klasse B5 Aktien;
f) sechshundertzwanzig (620) Klasse B6 Aktien;
g) sechshundertzwanzig (620) Klasse B7 Aktien;
h) sechshundertzwanzig (620) Klasse B8 Aktien;
i) sechshundertzwanzig (620) Klasse B9 Aktien; und
j) sechshundertzwanzig (620) Klasse B10 Aktien,
zu einem Bezugspreis von fünftausendachthundertsechsundsiebzig Euro und zweiundsiebzig Cent (EUR 5.876,72).
12) Matt Hemming, geschäftsansässig in 7 Eastdown Gardens, Weymouth, Dorset, DT3 6QP, hat sechstausendzwei-

hundert (6.200) Neue Aktien gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

k) sechshundertzwanzig (620) Klasse B1 Aktien;
l) sechshundertzwanzig (620) Klasse B2 Aktien;
m) sechshundertzwanzig (620) Klasse B3 Aktien;
n) sechshundertzwanzig (620) Klasse B4 Aktien;
o) sechshundertzwanzig (620) Klasse B5 Aktien;
p) sechshundertzwanzig (620) Klasse B6 Aktien;
q) sechshundertzwanzig (620) Klasse B7 Aktien;
r) sechshundertzwanzig (620) Klasse B8 Aktien;
s) sechshundertzwanzig (620) Klasse B9 Aktien; und
t) sechshundertzwanzig (620) Klasse B10 Aktien,
zu einem Bezugspreis von fünftausendachthundertsechsundsiebzig Euro und zweiundsiebzig Cent (EUR 5.876,72).
Die von den unter Punkt 2 bis 12 genannten Parteien gezeichneten zweihundertvierunddreißigtausendfünfhundertsech-

zig (234.560) Neuen Aktien wurden vollständig einbezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von zweihundertdreiunddrei-
ßigtausendsiebenhundertvierunddreißig Euro und vierundneunzig Cent (EUR 233.734,94). Der Betrag von zweihundertd-
reiunddreißigtausendsiebenhundertvierunddreißig Euro und vierundneunzig Cent (EUR 233.734,94) steht der Gesellschaft
von nun an zur Verfügung, worüber dem unterzeichnenden Notar ein Nachweis erbracht wurde.

Von der gesamten Einlage in Höhe von dreihundertdreißigtausendsechshunderteinunddreißig Euro und siebzehn Cent

(EUR 330.631,17) werden dreihundertdreißig Euro und fünfundsechzig Cent (EUR 330,65) dem Gesellschaftskapital und
dreihundertdreißigtausenddreihundert Euro und zweiundfünfzig Cent (EUR 330.300,52) dem Agio der Gesellschaft zu-
geführt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, Artikel 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, sodass

dieser nunmehr wie folgt lautet:

“ 5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertdreitausendneunhundertzweiundvierzig Euro und einundzwanzig Cent

(EUR  103.942,21),  bestehend  aus  einhundertdrei  Millionen  neunhundertzweiundvierzigtausendzweihundertzehn
(103.942.210) Aktien mit einem Nominalwert von einem Zehntel Cent (EUR 0,001) und unterteilen sich wie folgt:

(a) einhundert Millionen (100.000.000) A Aktien (die “A Aktien”);
(b)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinundzwanzig  (394.221)  Klasse  B1  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B1 Aktien”);

(c)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinundzwanzig  (394.221)  Klasse  B2  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B2 Aktien”);

(d)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinundzwanzig  (394.221)  Klasse  B3  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B3 Aktien”);

(e)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinundzwanzig  (394.221)  Klasse  B4  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B4 Aktien”);

(f)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinundzwanzig  (394.221)  Klasse  B5  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B5 Aktien”);

130462

L

U X E M B O U R G

(g)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinundzwanzig  (394.221)  Klasse  B6  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B6 Aktien”);

(h)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinundzwanzig  (394.221)  Klasse  B7  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B7 Aktien”);

(i)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinundzwanzig  (394.221)  Klasse  B8  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B8 Aktien”);

(j)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinundzwanzig  (394.221)  Klasse  B9  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B9 Aktien”); und

(k)  dreihundertvierundneunzigtausendzweihunderteinundzwanzig  (394.221)  Klasse  B10  rücknehmbare  Aktien  (die

“Klasse B10 Aktien”) (die Klasse B10 Aktien zusammen mit den Klasse B1 Aktien, Klasse B2 Aktien, Klasse B3 Aktien,
Klasse B4 Aktien, Klasse B5 Aktien, Klasse B6 Aktien, Klasse B7 Aktien, Klasse B8 Aktien und Klasse B9 Aktien, werden
kollektiv die „Klassen“ genannt).“

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wurde die Versammlung geschlossen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass

dieser Beschlüsse entstehen, werden auf ungefähr eintausend achthundert Euro (EUR 1.800) geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der beurkundende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der erschie-

nenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen besagter erschienener
Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung
maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vornamen

und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dem Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Signé: A. OLLIGES, D. TOTH, J. SZAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 10 août 2015. Relation: DAC/2015/13459. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 13 août 2015.

Référence de publication: 2015138886/635.
(150151154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2015.

VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A., Société Anonyme,

(anc. VPB-Finance S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 42.828.

L'an deux mille quinze, le trois août.
Par-devant Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître

Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera le dépositaire de la présente minute,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société VPB Finance S.A. (ci-après dénommée la

«société»), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28
janvier 1993, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 194 du 30 avril 1993, et dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 20 Mai 2015, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1825 du 22 juillet 2015.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Eduard von Kymmel, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Anke Weber-Düding demeurant professionnellement à Luxembourg,
et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Julia Weihsweiler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que le mandataire de l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le bureau de l'assemblée, le mandataire de l'actionnaire unique représenté et le notaire soussigné.
Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. La
procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants, restera également
annexée au présent acte.

130463

L

U X E M B O U R G

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social,

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, l'actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du Jour

1. Désignation de Monsieur Eduard von Kymmel comme président de l'assemblée;
2. Modification de la dénomination de la société et par conséquent de l'article 1 des statuts de sorte que la société se

dénomme désormais «VP Fund Solutions (Luxembourg) SA».

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En l'absence du président du conseil d'administration, l'assemblée décide de nommer Monsieur Eduard von Kymmel

comme président de l'assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société de sorte que la société se dénomme désormais «VP Fund

Solutions (Luxembourg) SA» en modifiant l'article 1 de ses statuts qui aura à présent la teneur suivante:

“  Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il existe une société sous la forme d'une société anonyme régie par les lois du Grand-

Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les “Statuts») sous la dénomination de «VP Fund Solutions (Luxembourg)
SA» (dénommée ci-après la «Société»).»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. VON KYMMEL, A. WEBER-DÜDING, J. WEIHSWEILER et D. KOLBACH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 7 août 2015. Relation: 1LAC/2015/25329. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015139875/56.
(150151867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2015.

Crystal Pumpkin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 154.926.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2015.

Référence de publication: 2015138773/10.
(150150973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2015.

Stiletto Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 189.681.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
Nico Patteet / K. Van Huynegem
<i>Administrateur–délégué / Administrateur–délégué

Référence de publication: 2015139810/13.
(150151477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

130464


Document Outline

Abensberg Acquisition S.à r.l.

Agacom

Benelux Partners Investholding S.A.

Brookstar A Note JV CO S.à r.l.

Brookstar Investments Lux S.à r.l.

Crystal Pumpkin S.A.

Firewall Management MIP S.A.

Garibaldi GP S.à r.l.

Global Restaurant Investments S.à r.l.

Happy Family I S.C.A.

Hassium Investment S.à r.l.

Imexal S. à r.l.

Immo-Contrat S.à r.l.

J. A. Restauration S.à r.l.

Jet Financial Services

JTC Luxembourg Holdings S.à r.l.

KG Far East (Luxembourg) Sàrl

Landericus Holding Limited S.à r.l.

Landericus Property Alpha S.à r.l.

Le Battant Dormant S.A.

Les Bains d'Aphrodite S.A.

Les Bains d'Aphrodite S.A.

Les Bains d'Aphrodite S.A.

Librairie Française

Loëndal

Losca International S.à r.l.

Lululemon LU Holdings S.à r.l.

Mainstream Shipping S.A.

Management Associates S.A.

Maxis Midco S.à r.l.

Medliner S.A.

Mira SA

OCM Luxembourg Serviced Apartments Holdings S.à r.l.

Papier Franzen S.à r.l.

Picard Bondco

Picard Bondco

Precious Metals &amp; Commodities Trading S.A.

Prime Credit 7 S.à r.l.

Prime Credit 9 S.à r.l.

Rigel International S.A.

Robor S.A.

Sandton Holdings III (Luxembourg) S.à r.l.

Semper Veritas Holding S.à r.l.

Socolem S.A.

Stiletto Investments S.A.

THS Kingsway Fund

Victoria Lux Invest S.à r.l.

VPB-Finance S.A.

VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.