This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2656
29 septembre 2015
SOMMAIRE
AB Acquisitions Luxco 5A S.à r.l. . . . . . . . . . .
127465
B8WB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127462
Berlys S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127478
Blackburn International Luxembourg . . . . . .
127478
bpfBOUW M&G SPIF Investment S.à r.l. . . .
127487
Ceres Finance (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .
127478
CO2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127482
Compagnie Financière Holding «La Petite Am-
boise» S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127482
Crescent European Specialty Lending (Leve-
red) A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127478
D & D Promotion SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127482
DePuy Synthes Leto Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127480
EAVF BEN Merkstein Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
127479
ECommerce Pay Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
127442
Elpa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127479
Emerald HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127483
Emirates NBD SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127479
ERE IV (N°5) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127481
Eric Coiffure Deluxe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
127481
Esmerald Partners I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127481
Eurasia Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127481
European Direct Property Fund . . . . . . . . . . .
127480
European Trailer Holding S.A. . . . . . . . . . . . .
127480
European Wines S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127485
EuroProp (EMC VI) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127480
Euro Secure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127483
FeneTech Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127485
Fide Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127484
Financière de la charcuterie JV . . . . . . . . . . . .
127485
Financière Privée Holding S.A. . . . . . . . . . . . .
127484
First Pacific Resources S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
127483
Fixmer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127483
FLIT - PTREL, SICAV-SIF S.C.A. . . . . . . . . .
127484
Frida Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127484
Frun Invest Real Estate S.C.A. SICAV-SIF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127485
Garigal Retail Europe No2 S.à r.l. . . . . . . . . . .
127486
Gazprom ECP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127486
Glenn Funds S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127466
Global Structured Finance . . . . . . . . . . . . . . . .
127486
International Campus Student Housing I . . . .
127477
Jamclouds Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127458
Lego One SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127468
Odyssée Marine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127487
Pamis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127487
PAN European Value Added Venture Feeder
S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127487
Phadia Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . .
127486
Pindify Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127458
Prologis Management II S.à. r.l. . . . . . . . . . . .
127486
Saint-James Investissement 2 S.à r.l. . . . . . . . .
127472
Searinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127471
SELP (Belgium) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127471
SELP (Poland and Czech Republic) S.à r.l. . .
127471
Siloe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127476
Sky Worldcom Travel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
127477
SRE One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127477
Star Supermarché Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127476
St. Jude Medical Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
127472
Swap Enhanced Asset Linked Securities
(SEALS) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127471
Synavic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127470
Taurus Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127476
T.M.I.P. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127471
T.M.I. S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127466
Towers Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
127473
Transat (Luxembourg) Holdings . . . . . . . . . . .
127473
Triple Star Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127488
Triple Star Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127488
Tulipfield Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127463
Turais S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127488
Twinley Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127488
WP Roaming III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127487
127441
L
U X E M B O U R G
ECommerce Pay Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 182.324.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of July,
before us, Maître Marc Loesch, civil notary, residing in Mondorf-les- Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Bambino 106. VV UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company incorporated and existing under the laws of
Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlot-
tenburg, Germany, under no. HRB 140396 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of twenty-five thousand (25,000) shares,
here represented by Mr. David Al Mari, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal in Berlin, Germany, on July 28, 2015;
2. eInnovations Holdings Pte. Ltd., a company incorporated and existing under the laws of Singapore with its statutory
seat in Singapore, registered with the Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), with registration
number 200710925M, having its registered office at 100 Beach Road #25-06, Shaw Towers, Singapore (189702) (herei-
nafter “eInnovations”),
becoming the holder of twenty-five thousand (25,000) shares,
here represented by Mr. David Al Mari, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal in Makati City, on July 22, 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The party under 1. (the “Existing Shareholder”) is the sole shareholder of ECommerce Pay Holding S.à r.l. (the “Com-
pany”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 182.324 and incorporated pursuant to a deed of Maître
Henri Hellinckx, civil law notary residing in Luxembourg, on 28 November 2013, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 213 dated 23 January 2014. The articles of association of the Company were amended
for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 27 February 2015, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1511 dated 16 June 2015.
The Existing Shareholder represents the entire share capital and has waived any notice requirement. The general meeting
of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby eInnovations partici-
pates and votes for the purpose of agenda point 3 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Acceptance of eInnovations Holdings Pte. Ltd., a company incorporated and existing under the laws of Singapore
with its statutory seat in Singapore, registered with the Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA),
with registration number 200710925M, having its registered office at 100 Beach Road #25-06, Shaw Towers, Singapore
(189702), as new shareholder of the Company (“eInnovations”), to the extent necessary;
2. Increase of the Company’s share capital by an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) so as to raise it
from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) to fifty thousand euro (EUR 50,000) by issuing twenty-
five thousand (25,000) new shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as
follows:
“The Company’s share capital is set at fifty thousand euro (EUR 50,000), represented by fifty thousand (50,000) shares
with a nominal value of one euro (EUR 1) each.”
4. Full restatement of the articles of association of the Company as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name ECommerce Pay
Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
127442
L
U X E M B O U R G
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may
be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifty-thousand Euros (EUR 50,000.00), represented by fifty-thousand (50,000)
common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption
127443
L
U X E M B O U R G
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Bambino 106. VV UG
(haftungsbeschränkt) ("Rocket") and the shareholder eInnovations Holdings Pte. Ltd. ("eInnovations", jointly with Rocket
the "Shareholders" and each also a "Shareholder") to a company affiliated to such Shareholder within the meaning of
sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Shareholder to a company (x) which
is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Shareholder or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Shareholder (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a
contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and
policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Sha-
reholder or one or more shareholders of such Shareholder has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation proce-
dures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company,
if the shareholders of the Company hold more than 50 % in any surviving legal entity after such transformation procedure.
7.5 In the cases provided for in art. 7.4.1 through 7.4.3 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of first
refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased
shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is
rejected for lack of assets;
8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such
enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration of
redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its share
register and to proceed with the relevant filings required by law.
8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one person;
independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way through
one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.
8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).
Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date
is the date before the redemption resolution.
9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding amounts
including interest.
9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert arbitrator
shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the Company. The
decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company and the
requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the redemption price and
127444
L
U X E M B O U R G
the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption
price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a person
named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or partial
assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
11.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also
be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a
shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of
managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
11.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must
state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must
be sent to each shareholder in writing without undue delay.
11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company and at such reasonable times as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
12.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or regis-
tered letter with confirmation of receipt) or electronically via email by the corporate secretary of the Company to each
shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of notice of at least twenty-five (25) business days. The
period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’ meeting is not counted in the
calculation of the period of notice.
12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another shareholder
authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.
12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders’
resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’ meeting (for
purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.
Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if both Shareholders are present or represented. Any resolutions
passed in a shareholders' meeting must be adopted unanimously by all Shareholders present or represented in the share-
holders' meeting.
127445
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of both Shareholders.
Art. 16. Matters requiring a shareholders’ resolution.
16.1 The approval by way of a shareholders’ resolution shall, in addition to any matters which require shareholders'
approval by operation of law, be required for the following matters:
16.1.1 distributions, by way of dividends or otherwise, by the Company to its shareholders or any of them;
16.1.2 any increase or decrease of the share capital of the Company;
16.1.3 the issuance of new shares and the subscription of such new shares in the Company by an existing shareholder
or a third party; and
16.1.4 the transfer of shares in the Company or in any affiliate of the Company.
17.3. Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold all
the issued shares of that class.
D. Board of managers
Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders. The board of managers shall, inter alia, be responsible
for the formation of the management teams of the Company as well as for the performance review of the personnel and for
exercising any shareholder rights in relation to any subsidiaries or participations of the Company.
Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by the chairman of the board of managers by fax or email to the other
members of the board of managers with a notice period of at least five (5) business days between the day of notice and the
day of the meeting. Meetings of the board of managers shall be held at least monthly.
20.2 No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 21. Management.
21.1 The board of managers shall elect among its members a chairman. It may also choose a company secretary, who
does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
127446
L
U X E M B O U R G
21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least one manager who has been nominated by the
Shareholder eInnovations and one manager who has been nominated by the Shareholder Rocket are present or represented
at a meeting of the board of managers.
21.6 Decisions shall be taken unanimously by all managers present or represented at such meeting. Each manager shall
have one vote. The chairman, if any, shall not have a casting vote.
21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
21.8 The prior consent of the board of managers shall be required for the following actions:
21.8.1 Any amendments to the business plan of the Company;
21.8.2 the establishment or incorporation of any company or entity by the Company;
21.8.3 the acquisition or sale of participations in any other company or partnership by the Company;
21.8.4 the cash funding plan as agreed by the Shareholders;
21.8.5 the budget of the Company and any amendments thereto;
21.8.6 any cash funding by a shareholder of the Company;
21.8.7 any cash funding by the Company to any subsidiary or participation of the Company;
21.8.8 the sale, transfer, pledge, charge or encumbrance of shares in, and any investment into, any subsidiary or parti-
cipation of the Company;
21.8.9 any capital increases or decreases concerning a subsidiary or participation;
21.8.10 an IPO of a subsidiary or participation;
21.8.11 the appointment or dismissal of directors of a subsidiary or participation.
21.9 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.10 The following business decisions of the board of managers require the subsequent approval of the Shareholders
by way of a unanimous shareholders' resolution:
21.10.1 Any loan agreement and similar financing agreement to be entered into by the Company or any of its affiliates
(as lender or borrower) with a value of more than EUR 10,000;
21.10.2 the granting of security interests in excess of an amount of EUR 10,000 by the Company or any of its affiliates.
Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by
the chairman pro tempore, and the corporate secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting
of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and
class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
127447
L
U X E M B O U R G
E. Audit
Art. 24. Auditor(s).
24.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
24.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
24.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
24.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
24.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.
26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
26.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
26.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
26.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
26.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
26.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
27.1 The board of managers may, by unanimous decision, decide to pay interim dividends on the basis of interim financial
statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to
be distributed shall be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial
year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to
be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
27.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Article 28 liquidation
Art. 28. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities
of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 29. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law and any shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the
Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles
conflicts with the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and
to the extent permitted by Luxembourg law.”
5. Subsequently, decision to grant power to any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mrs.
Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the share-
holders’ register of the Company.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned
notary to enact, the following resolutions:
127448
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Existing shareholder resolves to accept elnnovations, aforementioned, as new shareholder of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Existing Shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of twenty-five thousand euro
(EUR 25,000) so as to raise it from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) to fifty thousand euro
(EUR 50,000) by issuing twenty-five thousand (25,000) new shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The twenty-five thousand (25,000) new shares have been duly subscribed by eInnovations, aforementioned, for the price
of twenty-five thousand euro (EUR 25,000).
<i>Paymenti>
The twenty-five thousand (25,000) new shares subscribed by eInnovations, aforementioned, have been entirely paid up
through a contribution in cash in the amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000).
The proofs of the existence and of the value of the above contribution have been produced to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.00) consists of twenty-five thousand
euro (EUR 25,000) allocated to the share capital of the Company.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, so that
it shall henceforth read as stated in the agenda
<i>Fourth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend the articles of association of the Company, so that it shall
henceforth read as stated in the agenda.
<i>Fifth Resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby grants power to any manager of the Company, regardless of his category,
as well as Mrs. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely,
the shareholders’ register of the Company.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately one thousand seven hundred euros (EUR 1,700.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreißigsten Juli.
Vor uns, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Bambino 106.VV UG (haftungsbeschränkt), eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter deutschem Recht, mit
satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutsch-
land, unter der Nummer HRB 140396 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaberin von fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteilen,
hier vertreten durch Herrn David Al Mari, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht datiert vom 22. Juli 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
2. eInnovations Holdings Pte. Ltd., eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht Singapurs, mit sat-
zungsmäßigem Sitz in Singapur, eingetragen bei der Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA),
unter der Eintragungsnummer 200710925M, mit Sitz in 100 Beach Road #25-06, Shaw Towers, Singapur (189702) (im
Folgenden „eInnovations“),
zukünftige Inhaberin von fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteilen,
hier vertreten durch Herrn David Al Mari, oben genannt,
127449
L
U X E M B O U R G
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht datiert vom 22. Juli 2015, ausgestellt in Makati City.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar ne varietur paraphiert
wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Partei unter 1 (die „Bestehende Gesellschafterin“) ist die alleinige Gesellschafterin der ECommerce Pay Holding
S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 182.324,
gegründet am 28. November 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, welche
am 23. Januar 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 213 veröffentlicht wurde. Die Satzung
der Gesellschaft wurde zuletzt am 27. Februar 2015 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars geändert, welche
am 16. Juni 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1511 veröffentlicht wurde.
Die Bestehende Gesellschafterin vertritt das gesamte Gesellschaftskapital und hat auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
Tagesordnung verhandeln, wobei eInnovations ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und
stimmberechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Aufnahme der eInnovations Holdings Pte. Ltd., einer Gesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht Singa-
purs, mit satzungsmäßigem Sitz in Singapur, eingetragen bei der Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority
(ACRA), unter der Eintragungsnummer 200710925M, mit Sitz in 100 Beach Road #25-06, Shaw Towers, Singapur
(189702), als neue Gesellschafterin der Gesellschaft („eInnovations“), soweit erforderlich;
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro
(EUR 25.000) um einen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) auf einen Betrag von fünfzigtausend Euro
(EUR 50.000) durch die Ausgabe von fünfundzwanzigtausend (25.000) neuen Anteilen mit einem Nominalwert von je
einem Euro (EUR 1);
3. Dementsprechende Änderung des Artikels 5.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000), bestehend aus fünfzigtausend
(50.000) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).“
4. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
ECommerce Pay Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche das geistige Eigentum oder im Zusammenhang mit Grundeigentum vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser
Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
127450
L
U X E M B O U R G
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000), bestehend aus fünfzigtausend
(50.000) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-
gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des
betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten oder -pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung von
Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter
Bambino 106. VV UG (haftungsbeschränkt) („Rocket“) und den Gesellschafter eInnovations Holdings Pte. Ltd. („eIn-
novations“, gemeinschaftlich mit Rocket die „Gesellschafter“ und jeweils einzeln ein „Gesellschafter“) an eine mit einem
solchen Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen
Gesellschafter an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Gesellschafter oder (ii) einen oder mehrere
direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Gesellschafters (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrol-
liert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“
oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch
(a) die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das
Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt
oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmbe-
127451
L
U X E M B O U R G
rechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Gesellschafter oder einer
oder mehrere Gesellschafter dieses Gesellschafters eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Umwand-
lungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmel-
zung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als
fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.
7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.3 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte oder -pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten
gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters
für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an
Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen
Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile innerhalb der Grenzen des Gesetzes von 1915 zurückkaufen. Die Stimm-
rechte der von der Gesellschaft gehaltenen Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten
werden.
8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
8.2.2 ein Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes dar und die Gesellschaft bestätigt
hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung dieser Über-
tragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 9. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile ent-
spricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet wird und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
127452
L
U X E M B O U R G
10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich ge-
fasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt
sein Stimmrecht schriftlich aus.
11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß dem vorstehenden Satz eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschrif-
ten von Abschnitt XII des Gesetzes und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafterver-
sammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 12. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder und zu der Zeit statt, welche in der entsprech-
enden Einladung genauer bestimmt werden.
12.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) oder E-Mail vom Generalsekretär (corporate secretary) der Gesellschaft an jeden Gesell-
schafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung, wobei eine Ankündigungsfrist
von mindestens fünfundzwanzig (25) Werktagen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand.
Der Tag der Gesellschafterversammlung wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mit
einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn beide Gesellschafter anwesend oder vertreten
sind. Beschlüsse, die in einer Gesellschafterversammlung gefasst werden, sind von allen an der Gesellschafterversammlung
anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern einstimmig zu fassen.
Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 15. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung beider Gesellschafter.
127453
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Angelegenheiten, die einen Gesellschafterbeschluss erfordern.
16.1 Eine Genehmigung durch einen Gesellschafterbeschluss ist, außer bei Angelegenheiten, die kraft Gesetzes eine
Zustimmung der Gesellschafter erfordern, für die folgenden Angelegenheiten erforderlich:
16.1.1 Ausschüttungen, durch Dividenden oder anderweitig, durch die Gesellschaft an ihre Gesellschafter oder an einen
Gesellschafter;
16.1.2 eine Erhöhung oder Herabsetzung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft;
16.1.3 die Ausgabe neuer Anteile und die Zeichnung dieser neuen Anteile an der Gesellschaft durch einen bestehenden
Gesellschafter oder einen Dritten; und
16.1.4 die Übertragung der Anteile an der Gesellschaft oder an einem verbundenen Unternehmen der Gesellschaft.
16.2 Ist das Gesellschaftskapital der Gesellschaft in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der
Gesellschafter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer
Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse. Der
Rat der Geschäftsführer ist, unter anderem, für die Zusammenstellung von Geschäftsführungsteams der Gesellschaft sowie
für die Überprüfung der Leistungen des Personals und für die Ausübung von Gesellschafterrechten im Zusammenhang mit
Tochtergesellschaften oder Beteiligungen der Gesellschaft zuständig.
Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge, sofern
vorgesehen, und ihre Amtszeit festlegt.
18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterver-
sammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige
Ernennung entscheidet.
19.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer
mittels Fax oder E-Mail an die anderen Mitglieder des Rates der Geschäftsführer, wobei eine Ankündigungsfrist von
mindestens fünf (5) Werktagen zwischen dem Tag der Ankündigung und dem Tag der Sitzung einzuhalten ist. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden mindestens einmal im Monat statt.
20.2 Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem
vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermit-
telt wurde.
20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Rat der Geschäftsführer
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der für die
Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
127454
L
U X E M B O U R G
21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer (derselben Kategorie, sofern vorhanden) schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein
anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender
Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen oder mehrere (derselben Kategorie, sofern vorhanden), aber nicht alle
anderen Geschäftsführer vertreten.
21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest ein vom Gesell-
schafter eInnovations und ein vom Gesellschafter Rocket ernannter Geschäftsführer, in einer Sitzung des Rates der
Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
21.6 Beschlüsse werden einstimmig durch alle in einer Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.
Jeder Geschäftsführer hat eine Stimme.Der Vorsitzende, sofern vorhanden, hat keine entscheidende Stimme.
21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, oder per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
21.8 Die vorherige Zustimmung des Rates der Geschäftsführer ist für die folgenden Handlungen erforderlich:
21.8.1 Änderungen des Geschäftsplans der Gesellschaft;
21.8.2 die Errichtung oder Gründung einer Gesellschaft oder eines Unternehmens durch die Gesellschaft;
21.8.3 der Erwerb oder der Verkauf von Beteiligungen an einer anderen Gesellschaft oder Handelsgesellschaft (part-
nership) durch die Gesellschaft;
21.8.4 der zwischen den Gesellschaftern vereinbarte Finanzierungsplan (cash funding plan);
21.8.5 das Budget der Gesellschaft und alle diesbezüglichen Änderungen;
21.8.6 Finanzierungen (cash funding) durch die Gesellschafter der Gesellschaft;
21.8.7 Finanzierungen (cash funding) durch die Gesellschaft an eine Tochtergesellschaft oder eine Beteiligung der
Gesellschaft;
21.8.8 der Verkauf, die Übertragung, die Verpfändung oder die Belastung von Anteilen an, und Investitionen in, Toch-
tergesellschaften oder Beteiligungen der Gesellschaft;
21.8.9 Erhöhung oder Herabsetzung des Kapitals einer Tochtergesellschaft oder einer Beteiligung;
21.8.10 ein Börsengang einer Tochtergesellschaft oder einer Beteiligung;
21.8.11 die Ernennung oder Abberufung von Direktoren einer Tochtergesellschaft oder einer Beteiligung.
21.9 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
erlassen.
21.10 Die folgenden Geschäftsentscheidungen des Rates der Geschäftsführer erfordern die anschließende Zustimmung
der Gesellschafter durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss:
21.10.1 Kreditverträge und ähnliche Finanzverträge im Wert von über EUR 10.000, die von der Gesellschaft oder einer
ihrer Tochtergesellschaften (als Kreditgeber oder Kreditnehmer) eingegangen werden;
21.10.2 die Gewährung von Sicherungsrechten durch die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften, die einen
Betrag von EUR 10.000 übersteigen.
Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Generalsekretär (corporate
secretary) (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterver-
sammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und
Geschäftsführer der Kategorie B), werden diese Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in
einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der
Geschäftsführer, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschaf-
terversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie
A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
127455
L
U X E M B O U R G
22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht
Art. 24. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
24.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
24.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
24.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
24.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
24.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden
Art. 25. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 26. Jahresabschluss und Gewinne.
26.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
26.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
26.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
26.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
26.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
26.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 27. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
27.1 Der Rat der Geschäftsführer durch einstimmigen Beschluss beschließen, Abschlagsdividenden auf Grundlage von
Zwischenabschlüssen zu zahlen, welche vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende
Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls verteilt und darf
nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch
vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Sum-
men, die nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung einer Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.
27.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
127456
L
U X E M B O U R G
G. Liquidation
Art. 28. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die
Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Soweit nichts anderes bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der
Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 29. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915 und die Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen, die mitunter zwischen den Gesellschaftern
und der Gesellschaft eingegangen werden können und durch welche bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt
werden könnten. Sofern eine Bestimmung dieser Satzung mit einer Bestimmung einer Gesellschaftervereinbarung in Wi-
derspruch steht, so hat diese Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien und soweit nach luxemburgischem Recht
zulässig Vorrang.“
5. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie Frau
Magdalena Staniczek zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht den unterzeichnende Notar, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Bestehende Gesellschafterin beschließt, eInnovations, vorbenannt, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft zu
akzeptieren.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Bestehende Gesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) um einen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) auf
einen Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) durch die Ausgabe von fünfundzwanzigtausend (25.000) neuen An-
teilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die fünfundzwanzigtausend (25.000) neuen Anteile wurden ordnungsgemäß von eInnovations, vorbenannt, zum Preis
von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von eInnovations, vorbenannt, gezeichneten fünfundzwanzigtausend (25.000) neuen Anteile wurden vollständig
eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000).
Die Nachweise über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurden dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Die gesamte Einlage in Höhe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,00) besteht aus fünfundzwanzigtausend
Euro (EUR 25.000), die dem Gesellschaftskapital zugeführt werden.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie
in der Tagesordnung dargestellt lautet.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Satzung der Gesellschaft zu ändern, sodass diese nunmehr wie in der
Tagesordnung dargestellt lautet.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Frau Magdalena Staniczek, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit
uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr eintausendsiebenhundert Euro (EUR 1.700.-) geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
127457
L
U X E M B O U R G
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen des Bevollmächtigten der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer
deutschen Übersetzung; auf Verlangen besagtem Bevollmächtigten der erschienener Partei und im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen
und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dem Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Signé: D. Al Mari, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 3 août 2015. GAC/2015/6682. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 5 août 2015.
Référence de publication: 2015134667/891.
(150145464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
Pindify Sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. Jamclouds Sàrl).
Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 172.939.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of July.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of JAMCLOUDS Sàrl, a limited liability company,
having its registered office in L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons Malades (R.C.S. Luxembourg B 172.939), incor-
porated by deed of Me Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 19
November 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial"), n° 3 of 2 January
2013 and n°664 of March 19, 2013 (the “Company”).
There appeared:
1) Mr. Thomas Wallin, born on 4
th
of April 1949 in Gustav Adolf, Sweden, domiciled at Salwatorska 35/8 30-117
Krakow, Poland, in his capacity as holder of 4,900 shares (409 Class A shares; 409 Class B shares; 409 Class C shares;
409 Class D shares; 409 Class E shares; 409 Class F shares; 409 Class G shares; 409 Class H shares; 409 Class I shares
and 409 Class J shares or 40.9% of the capital of the Company, holder of passport n° SWE 80539935, (“Shareholder I”),
2) Mr. Christoffer Wallin, born on 4
th
of November 1979 in Stenkyrka, Sweden, domiciled at 1266, E Driggs avenue,
Salt Lake City, UT 84106, USA, in his capacity as holder of 3,600 shares (360 Class A shares; 360 Class B shares; 360
Class C shares; 360 Class D shares; 360 Class E shares; 360 Class F shares; 360 Class G shares; 360 Class H shares; 360
Class I shares and 360 Class J shares or 36 % of the capital of the Company, holder of passport n° SWE 85754997,
(“Shareholder II”)
3) Mr. Alexander Wallin, born on 27
th
of May 1987 in Stenkyrka, Sweden, domiciled at 935 Chalcedony, San Diego,
CA 92109, USA, in his capacity as holder of 1,280 shares (128 Class A shares; 128 Class B shares; 128 Class C shares;
128 Class D shares; 128 Class E shares; 128 Class F shares; 128 Class G shares; 128 Class H shares, 128 Class I shares
and 32 Class J shares or 12.8% of the capital of the Company, holder of passport n° SWE 84757661, (“Shareholder III”)
4) Mrs. Michaela Wallin, born on 23
rd
of April 1985 in Stenkyrka, Sweden, domiciled at 150 Myrtle Avenue Brooklyn,
apt. 908, New York, NY 11201, USA, in her capacity as holder of 320 shares (32 Class A shares; 32 Class B shares; 32
Class C shares; 32 Class D shares; 32 Class E shares; 32 Class F shares; 32 Class G shares; 32 Class H shares; 32 Class I
shares and 32 Class J shares or 3.2% of the capital of the Company, holder of passport n° SWE 89331512; (“Shareholder
IV”)
5) Hans Mathias Matsson, born on 26 September 1982 in Avesta, Sweden, domiciled at Olshammarsgatan 42, 12475
Bandhagen, Sweden, in his capacity as holder of 100 shares (10 Class A shares; 10 Class B shares; 10 Class C shares; 10
Class D shares; 10 Class E shares; 10 Class F shares; 10 Class G shares; 10 Class H shares; 10 Class I shares and 10 Class
J shares or 1 % of the capital of the Company, holder of passport n° SWE84018361 (“Shareholder V”)
6) Martin Martensson, born on 6 March 1991 in Vilhelmina, Sweden, domiciled at Asgatan 5B, 91231 Vilhelmina,
Sweden, in his capacity as holder of 100 shares (10 Class A shares; 10 Class B shares; 10 Class C shares; 10 Class D shares;
10 Class E shares; 10 Class F shares; 10 Class G shares; 10 Class H shares; 10 Class I shares and 10 Class J shares or 1 %
of the capital of the Company, holder of driving license n° 910306-0555 (“Shareholder VI”)
7) The company Walker Corp, with its registered office at La grande Route de Faldouet, Cour de la Reine, St. Martin,
JE3 6UE Jersey, registered with the “ Companies Registry” with the n°: 29610, represented by Mr. Maxwell Leo Walker,
holder of passport n° GBR 622276737, in its capacity as holder of 310 shares (31 Class A shares; 31 Class B shares; 31
127458
L
U X E M B O U R G
Class C shares; 31 Class D shares; 31 Class E shares; 31 Class F shares; 31 Class G shares; 31 Class H shares; 31 Class I
shares and 31 Class J shares or 3.1 % of the capital of the Company, (“Shareholder VII”)
8) Claes Wallin, born on 19 July 1954 in Gustav Adolf, Sweden, domiciled at Surbrunnsgatan 10, 41119 Göteborg,
Sweden, in his capacity as holder of 100 shares (10 Class A shares; 10 Class B shares; 10 Class C shares; 10 Class D shares;
10 Class E shares; 10 Class F shares; 10 Class G shares; 10 Class H shares; 10 Class I shares and 10 Class J shares or 1 %
of the capital of the Company, holder of passport n° SWE 81643550, (“Shareholder VIII”)
9) The company Peter Ahlstrand Agenturer AB, with its registered office at Ormestavägen 1, 700 06 Örebro, Sweden,
registered with the Swedish Companies Registration Office under the n°: 556228-4645, represented by Mr. Peter Ahlstrand,
holder of passport n° SWE 86733071, in its capacity as holder of 100 shares (10 Class A shares; 10 Class B shares; 10
Class C shares; 10 Class D shares; 10 Class E shares; 10 Class F shares; 10 Class G shares; 10 Class H shares; 10 Class I
shares and 10 Class J shares or 1 % of the capital of the Company (“Shareholder IX”),
All here represented by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,
by virtue of nine proxies given under private seal.
Which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed to be registered together therewith.
The agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decision to modify the denomination of the Company from Jamclouds Sàrl into PINDIFY Sàrl and therefore to modify
article 2 of the Articles of Association as follows:
Name. The Company’s name is “PINDIFY Sàrl”.
2. Decision to restructure the issued share capital of the Company by the creation of a share premium account as well
as a capital contribution account (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres"), next to the Share
capital and to modify article 6 of the Articles of Association accordingly.
In addition to the share capital, a share premium account as well as a capital contribution account (compte 115 "Apport
en capitaux propres non rémunéré par des titres") may be set up for each Class of Shares. The amount of such share premium
account and/or capital contribution account may be used to provide for the payment of any Shares, which the Company
may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate
funds to the legal reserve.
3. Decision to modify the signature power of the managers of the Company and therefore to modify article 12 par. 2 of
the Articles of Association as follows:
The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the sole
signature of one manager of the category “A” or by the joint signature of one manager of the category “A” and one manager
of the category “B”.
4. Decision to modify article 9 of the Articles of Association as follows:
The shares are freely transferable among shareholders of the Company.
Transfers of shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the sole shareholder, or in case of plurality
of shareholders, to the approval of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital.
Shares must be transferred by written instrument in accordance with the Law.
5. Any other business.
Then the Meeting, after deliberation, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves modify the denomination of the Company from Jamclouds Sàrl into PINDIFY Sàrl and therefore
to modify article 2 of the Articles of Association as follows:
“ 2. Name. The Company’s name is “PINDIFY Sàrl”.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to restructure the issued share capital of the Company by the creation of a share premium account
as well as a capital contribution account (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres"), next to
the Share capital and to add a new paragraph into article 6 infine of the Articles of Association accordingly as follows:
“In addition to the share capital, a share premium account as well as a capital contribution account (compte 115 "Apport
en capitaux propres non rémunéré par des titres") may be set up for each Class of Shares. The amount of such share premium
account and/or capital contribution account may be used to provide for the payment of any Shares, which the Company
may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate
funds to the legal reserve.”
127459
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to modify the signature power of the managers of the Company and therefore to modify the second
paragraph of article 12 of the Articles of Association as follows:
“The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the sole
signature of one manager of the category “A” or by the joint signature of one manager of the category “A” and one manager
of the category “B”.”
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves modify article 9 of the Articles of Association as follows:
“ 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders of the Company.
Transfers of shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the sole shareholder, or in case of plurality
of shareholders, to the approval of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital provided in a general meeting.
Shares must be transferred by written instrument in accordance with the Law.”
There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English
followed by a French translation; on request of the appearing person and in case of divergences between the English and
the French version, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, the said proxyholder signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre juillet.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire ("l'Assemblée") des associés de la société à responsabilité limitée, JAMCLOUDS
Sàrl, ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons Malades (R.C.S. Luxembourg B 172.939), constituée
suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 novembre 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), le 3 janvier 2013, numéro 3 et le 19 mars
2013 numéro 664 (la «Société»).
Ont comparu:
1) Mr. Thomas Wallin, né le 4 avril 1949 à Gustav Adolf, Suède, demeurant à Salwatorska 35/8 30-117 Krakow, Poland,
en qualité de détenteur de 4.900 parts sociales (409 Classe A parts sociales; 409 Classe B parts sociales; 409 Classe C parts
sociales; 409 Classe D parts sociales; 409 Classe E parts sociales; 409 Classe F parts sociales; 409 Classe G parts sociales;
409 Classe H parts sociales; 409 Classe I parts sociales et 409 Classe J parts sociales ou 40,9% du capital social de la
Société, détenteur du passeport n° SWE 80539935, («Associé I»),
2) Mr. Christoffer Wallin, né le 4 novembre 1979 à Stenkyrka, Suède, demeurant à 1266, E Driggs avenue, Salt Lake
City, UT 84106, Etats-Unis de l’Amérique, en qualité de détenteur de 3.600 parts sociales (360 Classe A parts sociales;
360 Classe B parts sociales; 360 Classe C parts sociales; 360 Classe D parts sociales; 360 Classe E parts sociales; 360
Classe F parts sociales; 360 Classe G parts sociales; 360 Classe H parts sociales; 360 Classe I parts sociales et 360 Classe
J parts sociales ou 36 % du capital social de la Société, détenteur du passeport n° SWE 85754997, («Associé II)»,
3) Mr. Alexander Wallin, né le 27 mai 1987 à Stenkyrka, Suède, demeurant à 935 Chalcedony, San Diego, CA 92109,
Etats-Unis de l’Amérique, en qualité de détenteur de 1.280 parts sociales (128 Classe A parts sociales; 128 Classe B parts
sociales; 128 Classe C parts sociales; 128 Classe D parts sociales; 128 Classe E parts sociales; 128 Classe F parts sociales;
128 Classe G parts sociales; 128 Classe H parts sociales, 128 Classe I parts sociales et 32 Classe J parts sociales ou 12,8%
du capital social de la Société, détenteur du passeport n° SWE 84757661, («Associé III)»,
4) Mrs. Michaela Wallin, née le 23 avril 1985 à Stenkyrka, Suède demeurant à 150 Myrtle Avenue Brooklyn, apt. 908,
New York, NY 11201, Etats-Unis de l’Amérique, en qualité de détenteur de 320 parts sociales (32 Classe A parts sociales;
32 Classe B parts sociales; 32 Classe C parts sociales; 32 Classe D parts sociales; 32 Classe E parts sociales; 32 Classe F
parts sociales; 32 Classe G parts sociales; 32 Classe H parts sociales; 32 Classe I parts sociales et 32 Classe J parts sociales
ou 3.2% du capital social de la Société, détentrice du passeport n° SWE 89331512, («Associée IV)»,
5) Hans Mathias Matsson, né le 26 september 1982 à Avesta, Suède, demeurant à Olshammarsgatan 42, 12475 Band-
hagen, Suède, en qualité de détenteur de 100 parts sociales (10 Classe A parts sociales; 10 Classe B parts sociales; 10 Classe
C parts sociales; 10 Classe D parts sociales; 10 Classe E parts sociales; 10 Classe F parts sociales; 10 Classe G parts sociales;
10 Classe H parts sociales; 10 Classe I parts sociales et 10 Classe J parts sociales ou 1 % du capital social de la Société,
détenteur du passeport n° SWE84018361 («Associé V)»,
127460
L
U X E M B O U R G
6) Martin Martensson, né le 6 mars 1991 à Vilhelmina, Suède, demeurant à Asgatan 5B, 91231 Vilhelmina, Suède, en
qualité de détenteur de 100 parts sociales (10 Classe A parts sociales; 10 Classe B parts sociales; 10 Classe C parts sociales;
10 Classe D parts sociales; 10 Classe E parts sociales; 10 Classe F parts sociales; 10 Classe G parts sociales; 10 Classe H
parts sociales; 10 Classe I parts sociales et 10 Classe J parts sociales ou 1 % du capital social de la Société, détenteur d’un
permis de conduire n° 910306-0555 («Associé VI)»,
7) la société Walker Corp, ayant son siège social à La grande Route de Faldouet, Cour de la Reine, St. Martin, JE3 6UE
Jersey, inscrite auprès du “Companies Registry” sous le n°: 29610, représentée par M. Maxwell Leo Walker, détenteur du
passeport n° GBR 622276737, en qualité de détentrice de 310 parts sociales (31 Classe A parts sociales; 31 Classe B parts
sociales; 31 Classe C parts sociales; 31 Classe D parts sociales; 31 Classe E parts sociales; 31 Classe F parts sociales; 31
Classe G parts sociales; 31 Classe H parts sociales; 31 Classe I parts sociales et 31 Classe J parts sociales ou 3,1 % du
capital social de la Société («Associé VII)»,
8) Claes Wallin, né le 19 juillet 1954 à Gustav Adolf, Suède, demeurant à Surbrunnsgatan 10, 41119 Göteborg, Suède,
en qualité de détenteur de 100 parts sociales (10 Classe A parts sociales; 10 Classe B parts sociales; 10 Classe C parts
sociales; 10 Classe D parts sociales; 10 Classe E parts sociales; 10 Classe F parts sociales; 10 Classe G parts sociales; 10
Classe H parts sociales; 10 Classe I parts sociales et 10 Classe J parts sociales ou 1 % du capital social de la Société,
détenteur du passeport n° SWE 81643550, («Associé VIII)».
9) La société Peter Ahlstrand Agenturer AB, ayant son siège social à Ormestavägen 1, 700 06 Örebro, Suède, inscrite
auprès du “Swedish Companies Registration Office” sous le n°: 556228-4645, représentée par M. Peter Ahlstrand, détenteur
du passeport n° SWE 86733071, en qualité de détentrice de 100 parts sociales (10 Classe A parts sociales; 10 Classe B
parts sociales; 10 Classe C parts sociales; 10 Classe D parts sociales; 10 Classe E parts sociales; 10 Classe F parts sociales;
10 Classe G parts sociales; 10 Classe H parts sociales; 10 Classe I parts sociales et 10 Classe J parts sociales ou 1 % du
capital social de la Société
Tous ici représentés par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,
En vertu de neuf procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le
notaire désigné, annexées au présent acte pour être soumises avec lui à l'enregistrement.
Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de modifier la dénomination de la Société de Jamclouds Sàrl en PINDIFY Sàrl et dès lors de modifier l’article
2 des statuts comme suit:
Dénomination. La dénomination de la Société est “PINDIFY Sàrl”.
2. Décision de restructurer le capital social émis par la Société par la création d’un compte de prime d'émission ainsi
qu'un compte d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres (compte 115), en plus du capital social et dès lors
de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
En plus du capital social, un compte de prime d'émission ainsi qu'un compte d'apport en capitaux propres non rémunéré
par des titres (compte 115) peut être établi pour chaque Classe de Parts Sociale. L'avoir de ce compte de prime d'émission
et/ou du compte d'apport en capitaux propres peut être utilisé pour payer les Parts Sociales que la Société pourrait racheter
des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté
à la réserve légale.
3. Décision de modifier le pouvoir de signature des gérants de la Société et dès lors modifier l’article 12 par. 2 des statuts
comme suit:
La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature unique d’un
gérant du type «A» ou par la signature jointe de l'un des gérants du type «A» et de l'un des gérants du type «B».
4. Décision de modifier l’article 9 des statuts comme suit:
Les parts sont librement cessibles entre associés de la Société.
Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable de l’associé unique ou en cas de pluralité
d’associés, soumises à l’agrément de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du
capital social de la Société donnée en assemblée générale.
Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la Loi.
5. Divers.
L'Assemblée, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société de Jamclouds Sàrl en PINDIFY Sàrl et dès lors de modifier
l’article 2 des statuts comme suit:
« 2. Dénomination. La dénomination de la Société est “PINDIFY Sàrl”.
127461
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de restructurer le capital social émis par la Société par la création d’un compte de prime d'émission
ainsi qu'un compte d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres (compte 115), en plus du capital social et dès
lors d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 6 infine des statuts comme suit:
«En plus du capital social, un compte de prime d'émission ainsi qu'un compte d'apport en capitaux propres non rémunéré
par des titres (compte 115) peut être établi pour chaque Classe de Parts Sociale. L'avoir de ce compte de prime d'émission
et/ou du compte d'apport en capitaux propres peut être utilisé pour payer les Parts Sociales que la Société pourrait racheter
des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté
à la réserve légale.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le pouvoir de signature des gérants de la Société et dès lors modifier le deuxième alinéa
de l’article 12 des statuts comme suit:
«La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature unique d’un
gérant du type «A» ou par la signature jointe de l'un des gérants du type «A» et de l'un des gérants du type «B».»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier de modifier l’article 9 des statuts comme suit:
« 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés de la Société.
Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable de l’associé unique ou en cas de pluralité
d’associés, soumises à l’agrément de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du
capital social de la Société donnée en assemblée générale.
Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la Loi.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent
procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergences entre la version anglaise
et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le
notaire le présent acte.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 3 août 2015. Relation: 1LAC/2015/24507. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 7 août 2015.
Référence de publication: 2015136617/243.
(150147842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.
B8WB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6360 Grundhof, 4-6, route de Beaufort.
R.C.S. Luxembourg B 128.364.
L'an deux mille quinze, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1) Monsieur Bertrand DUPONT, gérant, né à Arras (France) le 2 janvier 1969, demeurant à L-6370 Haller, 2, rue des
Romains;
Représenté par Monsieur Yves RICHER, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Haller le
23 juillet 2015, dont une copie,après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire, restera
annexée aux présentes pour être enregistrée avec lui,
2) Monsieur Yves RICHER, gérant, né à Commercy (France) le 25 novembre 1966, demeurant à L-6370 Haller, 2, rue
des Romains,
seuls associés de la société à responsabilité limitée "WB S.à r.l." (matricule 2007 24 36 874), avec siège social à L-6370
Haller, 2, rue des Romains,
constituée, alors sous la forme d'un société anonyme, suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire alors de
résidence à Remich, en date du 16 mars 2007, publié au Mémorial C, numéro 1463 du 16 juillet 2007,
127462
L
U X E M B O U R G
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro d'immatriculation B 128.364,
lesquels comparants, représentant l'intégralité du capital social de la susdite société, se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire et ont pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à Haller vers la commune de Berdorf
et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la société, qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Beaufort. Il pourra être transféré en toute autre lieu
du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés."
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée décide de fixer l'adresse de la société à L-6360 Grundhof, 4-6, route de Beaufort.
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée générale accepte la démission comme gérant unique de Monsieur Bertrand DUPONT, avec effet immédiat.
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Yves RICHER au poste de gérant unique, avec pouvoir de signature
unique en toutes circonstances.
<i>Cinquième résolution:i>
L'assemblée générale décide d'ajouter un cinquième alinéa à l'article 4 des statuts de la société, qui aura désormais la
teneur suivante:
« Art. 4. Cinquième alinéa. La société a également pour objet exploitation d'un hôtel, bar, restaurant avec débit de
boissons alcooliques et non-alcooliques et tout type d'hébergement ainsi que le commerce alimentaire.».
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais des présentes sont à charge de la société et évalués à 800,00 €.
<i>Déclarationi>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les
bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction
visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1
du Code Pénal (financement du terrorisme).
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Yves RICHER, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 29 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12711. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 11 août 2015.
Référence de publication: 2015137129/60.
(150148990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Tulipfield Investments, Société Civile.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg E 5.173.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the third day of August.
The undersigned:
127463
L
U X E M B O U R G
1) Mr. Jan Bogdan PILCH, Director of companies, born in Wisla (Poland) on 23/06/1965, residing at Skrzetuskiego 23,
30-441 Krakow (Poland), holder of 7.200 shares,
2) Mrs. Renata Bogumila PILCH, Director of companies, born in Pabianice (Poland) on 23/08/1968, residing at Skrze-
tuskiego 23, 30-441 Krakow (Poland), holder of 2.400 shares,
3) Mr. Wieslaw Piotr OLES, Lawyer, born in Rybnik (Poland) on 29/10/1965, residing at Retoryka 18, 31-108, Krakow
(Poland), holder of 2.720 shares,
4) Mr. Tomasz BARAN, Director of companies, born in Krakow (Poland) on 02/04/1966, residing at Komandosow 3
m.7, 30-334 Krakow (Poland), holder of 2.720 shares,
5) Mr. Mateusz Maria RODZYNKIEWICZ, Lawyer, born in Krakow (Poland) on 03/05/1964, residing professionally
at 95 m 11, Starowislna, 31-052 Krakow (Poland), holder of 960 shares
(Hereinfter referred collectively to "The Partners")
Have met in Extraordinary General Meeting by oral agreement and without notice in order to vote on the dissolution of
the company TULIPFIELD INVESTMENTS, Société civile.
The Partners hereby declare the following:
- that they are the sole partners of TULIPFIELD INVESTMENTS, Société civile, (the "Company"), a company incor-
porated by deed under private seal on September, 25
th
, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 2928 of November 20
th
, 2013 and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg,
Section E, under the number E 5173
- that the capital of the Company is fixed at SIXTEEN THOUSAND EUROS (16.000 EUR.-) represented by SIXTEEN
THOUSAND (16.000.-) shares with a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each, all fully paid-up;
- that they are the owners of all the shares and declare that they have full knowledge of the articles of incorporation and
the financial standing of the Company;
- that they, in their capacity as sole partners of the Company, have unanimously resolved to proceed to the voluntary
and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that, in their capacity as liquidators and according to the balance sheet of the Company as at August 3, 2015, they
declare that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;
The Partners furthermore declare that:
- the Company's activities have ceased;
- the Partners are thus vested with all the assets of the Company and undertake to settle all and any liabilities of the
terminated Company, the balance sheet of the Company as at August 3, 2015, being only one information for all purposes;
- the Partners hereby declare that Kancelaria Radcow Pranwych Oles & Rodzynkiewicz sp.k., a Polish company with
registered office at ul. Zablocie 25/40, 30-701 Krakow, Poland, and registered in the national court register under KRS
number 0000195063, is appointed as their representative and is entitled to, in the name and on behalf of the Partners,
perform any actual and legal actions connected with the settlement of the liquidation proceed of the Company, in particular:
(1) to receive the whole liquidation proceed of the Company on the bank account of Kancelaria Radcow Pranwych Oles
& Rodzynkiewicz sp.k. and to receive any asset connected with the settlement of the liquidation proceed of the Company
and (2) settle and distribute the received liquidation proceed to the Partners of the Company;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's managers are hereby granted full discharge with respect to their duties;
- there shall be proceeded to the cancellation of all the shares;
- the books and documents of the company shall be lodged during a period of five years at L-1118 Luxembourg, 23, rue
Aldringen.
The Partners state that the present deed is worded in English followed by a French version. In case of divergences
between the English and the French text, the French version will be prevailing.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le trois août.
LES SOUSSIGNÉS:
1) M. Jan Bogdan PILCH, Administrateur de sociétés, né à Wisla (Pologne) le 23/06/1965, demeurant à Skrzetuskiego
23, 30-441 Cracovie (Pologne), détenteur de 7.200 parts sociales,,
2) Mme Renata Bogumila PILCH, Administrateur de sociétés, née à Pabianice (Pologne) le 23/08/1968, demeurant à
Skrzetuskiego 23, 30-441 Cracovie (Pologne), détentrice de 2.400 parts sociales,
3) M. Wieslaw Piotr OLES, Avocat, né à Rybnik (Pologne) le 29/10/1965, demeurant à Retoryka 18, 31-108, Cracovie
(Pologne), détenteur de 2.720 sociales,
4) M. Tomasz BARAN, Administrateur de sociétés, né à Cracovie (Pologne) le 02/04/1966, demeurant à Komandosow
3 m.7, 30-334 Cracovie (Pologne), détenteur de 2.720 parts sociales,
127464
L
U X E M B O U R G
5) M. Mateusz Maria RODZYNKIEWICZ, Avocat, né à Cracovie (Pologne) le 03/05/1964, demeurant professionnel-
lement à 95 m 11, Starowislna, 31-052 Cracovie (Pologne), détenteur de 960 parts sociales,
(ci-après dénommés collectivement «Les Associés»
se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation verbale et sans préavis afin de voter la dissolution
de la société TULIPFIELD INVESTMENTS, Société Civile,
Les associés déclarent ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls associés de la société civile TULIPFIELD INVESTMENTS, (la «Société»), constituée par acte
sous seing privé, en date du 25 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2928
du 20 novembre 2013 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro E 5173.
- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à SEIZE MILLE EUROS (16.000,- EUR) représenté par SEIZE
MILLE (16.000) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR chacune, entièrement libérées;
- Qu'ils sont les seuls propriétaires de toutes les parts sociales et déclarent qu'ils ont une parfaite connaissance des statuts
et des états financiers de la Société;
- Qu'ils ont, en leur qualité d'associés de la Société, décidé unanimement de procéder à la dissolution anticipée et
immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- qu'en leur qualité de liquidateurs de la Société et au vu du bilan de la Société au 3 août 2015, ils déclarent que tout le
passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
Les Associés déclarent encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- les associés sont investis de l'entièreté de l'actif de la Société et déclarent prendre à leur charge l'entièreté du passif de
la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 3 août 2015 étant seulement un des éléments
d'information à cette fin;
- Les Associés déclarent par les présentes que la société polonaise Kancelaria Radcow Pranwych Oles & Rodzynkiewicz
sp.k., ayant son siège social à ul. Zablocie 25/40, 30-701 Cracovie, Pologne et immatriculée au registre national sous le
numéro KRS 0000195063, est nommée en tant que mandataire des Associés et est habilitée, au nom et pour le compte des
Associés, à accomplir toutes actions de fait ou de droit liées au règlement du produit de liquidation de la Société, notamment
(1) recevoir l'entièreté du produit de liquidation sur le compte bancaire de Kancelaria Radcow Pranwych Oles&Rodzyn-
kiewicz sp.k. et recevoir tout actif lié au règlement du produit de liquidation de la Société et 2) régler et distribuer au
Associés de la Société le boni de liquidation reçu.
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège social
de la Société au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
Les associés déclarent que le présent acte est documenté en langue anglaise suivi d'une version française. En cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.
Ne Varietur, Luxembourg, le 3 août 2015.
Jan Bogdan PILCH / Renata Bogumila PILCH / Wieslaw Piotr OLES /
Tomasz BARAN / Mateusz Maria RODZYNKIEWICZ.
Référence de publication: 2015135300/103.
(150146596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
AB Acquisitions Luxco 5A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.152.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 15 juin 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015137030/13.
(150149180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
127465
L
U X E M B O U R G
T.M.I. S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 112.757.
<i>Extrait des résolutions du Conseil de Gérance prises en date du 31 mars 2015i>
Le siège social de la société est transféré de son adresse actuelle 1A, rue de Trèves, L-2632 Luxembourg au 62, Avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Certifié sincère et conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015137804/15.
(150149561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Glenn Funds S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.080.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of July.
Before Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
Mr. Frédéric Olivier BAUDET, born in Arles (France), on October 30, 1965, residing at Ch. du Sorbier 10, CH-1295
Mies (Switzerland) (the “Sole Shareholder”),
here represented Mr. Max MAYER, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a power of
attorney given under private seal, which power of attorney after having been signed “ne varietur” by the attorney and the
undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities, who declared and
requested the notary to state that:
1.- The Company "Glenn Funds S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, with registered office at L-2453 Luxembourg,
6, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg trade registry, section B, under number 181080, (hereinafter
referred to as the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Me Cosita DELVAUX, residing then in Redange-
sur-Attert (Grand-Duchy of Luxembourg), dated October 17, 2013, published in the Mémorial C number 2997 of November
27, 2013.
2.- The corporate capital of the Company is fixed at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) represented by one
hundred thousand thousand (100,000) shares of a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
3.- The Sole Shareholder is the sole owner of all the shares of the Company.
4.- The Sole Shareholder acting as sole shareholder at an extraordinary shareholders' meeting amending the articles of
the Company declares the dissolution of the Company with immediate effect and the commencement of the liquidation
process.
5.- The Sole Shareholder appoints himself as liquidator of the Company; and in his capacity as liquidator of the Company
has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
6.- The Sole Shareholder decides to immediately convene the second and third general meeting of shareholders in
accordance with article 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies and to immediately hold these
meetings one after the other.
7.- The Sole Shareholder presents his liquidation report and accounts and declares that he takes over all the assets of the
Company, and that he will assume any presently known or unknown debts of the Company.
The liquidation report, after having been signed “ne varietur” by the attorney and the undersigned notary, shall stay
affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.
8.- The Sole Shareholder further declares in his capacity as sole shareholder of the Company having thorough knowledge
of the Company's articles of incorporation and of the financial situation of the Company, to waive his right to appoint an
auditor to the liquidation.
9. The Sole Shareholder decides to immediately approve the liquidation report and accounts.
127466
L
U X E M B O U R G
10.- The Sole Shareholder in the third extraordinary general meeting of shareholders, declares that the liquidation of the
Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be
cancelled. He confirms that the Company has definitely ceased to exist.
11.- Discharge is given to the managers.
12.- The books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at the
former registered office of the Company at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
<i>Costsi>
The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and
charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at EUR 1,100.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil
status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-sept juillet.
Pardevant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
M. Frédéric Olivier BAUDET, né à Arles (France), le 30 octobre 1965, demeurant à Ch. du Sorbier 10, CH-1295 Mies
(Suisse), («l'Associé Unique»)
ici représentée par M. Max MAYER, demeurant à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration
lui délivrée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement, qui a exposé
au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter que:
1.- La Société "Glenn Funds S.à r.l.", une société à responsabilité limitée avec siège à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène
Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 181080, (ci-après
nommée la “Société”), a été constituée suivant acte du notaire Me Cosita DELVAUX, résidant alors à Redange-sur-Attert
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 17 octobre 2013, publié au Mémorial C numéro 2997 du 27 novembre 2013.
2.- Le capital social de la Société est fixé à cent mille Euros (EUR 100.000,-) représenté par cent mille (100.000) parts
sociales d'une valeur nominale d'un Euros (EUR 1.-) chacune.
3.- L'Associé Unique est seul propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
4.- L'Associé Unique agissant comme associé unique siégeant en assemblée générale extraordinaire des associés mo-
dificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et la mise en
liquidation.
5.- L'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et
délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en
exécution les dispositions du présent acte.
6.- L'Associé Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l'article 151 de
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.
7.- L'Associé Unique présente le rapport de liquidation et les comptes de liquidation et déclare qu'il reprend tout l'actif
de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif impayé présent et futur de la Société.
Le rapport sur la liquidation, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé
au présent acte avec lequel il sera enregistré.
8.- L'Associé Unique en sa qualité d'associé unique de la Société ayant pleine connaissance des statuts de la Société et
de la situation financière de la Société, renonce à son droit de nommer un commissaire à la liquidation.
9.- L'Associé Unique décide par conséquent d'approuver immédiatement le rapport et les comptes de liquidation.
10.- L'Associé Unique, constituée en troisième assemblée générale extraordinaire, déclare que la liquidation de la Société
est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission des parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.
Il constate que la Société a définitivement cessé d'exister.
11.- Décharge est donnée aux gérants de la Société.
12.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien siège
social de la Société à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
127467
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison de cet acte, est dès lors évalué à 1.100,- EUR.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 juillet 2015. Relation GAC/2015/6530. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015137333/110.
(150148964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Lego One SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 55, Allée de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg E 5.711.
STATUTS
L'an deux mil quinze, le vingt-cinq juin.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Alain LESBACHES, né le 12 mars 1954 à Bordeaux (France), demeurant à L-8086 Bertrange, 34, Am
Wenkel;
2) Madame Karine LESBACHES GOLINVAL, née le 10 mars 1970 à Thionville (France), demeurant à L-8086 Ber-
trange, 34, Am Wenkel;
lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des
statuts d’une société civile immobilière qu'elles déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'acquisition, la vente, la location,
la mise en valeur et la gestion d'immeubles pour compte propre, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation, pour autant qu'elles
ne portent pas atteinte au caractère civil de la société.
Elle pourra faire en outre toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à faciliter son extension ou le développement.
Art. 2. La société prend la dénomination de «LEGO ONE SCI»
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Roeser. Il pourra être transféré en tout autre en droit du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.
Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cent Euros (2.500,- EUR) représenté par cent (100) parts d'intérêts
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Art. 6. La cession des parts s'opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l'article 1690 du Code Civil.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des associés ou des non-associés que suivant une décision unanime de tous
les associés.
En cas de transfert pour cause de mort, les héritiers ou légataires de l'associé décédé doivent être agréés à l'unanimité
des associés survivants. Cet agrément n'est cependant pas requis en cas de transfert aux héritiers légaux.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre
de parts qu'il possède.
127468
L
U X E M B O U R G
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire et
unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une
action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que
contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survivants
et les héritiers légaux de l'associé ou des associés décédés.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera
entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un
seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui
fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par
décision des associés.
Le ou les gérants ne pourront être révoqués que suivant une décision unanime de tous les associés.
Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes
circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet ainsi que les actes de disposition.
Art. 12. Chacun des associés à un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils jugent convenable, mais
ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un
cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux
associés au moins cinq jours à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-
sentés.
Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.
En cas de division de la propriété des parts d'intérêts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appartient à
l'usufruitier.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quel qu'en soit la nature et l'importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises que suivant une décision unanime de tous les associés.
Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-
gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnel-
lement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.
Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Elles ont été souscrites comme suit:
127469
L
U X E M B O U R G
1) Monsieur Alain LESBACHES, né le 12 mars 1954 à Bordeaux (France),
demeurant à L-8086 Bertrange, 34, Am Wenkel; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 Parts
2) Madame Karine LESBACHES GOLINVAL, née le 10 mars 1970 à Thionville (France),
demeurant à L-8086 Bertrange, 34, Am Wenkel; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 Parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts
Les parts d'intérêts ont été intégralement libérées en espèces de telle sorte que la somme de deux mille cinq cent euros
(2.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui
le constate expressément.
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que
définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (1.000.-euros). A l’égard du
notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paiement des dits frais,
ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l’intégralité du
capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après
avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à deux.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Alain LESBACHES, né le 12 mars 1954 à Bordeaux (France), demeurant à L-8086 Bertrange, 34, Am
Wenkel;
2) Madame Karine LESBACHES GOLINVAL, née le 10 mars 1970 à Thionville (France), demeurant à L-8086 Ber-
trange, 34, Am Wenkel;
La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature conjointe des
deux gérants.
3. L’adresse de la société est fixée à L-1899 Kockelscheuer, 55, allée de la Poudrerie
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elles ont signé le présent acte avec le notaire.
Signés: A. LESBACHES, K. LESBACHES GOLINVAL, K. REUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 01 juillet 2015. Relation: 2LAC/2015/14546. Reçu soixante-quinze euros
75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME
Luxembourg, le 11 août 2015.
Référence de publication: 2015137513/130.
(150149607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Synavic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 104.382.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
127470
L
U X E M B O U R G
<i>Pour SYNAVIC S.A.i>
Référence de publication: 2015137803/10.
(150148907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
T.M.I.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 138.517.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015137805/10.
(150148869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Swap Enhanced Asset Linked Securities (SEALS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 48.706.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2015.
Angelo Saracino
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015137802/13.
(150148820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
SELP (Poland and Czech Republic) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.100,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 177.377.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2015.
Référence de publication: 2015137778/10.
(150149435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Searinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 84.190.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015137773/10.
(150148676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
SELP (Belgium) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 178.124.
Le siège social de l'associé unique SELP (Germany and Benelux) S.à r.l., a changé et est désormais au 35-37, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
127471
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2015.
Référence de publication: 2015137775/12.
(150149006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
St. Jude Medical Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 174.258.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015137760/10.
(150148740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Saint-James Investissement 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 171.722.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt juillet.
Par devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
“Saint-James Investissement 1”, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 15,
rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 171.496 en tant qu'associé unique («l'Associé Unique”),
ici représentée par Madame Francine MAY, juriste, demeurant professionnellement à Ettelbruck, en vertu d'une pro-
curation donnée sous seing privé en date du 10 juillet 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
La partie comparante est propriétaire de toutes les parts sociales de la société «Saint-James Investissement 2 S.à r.l.»,
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward
Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.722, (ci-après nommée
la “Société”).
Le capital social émis de la Société est actuellement de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) représenté par douze
mille cinq cent (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement libérée.
Réunissant en ses mains la totalité des parts sociales de la Société, l'Associée Unique a décidé de dissoudre et de liquider
la Société, celle-ci ayant cessé toute activité et d'agir en tant que liquidateur de la Société.
L'Associé Unique décide d'approuver les comptes de liquidation de la Société au jour du présent acte;
L'Associée Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
L'Associé Unique déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les actifs sont devenus la propriété de l'Associé
Unique et que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
pour toutes dettes éventuelles (y compris et non exclusivement d'éventuelles dettes fiscales) actuellement inconnues de la
Société et non payées à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer, de sorte que la Société est
dissoute et la liquidation de la Société considérée comme clôturée.
L'Associée Unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat respectif
jusqu'à ce jour.
Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à compter de la date du présent acte à l'adresse
suivante: 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Les associés déclarent que les fonds de la société ne proviennent pas, respectivement que l'associée ne se livre(ra) pas
à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substance médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme
tels que définis à l'article 135-1 du code Pénal (financement du terrorisme).
127472
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à sept cent cinquante (750,-
EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: Francine MAY, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 22 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12255. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 10 août 2015.
Référence de publication: 2015137742/57.
(150148593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Towers Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 125.809.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2015.
Référence de publication: 2015137812/11.
(150148675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Transat (Luxembourg) Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 133.493.
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth of July.
Before Maître Martine DECKER, notary, residing in Hesperange,
There appeared:
"TRANSAT A.T. INC.", a Canadian public corporation duly incorporated and validly existing under the laws of Canada,
having its registered office at 300, rue Léo-Pariseau, Suite 600, Montréal, Québec, H2X 4C2, Canada, (the "Sole Share-
holder"),
represented by Mrs Véronique Wauthier, lawyer, professionally domiciled at 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxem-
bourg, by virtue of proxy given in Montréal on July 8
th
, 2015.
The said proxy after being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain annexed to
the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as aforesaid, has requested the officiating notary to record that it is the Sole Shareholder
of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established in Luxembourg under the name of
“Transat (Luxembourg) Holdings”, with registered office at 9 avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on November
7
th
, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2875 of December 11
th
, 2007, the
Articles of which have been amended by deeds of Maître Paul DECKER, then notary residing in Luxembourg:
- of October 29
th
, 2009, published in the Mémorial C number 2360 of December 3
rd
, 2009,
- of November 16, 2010, published in the Mémorial C number 123 of January 21
st
, 2011,
- of May 3
rd
, 2011, published in the Mémorial C number 1568 of July 14
th
, 2011,
- of October 24
th
, 2011, published in the Mémorial C number 3032 of December 9, 2011,
- of October 15
th
, 2012, published in the Mémorial C number 2875 of November 27
th
, 2012, and for the last time
- of July 8
th
, 2013, published in the Mémorial C number 2308 of September 19
th
, 2013,
127473
L
U X E M B O U R G
registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg) under section B number 133.493 (the "Company").
The Sole Shareholder, represented as aforesaid, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1) To decrease the corporate capital by an amount of EUR 4,500,000.- (four million five hundred thousand euro) so as
to decrease it from its present amount of EUR 6,175,650.- (six million one hundred and seventy-five thousand six hundred
and fifty euro) to an amount of EUR 1,675,650,-(one million six hundred and seventy-five thousand six hundred and fifty
euros) by reimbursement to the Sole Shareholder of the same amount and subsequent cancellation of 90,000 (ninety thou-
sand) shares.
2) Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation which shall have the following
wording:
“ Art. 6. Capital. The corporate capital is fixed at EUR 1,675,650.- (one million six hundred and seventy-five thousand
six hundred and fifty euro) divided into 33,513 (thirty-three thousand five hundred and thirteen) shares having a nominal
value of EUR 50.- (fifty euro) each, fully paid up.”
3) Miscellaneous.
The Sole Shareholder, represented as aforesaid, has requested the officiating notary to enact the following resolutions
taken:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to decrease the corporate capital by an amount of EUR 4,500,000.- (four million five
hundred thousand euro) so as to raise it from its present amount of EUR 6,175,650.- (six million one hundred and seventy-
five thousand six hundred and fifty euro) to an amount of EUR 1,675,650,- (one million six hundred and seventy-five
thousand six hundred and fifty euro) by reimbursement to the Sole Shareholder of the same amount and subsequent can-
cellation of 90,000 (ninety thousand) shares having a nominal value of EUR 50.- (fifty euro) each.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolution, the Sole Shareholder resolved to amend paragraph 1 of article 6 of the articles of
incorporation, which will from now on read as follows:
" Art. 6. Capital. The corporate capital is fixed at EUR 1,675,650.- (one million six hundred and seventy-five thousand
six hundred and fifty euro) divided into 33,513 (thirty-three thousand five hundred and thirteen) shares having a nominal
value of EUR 50.- (fifty euro) each, fully paid up.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital decrease
are estimated at EUR 1,340.-.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by her surname, first
name, civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mil quinze, le seize juillet,
Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,
A comparu:
«TRANSAT A.T. INC.», une compagnie publique de droit canadien dûment constituée et existant valablement sous le
droit canadien, ayant son siège social au 300, rue Léo-Pariseau, Suite 600, Montréal, Québec, H2X 4C2, Canada, (l'«As-
sociée Unique»),
ici représentée par Maître Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 10, rue Pierre
d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Montréal, le 8 juillet 2015
Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
La comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter qu'elle est l'Associée Unique de
la société à responsabilité limitée établie au Luxembourg sous le nom de «Transat (Luxembourg) Holdings» avec siège
social à L-1651 Luxembourg, 9, Avenue Guillaume, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître
127474
L
U X E M B O U R G
Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 7 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2875 du 11 décembre 2007, dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Paul
DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg:
- en date du 29 octobre 2009, publié au Mémorial C numéro 2360 du 3 décembre 2009,
- en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 123 du 21 janvier 2011,
- en date du 3 mai 2011, publié au Mémorial C numéro 1568 du 14 juillet 2011,
- en date du 24 octobre 2011, publié au Mémorial C numéro 3032 du 9 décembre 2011,
- en date du 15 octobre 2012, publié au Mémorial C numéro 2875 du 27 novembre 2012, et pour la dernière fois
- en date du 8 juillet 2013, publié au Mémorial C numéro 2308 du 19 septembre 2013,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B numéro 133.493 (la «Société»).
L'Associée Unique, représentée comme ci-avant, reconnaît être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur
base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Réduction du capital social à concurrence d'un montant de EUR 4.500.000,- (quatre millions cinq cent mille euros)
pour le porter de son montant actuel de EUR 6.175.650,- (six millions cent soixante-quinze mille six cent cinquante euros)
à un montant de EUR 1.675.650,- (un million six cent soixante-quinze mille six cent cinquante euros) par remboursement
à l'Associée Unique et annulation de 90.000 (quatre-vingt-dix mille) parts sociales.
2) Modification correspondante du paragraphe 1 de l'article 6 des statuts aux fins de lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à un million six cent soixante-quinze mille six cent cinquante euros (EUR
1.675.650,-), divisé en trente-trois mille cinq cent treize (33.513) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante
euros (EUR 50,-) chacune, entièrement libérées.»
3) Divers.
L'Associée Unique, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions prises suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de EUR 4.500.000,- (quatre millions
cinq cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 6.175.650,- (six millions cent soixante-quinze mille
six cent cinquante euros) à un montant de EUR 1.675.650,- (un million six cent soixante-quinze mille six cent cinquante
euros) par remboursement à l'Associée Unique et annulation de quatre-vingt-dix mille (90.000) parts d'une valeur nominale
de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l'Associée Unique décide de modifier le paragraphe 1 de l'article 6
des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à un million six cent soixante-quinze mille six cent cinquante euros (EUR
1.675.650,-), divisé en trente-trois mille cinq cent treize (33.513) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante
euros (EUR 50,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cette réduction de
capital sont estimés à EUR 1.340,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même com-
parante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante connue du notaire instrumentaire
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Wauthier, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/22722. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 10 août 2015.
Référence de publication: 2015137818/132.
(150148624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
127475
L
U X E M B O U R G
Star Supermarché Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4601 Differdange, 46, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 142.668.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>EUROFISC S.A.
Référence de publication: 2015137799/11.
(150148950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Siloe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 180.056.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions du conseil d'administration du 1 i>
<i>eri>
<i> juin 2015i>
Le Conseil d'administration a décidé de nommer la société FIDUCIAIRE DU KIEM S.à r.l., ayant son siège social au
2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 80232, comme dépositaire des actions au porteur de la Société, conformément à l'article 42 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015135222/13.
(150146527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
Taurus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 191.066.
<i>Extrait des contrats de cession de parts sociales de la Société en date du 29 juin 2015 avec effet au 30 juin 2015i>
En vertu d’un contrat de cession de parts sociales signé en date du 29 juin 2015, EQT Infrastructure II GP B.V., agissant
en sa qualité d'associé commandité (general partner) de EQT Infrastructure II Limited Partnership a transféré à EQT
Infrastructure II Executive Co-Investment Limited Partnership, une société en commandite, constituée selon les lois d’An-
gleterre, enregistrée auprès du Registre des Sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro LP15354, avec son
siège social au 15 Golden Square, Londres W1F 9JG (Royaume-Uni) et représentée par son associé commandité EQT
Services (UK) Limited, le nombre de parts sociales suivantes:
- 1 part sociale ordinaire;
- 1 Part Sociale de Catégorie A;
- 2 Parts Sociales de Catégorie B;
- 2 Parts Sociales de Catégorie C;
- 2 Parts Sociales de Catégorie D;
- 2 Parts Sociales de Catégorie E;
- 2 Parts Sociales de Catégorie F;
- 2 Parts Sociales de Catégorie G;
- 1 Part Sociale de Catégorie H, et;
- 1 Part Sociale de Catégorie I.
En plus du contrat de cession mentionné plus haut, EQT Infrastructure II Limited Partnership a transféré à CBTJ Financial
Resources B.V., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois des Pays-Bas, enregistrée auprès du registre
de commerce de la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 55299423 avec son siège social au 355, Schiphol
Boulevard, bâtiment World Trade Center Schiphol, H-Tower, étage 4
th
floor, 1118 BJ Schiphol, Pays-Bas et agissant en
tant que gérant de EQT Infrastructure II Co-Investment Scheme, le nombre de parts sociales suivantes:
- 140 parts sociales ordinaire;
- 142 Parts Sociales de Catégorie A;
- 141 Parts Sociales de Catégorie B;
127476
L
U X E M B O U R G
- 141 Parts Sociales de Catégorie C;
- 141 Parts Sociales de Catégorie D;
- 141 Parts Sociales de Catégorie E;
- 141 Parts Sociales de Catégorie F;
- 141 Parts Sociales de Catégorie G;
- 141 Parts Sociales de Catégorie H, et;
- 141 Parts Sociales de Catégorie I.
Luxembourg, le 11 août 2015.
Référence de publication: 2015138538/41.
(150149813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Sky Worldcom Travel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 21.356.
EXTRAIT
En date du 31 juillet 2015, l’assemblée générale ordinaire a décidé de reconduire tous les mandats (administrateurs,
administrateur-délégué et commissaire aux comptes) pour une nouvelle durée de 6 ans et ce jusqu'à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2021.
Luxembourg, le 31 juillet 2015.
SKY WORLDCOM TRAVEL S.A.
Référence de publication: 2015135225/13.
(150146275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
SRE One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 143.056.
Le bilan, le compte pertes et profits et les annexes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015135239/12.
(150146078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
International Campus Student Housing I, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.983.
Changement suivant le contrat de cession de parts sociales du 30 juillet 2015
- Ancienne situation associés:
Alcazar Entreprises Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts sociales
- Nouvelle situation associés
AC Limited, société limitée par actions de droit émirati, enregistrée auprès de la Chambre de
Commerce et des Sociétés de Dubai, sous le numéro CL1424, ayant son siège social au 607B,
312
th
Road, étage 6, Gate Precinct Building 5, 116020, Dubai, Emirats Arabes Unis. . . . . . . . . . . 250 parts sociales
Monsieur Horst Lieder, né le 28 octobre 1954 à Munich (Allemagne), résidant professionnellement
au 67c, Luisenstrasse, D-80798, Munich (Allemagne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 parts sociales
MMI Munich Medical International GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand,
enregistrée auprès du Tribunal d’Instance de Munich, sous le numéro HRB157447, ayant son
siège social au 53, Schillerstrasse, D-80336, Munich (Allemagne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 parts sociales
Monsieur Alexander Gulya, né le 7 novembre 1977 à Munich, (Allemagne), résidant
professionnellement au 67c, Luisenstrasse, D-80798 Munich (Allemagne). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 parts sociales
127477
L
U X E M B O U R G
Ricona Investments S.à r.l., société à responsabilité limitée, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B173642, ayant son siège social au 6,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 parts sociales
Luxembourg, le 10 août 2015.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour International Campus Student Housing I
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015138219/29.
(150149682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Ceres Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 95.244.
- Le mandat de Mme. Marion Fritz, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-
bourg, est terminé avec effet au 29 mai 2015.
- Mons. David Moscato, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est
nommé administrateur de la société, avec effet au 25 juin 2015.
- Le nouveau mandat de Mons. David Moscato prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.
Luxembourg, le 25 juin 2015.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015138012/15.
(150150281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Blackburn International Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 147.905.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2015.
<i>Pour: BLACKBURN INTERNATIONAL LUXEMBOURG
i>Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015137992/14.
(150149925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Berlys S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 55.432.
Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015137986/10.
(150149883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Crescent European Specialty Lending (Levered) A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 186.697.
Les comptes annuels de la Société pour la période du 22 avril 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
127478
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2015.
Malcolm Wilson
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015138028/13.
(150150216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Elpa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 67, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 99.297.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale du 10 août 2015i>
L'actionnaire unique décide de:
- Reconduire le mandat d'administrateur de Madame Eliane BESCH pour une durée de 6 ans et jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en l'année 2021.
- Reconduire le mandat de commissaire de Monsieur Alain GROSS pour une durée de 6 ans et jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en l'année 2021.
Signature.
Référence de publication: 2015138125/14.
(150150224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Emirates NBD SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 180.066.
Faisant suite à l'assemblée générale du 23 juillet 2015 sont nommés administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée
générale qui se tiendra en 2016:
David Marshall
Arjuna Mahendran
Martin Vogel
Est nommé réviseur d'entreprise jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016:
Ernst & Young
7, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand-Duché de Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 Août 2015.
<i>Pour State Street Bank Luxembourg S.A.i>
Référence de publication: 2015138126/20.
(150149968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
EAVF BEN Merkstein Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 130.386.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EAVF BEN MERKSTEIN S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015138118/10.
(150150170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
127479
L
U X E M B O U R G
European Trailer Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 85.233.
EXTRAIT
Le nouveau siège social du Commissaire aux Comptes de la Société est au 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227
Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07/08/2015.
Signatures
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015138112/14.
(150149875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
EuroProp (EMC VI) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 127.186.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015138113/10.
(150150407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
DePuy Synthes Leto Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 177.833.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DePuy Synthes Leto S.à r.l.
Le mandatairei>
Référence de publication: 2015138067/11.
(150150433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
European Direct Property Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement
à Capital Fixe.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 107.629.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 juin 2015 au siège sociali>
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, société coopérative, ayant son nouveau siège
au 2, rue Gerhard Mercator, L - 2182 Luxembourg as Réviseur d'Entreprises Agréé en tant que de Réviseur d'Entreprises
Agréé de la Société pour une période d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2016.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale prend acte des démissions:
- En date du 14 août 2014 de M. Bernard Carcon de Lichbuer
- En date du 18 août 2014 de celle de M. Robert Van Straelen et,
- En date du 19 décembre 2014 de celle de M. Henri Faure
De leur mandat de membre du conseil de surveillance de la Société.
Référence de publication: 2015138134/20.
(150150360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
127480
L
U X E M B O U R G
ERE IV (N°5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 175.509.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015138128/10.
(150149792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Eric Coiffure Deluxe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4994 Schouweiler, 22, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 120.769.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 29 juillet 2015i>
L'Assemblée constate et approuve la cession de 100 parts détenues Monsieur CASELLI Eric, né à Villerupt (France),
le 05 janvier 1964, demeurant à F-54880 Thil, 31, Rue Lucie Aubrac à La société FINANCIERE CASELLI, société par
actions simplifiée (Société à associé unique), ayant son siège social au F-54880 Thil (France), 31, Rue Lucie Aubrac,
Immatriculée au RCS sous le numéro 812 080 877 R.C.S. Briey le 07 juillet 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
ERIC COIFFURE DELUXE S. à R.L.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015138129/16.
(150149850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Esmerald Partners I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 114.926.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 juillet 2015 que:
- la cooptation de Mme Maria Helena GONCALVES, employée privée, avec adresse professionnelle au 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, en date du 9 octobre 2014 comme administrateur B en remplacement de
M. Fernand HEIM, démissionnaire, a été ratifiée;
- M. Nicolas GASZTONYI, avec adresse professionnelle au 1, rue de Jargonnant, CH-1207 Genève, a été nommé comme
administrateur A en remplacement de M. Stéphane ULLMANN, avec adresse professionnelle au 1, rue de Jargonnant,
CH-1207 Genève, démissionnaire.
Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en
2016.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2015138130/18.
(150150292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Eurasia Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 104.488.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
127481
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 12 Août 2015.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2015138131/13.
(150149957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
D & D Promotion SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2268 Luxembourg, 41, rue d'Orchimont.
R.C.S. Luxembourg B 182.151.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 27 juillet 2015i>
<i>Résolutions:i>
1. L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Geoffrey DEPRE au poste d'administrateur avec effet immédiat, sans
procéder au remplacement.
2. L'Assemblée accepte la démission de la société SO-IN-IMMO SA au poste d'administrateur avec effet immédiat, sans
procéder au remplacement.
3. L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Frédéric DUMOULINS demeurant à L-4131 Esch-sur-Al-
zette, 15, avenue de la Gare au poste d'administrateur et administrateur délégué et décide de le nommer administrateur
unique jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2021
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015138062/17.
(150150518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Compagnie Financière Holding «La Petite Amboise» S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 100.993.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE HOLDING "LA PETITE AMBOISE" S.A.-SPF
i>Société Anonyme
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015138054/14.
(150150157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
CO2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9633 Baschleiden, Poteau de Harlange.
R.C.S. Luxembourg B 146.814.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dierkirch, le 12/08/2015.
<i>Pour la société
i>C.F.N GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P. 80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015138060/17.
(150150200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
127482
L
U X E M B O U R G
Euro Secure, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 168.067.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2015.
Référence de publication: 2015138110/10.
(150149795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Emerald HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 178.467.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des Associés prises en date 10 août 2015i>
L'Associé Unique de Emerald HoldCo S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Paul White en tant que gérant de la Société à partir du 10 août 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2015.
<i>Pour Emerald HoldCo S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015138109/15.
(150149981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
First Pacific Resources S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4992 Sanem, 42, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 86.799.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue ce jour au siège de la société que monsieur STEPHAN
Thierry Daniel est révoqué de son mandat d'administrateur et que Monsieur SANCHEZ Maribel Larios né le 18 avril 1964
à Tecoman (Mexique) et demeurant au 200 Rumble Rd 95350 Modesto (Etats-Unis d'Amérique) est nommé administrateur
pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur STEPHAN Thierry Daniel.
Sanem, le 11 août 2015.
<i>Pour le conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2015138153/14.
(150149758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Fixmer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.000.000,00.
Siège social: L-4940 Hautcharage, 2, rue Laangwiss.
R.C.S. Luxembourg B 22.575.
<i>Rectificatif au dépôt N° L150004584 du 09/01/2015i>
Il convient de rectifier la date de nomination de Monsieur Michel THILMANT conformément à l'Assemblée Générale
Ordinaire du 28 juin 2010.
Monsieur Michel THILMANT demeure Gérant unique de la Société pour une durée indéterminée avec effet rétroactif
au 01/07/2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
127483
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 11 août 2015.
FIXMER S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015138154/17.
(150149885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
FLIT - PTREL, SICAV-SIF S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 164.525.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2015.
Référence de publication: 2015138155/11.
(150149908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Financière Privée Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 84.839.
Le Bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/05/2015.
Signature.
Référence de publication: 2015138152/10.
(150150395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Fide Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 186.056.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 26 juin 2015i>
L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire:
- Monsieur Pierre LE HARDY DE BEAULIEU, Président;
- Monsieur Fabrice DU CHASTEL, Administrateur;
- Monsieur Bernard DE MERODE, Administrateur.
pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.
2. de réélire KPMG Luxembourg, Société Coopérative, en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour le terme d'un an,
prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.
Luxembourg, le 12 août 2015.
<i>Pour FIDE FUNDS
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2015138151/20.
(150149937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Frida Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.735.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2015.
Référence de publication: 2015138147/10.
(150149786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
127484
L
U X E M B O U R G
European Wines S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 68.709.
Il résulte du «sale and purchase agreement» signé le 11 août 2015 que BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES)
LIMITED a cédé et transporté l'entièreté de ses parts sociales, c'est-à-dire 133.600 parts sociales d'EUROPEAN WINES
S.àr.l., à la société Wiberia Investments Lda, enregistrée sous le numéro 20131107 auprès du «Companies Registry of
Porto», avec siège social Avenida da República, n° 15, 5° Piso, P 1050-185 Lisbonne, Portugal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément à l'article 11
bis §2 3) de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.
Luxembourg, le 11 août 2015.
<i>Pour SG AUDIT S.àr.l.i>
Référence de publication: 2015138135/15.
(150150334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Financière de la charcuterie JV, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 167.587.
<i>Résolutions de l'actionnaire en date du 15 juin 2015i>
1. Monsieur Robert A. SHARPE II, né le 2 décembre 1957 à Michigan (Etats-Unis d'Amérique) a démissionné de son
mandat de gérant B.
2. Monsieur Roberto CHIAPPALONE, né le 15 mai 1978 à Metz (France), domicilié professionnellement à L-1420
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 5, avenue Gaston Diderich a été nommé gérant de catégorie B avec effet
immédiat pour une durée indéterminée.
<i>Pour Financière de la Charcuterie JV
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015138142/15.
(150149695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
FeneTech Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 7B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 150.816.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015138140/10.
(150149717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Frun Invest Real Estate S.C.A. SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 185.500.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2015.
<i>Pour: FRUN INVEST REAL-ESTATE S.C.A. SICAV SIF
i>Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015138158/15.
(150149927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
127485
L
U X E M B O U R G
Global Structured Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3/A, rue Guilllaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 192.632.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 11 août 2015.
Référence de publication: 2015138166/10.
(150149794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Gazprom ECP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 146.612.
- Le mandat de Mme. Marion Fritz, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-
bourg est terminé, avec effet au 29 mai 2015.
- Mons. David Moscato, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est
nommé administrateur de la société, avec effet au 25 juin 2015.
- Le nouveau mandat de Mons. David Moscato prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
Luxembourg, le 25 juin 2015.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015138163/15.
(150150097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Garigal Retail Europe No2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 125.589.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2015.
Michael Watrin
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015138162/13.
(150150528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.
Phadia Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 162.968.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015136011/9.
(150147608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
Prologis Management II S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 131.417.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015136017/9.
(150147239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
127486
L
U X E M B O U R G
Pamis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 177.854.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015136020/9.
(150146928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
Odyssée Marine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 78.588.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015135995/9.
(150146832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
PAN European Value Added Venture Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 186.798.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 983 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015136021/9.
(150147640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
bpfBOUW M&G SPIF Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 160.284.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2015.
Jean-Jacques Josset
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2015135384/13.
(150147671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
WP Roaming III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 38.759.250,00.
Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 109.535.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour WP Roaming III S.àr.l.
i>Mr. Carl Gillert
<i>Manageri>
Référence de publication: 2015135357/12.
(150145397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
127487
L
U X E M B O U R G
Triple Star Participation, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 109.789.
Les comptes de clôture au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2015.
Référence de publication: 2015136155/10.
(150147398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
Triple Star Participation, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 109.789.
Les comptes de clôture au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2015.
Référence de publication: 2015136156/10.
(150147399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
Turais S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 70.500,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 133.972.
L'adresse de Monsieur Andreas Demmel, gérant de la classe B de la Société, a changé et se trouve désormais au:
- Spaces Zuidas, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2015.
Référence de publication: 2015136160/12.
(150147174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
Twinley Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 104.573.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015136189/10.
(150147247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
127488
AB Acquisitions Luxco 5A S.à r.l.
B8WB S.à r.l.
Berlys S.C.A.
Blackburn International Luxembourg
bpfBOUW M&G SPIF Investment S.à r.l.
Ceres Finance (Luxembourg) S.A.
CO2 S.A.
Compagnie Financière Holding «La Petite Amboise» S.A.- SPF
Crescent European Specialty Lending (Levered) A S.à r.l.
D & D Promotion SA
DePuy Synthes Leto Sàrl
EAVF BEN Merkstein Sàrl
ECommerce Pay Holding S.à r.l.
Elpa S.A.
Emerald HoldCo S.à r.l.
Emirates NBD SICAV
ERE IV (N°5) S.à r.l.
Eric Coiffure Deluxe S.à r.l.
Esmerald Partners I S.A.
Eurasia Capital S.A.
European Direct Property Fund
European Trailer Holding S.A.
European Wines S.à.r.l.
EuroProp (EMC VI) S.A.
Euro Secure
FeneTech Europe S.à r.l.
Fide Funds
Financière de la charcuterie JV
Financière Privée Holding S.A.
First Pacific Resources S.A.
Fixmer S.à r.l.
FLIT - PTREL, SICAV-SIF S.C.A.
Frida Investments S.à r.l.
Frun Invest Real Estate S.C.A. SICAV-SIF
Garigal Retail Europe No2 S.à r.l.
Gazprom ECP S.A.
Glenn Funds S.à r.l.
Global Structured Finance
International Campus Student Housing I
Jamclouds Sàrl
Lego One SCI
Odyssée Marine S.A.
Pamis S.à r.l.
PAN European Value Added Venture Feeder S.C.A.
Phadia Luxembourg Holdings S.à r.l.
Pindify Sàrl
Prologis Management II S.à. r.l.
Saint-James Investissement 2 S.à r.l.
Searinvest S.A.
SELP (Belgium) S.à r.l.
SELP (Poland and Czech Republic) S.à r.l.
Siloe S.A.
Sky Worldcom Travel S.A.
SRE One S.A.
Star Supermarché Sàrl
St. Jude Medical Luxembourg
Swap Enhanced Asset Linked Securities (SEALS) S.A.
Synavic S.A.
Taurus Holding S.à r.l.
T.M.I.P. S.à r.l.
T.M.I. S.àr.l.
Towers Investments S.à r.l.
Transat (Luxembourg) Holdings
Triple Star Participation
Triple Star Participation
Tulipfield Investments
Turais S.à r.l.
Twinley Investments S.A.
WP Roaming III S.à r.l.