logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2651

29 septembre 2015

SOMMAIRE

Alistair Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

127202

Anasco Holding Company S.A.  . . . . . . . . . . . .

127230

Aquarium Wasserbillig S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

127230

ARMADEGE Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127230

Avantag Energy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127231

Batipart Immo Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

127232

Bisectra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127226

Cidron Disco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127233

Cidron Iugo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127232

Cidron Liberty Systems S.à r.l  . . . . . . . . . . . . .

127233

Décembre 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127232

Deutsche Oel & Gas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

127205

Digest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127232

Dorna-SBK Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

127232

Falke Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127229

Fondation de l'Architecture et de l'Ingénierie,

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127208

Global International Investments SICAV . . . .

127211

ING Direct  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127205

Isalpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127204

ISM Conseil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127228

Königinstrasse I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127238

La Baleine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127237

La Baleine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127238

L.D. Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127239

London Acquisition Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . .

127238

Lord Nominee S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127238

LR-Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127243

LuxCitation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127237

LuxST Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127236

Mahe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127233

Mahle Behr Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . .

127239

Mahle Behr Manufacturing Management Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127239

Malderen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127203

Manima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127206

Manulife Global Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127203

MC Diamond s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127241

MC Universal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127242

Megaram.lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127229

Microfinance Enhancement Facility SA, SI-

CAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127234

MIMOSA Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127203

Minerva Management Services S.A.  . . . . . . . .

127235

Mirlo Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

127228

MMB S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127202

NB Renaissance Partners (A) SCSp . . . . . . . . .

127245

NUR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127245

Opal One Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127205

Opera House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127246

Opera House Music  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127246

QM Holdings 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127243

Quatar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127248

Répertoire Culinaire Holding S.à r.l.  . . . . . . .

127242

Rizzo Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127230

SADMI (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

127202

SEB Green Bond Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127208

Segepa S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127248

SEGRO Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

127248

Sem Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127247

Senjo Payments Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

127235

Shere Khan SPF, S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127228

Smile Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127248

Stelarlux Industrie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127248

Supernova JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127247

127201

L

U X E M B O U R G

Alistair Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 119.916.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 octobre 2015 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur

l'exercice se clôturant au 30 juin 2015;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2015;
3. affectation des résultats au 30 juin 2015;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015151883/10/18.

MMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 29.898.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, le vendredi <i>16 octobre 2015 à 10.00 heures

avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2014;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2015157153/317/16.

SADMI (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 30.744.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

de la société SADMI (LUXEMBOURG) S.A. Société Anonyme Boulevard du Prince Henri, 3A L-1724 LUXEM-

BOURG R.C.S. Luxembourg B 30.744 qui se tiendra extraordinairement le <i>19.10.2015 à 16.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2014;
- Affectation du résultat au 31.12.2014;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Continuation de l'activité de la société
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l'Assemblée au Siège Social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015158304/20.

127202

L

U X E M B O U R G

Malderen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 61.058.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 octobre 2015 à 10h00 au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Décision sur la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la participation C.E.I.N. srl qui aura pour

ordre du jour:
a) changement de l'administrateur unique

2. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015157154/536/15.

MIMOSA Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.681.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être

exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de LCSC. En outre, le
Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18
février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 28 septembre 2015 à 10 heures au siège social n'a pas pu se

prononcer quant à l'article 100 des LCSC repris à l'ordre du jour. En effet, la moitié au moins du capital n'y était pas
représentée.

Par conséquent, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Qui se tiendra au siège social, en date du <i>27 octobre 2015 à 10 heures, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Décision conformément à l'article 100 des L.C.S.C.
2. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015158305/1004/20.

Manulife Global Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 26.141.

We are pleased to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of Manulife Global Fund to be held at the offices of the Company's Administrator, Citibank International

Limited,Luxembourg Branch31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg at 11:00 a.m. on <i>Oc-
tober 16, 2015 , for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Review of the report of the Board of Directors to the shareholders for the financial year ended June 30, 2015;
2. Review of the auditor's report for the financial year ended June 30, 2015;
3. Approval of the audited annual accounts of the Company for the financial year ended June 30, 2015;
4. Declaration of the Final Dividend;
5. Discharge of Mr. Paul Smith, Dr. Yves Wagner, Mr. Christakis Partassides and Mrs. Donna Cotter as Directors of

the Company in respect of the carrying out of their duties for the financial year ended on June 30, 2015 as well to
Mr. Robert Allen Cook, for the period from July 1, 2014 until May 05, 2015, Mr. Philip Witherington for the period
from February 18, 2015 until June 30, 2015, Mr. Clive Anderson for the period from October 17, 2014 until February
13, 2015 and Mr. Steven Yeo for the period from June 24, 2015 until June 30, 2015.

127203

L

U X E M B O U R G

6. Re-election of Mr. Paul Smith (residing in Hong Kong), Dr. Yves Wagner (residing in Luxembourg)and Mr. Chris-

takis Partassides (residing in Cyprus), as Directors of the Company until the next Annual General Meeting scheduled
in 2016;

7. Election of Mr. Philip Witherington (residing in Hong Kong) as Director of the Company until the next Annual

General Meeting scheduled in 2016;

8. Election of Mr. Steven Yeo (residing in Hong Kong) as Director of the Company until the next Annual General

Meeting scheduled in 2016;

9. Election of Mr. Gianni Fiacco (residing in Hong Kong) as Director of the Company until the next Annual General

Meeting scheduled in 2016;

10. Re-election of the Auditors of the Company, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, for the financial year

beginning on July 1, 2015 and until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for
the financial year ending on June 30, 2016;

11. Approval of the Directors 'remuneration to be paid for the financial year ending June 30, 2016

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of

the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy

form to Ms Laurence Kreicher, Citibank International Limited,Luxembourg Branch, by mail to 31, Z.A. Bourmicht, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, or by fax to +352 45 14 14 439 no later than October 15, 2015. Proxy forms will
be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the Company's Administrator
at the above-mentioned address in Bertrange.

Bearer shareholders wishing to attend the meeting are required to deposit their shares five clear days before the meeting

at Arendt Services S.A. 19 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg. Bearer shareholders are reminded to provide the identi-
fication documents as required by Arendt Services when depositing their bearer certificates in accordance with Luxembourg
Know-Your-Client requirements.

Copy of the Annual Report of the Company for the year ended on June 30, 2015 is available in electronic format at

www.manulifefunds.com.hk via the web-path "Forms &amp; Documents > Annual Reports > Download" and in printed format
for collection free of charge at the following locations, subject to inventory availability:

* 22/F, Tower A, Manulife Financial Centre, 223-231 Wai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong
* Avenida Praia Grande. No. 517, 8 andar, Edif. Commercial NamTung, Macau
* 9F, 89 SongRen Road, XinYi District, Taipei 11073, Taiwan
* 1 Kim Seng Promenade #11-07/08, Great World City West Tower, Singapore 237994
* 10 King William Street, London, EC4N 7TW
* 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg

Shareholders  requiring  further  information  may  contact  the  Administrator  of  the  Company,  Citibank  International

Limited, Luxembourg Branch on telephone number (352) 45 14 14 258, or fax number (352) 45 14 14 332, or the Hong
Kong Distributor, Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited, on telephone number (852) 2108 1110, or fax number
(852) 2810 9510, at any time during normal local business hours.

Référence de publication: 2015158306/755/58.

Isalpha, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 141.093.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 octobre 2015 à 15.30 heures dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg,

1, rue Sainte Zithe, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 30

juin 2015.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2015; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'entreprises.
6. Divers.

127204

L

U X E M B O U R G

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées

si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée devront

en aviser la Société et délivrer un certificat de blocage de leur institution financière au moins cinq jours francs avant
l'Assemblée à l'agent domiciliataire, à savoir la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2015154245/755/24.

ING Direct, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 109.614.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ING DIRECT will be held in the premises of NN Investment Partners Luxembourg S.A., at 3, rue

Jean Piret, L-2350 Luxembourg on <i>8 October 2015 at 4.00 p.m. with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the board of directors and of the auditors;
2. Approval of the annual accounts as of 31 May 2015;
3. Allocation of results;
4. Discharge to the directors;
5. Statutory appointments (resignation(s) and/or appointment(s)).

Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors of

their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015154248/755/19.

Deutsche Oel &amp; Gas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.408.

Hiermit laden wir Sie herzlich zu der

AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Gesellschaft ein, die am Mittwoch den <i>7. Oktober 2015 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Notariats Martine

Schaeffer, 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg-Stadt (Luxemburg), abgehalten wird und deren Tagesordnung
wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1. Gründung einer neuen Aktienklasse D. Aktien der Klasse D tragen alle ordentlichen, gesetzlich vorgesehenen Rechte,

können jedoch über einen Zeitraum von drei Jahren ab deren Ausgabe nur mit dem Einverständnis des Verwal-
tungsrats der Gesellschaft von deren Halter veräußert werden (im Todesfall eines Halters gilt diese Vinkulierung
auch hinsichtlich jeglichen Rechtsnachfolgern des Halters).

2. Umwandlung von 125.000.000 Aktien der Klasse A in 125.000.000 Aktien der Klasse D.
3. Dementsprechende Anpassung des Artikels 5 (Kapital - Aktien und Aktienzertifikate) der Statuten.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015154671/1729/19.

Opal One Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.040.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 24 août

<i>2015

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l'Assemblée) en

date du 24 août 2015 que:

127205

L

U X E M B O U R G

- L'Assemblée a entendu et approuvé le rapport du réviseur d'entreprises agréé pour la période du 1 

er

 septembre 2010

au 30 juin 2011 (date d'ouverture de la liquidation);

- L'Assemblée a décidé d'approuver les comptes d'ouverture de la liquidation à la date du 30 juin 2011 et de donner

décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat pendant la période allant du 1 

er

 septembre 2010

au 30 juin 2011;

- L'Assemblée a entendu le rapport du liquidateur daté du 30 juillet 2015;
- L'Assemblée a entendu et approuvé le rapport du réviseur d'entreprises agréé à la liquidation émis en date du 30 juillet

2015;

- L'Assemblée a décidé d'approuver le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de clôture de liquidation au 28

novembre 2014;

- L'Assemblée, après avoir donné décharge au liquidateur et au réviseur d'entreprises agréé à la liquidation pour l'exercice

de leur mandat pendant et dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société, a décidé de clôturer la liquidation de la
Société;

- Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de 5 ans au siège social de la Société,

sis au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

POUR EXTRAIT CONFORME
OPAL ONE SICAV (en liquidation)
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015146149/32.
(150159482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2015.

Manima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 157.934.

L'an deux mille quinze, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Manima S.A., ayant son siège social à L-1637

Luxembourg, 1, rue Goethe., R.C.S. Luxembourg numéro B157.934, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER,
alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 20 décembre 2010, acte publié au
Mémorial C numéro 541 du 23 mars 2011. (ci-après la «Société»).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Magda LION, administrateur, demeurant à B-9506 Geraardsbergen

(Smeerebbe-Vloerzegem), Aalstsesteenweg 253 (Belgique)

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur José Van Der Schueren,

administrateur, né le 17 octobre 1944 à Voorde (Belgique), demeurant à B-9506 Geraardsbergen (Smeerebbe-Vloerzegem),
Aalstsesteenweg 253 (Belgique)

La présidente expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix (310)

actions sans désignation de la valeur nominale représentant ensemble le capital total émis de la Société qui s'élève actuel-
lement à trente-et-un mille Euros (31.000,- EUR), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, toutes les personnes présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre
du jour. Tous les actionnaires ont par ailleurs renoncé à des convocations spéciales et préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de
l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transférer le siège social, statutaire et administratif de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers

la Belgique.

2. Décision de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en belge et de soumettre la Société entièrement

à l'ordonnancement juridique et fiscal belge, avec cessation intégrale de la soumission de la Société à l'ordonnancement
juridique et fiscal luxembourgeois.

127206

L

U X E M B O U R G

3. Décision d'adopter les comptes et le bilan de clôture des opérations de la Société au Grand-Duché de Luxembourg,

qui servira de bilan d'ouverture des opérations de la Société en Belgique.

4. Désignation de mandataires avec pouvoir pour représenter la Société en Belgique dans toutes les instances et dans

toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir
en relation avec le transfert du siège social.

5. Décision d'accepter les démissions des administrateurs et du commissaire actuellement en fonctions, et de leur accorder

décharge pour leur mission.

6. Décision de nommer de nouveaux administrateurs.
7. Divers.
III.- Que les statuts de la Société permettent de transférer de manière définitive le siège de la Société, avec changement

de la nationalité, vers un autre pays, dans les formes et sous les conditions telles que prévues par la loi fondamentale sur
les sociétés commerciales.

IV.- Que l'unanimité des actionnaires est favorable à un transfert du siège social de la Société vers la Belgique, avec

changement concomitant de la nationalité de la Société de luxembourgeoise en belge, avec adoption de statuts en conformité
avec la loi sur les sociétés belges.

V.- Que la Société n'émet actuellement pas d'autres titres que des actions ordinaires et qu'il n'est partant pas nécessaire

de convoquer des assemblées générales de porteurs d'autres titres pour délibérer sur la présente opération de transfert de
siège social.

VI.- Que le transfert de siège de la Société vers la Belgique rendra nécessaire un remplacement du conseil d'adminis-

tration actuel de la Société.

VII.- Qu'au vu du projet de transfert de siège dont il sera délibéré ci-après, les administrateurs et commissaire aux

comptes actuellement en fonctions ont offert leurs démissions, tout en remerciant les actionnaires de la confiance dont ces
derniers ont bien voulu leur témoigner, et en priant les actionnaires, en cas d'acceptation de leur démission, de leur accorder
pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité et par votes séparés, sans abstentions, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide, en application de l'article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales, de transférer le siège

social, statutaire et administratif de la Société, jusqu'ici fixé à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe., en Belgique à l'adresse
suivante: B-9506 Geraardsbergen (Smeerebbe-Vloerzegem), Aalstsesteenweg 253 (Belgique)

L'assemblée générale décide que par conséquent la Société sera enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises

en Belgique.

L'assemblée générale décide que ce transfert de siège a lieu avec tous les avoirs, les actifs et les passifs de la Société,

tout compris et rien excepté, sans dissolution ni liquidation préalables de la Société, qui continuera d'exister sous la natio-
nalité belge.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence du transfert de siège qui vient d'être décidé, l'assemblée générale décide de changer la nationalité de la

Société et d'adopter dorénavant pour la Société la nationalité belge, et l'assemblée décide de soumettre la Société entièrement
à l'ordonnancement juridique et fiscal belge, avec cessation intégrale de la soumission de la Société à l'ordonnancement
juridique et fiscal luxembourgeois.

<i>Troisième résolution:

L'assemblée générale décide d'approuver le bilan et les comptes de la Société, arrêtés au 27 juillet 2015, tels que présentés

à la présente assemblée, et elle décide que ce bilan et les comptes, dont une copie restera annexée au présent acte, et qui
après signatures ne varietur par tous les membres du bureau, seront présentés avec lui à la formalité de l'enregistrement.

<i>Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide de conférer à Madame Magda Lion ou à Monsieur José Van Der Schueren, tous deux de

nationalité belge et demeurant B-9506 Geraardsbergen (Smeerebbe-Vloerzegem), Aalstsesteenweg 253 (Belgique) avec
faculté de substitution, tous pouvoirs pour représenter seule la Société en Belgique, pour effectuer toutes formalités dans
toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir
en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des
statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

<i>Cinquième résolution:

L'assemblée décide d'accepter les démissions présentées par tous les membres du conseil d'administration actuels et

décide d'accepter la démission présentée par le commissaire actuel.

127207

L

U X E M B O U R G

L'assemblée générale constate par un vote spécial d'accorder à tous les administrateurs et au commissaire, démission-

naires, pleine et entière décharge, cette décharge étant accordée sans restrictions, et notamment au vu des comptes et du
bilan de clôture au 27 juillet 2015 de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, bilan approuvé ci-avant.

<i>Sixième résolution:

L'assemblée décide que la Société sera gérée par un Conseil d'Administration, conformément aux nouveaux statuts et

à la loi belge, et elle décide de fixer le nombre des administrateurs à 2 et de nommer aux fonctions d'Administrateurs:

(i) Madame Magda LION, administrateur, née le 11 mars 1944 à Geraardsbergen (Belgique), demeurant à B-9506

Geraardsbergen (Smeerebbe-Vloerzegem), Aalstsesteenweg 253 (Belgique);

(ii) Monsieur José Van Der Schueren, administrateur, né le 17 octobre 1944 à Voorde (Belgique), demeurant à B-9506

Geraardsbergen (Smeerebbe-Vloerzegem), Aalstsesteenweg 253 (Belgique).

L'assemblée générale décide de nommer les membres du Conseil d'administration pour une durée de six ans et donc

jusqu'à l'assemblée qui sera chargée d'approuver le bilan en 2021.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à 1.550,-EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg par Nous le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Magda LION, José Van Der Schueren, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 juillet 2015. Relation GAC/2015/6522. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015137556/111.
(150148639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

SEB Green Bond Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné de SEB Green Bond Fund a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SEB Asset Management S.A.

Référence de publication: 2015155112/9.
(150170398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Fondation de l'Architecture et de l'Ingénierie, Luxembourg, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 1, rue de l'Aciérie.

R.C.S. Luxembourg G 115.

L'an deux mille quinze, le treize juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Mathias FRITSCH, (Architecte), demeurant professionnellement à L1371 Luxembourg, 1, Val Ste Croix,

de nationalité luxembourgeoise.

2. Madame Tatiana FABECK, (Architecte), demeurant professionnellement à L8385 Koerich, 1, rue du Château, de

nationalité luxembourgeoise.

3. Monsieur Bob KRIEPS, (1 

er

 Conseiller de Gouvernement, Ministère de la Culture), demeurant professionnellement

à L-2450 Luxembourg, 4, boulevard Roosevelt, de nationalité luxembourgeoise.

4. Monsieur Stefano MORENO, (Architecte), demeurant professionnellement à L1112 Luxembourg, 18, rue de l'Aciérie,

de nationalité belge.

5. Monsieur Nico Pierre STEINMETZ, (Architecte), demeurant professionnellement à L-1260 Luxembourg, 39, rue de

Bonnevoie, de nationalité luxembourgeoise.

6. Monsieur Joseph DELL, (Architecte), demeurant professionnellement à L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth-Paquet,

de nationalité luxembourgeoise.

7. Monsieur John VONCKEN, (Architecte), demeurant professionnellement à L2160 Luxembourg, 26, rue Münster, de

nationalité luxembourgeoise.

127208

L

U X E M B O U R G

8. Monsieur Marc EWEN, (Ingénieur-Conseil), demeurant professionnellement à L-1852 Luxembourg, 13, rue Kal-

chesbruck, de nationalité luxembourgeoise.

9. Monsieur Jean-Marie dit Jim CLEMES, (Architecte), demeurant à L-2430 Luxembourg, 50, rue Michel Rodange, de

nationalité luxembourgeoise,

Ici représenté par Monsieur Nico Pierre STEINMETZ, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle

procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes
pour être formalisée avec elles,

Tous les comparants agissent en leurs qualités d'administrateurs de la Fondation dénommée FONDATION DE L'AR-

CHITECTURE ET DE L'INGENIERIE, LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1112 Luxembourg, 1, rue de l'Aciérie,
constituée suivant acte notarié, en date du 13 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 545 du 25 novembre 1992, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de
résidence à Echternach, le 5 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 555 du 6
avril 2007.

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Nico Pierre STEINMETZ, prénommé.
Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) Conformément à l'article 12 du chapitre VII des statuts de la fondation, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité

de procéder à la refonte des statuts de la Fondation, qui a été approuvée au préalable par le Ministère de la Culture et par
l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils.

Suite à l'adoption de cette refonte, les statuts de la Fondation de l'Architecture et de l'Ingénierie auront dorénavant la

teneur suivante:

«Chapitre I 

er

 . Dénomination - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  La Fondation prend la dénomination de «FONDATION DE L'ARCHITECTURE ET DE L'INGÉNIERIE,

LUXEMBOURG».

Art. 2. Le siège de la Fondation est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par décision du Conseil d'administration statuant conformément à l'article 12 des statuts.

Art. 3. La Fondation est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. Objet

Art. 4.  La  Fondation  a  pour  objet  la  promotion  de  la  qualité  architecturale  comme  un  fait  culturel.  Son  but  est  de

développer, auprès du public en général et des professionnels en particulier, la conscience d'une continuité du patrimoine
architectural (historique, présent et futur).

Elle favorisera l'échange d'idées et le débat public autour des thèmes de l'Architecture, de l'Ingénierie, de l'Urbanisme,

du Patrimoine bâti, de l'Architecture du paysage et d'autres disciplines impliquées par l'acte de construire.

Elle mettra en oeuvre toute manifestation destinée à atteindre les objectifs énoncés.
Elle organisera le «Prix Luxembourgeois d'Architecture» qui récompense des oeuvres architecturales de qualité choisies

dans la production récente.

Elle rassemblera des archives pour conserver toutes sortes de documents, tels que notamment des plans, photographies

ou maquettes ayant trait à l'acte de construire.

Elle constituera une bibliothèque d'ouvrages en relation avec l'objet de la Fondation tel qu'il est défini par le présent

article. Les ouvrages sur toute sorte de support seront conservés et mis à disposition du public.

Chapitre III. Patrimoine

Art. 5. Le patrimoine de la Fondation comprend la dotation initiale de 4.957,87 euros qui avait été affectée par l'Ordre

des Architectes et des Ingénieurs-Conseils à la Fondation lors de sa constitution en date du 13 juillet 1992, ainsi que le
patrimoine acquis depuis sa constitution et qui est reflété dans l'inventaire joint en annexe.

Art. 6. Les recettes de la Fondation consistent dans:
a) les contributions financières allouées à charge du budget de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg
b) les contributions financières allouées à charge du budget de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (l'Or-

dre), telles que définies dans la convention signée entre la Fondation et l'Ordre.

c) les intérêts et revenus provenant de la gestion du patrimoine de la Fondation.
d) les dons et legs, subsides et subventions de toutes sortes que la Fondation pourra recevoir dans les conditions prévues

par l'art. 36 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Chapitre IV. Conseil d'administration, organes de direction.

Art. 7.  L'administration  de  la  Fondation  est  confiée  à  un  conseil  d'administration,  dénommé  ci-après  le  «Conseil»,

composé d'un minimum de cinq (5) et d'un maximum de onze (11) membres.

127209

L

U X E M B O U R G

La durée de leur mandat est de trois (3) ans. Le mandat est renouvelable une (1) fois.
Les administrateurs sont nommés des deux tiers des membres du Conseil d'administration présents ou représentés, sur

proposition d'un des membres du Conseil.

La révocation d'un administrateur a lieu à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, l'ad-

ministrateur concerné ne prenant part ni à la délibération ni au vote.

Le Conseil comprendra obligatoirement:
- un administrateur désigné par le ministère ayant la culture dans ses attributions
- un administrateur désigné par l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils.
Après consultation de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils, le Conseil élit parmi ses membres un président

dont la candidature devra être compatible avec le caractère de profession réglementée et les intérêts légitimes des membres
de l'OAI tels que retenus dans la loi du 13 décembre 1989 régissant l'OAI. En outre, le Conseil élit parmi ses membres un
vice-président et un trésorier.

Ils sont nommés des deux tiers des membres du Conseil d'administration présents ou représentés et désignés pour une

durée de trois (3) ans. Leur mandat est renouvelable une (1) fois.

Leur révocation a lieu à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, l'administrateur concerné

ne prenant part ni à la délibération ni au vote.

Les administrateurs représentant le Ministère ayant la culture dans ses attributions et l'Ordre des Architectes et des

Ingénieurs-Conseils sont respectivement proposés par le Ministère ayant la culture dans ses attributions et l'Ordre des
Architectes et des Ingénieurs-Conseils.

Les mandats des administrateurs sont honorifiques et ne donnent droit à aucune rémunération.

Art. 8. Les séances du Conseil sont présidées par le président, à défaut par le vice-président, et, en leur absence par

l'administrateur le plus ancien en rang et, en cas d'égalité de rang, le plus âgé.

Le Conseil se réunira aussi souvent que les intérêts de la Fondation l'exigent, mais au moins trois (3) fois par an, sur

convocation écrite du président, adressée au moins huit jours à l'avance.

Il doit se réunir de façon exceptionnelle sur réquisition de trois autres membres du Conseil, adressée au moins huit jours

à l'avance.

Le Conseil peut s'adjoindre un secrétaire. Celui-ci rédige les rapports du Conseil, qui sont contresignés par le président

de séance.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Un membre peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil en vertu d'un mandat écrit. Un membre

ne peut représenter qu'un seul autre membre aux réunions du Conseil. Le mandat n'est valable que pour une seule séance
ainsi que pour les points inscrits dans l'ordre du jour.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de

partage des voix, la voix de celui qui préside la séance est prépondérante.

Chapitre V. Pouvoirs du Conseil d'administration

Art. 9. Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'objet de la Fondation, conformément à l'art. 4 des présents

statuts: il décide de tous les actes de gestion, d'administration et de disposition.

Le Conseil peut se donner à cet effet un règlement d'ordre intérieur, à approuver par la majorité des deux tiers (2/3) des

membres qui le composent.

Art. 10. La Fondation est engagée dans toutes les affaires civiles et administratives par la signature conjointe du président

et d'un administrateur ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes auxquelles ce pouvoir de signature
aura été délégué par le Conseil. L'étendue du pouvoir de signature sera déterminée au cas par cas par le Conseil.

Le Conseil peut déléguer la gestion journalière de la Fondation à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non,

nommés  par  lui  et  confier  des  mandats.  Les  délégués  et  mandataires  ainsi  nommés  engageront  la  Fondation  dans  les
conditions et limites de leurs pouvoirs, définis par le règlement d'ordre intérieur, à mettre en place par le Conseil confor-
mément à l'art. 9 des présents statuts.

Le Conseil peut instituer des comités composés d'administrateurs ou non en vue de le conseiller dans la réalisation

d'aspects spécifiques de l'objet de la Fondation. Leurs attributions, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont
fixées par le règlement d'ordre intérieur, à mettre en place par le Conseil conformément à l'art. 9 des présents statuts.

Chapitre VI. Comptes et Budget

Art. 11. L'année sociale commence le premier (1 

er

 ) janvier et se termine le trente et un (31) décembre.

Avant le premier (1 

er

 ) décembre de chaque année, le Conseil arrête le budget pour l'année à venir.

A la clôture de l'exercice, le Conseil arrête le bilan et le compte de recettes et dépenses.
Les administrateurs de la Fondation sont tenus de communiquer au Ministre de la Justice leur compte et leur budget

chaque année dans les deux mois de la clôture de l'exercice.

127210

L

U X E M B O U R G

Le compte et le budget sont publiés dans le même délai au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Chapitre VII. Modifications des statuts

Art. 12. Les modifications des statuts sont décidées par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des membres

qui le composent. Toute modification des statuts nécessite l'accord préalable de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-
Conseils.

Les modifications doivent être approuvées par arrêté grand-ducal et être publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Chapitre VIII. Dissolution

Art. 13. Au cas où la Fondation viendrait à disparaître pour quelque raison que ce soit, ou serait jugée par les adminis-

trateurs alors en fonction, statuant comme en matière de modification des statuts, ne plus pouvoir remplir suffisamment à
l'avenir la mission en vue de laquelle elle a été constituée, son actif net sera transmis à une fondation de droit luxembourgeois
ou à une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique par arrêté grand-ducal poursuivant une activité analogue
et qui sera déterminée par le conseil d'administration alors en fonction d'un commun accord avec l'Ordre des Architectes
et des Ingénieurs-Conseils.

Chapitre IX. Dispositions finales

Art. 14. Toutes les matières non réglées par les présents statuts le sont conformément à la loi susdite du 21 avril 1928,

telle qu'elle a été modifiée dans la suite.»

II) Le président constate que la refonte des statuts, telle que reproduite ci-avant, a été définitivement adoptée, sous

réserve de son approbation par arrêté grand-ducal.

DONC ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. FRITSCH, T. FABECK, B. KRIEPS, S. MORENO, N. STEINMETZ, J. DELL, J. VONCKEN, M. EWEN

et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 15 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/22216. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

<i>Approbation

L'acte reçu en date du 13 juillet 2015 portant modification des statuts de la fondation dénommée «FONDATION DE

L'ARCHITECTURE ET DE L'INGÉNIERIE, LUXEMBOURG» a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 septembre
2015.

- POUR EXPEDITION CONFORME - en vue d'approbation par arrêté grand-ducal.

Luxembourg, le 17 septembre 2015.

Référence de publication: 2015156719/163.
(150172411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Global International Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 200.143.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Banca March, a company incorporated under the laws of Spain, having its registered office at 8, Avenida Alejandro

Rosselló, Palma de Mallorca, Spain, registered with the Registro Mercantil de Baleares volume 410, page PM-644 and
registered with the Registro de Depositarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores under number 10;

represented by Allen &amp; Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, with registered

office at 33, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, itself being represented by Mathieu Voos, lawyer, with professional
address at 33, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg by virtue of a power of attorney, given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its capacity as representative of the shareholders, has requested the officiating notary to

enact the following articles of incorporation of a company, which it declares to establish as follows:

127211

L

U X E M B O U R G

1. Art. 1. Name.
1.1 There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who will become owners of the shares hereafter

created, an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) in the form of a public
limited liability company (société anonyme) under the name "Global International Investments SICAV" (the Company).

1.2 Any reference to shareholders of the Company (Shareholders) in the articles of incorporation of the Company (the

Articles) will be a reference to 1 (one) Shareholder as long as the Company will have 1 (one) Shareholder.

2. Art. 2. Registered Office.
2.1  The  registered  office  of  the  Company  is  established  in  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg.  It  may  be

transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of Shareholders
of the Company (the General Meeting), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles or by the board
of directors of the Company (the Board) if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries
of the municipality by a resolution of the Board.

2.2 The Board will further have the right to set up offices, administrative centres and agencies wherever it will deem

fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3 If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries, occur or are imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such a
transfer will have no effect on the nationality of the Company, which will remain a Luxembourg company. The declaration
of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the
officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

3. Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

4. Art. 4. Object of the company.
4.1 The exclusive purpose of the Company is to invest the assets of the Company in Transferable Securities (as defined

in article 19.4(a)) and other assets permitted by law in accordance with the principle of risk diversification, within the limits
of the investment policies and restrictions determined by the Board pursuant to article 19 hereof, and with the objective of
paying out to Shareholders the profits resulting from the management of the assets of the Company, either through distri-
butions or through accumulation of income in the Company.

4.2 The Company may take any measures and execute any transactions that it considers expedient with regard to the

fulfilment and implementation of the object of the Company to the full extent permitted by Part I of the act dated 17
December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the 2010 Act).

5. Art. 5. Share capital, Share classes.
5.1 The capital of the Company will at all times be equal to the total net assets of the Company and will be represented

by fully paid-up shares of no par value.

5.2 The minimum capital, as provided by law, is fixed at EUR 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand

euro) to be reached within a period of six months as from the authorisation of the Company by the Luxembourg supervisory
authority, being provided that shares of a Target Sub-fund held by an Investing Sub-fund (as defined in article 19.10 below)
will not be taken into account for the purpose of the calculation of the EUR 1,250,000 minimum capital requirement. Upon
the decision of the Board, the shares issued in accordance with these Articles may be of more than one share class. The
proceeds from the issue of shares of a share class, less a sales commission (sales charge) (if any), are invested in Transferable
Securities of all types and other legally permissible assets in accordance with the investment policy as set forth by the Board
and taking into account investment restrictions imposed by law. The Company was incorporated with an initial capital of
thirty one thousand euro (EUR 31,000) represented by three hundred and ten (310) fully paid up shares with no par value.

5.3 The Company has an umbrella structure, each compartment corresponding to a distinct part of the assets and liabilities

of the Company (a Sub-fund) as defined in article 181 of the 2010 Act, and that is formed for one or more share classes of
the type described in these Articles. Each Sub-fund will be invested in accordance with the investment objective and policy
applicable to that Sub-fund, the investment objective, policy, as well as the risk profile and other specific features of each
Sub-fund are set forth in the prospectus of the Company (the Prospectus). Each Sub-fund may have its own funding, share
classes, investment policy, capital gains, expenses and losses, distribution policy or other specific features.

5.4 Within a Sub-fund, the Board may, at any time, decide to issue one or more share classes the assets of which will

be commonly invested but subject to different fee structures, distribution, marketing targets, currency or other specific
features, including special rights as regards the appointment of directors in accordance with article 13 of these Articles. A
separate NAV (as defined in article 11 below) per share, which may differ as a consequence of these variable factors, will
be calculated for each share class.

5.5 The Company may create additional share classes whose features may differ from the existing share classes and

additional Sub-funds whose investment objectives may differ from those of the Sub-funds then existing. Upon creation of
new Sub-funds or share classes, the Prospectus will be updated, if necessary.

5.6 The Company is one single legal entity. However, the rights of the Shareholders and creditors relating to a Sub-fund

or arising from the setting-up, operation and liquidation of a Sub-fund are limited to the assets of that Sub-fund. The assets

127212

L

U X E M B O U R G

of a Sub-fund are exclusively dedicated to the satisfaction of the rights of the Shareholder relating to that Sub-fund and the
rights of those creditors whose claims have arisen in connection with the setting-up, operation and liquidation of that Sub-
fund, and there will be no cross liability between Sub-funds, in derogation of article 2093 of the Luxembourg Civil Code.

5.7 The Board may create each Sub-fund for an unlimited or limited period of time; in the latter case, the Board may,

at the expiration of the initial period of time, extend the duration of that Sub-fund one or more times. At the expiration of
the duration of a Sub-fund, the Company will redeem all the shares in the share class(es) of that Sub-fund, in accordance
with article 8 of these Articles, irrespective of the provisions of article 23 of these Articles. At each extension of the duration
of a Sub-fund, the registered Shareholders will be duly notified in writing, by a notice sent to their address as recorded in
the Company's register of Shareholders. The Prospectus indicates the duration of each Sub-fund and, if applicable, any
extension of its duration.

5.8 For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each share class will, if not

already denominated in euro, be converted into euro. The capital of the Company equals the total of the net assets of all
the share classes.

6. Art. 6. Shares.
6.1 The Company may, upon decision of the Board, issue shares in registered form or in dematerialised form on such

terms and conditions as the Board will prescribe. Dematerialised shares are shares exclusively issued by book entry in an
issue account (compte d'émission), held by an authorised central account holder or an authorised settlement system desi-
gnated by the Company and disclosed in the Prospectus.

6.2 All registered shares issued by the Company are entered in the register of Shareholders, which is kept by the Company

or by one or more persons designated by the Company. This register contains the names of the owners of registered shares,
their permanent residence or elected domicile as indicated to the Company, and the number of registered shares held by
them.

6.3 The entry of the Shareholder's name in the register of shares evidences the Shareholder's right of ownership to such

registered shares. The Shareholder will receive a written confirmation of its shareholding.

6.4 Shareholders entitled to receive registered shares must provide the Company with an address to which all notices

and announcements may be sent. This address will also be entered into the register of Shareholders.

6.5 In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may have a notice to this effect entered

into the register of Shareholders. The Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company,
or at such other address as may be determined by the Company from time to time, until another address is provided to the
Company by that Shareholder. A Shareholder may, at any time, change the address entered in the register of Shareholders
by means of a written notification to the registered office of the Company or to such other address as may be determined
by the Company from time to time.

6.6 Holders of dematerialised shares must provide, or must ensure that registrar agents shall provide, the Company with

information for identification purposes of the holders of such shares in accordance with applicable laws. If on a specific
request  of  the  Company,  the  holder  of  dematerialised  shares  does  not  furnish  the  requested  information,  or  furnishes
incomplete or erroneous information within a time period provided for by law or determined by the Board at its discretion,
the Board may decide to suspend voting rights attached to all or part of the dematerialised shares held by the relevant person
until satisfactory information is received.

6.7 The Company recognises only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of

a share or shares is disputed, all persons claiming a right to those shares will appoint one owner to represent those shares
towards the Company. The failure to appoint such an attorney results in the suspension of the exercise of all rights attached
to such shares.

6.8 The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares do not carry voting rights, except where

their number is so that they represent a whole share, but are entitled to participate in the net assets attributable to the relevant
share class on a pro rata basis.

7. Art. 7. Issue of shares.
7.1 The Board is authorised, without limitation, to issue an unlimited number of fully paid up shares at any time without

reserving a preferential right to subscribe for the shares to be issued for the existing Shareholders.

7.2 The Board may impose restrictions on the frequency at which shares of a certain share class are issued; the Board

may, in particular, decide that shares of a particular share class will only be issued during one or more subscription periods
or at such other intervals as provided for in the Prospectus and the Board may decide not to issue any further shares of a
particular share class in its entire discretion.

7.3 Shares in Sub-funds will be issued at the subscription price. The subscription price for shares of a particular share

class of a Sub-fund corresponds to the NAV per share of the respective share class (see articles 11 and 12 below) plus any
subscription fee, if applicable. Additional fees may be incurred if distributors and paying agents are involved in a transaction.
The relevant subscription price may be rounded up or down to the nearest unit of the currency in which it is to be paid, as
determined by the Board.

127213

L

U X E M B O U R G

7.4 A process determined by the Board and described in the Prospectus will govern the chronology of the issue of shares

in a Sub-fund.

7.5 The subscription price is payable within a period determined by the Board, which may not exceed three (3) business

days from the relevant valuation day (the Valuation Day), determined on every such day on which the NAV per share for
a given share class or Sub-fund is calculated (the NAV Calculation Day).

7.6 The Board may confer the authority upon any of its members, any managing director, officer or other duly authorised

representative to accept subscription applications, to receive payments for newly issued shares and to deliver these shares.

7.7 Subject to the terms of the Prospectus, the Company can accept subscriptions through contributions in kind of assets

to a Sub-fund in lieu of cash.

7.8 Applications for subscription are irrevocable, except -for the duration of such suspension - when the calculation of

the NAV has been suspended in accordance with article 12 of these Articles.

8. Art. 8. Redemption of shares.
8.1 Any Shareholder may request redemption of all or part of his shares from the Company, pursuant to the conditions

and procedures set forth by the Board in the Prospectus and within the limits provided by law and these Articles.

8.2 Subject to the provisions of article 12 of these Articles and this article 8, the redemption price per share will be paid

within a period determined by the Board which may not exceed three (3) business days from the relevant NAV Calculation
Day, as determined in accordance with the current policy of the Board.

8.3 The redemption price per share for shares of a particular share class of a Sub-fund corresponds to the NAV per share

of the respective share class less any redemption fee, if applicable. Additional fees may be incurred if distributors and
paying agents are involved in a transaction. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit
of the currency in which it is to be paid, as determined by the Board.

8.4 A process determined by the Board and described in the Prospectus will govern the chronology of the redemption

of shares in a Sub-fund.

8.5 If as a result of a redemption application, the number or the value of the shares held by any Shareholder in any share

class falls below the minimum number or value that is then determined by the Board in the Prospectus, the Company may
decide to treat such an application as an application for redemption of all of that Shareholder's shares in the given share
class.

8.6 The Company may satisfy payment of the redemption price owed to any Shareholder, subject to such Shareholder's

agreement, in specie by allocating assets to the Shareholder from the portfolio set up in connection with the share class(es)
equal in value to the value of the shares to be redeemed (calculated in the manner described in article 11 below) as of the
Valuation Day or the time of valuation when the redemption price is calculated if the Company determines that such a
transaction would not be detrimental to the best interests of the remaining Shareholders of the relevant Sub-fund. The nature
and type of assets to be transferred in such case will be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing
the interests of the other Shareholders in the given share class or share classes, as the case may be. The valuation used will
be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers are borne by the transferee.

8.7 All redeemed shares will be cancelled.
8.8 All applications for redemption of shares are irrevocable, except - in each case for the duration of the suspension -

in accordance with article 12 of these Articles, when the calculation of the NAV has been suspended or when redemption
has been suspended as provided for in this article.

8.9 The Company may redeem shares of any Shareholder if:
(a) any of the representations given by the Shareholder to the Company were not true and accurate or have ceased to be

true and accurate; or

(b) the Shareholder is a Restricted Person (as defined in article 10 below); or
(c) that the continuing ownership of shares by the Shareholder would cause an undue risk of adverse tax consequences

to the Company or any of its Shareholders; or

(d) the continuing ownership of shares by such Shareholder may be prejudicial to the Company or any of its Shareholders;

or

(e) further to the satisfaction of a redemption request received by a Shareholders, the number or aggregate amount of

shares  of  the  relevant  class  held  by  this  Shareholder  is  less  than  the  minimum  holding  amount  as  is  stipulated  in  the
Prospectus.

9. Art. 9. Conversion of shares.
9.1 A Shareholder may convert shares of a particular share class of a Sub-fund held in whole or in part into shares of

the corresponding share class of another Sub-fund; conversions from shares of one share class of a Sub-fund to shares of
another share class of either the same or a different Sub-fund are also permitted, except otherwise decided by the Board.

9.2 The Board may make the conversion of shares dependent upon additional conditions.
9.3 A conversion application will be considered as an application to redeem the shares held by the Shareholder and as

an application for the simultaneous acquisition (issue) of the shares to be acquired. The conversion ratio will be calculated

127214

L

U X E M B O U R G

on the basis of the NAV per share of the respective share class; a conversion fee may be incurred. Additional fees may be
incurred if distributors and paying agents are involved in a transaction. The prices of the conversion may be rounded up or
down to the nearest unit of the currency in which they are to be paid, as determined by the Board. The Board may determine
that balances of less than a reasonable amount to be set by the Board, resulting from conversions will not be paid out to
Shareholders.

9.4 As a rule, both the redemption and the acquisition parts of the conversion application should be calculated on the

basis of the values prevailing on one and the same Valuation Day. If there are different order acceptance deadlines for the
Sub-funds in question, the calculation may deviate from this, in particular depending on the sales channel. In particular
either:

(a) the sales part may be calculated in accordance with the general rules on the redemption of shares (which may be

older than the general rules on the issue of shares), while the purchase part would be calculated in accordance with the
general (newer) rules on the issue of shares; or

(b) the sales part is not calculated until a time later in relation to the general rules on share redemption together with the

purchase part calculated in accordance with the newer (in relation to the sales part) rules on the issue of shares.

9.5 Conversions may only be effected if, at the time, both the redemption of the shares to be converted and the issue of

the  shares  to  be  acquired  are  simultaneously  possible;  there  will  be  no  partial  execution  of  the  application  unless  the
possibility of issuing the shares to be acquired ceases after the shares to be converted have been redeemed.

9.6 All applications for the conversion of shares are irrevocable, except - in each case for the duration of the suspension

- in accordance with article 12 of these Articles, when the calculation of the NAV of the shares to be redeemed has been
suspended or when redemption of the shares to be redeemed has been suspended as provided for in article 8 above. If the
calculation of the NAV of the shares to be acquired is suspended after the shares to be converted have already been redeemed,
only the acquisition part of the conversion application can be revoked during this suspension.

9.7 If as a result of a conversion application, the number or the value of the shares held by any Shareholder in any share

class falls below the minimum number or value that is then - if the rights provided for in this sentence are to be applicable
- determined by the Board in the Prospectus, the Company may decide to treat the purchase part of the conversion application
as a request for redemption for all of the Shareholder's shares in the given share class; the acquisition part of the conversion
application remains unaffected by any additional redemption of shares.

9.8 Shares that are converted to shares of another share class will be cancelled.

10. Art. 10. Restrictions on ownership of shares - Transfer of shares.
10.1 The Board may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any individual or legal entity:
(a) if such individual or legal entity would not comply with the eligibility criteria of a given class or Sub-fund as set out

in the Prospectus; or

(b) if it may result in a breach of any law or regulation, whether under Luxembourg law or other law; or
(c) if such individual or legal entity is a US Person (as defined in the Prospectus) and any person, determined in the sole

discretion of the Board as being not entitled to subscribe or hold shares in the Company or any Sub-fund or share class(es)
if, in the opinion of the Board; or

(d) if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that

it would not have otherwise incurred (such individuals or legal entities are to be determined by the Board in its discretion
and are defined herein as Restricted Persons).

10.2 For such purposes the Company may:
(a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of shares, where such registration or transfer would

result in legal or beneficial ownership of such shares by a Restricted Person; and

(b) at any time require any person whose name is entered in the register of Shareholders or who seeks to register the

transfer of shares in the register of Shareholders to furnish the Company with any information, supported by affidavit,
which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's
shares rests with a Restricted Person, or whether such registration will result in beneficial ownership of such shares by a
Restricted Person; and

(c) decline to accept the vote of any Restricted Person at the General Meeting; and
(d) instruct a Shareholder to sell his shares and to demonstrate to the Company that this sale was made within ten (10)

business days of the sending of the relevant notice if the Company determines that a Restricted Person is the sole beneficial
owner or is the beneficial owner together with other persons.

10.3 If the investor does not comply with the relevant notice, the Company may, in accordance with the procedure

described below, compulsorily redeem all shares held by such a Shareholder or have this redemption carried out:

(a) The Company provides a second notice (Purchase Notice) to the investor or the owner of the shares to be redeemed,

in accordance with the entry in the register of Shareholders; this Purchase Notice designates the shares to be redeemed, the
procedure under which the redemption price is calculated and the name of the acquirer.

(b) Such Purchase Notice will be sent by registered mail to the last known address or to the address listed in the Company's

books.

127215

L

U X E M B O U R G

(c) Immediately upon close of business on the date designated in the Purchase Notice, the Shareholder's ownership of

the shares which are designated in the Purchase Notice ends. For registered shares and dematerialised shares, the name of
the Shareholder is deleted from the register of Shareholders.

(d) The price at which these shares are acquired (Sales Price) corresponds to an amount determined on the basis of the

share value of the corresponding share class on a Valuation Day, or at some time during a Valuation Day, as determined
by the Board, less any redemption fees incurred, if applicable. The purchase price is, less any redemption fees incurred, if
applicable, the lesser of the share value calculated before the date of the Purchase Notice.

(e) The exercise of the powers by the Company in accordance with this article may in no way be called into question or

declared invalid on the grounds that the ownership of shares was not sufficiently proven or that the actual ownership of
shares did not correspond to the assumptions made by the Company on the date of the Purchase Notice, provided that the
Company exercised the above-named powers in good faith.

10.4 Restricted Persons as defined in these Articles are neither persons who subscribe shares for the duration of their

shareholding in connection with the formation of the Company nor securities dealers who subscribe shares in the Company
for distribution.

10.5 The Company may decline to register a transfer of shares:
(a) if in the opinion of the Company, the transfer will be unlawful or will result or be likely to result in any adverse

regulatory, tax or fiscal consequences to the Company or its Shareholders; or

(b) if the transferee is a US Person (as defined in the Prospectus) or is acting for or on behalf of a US Person; or
(c) if the transferee is a Restricted Person or is acting for or on behalf of a Restricted Person; or
(d) in relation to share classes reserved for subscription by institutional investors, if the transferee is not an institutional

investor; or

(e) in circumstances where an investor engages in market trading or late trading activities; or
(f) if in the opinion of the Company, the transfer of the shares would lead to the shares being registered in a depositary

or clearing system in which the shares could be further transferred otherwise than in accordance with the terms of the
Prospectus or these Articles.

11. Art. 11. Calculation of net asset value per share.
11.1 The Company, each Sub-fund and each share class in a Sub-fund have a net asset value (NAV) determined in

accordance with these Articles. The reference currency of the Company is the Euro. The NAV of each Sub-fund and share
class will be calculated in the reference currency of the Sub-fund or share class, as it is stipulated in the Prospectus, and
will be determined by the administrative agent of the Company (the Administrative Agent) for each Valuation Day on each
NAV Calculation Day as stipulated in the Prospectus, by calculating the aggregate of:

(a) the value of all assets of the Company which are allocated to the relevant Sub-fund and share class in accordance

with the provisions of these Articles; less

(b) all the liabilities of the Company which are allocated to the relevant Sub-fund and share class in accordance with

the provisions of these Articles, and all fees attributable to the relevant Sub-fund and share class, which fees have accrued
but are unpaid on the relevant Valuation Day.

11.2 The NAV per share for a Valuation Day will be calculated in the reference currency of the relevant Sub-fund and

will be calculated by the Administrative Agent as at the NAV Calculation Day of the relevant Sub-fund by dividing the
NAV of the relevant Sub-fund by the number of shares which are in issue on the Valuation Day corresponding to such
NAV Calculation Day in the relevant Sub-fund (including shares in relation to which a Shareholder has requested re-
demption on such Valuation Day in relation to such NAV Calculation Day).

11.3 If the Sub-fund has more than one share class in issue, the Administrative Agent will calculate the NAV per share

of each share class for a Valuation Day by dividing the portion of the NAV of the relevant Sub-fund attributable to a
particular share class by the number of shares of such share class in the relevant Sub-fund which are in issue on such
Valuation Day (including shares in relation to which a Shareholder has requested redemption on the Valuation Day in
relation to such NAV Calculation Day).

11.4 The NAV per share may be rounded up or down as set out in the Prospectus.
11.5 The allocation of assets and liabilities of the Company between Sub-funds (and within each Sub-fund between the

different share classes) will be effected so that:

(a) the subscription price received by the Company on the issue of shares, and reductions in the value of the Company

as a consequence of the redemption of shares, will be attributed to the Sub-fund (and within that Sub-fund, the share class)
to which the relevant shares belong;

(b) assets acquired by the Company upon the investment of the subscription proceeds and income and capital appreciation

in relation to such investments which relate to a specific Sub-fund (and within a Sub-fund, to a specific share class) will
be attributed to such Sub-fund (or share class in the Sub-fund);

(c) assets disposed of by the Company as a consequence of the redemption of shares and liabilities, expenses and capital

depreciation relating to investments made by the Company and other operations of the Company, which relate to a specific

127216

L

U X E M B O U R G

Sub-fund (and within a Sub-fund, to a specific share class) will be attributed to such Sub-fund (or share class in the Sub-
fund);

(d) where the use of foreign exchange transactions, instruments or financial techniques relates to a specific Sub-fund

(and within a Sub-fund, to a specific share class) the consequences of their use will be attributed to such Sub-fund (or share
class in the Sub-fund);

(e) where assets, income, capital appreciations, liabilities, expenses, capital depreciations or the use of foreign exchange

transactions, instruments or techniques relate to more than one Sub-fund (or within a Sub-fund, to more than one share
class), they will be attributed to such Sub-funds (or share classes, as the case may be) in proportion to the extent to which
they are attributable to each such Sub-fund (or each such share class);

(f) where assets, income, capital appreciations, liabilities, expenses, capital depreciations or the use of foreign exchange

transactions, instruments or techniques cannot be attributed to a particular Sub-fund they will be divided equally between
all Sub-funds or, in so far as is justified by the amounts, will be attributed in proportion to the relative NAV of the Sub-
funds (or share classes in the Sub-fund) if the Board, in its sole discretion, determines that this is the most appropriate
method of attribution; and

(g) upon payment of dividends to the Shareholders of a Sub-fund (and within a Sub-fund, to a specific share class) the

net assets of this Sub-fund (or share class in the Sub-fund) are reduced by the amount of such dividend.

11.6 The assets of the Company will be valued as follows:
(a) Transferable Securities or Money Market Instruments quoted or traded on an official stock exchange or any other

regulated market as defined in the Council Directive 2004/39/EEC dated 21 April 2004 on markets in financial instruments
or any other market established in the European Economic Area which is regulated, operates regularly and is recognised
and open to the public (a Regulated Market), are valued on the basis of the last known price, and, if the securities or money
market instruments are listed on several stock exchanges or Regulated Markets, the last known price of the stock exchange
which is the principal market for the security or Money Market Instrument in question, unless these prices are not repre-
sentative.

(b) For Transferable Securities or Money Market Instruments not quoted or traded on an official stock exchange or any

other Regulated Market, and for quoted Transferable Securities or Money Market Instruments, but for which the last known
price is not representative, valuation is based on the probable sales price estimated prudently and in good faith by the
Company.

(c) Units and shares issued by undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) or other un-

dertakings for collective investment (UCI) will be valued at their last available net asset value.

(d) The liquidating value of futures, forward or options contracts that are not traded on exchanges or on other Regulated

Markets will be determined pursuant to the policies established in good faith by the Board, on a basis consistently applied.
The liquidating value of futures, forward or options contracts traded on exchanges or on other Regulated Markets will be
based  upon  the  last  available  settlement  prices  of  these  contracts  on  exchanges  and  Regulated  Markets  on  which  the
particular futures, forward or options contracts are traded; provided that if a futures, forward or options contract could not
be liquidated on such Valuation Day with respect to which a NAV is being determined, then the basis for determining the
liquidating value of such contract will be such value as the Board may, in good faith and pursuant to verifiable valuation
procedures, deem fair and reasonable.

(e) Liquid assets and Money Market Instruments as defined in article 19.4(b) of these Articles with a maturity of less

than 12 months may be valued at nominal value plus any accrued interest or using an amortised cost method (it being
understood that the method which is more likely to represent the fair market value will be retained). This amortised cost
method may result in periods during which the value deviates from the price the relevant Sub-fund would receive if it sold
the investment. The Board may, from time to time, assess this method of valuation and recommend changes, where ne-
cessary, to ensure that such assets will be valued at their fair value as determined in good faith pursuant to procedures
established by the Board. If the Board believes that a deviation from the amortised cost may result in material dilution or
other unfair results to Shareholders, the Board will take such corrective action, if any, as it deems appropriate, to eliminate
or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results.

(f) The swap transactions will be consistently valued based on a calculation of the net present value of their expected

cash flows. For certain Sub-funds using over-the-counter financial derivative instruments (OTC Derivative) as part of their
main investment policy, the valuation method of the OTC Derivative will be further specified in the Prospectus.

(g) Accrued interest on securities will be included if it is not reflected in the share price.
(h) Cash will be valued at nominal value, plus accrued interest.
(i) All assets denominated in a currency other than the reference currency of the respective Sub-fund/share class will be

converted at the mid-market conversion rate between the reference currency and the currency of denomination.

(j) All other securities and other permissible assets as well as any of the above mentioned assets for which the valuation

in accordance with the above sub-paragraphs would not be possible or practicable, or would not be representative of their
probable realisation value, will be valued at probable realisation value, as determined with care and in good faith pursuant
to procedures established by the Board.

11.7 The assets of the Company will include:

127217

L

U X E M B O U R G

(a) all cash on hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
(b) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not yet

collected);

(c) all securities, shares, bonds, debentures, swaps, options or subscription rights and any other investments and securities

belonging to the Company;

(d) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company provided

that the Company may adjust the valuation for fluctuations in the market value of securities due to trading practices such
as trading ex-dividend or ex-rights;

(e) all accrued interest on any interest bearing securities held by the Company except to the extent that such interest is

comprised in the principal thereof;

(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and
(g) all other permitted assets of any kind and nature including prepaid expenses.
11.8 The liabilities of the Company will include:
(a) all borrowings, bills and other amounts due;
(b) all administrative expenses due or accrued including but not limited to the costs of its constitution and registration

with regulatory authorities, as well as legal, audit, management, custodial, paying agency and corporate and central admi-
nistration agency fees and expenses, the costs of legal publications, prospectuses, financial reports and other documents
made available to Shareholders, translation expenses and generally any other expenses arising from the administration of
the Company;

(c) all known liabilities, due or not yet due including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of all dividends declared by the Company for which no coupons have been presented and
which therefore remain unpaid until the day these dividends revert to the Company by prescription;

(d) any appropriate amount set aside for taxes due on the date of the valuation and any other provisions of reserves; and
(e) any other liabilities of the Company of whatever kind towards third parties.
11.9 General rules
(a) all valuation regulations and determinations will be interpreted and made in accordance with Luxembourg law;
(b) the latest NAV per share may be obtained at the registered office of the Company in accordance with the terms of

the Prospectus;

(c) for the avoidance of doubt, the provisions of this article 11 are rules for determining the NAV per share and are not

intended to affect the treatment for accounting or legal purposes of the assets and liabilities of the Company or any shares
issued by the Company;

(d) the NAV per share of each share class in each Sub-fund is made public at the offices of the Company and Admi-

nistrative Agent. The Company may arrange for the publication of this information in the reference currency of each Sub-
fund/ share class and any other currency at the discretion of the Company in leading financial newspapers. The Company
cannot accept any responsibility for any error or delay in publication or for non-publication of prices;

(e) different valuation rules may be applicable in respect of a specific Sub-fund as further laid down in the Prospectus.

12. Art. 12. Frequency and temporary suspension of the calculation of share value and of the issue, Redemption and

conversion of shares.

12.1 The NAV of shares issued by the Company will be determined with respect to the shares relating to each Sub-fund

by the Company from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the Board may decide.

12.2 During the existence of any state of affairs which, in the opinion of the Board, makes the determination of the NAV

of a Sub-fund in the reference currency either not reasonably practical or prejudicial to the Shareholders of the Company,
the NAV and the subscription price and redemption price may temporarily be determined in such other currency as the
Board may determine.

12.3 The Company may at any time and from time to time suspend the determination of the NAV and/or the issue and

redemption of shares in any Sub-fund as well as the right to convert shares of any Sub-fund into shares relating to another
Sub-fund:

(a) when one or more stock exchanges or markets, which provide the basis for valuing a substantial portion of the assets

of the Sub-fund or of the relevant share class, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a
substantial portion of the assets of the Sub-fund or of the relevant share class are denominated, are closed otherwise than
for ordinary holidays or if dealings therein are restricted or suspended;

(b) when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsibility

and the control of the Board, disposal of the assets of the Sub-fund or of the relevant share class is not reasonably or normally
practicable without being seriously detrimental to the interests of the Shareholders;

(c) in the case of a breakdown in the normal means of communication used for the valuation of any investment of the

Sub-fund or of the relevant share class or if, for any reason beyond the responsibility of the Board, the value of any asset
of the Sub-fund or of the relevant share class may not be determined as rapidly and accurately as required;

127218

L

U X E M B O U R G

(d) if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of

the Company are rendered impracticable or if purchases and sales of the Sub-fund's assets cannot be effected at normal
rates of exchange;

(e) in respect of a feeder Sub-fund, following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the

issue, redemption and/or the conversion at the level of a master fund in which the relevant Sub-fund invests in its capacity
as feeder fund of such master fund;

(f) when the Board so decides, provided that all Shareholders are treated on an equal footing and all relevant laws and

regulations are applied (i) upon publication of a notice convening a General Meeting of Shareholders of the Company or
of a Sub-fund for the purpose of deciding on the liquidation, dissolution, the merger or absorption of the Company or the
relevant Sub-fund and (ii) when the Board is empowered to decide on this matter, upon their decision to liquidate, dissolve,
merge or absorb the relevant Sub-fund;

(g) in case of the Company's liquidation or in the case a notice of termination has been issued in connection with the

liquidation of a Sub-fund or a share class;

(h) where, in the opinion of the Board, circumstances which are beyond the control of the Board make it impracticable

or unfair vis-à-vis the Shareholders to continue trading the shares.

12.4 The suspension in respect of a Sub-fund will have no effect on the calculation of the NAV and the issue, redemption

and conversion of the shares of any other Sub-fund.

12.5 Any such suspension may be notified by the Company in such manner as it may deem appropriate to the persons

likely to be affected thereby. The Company will notify Shareholders requesting redemption and/or conversion of their
shares of such suspension.

13. Art. 13. Board of directors.
13.1 The Company will be managed by a Board of at least three (3) director (including the chairman of the Board). The

directors of the Company, either Shareholders or not, are appointed for a term which may not exceed 6 (six) years, by a
General Meeting.

13.2 When a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate

a permanent representative in order to accomplish this task in its name and on its behalf (the Representative). The Repre-
sentative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability as if he was performing this task
for his own account and on his own behalf, without prejudice to the joint liability of him and the Legal Entity. The Legal
Entity cannot revoke the Representative unless it simultaneously appoints a new permanent representative.

13.3 Members of the Board are selected by a majority vote of the shares present or represented at the relevant General

Meeting.

13.4 Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the General

Meeting.

13.5 In the event of a vacancy in the office of a member of the Board, the remaining directors may temporarily fill such

vacancy; the Shareholders will take a final decision regarding such nomination at their next General Meeting.

14. Art. 14. Board meetings.
14.1 The Board will elect a chairman out of the members of the Board. It may further choose a secretary, either director

or not, who will be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board. The Board will meet upon call by the
chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

14.2 The chairman will preside at all meetings of the Board. In his absence the Board will appoint another member of

the Board as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

14.3 Meetings of the Board are convened by the chairman or by any other two members of the Board.
14.4 Written notice of any meeting of the Board will be given to all directors at least twenty four (24) hours prior to the

date set for such meeting, except in emergencies, in which case the nature of the emergency will be set forth in the notice
of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax, e-mail or other similar means of
communication. No separate invitation is necessary for meetings whose date and location have been determined by a prior
resolution of the Board.

14.5 The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
14.6 Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or telegram or telex another

director as his proxy.

14.7 A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors

are present at the meeting.

14.8 Any director may participate in any meeting of the Board by conference call or by other similar means of com-

munication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation in a
meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and is deemed to be held at the registered
office of the Company.

14.9 The Board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or duly represented.

127219

L

U X E M B O U R G

14.10  The  Board  may  validly  deliberate  and  make  decisions  only  if  at  least  one  half  of  its  members  is  present  or

represented. Decisions are made by the majority of the votes expressed by the members present or represented. If a member
of the Board abstains from voting or does not participate to a vote, this abstention or non-participation are not taken into
account in calculating the majority.

14.11 In the case of a tied vote, the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, will have a casting vote.
14.12 Resolutions signed by all directors will be valid and binding in the same manner as if they were passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or telefax.

14.13 The decisions of the Board will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the

chairman or by any two other directors. Any proxies will remain attached thereto.

14.14 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by

the chairman or by any two other directors.

14.15 No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity will be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in, or
are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is director or
officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company will contract or otherwise engage in
business will not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

14.16 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of

the Company, such director will make known to the Board such personal and opposite interest and will not consider or vote
upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, will be reported to the next following
annual General Meeting.

14.17 The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary

course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

14.18 If, a quorum of the Board cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the required majority

of the other members of the Board present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.

15. Art. 15. Powers of the board of directors.
15.1 The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within the

Company's purpose, in compliance with the investment policy as determined in article 19 of these Articles, to the extent
that such powers are not expressly reserved by law or by these Articles to the General Meeting.

15.2 All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the General Meeting lie in the competence of the

Board.

16. Art. 16. Corporate signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two

members of the Board or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the
Board.

17. Art. 17. Delegation of powers.
17.1 The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers

to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board, acting under the supervision of the Board. The Board may also delegate certain of its powers,
authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member of members of the
Board or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are directors of the Company and
that no meeting of the committee will be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions
unless a majority of those present are directors of the Company.

17.2 The Board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

18. Art. 18. Indemnification.
18.1 The Company may indemnify any director or officer and his/her/its heirs, executors and administrators, against

expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he/she/it may be made a
party by reason of his/her/it being or having been a director or officer of the Company or, at his/her/its request, of any other
corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he/she/it is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he/she/it will be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or wilful misconduct, in the event of a settlement indemnification will be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification will not exclude other rights to which he/
she/it may be entitled.

18.2 In the event of a settlement, indemnification will be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach
of duty.

127220

L

U X E M B O U R G

19. Art. 19. Investment policies and restrictions.
19.1 The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's

interest. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the General Meeting may be exercised by the
Board.

19.2 The Board has, in particular, the power to determine the corporate policy. The course of conduct of the management

and business affairs of the Company will fall under such investment restrictions as may be imposed by the 2010 Act or be
laid down in the laws and regulations of those countries where the shares are offered for sale to the public or as will be
adopted from time to time by resolutions of the Board and as will be described in any prospectus relating to the offer of
shares.

19.3 The management of the assets of the Sub-funds will be undertaken within the following investment restrictions. A

Sub-fund may be subject to different or additional investment restrictions set out in the relevant special section of the
Prospectus.

19.4 Subject to compliance with all investment restrictions which apply to UCIs subject to Part I of the 2010 Act and

the additional investment restrictions set out in the Prospectus, the Company may invest in:

(a)  shares  in  companies  and  other  securities  equivalent  to  shares  in  companies  (shares),  bonds  and  other  forms  of

securities, debt and any other negotiable securities which carry the right to acquire any such transferable securities by
subscription or exchange (Transferable Securities);

(b) instruments normally dealt in on the money market which are liquid, and have a value which can be accurately

determined at any time (Money Market Instruments);

(c) shares or units of other UCIs, including shares or units of a master fund qualified as a UCITS;
(d) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are

maturing in no more than twelve (12) months;

(e) financial derivative instruments; and in
(f) shares issued by one or several other Sub-funds under the conditions provided for by the 2010 Act.
19.5 The Company may purchase Transferable Securities and Money Market Instruments on any Regulated Market of

a state of Europe being or not a Member State, of America, Africa, Asia, Australia or Oceania. The Company may also
invest in recently issued Transferable Securities and Money Market Instruments, provided that the terms of issue include
an undertaking that application will be made for admission to official listing on a Regulated Market and that such admission
be secured within one year of issue. Each Sub-fund may also invest up to 10% of its net assets in other Transferable Securities
and Money Market Instruments.

19.6 A Sub-fund may have as objective to replicate the composition of an index of securities or debt securities recognised

by the Luxembourg supervisory authority.

19.7 In accordance with the principle of risk spreading, a Sub-fund may invest up to 100% of its net assets in Transferable

Securities or Money Market Instruments issued or guaranteed by an EU member state, its territorial authorities, by a member
state of the OECD, by certain non-OECD member states (currently Singapore and Hong-Kong) or by public international
bodies of which one or more EU member states are members if (i) the relevant Sub-fund holds securities belonging to six
different issues at least and (ii) the securities belonging to one issue do not represent more than 30% of the net assets of
the relevant Sub-fund.

19.8 The Board, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the Prospectus, that:

(i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-fund be co-managed on a segregated basis with other assets held
by other investors, including other UCIs and/or their sub-funds; or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-
funds be co-managed amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.

19.9 Investments of each Sub-fund may be made either directly or indirectly through wholly-owned subsidiaries, as the

Board may from time to time decide and as described in the Prospectus. Reference in these Articles to "investments" and
"assets" shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made and
assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

19.10 A Sub-fund (the Investing Sub-fund) may invest in one or more other Sub-funds. Any acquisition of shares of

another Sub-fund (the Target Sub-fund) by the Investing Sub-fund is subject to the following conditions (and such other
conditions as may be applicable in accordance with the terms of the Prospectus):

(a) the Target Sub-fund may not invest in the Investing Sub-fund;
(b) the Target Sub-fund may not invest more than 10% of its net assets in UCITS (including other Sub-funds) or other

UCIs;

(c) the voting rights attached to the shares of the Target Sub-fund are suspended during the investment by the Investing

Sub-fund;

(d) the value of the share of the Target Sub-fund held by the Investing Sub-fund are not taken into account for the purpose

of assessing the compliance with the EUR1,250,000 minimum capital requirement; and

(e) duplication of management, subscription or redemption fees is prohibited.

127221

L

U X E M B O U R G

19.11 The Company may employ techniques and instruments relating to Transferable Securities and Money Market

Instruments for hedging or efficient portfolio management purposes.

19.12 Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board may, at any time it deems appropriate

and to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations:

(a) create any Sub-fund and/or class of shares qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS;
(b) convert any existing Sub-fund and/or share class into a feeder UCITS sub-fund and/or class of shares or change the

master UCITS of any of its feeder UCITS sub-fund and/or class of shares.

20. Art. 20. Auditor.
20.1 The accounting data reported in the annual report of the Company will be examined by an auditor (réviseur d'en-

treprises agréé) appointed by the General Meeting and remunerated by the Company.

20.2 The auditor fulfils all duties prescribed by the 2010 Act.

21. Art. 21. General meeting of shareholders of the company.
21.1 The General Meeting represents, when properly constituted, the entire body of Shareholders of the Company. Its

resolutions are binding upon all the Shareholders, regardless of the share class held by them. It has the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

21.2 The General Meeting meets when called by the Board. It will be necessary to call a General Meeting within a month

whenever a group of Shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital requires so by written notice. In
such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.

21.3 The annual General Meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place in the

municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on 30 April of each year at 3.00pm
(Luxembourg time). If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting will be held on the
preceding business day.

21.4 Other General Meetings may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of

meeting.

21.5 Shareholders meet when called by the Board pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least eight days

prior to the meeting to each registered Shareholder at the Shareholder's address in the register of Shareholders. It is not
necessary to provide proof at the meeting that such notices were actually delivered to registered Shareholders. The agenda
is prepared by the Board, except when the meeting is called on the written request of the Shareholders, in which case the
Board may prepare a supplementary agenda.

21.6 If all shares are in registered form and dematerialised form and if no publications are made, notices to Shareholders

may be sent by registered mail only.

21.7 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the General Meeting may take place without notice of meeting.

21.8 The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to attend any meeting

of Shareholders. To the extent permitted by law, the convening notice to a General Meeting may provide that the quorum
and majority requirements will be assessed against the number of shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg
time) on the fifth day prior to the relevant meeting (the Record Date) in which case, the right of any Shareholder to participate
in  the  meeting  will  be  determined  by  reference  to  his/her/its  holding  as  at  the  Record  Date.  The  right  of  a  holder  of
dematerialised shares to attend a General Meeting and to exercise the voting rights attached to such shares will be determined
by reference to the shares held by this holder as at the time and date provided for by Luxembourg laws and regulations.

21.9  The  business  transacted  at  any  meeting  of  the  Shareholders  will  be  limited  to  the  matters  on  the  agenda  and

transactions related to these matters.

21.10 Each share of any share class is entitled to one vote, in accordance with Luxembourg law and these Articles. A

Shareholder may act at any meeting of Shareholders through a written proxy to another person, who need not be a Share-
holder and who may be a member of the Board.

21.11 Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority

vote of the Shareholders present or represented.

22. Art. 22. General meetings of shareholders in a sub-fund or in a share class.
22.1 The Shareholders of the share classes issued in a Sub-fund may hold, at any time, General Meetings to decide on

any matters which relate exclusively to that Sub-fund.

22.2 In addition, the Shareholders of any share class may hold, at any time, General Meetings for any matters which are

specific to that share class.

22.3 The provisions of article 21 of these Articles apply to such General Meetings.
22.4 Unless otherwise provided for by law or in these Articles, the resolutions of the General Meeting of a Sub-fund or

of a share class are passed by a simple majority vote of the Shareholders present or represented.

127222

L

U X E M B O U R G

23. Art. 23. Liquidation of sub-funds or share classes.
23.1 In the event that for any reason the net assets of a Sub-fund or of any class fall below the equivalent of the minimum

NAV as set out in the Prospectus or if a change in the economic or political environment of the relevant Sub-fund or class
may  have  material  adverse  consequences  on  the  Sub-fund  or  class's  investments,  or  if  an  economic  rationalisation  so
requires, the Board may decide on a compulsory redemption of all outstanding shares in such Sub-fund or share class(es)
on the basis of the NAV per share (after taking into account current realisation prices of investments as well as realisation
expenses) calculated as of the day the decision becomes effective. The Company will serve a notice to the holders of the
relevant share class(es) at the latest on the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons
and the procedure for the redemption operations. Registered Shareholders will be notified in writing. Unless the Board
decides otherwise in the interests of, or in order to keep equal treatment between the Shareholders, the Shareholders of the
Sub-fund or of the share class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of redemption
or conversion charge. However, the liquidation costs will be taken into account in the redemption and conversion price and
any amounts unclaimed by the Shareholders at the closing of the liquidation will be deposited with the Caisse de Consi-
gnation in Luxembourg for a duration of thirty (30) years. If amounts deposited remain unclaimed beyond the prescribed
time limit, they will be forfeited.

23.2 Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, the General Meeting of any one

or all share classes issued in any Sub-fund may upon proposal from the Board, to decide to repurchase all the shares of the
relevant share class(es) and to reimburse the Shareholders on the basis of the NAV of their shares (taking into account
current realisation prices of the investments and realisation expenses) calculated as of the Valuation Day on which such
decision will become effective. No quorum will be required at this General Meeting and resolutions will be passed by a
simple majority of the Shareholders present or duly represented and voting at such meeting, provided that the decision does
not result in the liquidation of the Company.

23.3 All redeemed shares will be cancelled.

24. Art. 24. Merger of sub-funds or share classes.
24.1 In accordance with the provisions of the 2010 Act and of these articles, the Board may decide to merge or consolidate

the Company with, or transfer substantially all or part of the Company's assets to, or acquire substantially all the assets of,
another UCITS established in Luxembourg or another EU member state. For the purpose of this article, the term UCITS
also refers to a sub-fund of a UCITS and the term Company also refers to a Sub-fund.

24.2 Any merger leading to termination of the Company must be approved by a resolution of the General Meeting

adopted in the manner required for amendments of these Articles as set out in article 29 of these Articles. For the avoidance
of doubt, this provision does not apply in respect of a merger leading to the termination of a Sub-fund.

24.3 Shareholders will receive shares of the surviving UCITS or sub-fund and, if applicable, a cash payment not ex-

ceeding 10% of the NAV of those shares.

24.4 The Company will provide appropriate and accurate information on the proposed merger to its Shareholders so as

to enable them to make an informed judgment of the impact of the merger on their investment and to exercise their rights
under this article 24 and the 2010 Act.

24.5 The Shareholders have the right to request, without any charge other than those retained by the Company to meet

disinvestment costs, the redemption of their Shares.

24.6 Under the same circumstances as provided by article 23.1 above, the Board may decide to allocate the assets of a

Sub-fund to those of another existing Sub-fund within the Company or to another Luxembourg UCITS or to another sub-
fund within such other Luxembourg UCITS (the New Sub-fund) and to repatriate the shares of the class or classes concerned
as shares of another (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any
fractional entitlement to Shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in article 24.4
one month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the New Sub-
fund), in order to enable the Shareholders to request redemption of their Shares, free of charge, during such period.

24.7 Notwithstanding the powers conferred to the Board by article 24.6 above, a contribution of the assets and of the

liabilities attributable to any Sub-fund to another Sub-fund within the Company may in any other circumstances be decided
by a General Meeting of Shareholders of the class or classes issued in the Sub-fund concerned for which there will be no
quorum requirements and which will decide upon such a merger by resolution taken by simple majority of those present
or represented and voting at such meeting.

24.8 If the interest of the Shareholders of the relevant Sub-fund or in the event that a change in the economic or political

situation relating to a Sub-fund so justifies, the Board may proceed to the reorganisation of a Sub-fund by means of a
division into two or more Sub-funds. Information concerning the New Sub-fund(s) will be provided to the relevant Sha-
reholders. Such publication will be made one month prior to the effectiveness of the reorganisation in order to permit
Shareholders to request redemption of their Shares free of charge during such one month prior period.

25. Art. 25. Financial year. The financial year of the Company commences on 1 January of each year and terminates on

31 December of the same year.

127223

L

U X E M B O U R G

26. Art. 26. Application of income.
26.1 The General Meeting determines, upon proposal from the Board and within the limits provided by law, how the

income from the Sub-fund will be applied with regard to each existing share class, and may declare, or authorise the Board
to declare, distributions.

26.2 For any share class entitled to distributions, the Board may decide to pay interim dividends in the form and under

the conditions provided by law.

26.3 Payments of distributions to owners of registered shares will be made to such Shareholders at their addresses in

the register of Shareholders.

26.4 Distributions may be paid in such a currency and at such a time and place as the Board determines from time to

time.

26.5 The Board may decide to distribute bonus stock in lieu of cash dividends under the terms and conditions set forth

by the Board.

26.6 Any distributions that has not been claimed within 5 (five) years of its declaration will be forfeited and revert to

the share class(es) issued in the respective Sub-fund.

26.7 No interest will be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

27. Art. 27. Depositary.
27.1 To the extent required by law, the Company will enter into a depositary agreement with a bank or credit institution

as defined by the act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the Depositary).

27.2 The Depositary will fulfil its obligations in accordance with the 2010 Act.
27.3 If the Depositary indicates its intention to terminate the custodial relationship, the Board will make every effort to

find a successor depositary within two months of the effective date of the notice of termination of the depositary agreement.
The Board may terminate the agreement with the Depositary but may not relieve the Depositary of its duties until a successor
depositary has been appointed.

28. Art. 28. Liquidation of the company.
28.1 The Company may at any time be dissolved by a resolution of the General Meeting, adopted in the required manner

for amendments of the Articles as set out in article 29 of these Articles.

28.2 If the assets of the Company fall below two-thirds of the minimum capital indicated in article 5 of these Articles,

the Board must submit the question of the Company's dissolution to the General Meeting. The General Meeting, for which
no quorum will be required, will decide by simple majority of the votes of the shares represented at the General Meeting.

28.3 The question of dissolution of the Company will further be referred to the General Meeting whenever the share

capital falls below one-fourth of the minimum capital indicated in article 5 of these Articles; in such event, the General
Meeting will be held without any voting quorum requirements and the dissolution may be decided by Shareholders holding
one-quarter of the votes of the shares represented at the meeting.

28.4 The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from the ascertainment that the net

assets of the Company have fallen below two-thirds or one-quarter of the legal minimum, as the case may be.

28.5 If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators appointed in accordance

with the provisions of the 2010 Act.

28.6  The  decision  to  dissolve  the  Company  will  be  published  in  the  Mémorial  and  two  newspapers  with  adequate

circulation, one of which must be a Luxembourg newspaper.

28.7 The liquidator(s) will realise each Sub-fund's assets in the best interests of the Shareholders and apportion the

proceeds of the liquidation, after deduction of liquidation costs, amongst the Shareholders of the relevant Sub-fund ac-
cording to their respective pro rata.

28.8 Any amounts unclaimed by the Shareholders at the closing of the liquidation of the Company will be deposited

with the Caisse des Consignations in Luxembourg for a duration of thirty (30) years. If amounts deposited remain unclaimed
beyond the prescribed time limit, they will be forfeited.

29. Art. 29. Amendments to the articles. These Articles may be amended by a General Meeting of Shareholders subject

to the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the 1915 Act).

30. Art. 30. Definitions. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing

persons or Shareholders also include corporations, partnerships, associations and any other organised group of persons,
whether incorporated or not.

31. Art. 31. Applicable law. All matters not governed by these Articles will be determined in accordance with the 1915

Act and the 2010 Act. In case of conflict between the 1915 Act and the 2010 Act, the 2010 Act will prevail.

<i>Transitional provisions

The first business year begins today and ends on 31 December 2015.

127224

L

U X E M B O U R G

The first annual General Meeting will be held in 2016.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, all shares have been subscribed as follows:

Banca March, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . three hundred ten (310) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . three hundred ten (310) shares

All these shares have been fully paid up by the shareholders by payment in cash, so that the sum of EUR thirty-one

thousand (31,000 EUR) paid by the shareholders is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof
having been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by articles 26, 26-3 and 26-5 of the 1915 Act have

been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these
Articles comply with the provisions of article 27 of the 1915 Act.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 2,500.

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

The above named party, representing the whole of the subscribed capital, considering itself to be duly convened, has

proceeded to hold an extraordinary general meeting of Shareholders and having stated that it was regularly constituted, it
has passed the following resolutions by unanimous vote:

1. the number of directors is set at 5 (five);

2. the following persons are appointed as members of the Board for a period ending on the date of the annual General

Meeting to be held in 2016:

- David Nuevo, Director, born on 2 February 1973 in Madrid, Spain and having his residential address at Nuñez de

Balboa, 70bis, Madrid, Spain;

- Hugo Aramburu, Director, born on 24 March 1976 in Madrid, Spain and having his professional address at Nuñez de

Balboa, 70bis, Madrid, Spain;

- Hector Esteban, Director, born on 24 August 1973 in Madrid, and having his professional address at 21-25 Allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Noël Ford, Director, born on 12 December 1960 in Dublin, Ireland, and having his professional address at 14, Milltown

Drive, Churchtown, Dublin 14, Ireland;

- Reginald Van Leer, Director, born on 15 July 1944 in Ixelles, and having his professional address at 63a, rue Jean-

Pierre Huberty, L-1742 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

3. Deloitte Audit S.à r.l., with registered office at 560, rue Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

is appointed as external auditor of the Company for a period ending on the date of the annual general meeting to be held
in 2016;

4. the Company's registered office will be at 20, Boulevard Emmanuel Servais, L2535 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: M. VOOS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 18 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29773. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Référence de publication: 2015156730/809.

(150173250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

127225

L

U X E M B O U R G

Bisectra, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 140.019.

L'an deux mille quinze, le dixième jour du mois de septembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme régie par les lois du Grand-

Duché de Luxembourg “BISECTRA”, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 140019, (la “Société”), constituée suivant
acte reçu par Maître Joseph GLODEN, notaire alors de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg), le 4
juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1874 du 30 juillet 2008,

et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 septembre

2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3460 du 19 novembre 2014.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe GILAIN, employé, demeurant professionnellement à Howald.
Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine BEERENS, em-

ployée, demeurant professionnellement à Howald.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président produit les documents suivants dans le cadre de la fusion de la Société

par absorption de sa filiale détenue à cent pour cent, “BICERVA INVESTMENTS”, une société anonyme régie par les lois
de la Belgique, établie et ayant son siège social à B-1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain 90, enregistrée au
greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0454.786.775:

- une copie de la publication du projet commun de fusion au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1936 du 31 juillet 2015;

- une copie de la publication aux annexes du Moniteur belge daté du 30 juillet 2015 du projet commun de fusion déposé

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles le 20 juillet 2015;

- un certificat, daté du 9 septembre 2015 émis par Maître Frédéric de GRAVE notaire à Molenbeek-Saint-Jean (Belgi-

que), attestant l'existence et la légalité tant interne qu'externe, des actes et formalités préalables à la fusion transfrontalière
en droit belge et leur réalisation conforme.

Après examen de ces documents et approbation par l'Assemblée, le Président expose et prie le notaire instrumentaire

d'acter ce qui suit:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Prise d'acte du projet de fusion transfrontalière entre la Société et “BICERVA INVESTMENTS”, une société anonyme

régie par les lois de la Belgique, établie et ayant son siège social à B-1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain
90, enregistrée au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0454.786.775, adopté par le conseil d'administration de la Société le 17 juillet 2015 et publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1936 du 31 juillet 2015 et son dépôt auprès du greffe du tribunal de
commerce francophone de Bruxelles, le 20 juillet 2015 (le “Projet de Fusion”);

2. Prise d'acte du fait que les documents listés à l'article 267 (1) inclus, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée (la “Loi”) ont été déposés au siège social de la Société et mis à la disposition des action-
naires pour inspection au moins un mois avant la date de la présente assemblée;

3. Renonciation au rapport justificatif du conseil d'administration prévu par l'article 265 de la loi sur les sociétés com-

merciales.

4. Prise d'acte du fait que (i) d'un point de vue comptable, les opérations de la société “BICERVA INVESTMENTS”,

seront traitées comme si elles l'avaient été pour le compte de la Société à partir du 15 juillet 2015 et (ii) que la Fusion (telle
que définie ci-après) ne sera effective entre les sociétés fusionnantes et vis-à-vis des tiers qu'après la publication de la
présente assemblée dans le Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, conformément aux articles 273ter et 9 de la
Loi;

5.  Prise  de  connaissance  du  certificat  de  conformité  émanant  de  ...,  attestant  que  “BICERVA  INVESTMENTS”  a

accompli les formalités lui incombant en vertu du droit belge pour la Fusion;

6.  Approbation  de  la  fusion  transfrontalière  simplifiée  entre  de  la  Société  et  de  “BICERVA  INVESTMENTS”  (la

“Fusion”), par laquelle “BICERVA INVESTMENTS” transfert à la Société tous ses actifs et passifs conformément à
l'article 278 de la Loi, tel que décrit dans le Projet de Fusion.

127226

L

U X E M B O U R G

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés

sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les mandataires, les membres du bureau

de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  et  que  les  actionnaires,  présents  ou  représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée prend connaissance du projet de fusion adopté le 17 juillet 2015 et publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, le 31 juillet 2015 sous le numéro 1936 et dans les annexes du Moniteur belge le 30 juillet 2015
sous le numéro 15109728 (le “Projet de Fusion”) et prévoyant l'absorption par la Société de “BICERVA INVESTMENTS”,
pré-désignée (la “Société Absorbée”).

L'Assemblée a noté que s'agissant d'une fusion transfrontalière simplifiée, les actionnaires de la Société et l'associé

unique de “BICERVA INVESTMENTS” ont établi et décidé que la Fusion serait faite sans qu'il soit besoin que le Projet
de Fusion soit examiné par un expert indépendant et sans un rapport écrit rédigé par un expert indépendant.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée prend acte que tous les documents listés à l'article 267 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales (la “Loi”) ont été déposés au siège social de la Société et mis à la disposition des actionnaires pour inspection
au moins un mois avant la date de la présente assemblée.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée prend acte que les actionnaires ont renoncé en vertu de l'article 265 (3) de la Loi au rapport de fusion du

conseil d'administration.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte (i) du fait que, d'un point de vue comptable, les opérations de “BICERVA INVESTMENTS”

seront traitées comme si elles l'avaient été pour le compte de la Société à partir du 15 juillet 2015 et (ii) que la Fusion ne
sera effective vis-à-vis des tiers qu'après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de la présente
assemblée conformément aux articles 273ter et 9 de la Loi.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée prend connaissance du certificat de conformité émanant de Maître Frédéric de GRAVE, notaire à Molen-

beek-Saint-Jean (Belgique), attestant que “BICERVA INVESTMENTS” a accompli les formalités lui incombant en vertu
du droit belge pour la Fusion. Une copie de ce dernier étant annexée aux présentes.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide d'approuver la fusion transfrontalière par absorption par la Société de sa filiale détenue à cent pour

cent (100%), “BICERVA INVESTMENTS”, opérant la dissolution sans liquidation de cette dernière et la transmission de
plein droit de tous ses actifs et passifs, tel que décrit dans le Projet de Fusion, de sorte que la Fusion est considérée réalisée
entre les sociétés fusionnantes.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite

clôturé l'Assemblée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément à l'article 271 (2) de la Loi avoir vérifié et certifie l'existence et la légalité

de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille neuf cents euros.

DONT ACTE, passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. GILAIN, C. BEERENS, C. WERSANDT.

127227

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 septembre 2015 2LAC/2015/20758. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157256/114.
(150173561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Shere Khan SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 198.846.

RECTIFICATIF

Dans l'en-tête de la publication des statuts, à la page 120744 du Mémorial C n° 2516 du 16 septembre 2015, il y a lieu

de corriger comme suit la forme juridique de la société:

- au lieu de: "Société à responsabilitée limitée - Société de gestion de patrimoine familial",
- lire: " Société Anonyme - Société de gestion de patrimoine familial "
Référence de publication: 2015157719/11.

Mirlo Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 183.962.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Mirlo Investments S.à r.l.

Référence de publication: 2015134986/11.
(150145586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

ISM Conseil, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 68, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 150.447.

L'an deux mille quinze, le trente juillet.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Patrick GALAMPOIX, salarié, né à Sarcelles (France), le 14 décembre 1963, demeurant à L-7243 Berel-

dange, 23, rue du 10 Octobre, et

2.- Madame Nathalie GALAMPOIX, née FIORITI, gérante de sociétés, née à Thionville (F), le 11 septembre 1965,

demeurant à L-7243 Bereldange, 23, rue du 10 Octobre

ici représentés par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Lu-

xembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "ISM Conseil", avec siège social à L-7243 Bereldange, 23, rue du 10 Octobre,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 150.447, a été constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 241 du 4 février 2010. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant
en date du:

- 12 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2937 du 4 décembre 2012, et
- 11 décembre 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 110 du 15 janvier 2015.
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social vers L-2560 Luxembourg, 68, rue de Strasbourg.

127228

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide en conséquence de ce qui précède de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«  Art. 4. (1 

er

 alinéa).  Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de neuf cents euros, sont à charge de la société, et les

associés s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 août 2015. Relation GAC/2015/6745. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015137445/43.
(150148989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

Megaram.lu, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8528 Colpach Haut, 60, rue A. et E. Mayrich.

R.C.S. Luxembourg B 167.865.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2015.

Référence de publication: 2015135001/10.
(150145794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

Falke Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 75.221.

DISSOLUTION

L'an deux mil quinze, le dix-huit juin.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme CORIS HOLDING S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, avec siège à L-1637

Luxembourg, 24-28, rue Goethe, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 70 658, représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Franco FASOLATO et Luciano DAL ZOTTO.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire d'acter:
- qu'il existe avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, une société anonyme sous la dénomination de

FALKE HOLDING, au capital social actuel d'un million huit cent mille euros (1 800 000.-EUR), représenté par dix-huit
mille (18 000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune;

- que la Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire alors de résidence à Pétange,

en date du 7 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 538 du 27 juillet 2000;

- que cette Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B No 75 221;
- que la totalité des dix-huit mille (18 000) actions de la société anonyme FALKE HOLDING ont été réunies entre les

mains du mandant, la société anonyme CORIS HOLDING S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, préqua-
lifiée;

- que le mandant, actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la société anonyme FALKE

HOLDING, avec effet immédiat;

- que partant, l'actionnaire unique qui déclare avoir parfaite connaissance de la situation de la société anonyme FALKE

HOLDING se trouve investi de tous les éléments actifs de la Société et reprend à son compte tout le passif social et tous
les engagements de la Société, sans restriction ni réserve, même inconnus à l'heure actuelle;

- que, partant, la liquidation de la société anonyme FALKE HOLDING est dès lors achevée et la Société est définiti-

vement dissoute et liquidée;

127229

L

U X E M B O U R G

- que décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d'administration et au Commissaire de la Société;
- que le mandant déclare en outre que les livres et documents de la Société dissoute resteront déposés pendant la durée

légale de cinq années à son ancien siège social.

Sur ce, les représentants de la comparante ont présenté au notaire, pour vérification, le registre d'actionnaires de la

Société dissoute qui a été immédiatement annulé par le notaire instrumentant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège de la Société dissoute, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux représentants de la comparante, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instru-

mentant.

Signés: L. DAL ZOTTO, K. REUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 24 juin 2015. Relation: 2LAC/2015/14006. Reçu soixante-quinze euros 75.-

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 11 août 2015.

Référence de publication: 2015137314/44.
(150149258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

Rizzo Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 166.979.

EXTRAIT

Monsieur Rizzo Manuel a démissionné par courrier avec effet immédiat en date du 23/07/2015 de son poste de gérant

de la société

Rizzo Group Sàrl
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015135161/12.
(150145817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

Anasco Holding Company S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 14.859.

Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015136312/10.
(150147821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

Aquarium Wasserbillig S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6645 Wasserbillig, rue des Pépinières.

R.C.S. Luxembourg B 99.189.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
EUROFISC S.A.

Référence de publication: 2015136316/11.
(150148056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

ARMADEGE Benelux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9672 Niederwampach, maison 65.

R.C.S. Luxembourg B 173.813.

L'an deux mille quinze, le treize juillet.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

127230

L

U X E M B O U R G

Ont comparu:

1. Mademoiselle Véronique SOUBIELLE, directeur commercial, née le 2 avril 1957 à Paris (France) (matr: 1957 0402

660), demeurant à L-9672 Niederwampach, maison 65;

2. Monsieur Jérôme SOUBIELLE , directeur technique, né le 26 juillet 1960 à Suresnes (France) (matr:1960 07 26 733),

demeurant à L-9672 Niederwampach, maison 65;

Ici représenté par Mademoiselle Véronique SOUBIELLE, préqualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé datée

du 13 juillet 2015 à Niederwampach, laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui;

3. La société ARMADEGE, société à responsabilité limitée de droit français, ayant son siège social à F-75171 Paris

Cedex 19, 118-130 avenue Jean Jaurès, RCS Versailles 504 674 268 représentée aux fins des présentes par Mademoiselle
Nathalie BARET, gérante, demeurant à F-78124 Mareil-sur-Mauldre;

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associé de la société à responsabilité limitée "ARMADEGE

Benelux", avec siège social à L-9946 BINSFELD, 34, Duarrefstrooss , inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 173.813,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 décembre 2012, publié au Mémorial C, numéro 342
du 12 février 2013,

réunis en assemblée générale et déclarant que cette assemblée peut valablement délibérer, ont pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-9946 Binsfeld à L-9672 Niederwampach, maison 65, et en

conséquence décident de modifier l'article 4 des statuts comme suit:

« Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Niederwampach Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être
transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans
toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 850,00 €.

<i>Déclaration des comparants

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5
du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Véronique SOUBIELLE, Nathalie BARET, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 14 juillet 2015. Relation: DAC/2015/11843. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-

€.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 7 août 2015.

Référence de publication: 2015136318/51.
(150148000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

Avantag Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 50.989.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 10 août 2015.

Référence de publication: 2015136328/10.
(150148843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

127231

L

U X E M B O U R G

Batipart Immo Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 196.312.

Les statuts coordonnés au 24/07/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10/08/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015136343/12.
(150148656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

Cidron Iugo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.110.000,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 153.178.

L'adresse de Monsieur Andreas Demmel, gérant de classe B de la Société, a changé et se trouve désormais au:
- Spaces Zuidas, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas.
L'adresse de Monsieur Claes-Johan Geijer, gérant de classe A de la Société, a changé et se trouve désormais au:
- 2, rue Siggy Vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duché de Luxemburg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Référence de publication: 2015136395/14.
(150148434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

Digest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 24.653.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 août 2015.

Référence de publication: 2015136470/10.
(150147909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

Décembre 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 192.749.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
DECEMBRE 2 S.à r.l.

Référence de publication: 2015136462/11.
(150147920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

Dorna-SBK Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 172.224.

RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle survenue dans la publication datée du 25 mai 2015, et déposée au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg le 27 mai 2015, sous la référence L150088912:

127232

L

U X E M B O U R G

En date du 14 février 2015, l'associé CPPIB (Hong Kong) Limited, avec siège social au 15, Queen's Road Central, 11/

F York House, The Landmark, Central, Hong Kong, a transféré 127 parts sociales de catégorie A à l'associé 4372859
Canada Inc. avec siège social au 1250, boul. René-Lévesque, suite 4500, H3B4W8 West Montréal, Canada, qui les acquiert.

En conséquence, les associés de la société sont les suivants:
- CPPIB (Hong Kong) Limited, précité, avec 597.232 parts sociales de catégorie A
- 4372859 Canada Inc., précité, avec 2.768parts sociales de catégorie A
- Bridgepoint Europe IV Investments, S.à r.l., avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

avec 1.400.000 parts sociales de catégorie B

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2015.

Référence de publication: 2015136455/21.
(150148307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

Cidron Liberty Systems S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 254.000,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 153.198.

L'adresse de Monsieur Claes-Johan Geijer, gérant de classe A de la Société, a changé et se trouve désormais au:
- 2, rue Siggy Vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duché de Luxemburg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Référence de publication: 2015136397/12.
(150148440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

Cidron Disco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 205.100,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 165.366.

L'adresse de Monsieur Andreas Demmel, gérant de classe B de la Société, a changé et se trouve désormais au:
- Spaces Zuidas, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas.
L'adresse de Monsieur Claes-Johan Geijer, gérant de classe A de la Société, a changé et se trouve désormais au:
- 2, rue Siggy Vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duché de Luxemburg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Référence de publication: 2015136394/14.
(150148426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

Mahe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 140.398.

L'an deux mille quinze, le vingt-neuf juillet.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «MAHE S.A.» ayant son siège social à L-1219 Luxembourg,

17, rue Beaumont, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 140.398,

constituée suite à une scission, suivant un acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 4 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1968, du 12 août 2008.

avec un capital souscrit de fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000.-) divisé en deux mille cinq cents (2.500)

actions de cent euros (EUR 100.-) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christine ALTENHOVEN, employée, demeurant professionnel-

lement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sophie ERK, employée, de-

meurant professionnellement à Luxembourg, 17, rue Beaumont.

127233

L

U X E M B O U R G

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur Madame Mireille ROSE, expert-comptable, née à Thionville (France), le 22

juillet 1975, demeurant professionnellement au 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la

loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation
est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L'assemblée accepte les démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur confère, pleine et entière

décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille euros (900,- EUR), sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Christine ALTENHOVEN, Sophie ERK, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 31 juillet 2015. Relation GAC/2015/6645. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015136688/61.
(150147684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 144.746.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

127234

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 23 juillet 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015137536/15.
(150148884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

Senjo Payments Europe S.A., Société Anonyme,

(anc. Minerva Management Services S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 178.296.

L'an deux mil quinze, le quatre août.
Par-devant, Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck

A COMPARU

La société Caireen S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au RCS sous le

numéro B 119.660.

représentée par son gérant unique Monsieur Roy Phillip HARDING, né à Cape Town (ZA) le 16 octobre 1951, demeurant

à L-2215 Beggen (Luxembourg), 14 rue de Neuerburg,

(ci-après le «Comparant» ou l'«Associé unique»),
ici représenté par Madame Carina RODRIGUES, secrétaire, née à Luxembourg le 12 juillet 1990, professionnellement

à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,

en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée à Luxembourg le 29 juillet 2015;
Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le notaire instrumentant et le mandataire du Comparant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel Comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
- Qu'il est le seul et unique associé de la société anonyme de droit luxembourgeois «Minerva Management Services

S.A.» établie et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 178 296, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Lecuit de
résidence à Mersch, le 18 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations du 17 août 2013,
numéro 1996 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés

(ci-après la «Société»);
- Qu'en sa qualité d'Associé unique de la Société, il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de société de «Minerva Management Services S.A.» en «Senjo Payments

Europe S.A.», de sorte que l'article aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de «Senjo Payments Europe

S.A.» (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois applicables et plus particulièrement par la loi du 10 novembre 2009
relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement
dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres, portant transposition de la directive
2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, telle que modifiée (la «Loi sur les Services de
Paiement»), la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») de même que par les présents
statuts (ci-après les «Statuts»).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social, de sorte que l'article 2 aura désormais la teneur suivante:
2.1. La Société a pour objet la fourniture de services de paiement dans le sens de la Loi sur les Services de Paiement,

et, en particulier, sans préjudice quant à l'exhaustivité de l'énumération qui suivra, les services énumérés aux points 6 de
l'Annexe de la Loi sur les Services de Paiement, à savoir:

(i) Le transmissions de fonds (money rémittence)
2.2. La Société pourra, dans les limites prévues par la Loi sur les Services de Paiement, acquérir et détenir des partici-

pations, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres sociétés luxembourgeoises ou
étrangères, à travers, entre autres, la souscription ou l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport,
de garantie, de souscription, d'achat ou d'option, de négociation ou de toute autre manière, respectivement des instruments
financiers sous quelque forme que ce soit, et généralement gérer, développer, contrôler, vendre et transférer en considération

127235

L

U X E M B O U R G

d'un prix que la Société jugera approprié (et plus particulièrement en considération des actions ou d'autres parts d'intérêts
de toute société acquérant de telles participations), tout ou partie de telles participations.

2.3. La Société pourra également, dans les limites prévues par la Loi sur les Services de Paiement, exécuter, assister ou

être partie à une transaction financière ou commerciale et prêter tout concours, que ce soit sous forme de prêts, garanties
ou autrement, à ses filiales ou toute société dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, même non
substantielle, ou toute société appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Liées»), y compris l'octroi
de garanties et gages au bénéfice d'un tiers pour garantir l'exécution des obligations de ces Sociétés Liées.

2.4. La Société pourra aussi, dans les limites prévues par la Loi sur les Services de Paiement, emprunter ou lever des

fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée, et exécuter toute opération
qui est directement ou indirectement liée à son objet social.

2.5. Pour les besoins de l'application de cet article, une société sera considérée comme faisant partie du même «groupe»

que la Société si telle autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, est contrôlée par, ou est sous
contrôle commun avec, ou est contrôlée par un actionnaire de, la Société, dans chaque cas que ce soit en tant que bénéficière
économique ou en tant que trustee, gardienne ou autre fiduciaire.

Une société est considérée comme contrôlant une autre société si la société contrôlante détient, directement ou indirec-

tement, tout ou pratiquement tout le capital social de la société ou a le pouvoir de diriger ou d'influencer la direction de
l'administration ou l'orientation de toute autre société, que ce soit par le biais de la propriété des droits de vote, par le biais
de convention ou autrement.

2.6. En plus de ce qui précède, la Société pourra, dans les limites prévues par la Loi sur les Services de Paiement, réaliser

toutes  opérations  juridiques,  commerciales,  techniques  et  financières,  (en  ce  y  inclus  toutes  techniques  et  instruments
destinées à la protéger contre les risques liés au crédit, à l'échange de devise, au taux d'intérêt ou à toutes autres risques),
et, en général, toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social ainsi que toutes opérations
liées de manière directe ou indirecte aux domaines d'activité pré-décrits afin de faciliter l'accomplissement de son objet
social dans tous les domaines d'activité pré décrites.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9227 Diekirch, 50 Esplanade au L-2449 Luxembourg, 26 boulevard

Royal.

“ Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de

l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.”

<i>Déclaration des comparants

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5
du Code Pénal (financement du terrorisme).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du Comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et

demeure il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Carina RODRIGUES, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 5 août 2015. Relation: DAC/2015/13181. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 11 août 2015.

Référence de publication: 2015137539/96.
(150149057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

LuxST Finance S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 185.349.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

127236

L

U X E M B O U R G

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015137499/10.
(150149130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

LuxCitation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 140.406.

EXTRAIT

En date du 21 avril 2015, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
- Le renouvellement du mandat des administrateurs de la Société et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année

2019:

Le conseil d'administration continue à être composé par les personnes suivantes:
* Monsieur Knut Reinertz
* Monsieur Patrick Hansen
* Monsieur Philippe Kauffman
* Monsieur Nicolas Rouiller
- Les administrateurs suivants ont changé d'adresse professionnelle au 35a, avenue John F Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg:

* Philippe Kauffman
* Patrick Hansen
- Monsieur Knut Reinertz a changé d'adresse professionnelle au Suite 1512A, 15/F, Ocean Centre Harbour City, Hong-

Kong.

- L'acceptation de la démission de la société AUDEX &amp; Associés en tant que commissaire aux comptes de la Société

avec effet au 3 février 2014.

- La nomination de PRO FIDUCIAIRE Auditing &amp; Accounting S.à r.l., ayant son siège social au 20 rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 176 448
en tant que nouveau commissaire aux comptes de la Société avec effet au 3 février 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de la Société de l'année 2019.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 août 2015.

Référence de publication: 2015137498/30.
(150149408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

La Baleine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.251.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 20 mai 2015.

<i>Résolutions:

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société, avec effet au 20 mars 2015,

à l'adresse suivante:

44, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Par ailleurs, le Conseil d'Administration informe que l'adresse de:
JALYNE SA a changé également:
JALYNE SA: 44, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par Jacques BONNIER, 44, avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg.

<i>Pour le Conseil d'Administration
P. BOUYE / JALYNE
- / Signature
<i>Administrateur A / Administrateur B

Référence de publication: 2015137500/21.
(150148872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

127237

L

U X E M B O U R G

La Baleine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.251.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
44, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2015137501/13.
(150149137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

London Acquisition Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 683.654,84.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.574.

Suite à l'Assemblée Générale Annuelle en date du 04 août 2015, la décision suivante a été prise:
- Renouvellement du mandat de KPMG Luxembourg en qualité de Réviseur d'entreprises agréé, à compter du 04 août

2015 jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2016.

Veuillez prendre note que l'adresse de KPMG Luxembourg a changé du 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 39,

avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TMF Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015137492/16.
(150148614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

Lord Nominee S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 177.793.

EXTRAIT

Suite à un changement de dénomination sociale:
- NEO Capital Private Equity LLP, associé de la société susmentionnée, enregistré auprès de la Companies House sous

le numéro OC331931 et ayant son siège social au 36-38, Wigmore Street, GB-W1U 2LJ Londres, est désormais NEO
Investment Partners LLP.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2015137494/15.
(150148824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

Königinstrasse I S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.908.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

127238

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 11 août 2015.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2015137485/13.
(150149400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

L.D. Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 96.369.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015137486/10.
(150149330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

Mahle Behr Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 196.854.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015137552/11.
(150149357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

Mahle Behr Manufacturing Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 196.887.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the second day of July.
Before Us, Me Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, the undersigned,

There appeared:

MAHLE Behr Luxembourg Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 39, Boulevard John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under Section B, number 196.854 (the “Sole Sharehol-
der”),

here duly represented by Mr. Daniel BOONE, lawyer, residing professionnally in Luxembourg;
acting in his capacity as sole manager of the Sole Shareholder.
Such appearing party, represented as stated above, declares that:
1) It holds WHOLE and ALL of the twelve thousand five hundred (12,500) shares of MAHLE Behr Manufacturing

Management Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 39, Boulevard John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered
with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under Section B, number 196.887, incorporated pursuant to a
notarial deed received by the undersigned notary on 24 April 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the “Company”).

The share capital of the Company is fixed at EUR 12,500.-, represented by 12,500 shares with a par value of EUR 1.-

each, fully paid up;

2) The activities of the Company have been terminated;
3) Sitting in Extraordinary General Meeting modifying the articles of association of the Company, the Sole Shareholder

now pronounces the anticipated dissolution of the Company, with immediate effect;

4) The Sole Shareholder appoints itself as Company's liquidator, and in this capacity, requests the notary to act that all

the liabilities of the Company have been settled, whereas liabilities in relationship with the dissolution have been duly paid,

127239

L

U X E M B O U R G

and finally, with regards to possible liabilities of the Company unknown and unpaid at this time, it irrevocably takes upon
itself obligation to pay any such liabilities, if any, so that all liabilities of the Company have been regulated;

5) The remaining assets have been attributed to the Sole Shareholder;
6) The dissolution of the Company is to be considered as done and closed;
7) The sole manager of the Company is discharged from his duties and is granted full discharge;
8) The accounting books and documents of the Company will remain at the previous registered office of the Company

during five (5) years;

9) According to the law of November 12 

th

 , 2004, as amended, the Sole Shareholder is the economic beneficiary of the

transaction.

The one who bears a certified copy of this present deed is able to do publications and deposits.
In witness whereof, the undersigned notary who understands and speaks English, declares that on request of the appearing

party, this deed is worded in English followed by a French version. In case of divergences between the French and the
English version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing who is known to the notary by its last name, first name, civil

status, profession and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le deux juillet,
Par devant Me Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné,

A comparu:

MAHLE Behr Luxembourg Sàrl, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège

social à 39, Boulevard John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous la Section B, numéro 196.854 (l’«Associé Unique»),

ici valablement représentée par Monsieur Daniel BOONE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, agissant en sa qualité de gérant unique de l’Associé Unique.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-dessus, expose ce qui suit:
1) Elles détient la totalité des 12.500 parts sociales de MAHLE Behr Manufacturing Management Sàrl, une société à

responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 39, Boulevard John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro
196.887, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 avril 2015, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,-, représenté par 12.500 parts sociales d’une valeur nominale de

EUR 1.-chacune, entièrement libérées.

2) L'activité de la Société a cessé;
3) Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, l’Associé Unique prononce la

dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

4) L’Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout

le passif de la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la dissolution est dûment provisionné et qu'enfin, par
rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, il assume irrévocablement
l'obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé;

5) L'actif restant est attribué à L’Associé Unique;
6) La dissolution de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
7) Décharge pleine et entière est donnée au gérant unique, lesquels est relevé de ses fonctions;
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social;
9) Conformément à la loi du 12 novembre 2004, telle que modifiée, l’Associé Unique est le bénéficiaire économique

de l'opération.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande du comparant, le présent acte

de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, statut civil, profession

et domicile, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. BOONE, R. ARRENSDORFF.

127240

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 juillet 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 20771. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 10 août 2015.

Référence de publication: 2015137553/90.
(150148684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

MC Diamond s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 184.606.

L'an deux mille quinze, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Christian GIACALONE, gérant de société, né à Ashington (Royaume-Uni) le 14 septembre 1972, demeurant

à L-1857 Luxembourg, 20, rue du Kiem,

détenteur de cent vingt-quatre (124) parts sociales,
ici  représenté  aux  fins  des  présentes  par  Maître  Marc  THEISEN,  avocat,  demeurant  professionnellement  à  L-1148

Luxembourg, 12, rue Jean L'Aveugle, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 20 juillet 2015,
laquelle procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité

limitée "MC DIAMOND s. à r.l." (numéro d'identité 2014 24 05 467), avec siège social à L-1148 Luxembourg, 12, rue
Jean L'Aveugle, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 184.606, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 6 février 2014, publié au Mémorial C, numéro 959 du 15 avril 2014,

a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'insérer dans l'article 2 des statuts, relatif à l'objet social, un deuxième alinéa ayant la teneur

suivante:

«La  société  a  également  pour  objet  l'achat,  la  gestion,  la  location,  l'échange,  la  mise  en  valeur  et  la  vente  de  tous

immeubles bâtis et non-bâtis, situés dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations
accessoires nécessaires ou utiles à l'accomplissement dudit objet.»

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Christian GIACALONE comme gérant unique de la société

et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de nommer pour une durée indéterminée:
a) en qualité de gérant en ce qui concerne les activités visées au 1 

er

 alinéa de l'article 2 des statuts, relatif à l'objet social:

Monsieur Christian GIACALONE, préqualifié.
b) en qualité de gérant en ce qui concerne les activités visées au 2 

ème

 alinéa de l'article 2 des statuts, relatif à l'objet

social:

Monsieur  Darren  BRESSAGLIA,  gérant  de  société,  né  à  Luxembourg,  le  21  décembre  1982,  demeurant  à  L-2680

Luxembourg, 45, rue de Vianden.

La société est valablement engagée en toutes circonstances de la manière suivante:
a) en ce qui concerne les activités visées au 1 

er

 alinéa de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social, par la signature

individuelle du gérant Monsieur Christian GIACALONE;

b) en ce qui concerne les activités visées au 2 

ème

 alinéa de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social, par la signature

individuelle du gérant Monsieur Darren BRESSAGLIA.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à environ mille euros (€ 1.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

127241

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: THEISEN, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/24245. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 11 août 2015.

Référence de publication: 2015137564/55.
(150149036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

MC Universal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 86.735.

Nous vous informons par la présente de notre démission en tant que commissaire aux comptes de votre société, avec

effet immédiate.

Le 11.08.2015.

INVEST CONTROL SARL
E. Wirtz
<i>Gérant

Référence de publication: 2015137568/13.
(150149560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

Répertoire Culinaire Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 193.496.

L'an deux mil quinze, le deux juillet.
Par-devant Maître Karine Reuter, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

une Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des associés de la société à responsabilité limitée "REPER-

TOIRE CULINAIRE HOLDING S.àr.l. "(la «Société»), ayant son siège social au 21 A rue de la Libération, L-7347 Steinsel,

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2014,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 385 du 12 février 2015,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 193496.
L'Assemblée est ouverte à 11H05 heures sous la présidence de Monsieur Edouard d'Espous, demeurant Château de

Boisbonnard, F-37260 Villeperdue (France),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Arthur d'Espous, demeurant Château de Boisbonnard, F-37260 Villeperdue

(France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Didier Schönberger, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement

au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de présente Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social au 2 Place de Paris, L-2314 Luxembourg.
- Divers.
II.- Les associés représentés à la présente Assemblée et le nombre de parts sociales dont ils disposent ont été portés sur

une liste de présence, signée par la mandataire des associés représentés.

III.- Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

IV.- Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

associés représentés à la présente Assemblée, paraphées «ne varietur» par la mandataire desdits actionnaires, les membres
du bureau et le notaire instrumentant.

V.- L'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

127242

L

U X E M B O U R G

<i>Résolution unique

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 21 A rue de la Libération, L-7347 Steinsel au 2 Place

de Paris, L-2314 Luxembourg et modifie en conséquence l'article 4.1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 4.1. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg».
Aucun autre point ne restant à l'ordre du jour, l'assemblée générale a été clôturée à ... heures.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cette assemblée, s'élève approximativement à la somme de huit cents cinquante
euros 850,-EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils

ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signés: E. D'ESPOUS, A. D'ESPOUS, D. SCHÖNBERGER, K. REUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 10 juillet 2015. Relation: 2LAC/2015/15581. Reçu soixante-quinze euros

75.-.

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 11 août 2015.

Référence de publication: 2015137699/52.
(150149542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

QM Holdings 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 116.471.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2015.

TMF Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015137691/13.
(150148796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

LR-Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 199.261.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le trente juillet.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Hugues Jean Philippe LERMUSIAUX, ingénieur civil, né à Namur, Belgique, le 24 septembre 1974, demeu-

rant à B-6700 Arlon, rue des étangs 73.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il

déclare constituer par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, au Luxembourg ou à

l’étranger:

L’amélioration de la performance des entreprises ou organisations d’un point de vue technique, financier et structurel

(organisationnel et humain) pour tous projets au sens large du terme, tels que audits et conseils de tout projet ou avant-
projet ainsi que toutes activités liées au projet proprement dit (incluant entre autre la gestion d’entreprise, la gestion des
ressources humaines et également le suivi opérationnel).

127243

L

U X E M B O U R G

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société,

liée ou non.

La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles pour compte

propre tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger. La société pourra exercer l’activité d’agent immobilier et/ou
de promoteur immobilier

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant

directement ou indirectement à son objet.

Elle peut notamment s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en

partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement des ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.

Art. 3. La société prend la dénomination "LR-MANAGEMENT S. à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Lorsque la société compte plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après

avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est
toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 10. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est gérée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la

durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Si et aussi longtemps que la société sera unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi

ou les présents statuts à l'Assemblée Générale.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18.  L'excédent  favorable  du  bilan,  déduction  faite  des  charges  sociales,  amortissements  et  moins-values  jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales.

127244

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

L'intégralité des cinq cents (500) parts sociales est souscrite par Monsieur Hugues Jean Philippe LERMUSIAUX, pré-

qualifié.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2015.

<i>Décision de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant pour une durée illimitée:
Monsieur Hugues Jean Philippe LERMUSIAUX, ingénieur civil, né à Namur, Belgique, le 24 septembre 1974, demeu-

rant à B-6700 Arlon, rue des étangs 73.

2. Le siège social est fixé à 42-44 rue de Hollerich L-1740 Luxembourg.

<i>Avertissement

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la Société doit obtenir une autorisation d'établissement de la

part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commer-
ciale, avertissement que le comparant reconnaît avoir reçu.

<i>Évaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. LERMUSIAUX et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 4 août 2015. 1LAC/2015/24668. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING Paul.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 12 août 2015.

Référence de publication: 2015138284/99.
(150150008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.

NUR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 177.443.

Der alleinige Anteilinhaber, Herr Jaho DEDEIC, Maurer, wohnhaft in L-4640 Pifferdingen 12, avenue d'Obercorn,

beschliesst den Sitz der Gesellschaft von der jetzigen Adresse in L-2222 Luxembourg, 84, rue de Neudorf nach L-1342
Luxembourg, 42, rue de Clausen, zu verlegen.

Luxemburg, den 29. Juni 2015.

Unterschrift.

Référence de publication: 2015135047/11.
(150145664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

NB Renaissance Partners (A) SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, Rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 193.549.

<i>Dépôt complémentaire au dépôt du 7 août 2015 enregistré sou la référence L150146764

Modifications du contrat social (le “Contrat”) de NB Renaissance Partners (A) SCSp suite aux résolutions du conseil

de gérance de NB Renaissance Associates GP S.à r.l., agissant en son propre nom et en tant qu'associé-gérant-commandité
de NB Renaissance Associates SCSp, agissant en son propre nom et en tant qu'associé-gérant-commandité de, inter alios,
NB Renaissance Partners (A) SCSp signées en date du 14 avril 2015

127245

L

U X E M B O U R G

<i>Objet social

Les objets de la Société sont (a) d'identifier des Investissements (tels que définis dans le Contrat) potentiels, (b) d'acquérir,

de détenir, de financer, de gérer et de disposer des Investissements, (c) dans l'attente de l'utilisation ou de décaissement des
fonds, d'investir ces fonds en conformité avec les modalités du Contrat, et (d) de faire tout ce qui est nécessaire ou désirable
pour l'accomplissement des objets susmentionnés ou la réalisation de tout pouvoir définis dans le Contrat et de faire tout
acte ou action relatif à en connexion avec cela permis par la Loi de 1915 (telle que définie dans le Contrat) et la Loi AIFM
(telle que définie au Contrat).

<i>Désignation des gérants et pouvoirs de signature

NB Renaissance Manager S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B196239, ayant un capital social de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500) (le «Gérant») est exclusivement investi des pouvoirs de gestion, de contrôle et d'exploitation de la
Société. Les tiers traitant avec la Société sont en droit de s'en remettre au pouvoir et à l'autorité du Gérant tel qu'en dispose
le Contrat. Les Associés Commanditaires (tels que définis dans le Contrat) ne doivent pas prendre part à la gestion, au
contrôle ou à l'exploitation de la Société et ne doivent avoir aucune autorité ou droit d'agir au nom de la Société relativement
à toute affaire. Les Associés Commanditaires ne doivent avoir aucun droit de vote concernant les affaires de la Société (tel
qu'en dispose le Contrat ou la Loi de 1915), autre que le droit de vote relatif aux modifications du Contrat et autres affaires
dont disposent le Contrat et la Loi de 1915.

Le Gérant doit avoir le pouvoir, pour le compte et au nom de la Société, de procéder à la réalisation de tout objet de la

Société et d'effectuer tout acte qu'il pourrait, à son entière discrétion, considérer nécessaire ou désirable, incluant les pou-
voirs mentionnés à la section 3.1 (b) du Contrat.

Le Gérant peut déléguer à toute Personne ou Personnes (tels que ces termes sont définis dans le Contrat), incluant sans

limitation, l'AIFM (tel que défini dans le Contrat) conformément au Contrat de Gestion d'Investissement (tel que défini
dans le Contrat), tout ou partie des pouvoirs, droits, privilèges, devoirs et discrétion lui ayant été dévolus et cette délégation
peut être faite selon les modalités et conditions définies par le Gérant; à condition qu'aucune délégation ne modifie les
obligations et responsabilités du Gérant en tant que gérant de la Société au regard de la Loi de 1915, de la Loi AIFM et du
Contrat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2015.

NB Renaissance Manager S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2015137604/43.
(150149089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

Opera House, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 982.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 169.226.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Opera House S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015135059/11.
(150146441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

Opera House Music, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.752.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 171.033.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

127246

L

U X E M B O U R G

<i>Pour Opera House Music S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015135062/11.
(150146463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

Supernova JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.590,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 197.283.

En date du 2 juillet 2015, l’associé unique AASA LuxCo S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, a transféré 624.997 parts sociales de catégorie A, 499 parts sociales de catégorie B, 499 parts sociales de
catégorie C, 499 parts sociales de catégorie D, 499 parts sociales de catégorie E, 500 parts sociales de catégorie F, 500
parts sociales de catégorie G, 500 parts sociales de catégorie H, 500 parts sociales de catégorie I et 500 parts sociales de
catégorie J à Supernova Investco Limited, avec siège social à Road Town, Morgan &amp; Morgan Building Pasea Estate,
Tortola, Les Iles Vierges Britanniques qui les acquiert;

En conséquence, les associés de la société sont les suivants:

- AASA LuxCo S.à r.l., précité, avec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627.503 parts sociales de catégorie A

501 parts sociales de catégorie B
501 parts sociales de catégorie C

501 parts sociales de catégorie D

501 parts sociales de catégorie E

- Supernova Investco Limited, précité, avec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624.997 parts sociales de catégorie A

499 parts sociales de catégorie B
499 parts sociales de catégorie C

499 parts sociales de catégorie D

499 parts sociales de catégorie E

500 parts sociales de catégorie F

500 parts sociales de catégorie G
500 parts sociales de catégorie H

500 parts sociales de catégorie I

500 parts sociales de catégorie J

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2015.

Référence de publication: 2015138458/32.
(150150183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2015.

Sem Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 106.324.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 juillet 2015 que:
1. Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés:
- Madame Laurence BARDELLI,
- Monsieur Vincent WILLEMS,
- Monsieur Bertrand MICHAUD.
Ils prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2021.
2. Le mandat du commissaire aux comptes SER.COM Sàrl, B 117942, a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'Assemblée

Générale qui se tiendra en 2021.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015135217/17.
(150145630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

127247

L

U X E M B O U R G

Segepa S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 170.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
SEGEPA S.A. SPF
Signature

Référence de publication: 2015135214/12.
(150146135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

SEGRO Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 177.317.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015135215/10.
(150145757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

Stelarlux Industrie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 158.446.

Les comptes annuels au 31 mai 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015135195/10.
(150145777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

Quatar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 11, Am Buurgbierg.

R.C.S. Luxembourg B 189.826.

Les statuts coordonnés au 27 juillet 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 06 août 2015.

Référence de publication: 2015135139/10.
(150146453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

Smile Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 132.138.

Les comptes annuels au 31 mai 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015135184/10.
(150145750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

127248


Document Outline

Alistair Investissement S.A.

Anasco Holding Company S.A.

Aquarium Wasserbillig S.à r.l.

ARMADEGE Benelux

Avantag Energy S.à r.l.

Batipart Immo Europe S.à r.l.

Bisectra

Cidron Disco S.à r.l.

Cidron Iugo S.à r.l.

Cidron Liberty Systems S.à r.l

Décembre 2 S.à r.l.

Deutsche Oel &amp; Gas S.A.

Digest S.A.

Dorna-SBK Holdings S.à r.l.

Falke Holding

Fondation de l'Architecture et de l'Ingénierie, Luxembourg

Global International Investments SICAV

ING Direct

Isalpha

ISM Conseil

Königinstrasse I S.à r.l.

La Baleine S.A.

La Baleine S.A.

L.D. Group S.A.

London Acquisition Luxco S.à r.l.

Lord Nominee S.à r.l.

LR-Management S.à r.l.

LuxCitation S.A.

LuxST Finance S.A.

Mahe S.A.

Mahle Behr Luxembourg Sàrl

Mahle Behr Manufacturing Management Sàrl

Malderen S.A.

Manima S.A.

Manulife Global Fund

MC Diamond s.à r.l.

MC Universal S.A.

Megaram.lu

Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF

MIMOSA Invest

Minerva Management Services S.A.

Mirlo Investments S.à r.l.

MMB S.A.

NB Renaissance Partners (A) SCSp

NUR S.à r.l.

Opal One Sicav

Opera House

Opera House Music

QM Holdings 4 S.à r.l.

Quatar S.A.

Répertoire Culinaire Holding S.à r.l.

Rizzo Group S.à r.l.

SADMI (Luxembourg) S.A.

SEB Green Bond Fund

Segepa S.A. SPF

SEGRO Luxembourg S.à r.l.

Sem Investment S.A.

Senjo Payments Europe S.A.

Shere Khan SPF, S.A.

Smile Invest S.A.

Stelarlux Industrie S.A.

Supernova JV S.à r.l.