This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2642
28 septembre 2015
SOMMAIRE
Adagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126795
Armador S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126799
Brevaco Succ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126803
Britanny Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126803
Chambertin S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126807
Cofinimmo Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
126806
Coldod S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126806
Comifar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126809
Compagnie Générale de Matériaux et Cons-
truction S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126805
Com-Pass S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126805
Concrete Settlement Agent S.à r.l. . . . . . . . . . .
126810
Consultlux GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126804
Co.Re.Mont S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126808
Corestate Capital Holding S.A. . . . . . . . . . . . .
126772
Crescent European Specialty Lending (Unleve-
red) A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126809
Crescent European Specialty Loan S.à r.l. . . .
126809
CVC Administration Services S.à r.l. . . . . . . .
126804
CVC Investments Vista II S.C.A. . . . . . . . . . . .
126804
CVC Investments Vista S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
126809
Cyaniris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126803
Dîon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126804
Fitness Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126812
Fleet Renting SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126812
General Marva S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126811
GFI Software IP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126811
Grana Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126812
Gregelvi S.à.r.l. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126811
GRE Spirit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126812
Grosvenor Continental Europe Holdings S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126812
Grosvenor First European Property Invest-
ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126813
Hamamelis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126814
Harlequin Enterprises II B.V./ S.à.r.l. . . . . . . .
126813
Harvey Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126814
HBS Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126814
Henderson Joint Ventures Property Funds
Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126813
Hines-Laser Brindley 9 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
126813
Hôtel MEYER S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126814
HV. Com International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
126815
Knoxville Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
126799
Lglobal Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126797
LI-Invest Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126795
Merck-Finanz AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126816
Meyrin Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126816
Michael Page International (Luxembourg) . .
126816
Quaesta Capital Umbrella SICAV-SIF . . . . . .
126796
Quilvest Asset Management S.A. . . . . . . . . . . .
126816
R42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126799
Rockspring TransEuropean Properties V FIG
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126770
Rockspring TransEuropean Properties VI
Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126770
Rose Lila S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126801
RREEF Pan-European Infrastructure Lux S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126799
S.C.I. Amavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126800
Syncro Funds (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126799
Valore Credit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126812
Weblab S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126801
Yoseom s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126802
You immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126802
126769
L
U X E M B O U R G
Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Rockspring TransEuropean Properties V FIG S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 188.171.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty first day of July;
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at 74 Avenue Victor Hugo Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg
THERE APPEARED:
Rockspring TransEuropean Properties V Holdings S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 having its registered
office at 40, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register (Registre de commerce et des Sociétés) under number B 173.242 (the "Sole Shareholder"),
here represented by Mr. Youssef Lqoule, with professional address at 40 avenue Monterey L-2163 Luxembourg, by
virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on 21 July 2015.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
a. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of Rockspring TransEuropean Properties V FIG S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with a share capital of twelve thousand and five
hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered address at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 188.171 (the “Company”);
the Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer residing in Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg) on June 13
th
, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2373 on
4 September 2014; the articles of association of the Company and have not been amended since.
b. That the agenda of the meeting is worded as follows:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the denomination of the Company to “Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l.”
and subsequently, amendment of Art. 1. of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
“Name
The name of the company is ”Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l.” (the “Company”). The Com-
pany is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), and these
articles of incorporation (the "Articles")."
2. Miscellaneous.
That on the basis on the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the denomination of the Company to Rockspring TransEuropean Properties
VI Holdings S.à r.l. and subsequently, amend Art. 1. of the articles of association of the Company which shall henceforth
read as follows:
“ Art. 1. Name. The name of the company is ”Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l.” (the "Com-
pany"). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the
"Law"), and these articles of incorporation (the "Articles")."
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the proxyholder of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
126770
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, he signed together with the notary the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt et un juillet.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Rockspring TransEuropean Properties V Holdings S.à r.l., une Société à responsabilité limitée, constituée selon les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.242 (l’ "Ac-
tionnaire Unique"),
ici représenté par Monsieur Youssef Lqoule, ayant son adresse au 40, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé au Luxembourg le 21 juillet 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
a. Que l'Actionnaire Unique détient toutes les actions dans le capital social de Rockspring TransEuropean Properties V
FIG S.à r.l., Société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B B 188.171 (la "Société");
la Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), en date 13 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2373
du 4 septembre 2014; les statuts de la Société n’ont depuis lors plus été changés.
b. Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
<i>Agenda:i>
1. Modification de la Dénomination Sociale de la Société qui prendra comme dénomination «Rockspring TransEuropean
Properties VI Holdings S.à r.l.» pour ainsi modifier l’article Art. 1. des statuts de la Société (les «Statuts»), qui aura la
teneur suivante:
" Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l." (la
"Société"). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en
particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents
statuts (les "Statuts")."
2. Divers.
Que sur la base de l'ordre du jour ci-dessus, l'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de modifier l’article Art. 1. des Statuts qui aura la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l." (la
"Société"). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en
particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents
statuts (les "Statuts")."
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de
cette assemblée générale extraordinaire des présentes sont estimés à mille deux cents euros (1.200.- EUR).
Le notaire instrumentant, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare qu'à la demande du
mandataire de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, le présent acte notarié a été préparé à Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, il a signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: Y. Lqoule et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 juillet 2015. 2LAC/2015/16761. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): André Muller.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
126771
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 5 août 2015.
Référence de publication: 2015135146/109.
(150145822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
Corestate Capital Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 199.780.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-first day of August.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Ralph Winter, having his professional address at CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Switzer-
land);
represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, with professional address at 101, rue cents, L-1319 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
2. Thomas Landschreiber, having his professional address at CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug
(Switzerland);
represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, with professional address at 101, rue cents, L-1319 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
3. Intershop Holding AG, a public limited liability company (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Switzerland,
having its registered office at Puls 5 Giessereistrasse 18, Postbox 1601,CH-8031 Zürich registered with the commercial
register of the canton Zurich (Switzerland) under number CHE-103.878.436;
represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, with professional address at 101, rue cents, L-1319 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
4. Christine Winter, having her professional address at CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Swi-
tzerland);
represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, with professional address at 101, rue cents, L-1319 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and
5. Silke Otto, having her professional address at Ortsstaße 29, 87746 Daxberg (Germany);
represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, with professional address at 101, rue cents, L-1319 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
The said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary,
shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing parties referred to in items 1. to 5. above shall be referred to as the Subscribers.
The Subscribers, represented as stated above, have requested the undersigned notary to enact the following articles of
incorporation of a company, which they declare to establish as follows:
1. Form, Name and number of shareholders.
1.1 Form and name
There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Corestate Capital Holding
S.A." (the Company).
1.2 Number of shareholders
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company shall not be
dissolved upon the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Where the Company has only one shareholder, any reference to the shareholders in the articles of association of the
Company (the Articles) shall be a reference to the Sole Shareholder.
2. Registered office.
2.1 Place and transfer of the registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within such municipality by
a resolution of the management board of the Company (the Management Board). The registered office may also be trans-
ferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the shareholders of
the Company (the General Meeting) adopted in the manner provided for in Article 10 with respect to the amendments of
the Articles.
2.2 Branches, offices, administrative centres and agencies
126772
L
U X E M B O U R G
The Management Board shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies
wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.
3. Duration.
3.1 Unlimited duration
The Company is formed for an unlimited duration.
3.2 Dissolution
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner provided
for in Article 10 with respect to the amendments of the Articles.
4. Purpose. The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether
directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies or
other assets including but not limited to real estate assets, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other
securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual
funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating
thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among
other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).
The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds,
debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets including, without
limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations
or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments relating
to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments
designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose shall
include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing
matters.
In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction
which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.
The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly
connected with its purpose or which may favour its development.
5. Share capital.
5.1 Outstanding share capital
The share capital is set at EUR 35,000 (thirty-five thousand Euro), represented by 1,750,000 (one million seven hundred
fifty thousand) shares having a nominal value of EUR 0.02 (two cents of an Euro) each.
5.2 Share capital increase and share capital reduction
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the
manner required for amendment of the Articles, as provided for in Article 10.
5.3 Pre-emptive rights
In the case of an issuance of shares in consideration for a payment in cash or an issuance in consideration for a payment
in cash of those instruments covered in article 32-4 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the Companies Act), including, without limitation, convertible bonds that entitle their holders to subscribe for or to be
allocated with shares, the shareholders shall have pro rata pre-emptive rights with respect to any such issuance in accordance
with the Companies Act.
6. Shares.
6.1 Form of the shares
The shares of the Company are in registered form, are bearer shares or are shares in dematerialised form, at the option
of the shareholder. They shall be in registered form until they are fully paid-up.
6.2 Share register and share certificates
The terms of this Articles 6.2 are applicable to shares in registered form only.
A share register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Such
register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by it, the
126773
L
U X E M B O U R G
nominal value or accounting par value paid in on each such share, the issuance of shares, the transfer of shares and the
dates of such issuance and transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.
Certificates of these entries may be issued to the shareholders and such certificates, if any, will be signed by the chairman
of the Management Board or by any other two members of the Management Board.
6.3 Ownership and co-ownership of shares
The Company will recognise only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person, the
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as
sole owner in relation to the Company.
6.4 Bearer shares
Bearer shares must be deposited with a depositary and transferred in accordance with the Companies Act.
6.5 Dematerialised shares
Shares in registered form and shares in bearer form may be converted into shares in dematerialised form in accordance
with the Companies Act.
Dematerialised shares are materialised by their booking on a securities account in the name of the account holder with
a liquidation body, a central account keeper, an account keeper or a foreign account keeper. Transfers shall be carried out
by means of book entry transfers.
6.6 Share repurchases
The Company may repurchase its own shares within the limits set forth by law.
7. Transfer of shares.
7.1 Shares in registered form
A transfer of shares in registered form may be effected by a written declaration of transfer entered in the share register
of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding
suitable powers of attorney, and in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article
1690 of the Luxembourg civil code.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the
transferor and the transferee satisfactory to the Company.
7.2 Shares in bearer form
The transfer of bearer shares shall be made in accordance with Luxembourg law.
8. Powers of the general meeting. As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder has the same
powers as those conferred on the General Meeting. In such a case, any reference in these Articles to decisions made or
powers exercised by the General Meeting shall be a reference to decisions made or powers exercised by the Sole Share-
holder. Decisions made by the Sole Shareholder are documented in the form of minutes or written resolutions, as the case
may be.
In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
9. Annual general meeting of the shareholders - Other meetings. The annual General Meeting shall be held, in accordance
with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place within
the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting, on the last Friday of April of
each year at 10.00 a.m. Luxembourg time. If such a day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting
shall be held on the following business day, at the same hour.
Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of the
meeting.
10. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and vote.
10.1 Right and obligation to convene a General Meeting
The Management Board, the supervisory board of the Company (the Supervisory Board) as well as the statutory auditors,
if any, may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month,
if shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing, with an indication of the agenda.
10.2 Quorum, majority requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the majority
of the votes expressed by the shareholders present or represented, no quorum of presence being required.
However, resolutions to amend the Articles may only be passed in a General Meeting where at least one half of the share
capital is represented (the Presence Quorum) and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the
case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Presence Quorum is not
reached, a second General Meeting may be convened in accordance with applicable law. Such convening notice shall
reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting
126774
L
U X E M B O U R G
shall deliberate validly regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be
passed, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting.
In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to shares in which the
shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into account.
The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with
the unanimous vote of the shareholders and bondholders.
10.3 Waiver of convening notice formalities
If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being
duly convened and informed of the agenda of the General Meeting set by the Management Board or by the statutory auditors,
as the case may be, the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if all the shareholders of the Company
are present or represented at a General Meeting and agree unanimously to set the agenda of the General Meeting, the General
Meeting may be held without having been convened by the Management Board or by the statutory auditors, as the case
may be.
10.4 Voting rights attached to the shares
Each share entitles its holder to one vote.
10.5 Participation by proxy
A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a shareholder, as its proxy
in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such written
proxies at a General Meeting.
10.6 Vote by correspondence
If provided for in the relevant convening notice, the shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin)
provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and signature of the relevant shareholder,
(ii) an indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the Convening
Notice with the proposals for resolutions relating to each agenda item and (iv) the vote (approval, refusal, abstention) on
the proposals for resolutions relating to each agenda item. The voting bulletins in which it is not indicated in which way
the votes shall be cast or if the vote is to be withheld are considered void. Copies of voting bulletins that are transmitted
by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such voting bulletins at a General Meeting.
In order to be taken into account, the voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours) before
the relevant General Meeting.
10.7 Participation in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications
If provided for in the relevant convening notice, a shareholder may participate in a General Meeting by conference call,
video conference or similar means of communication whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified,
(ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed
on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall
constitute presence in person at such meeting.
10.8 Bureau
The shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the share-
holders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the General
Meeting.
10.9 Minutes and certified copies
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any
shareholder who wishes to do so.
However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere
must be signed by the chairman of the Management Board or by any two other members of the Management Board.
11. Management board.
11.1 Management
The Company is managed by the Management Board under the supervision of the Supervisory Board.
11.2 Minimum number of members of the Management Board and term of office
The Management Board must be composed of at least two members. However, for so long as the Company has a Sole
Shareholder or has a share capital of less than EUR 500,000 (five hundred thousand Euros), the Company may be managed
by a sole director (the Sole Director).
The members of the Management Board shall be elected for a term ending on the last day of the third calendar year
following the calendar year in which the member of the Management Board is appointed (for example, if a member of the
Management Board is appointed during the calendar year 2015, his mandate shall end on 31 December 2018).
The Sole Director shall be elected for a term ending on (a) 30 September of the calendar year in which the Sole Director
is appointed if the Sole Director is appointed before 30 September of that calendar year (for example, if the Sole Director
is appointed before 30 September 2015, his mandate shall end on 30 September 2015) or (b) 31 December of the calendar
126775
L
U X E M B O U R G
year in which the Sole Director is appointed if the Sole Director is appointed after 30 September and before 31 December
of that calendar year.
The members of the Management Board and the Sole Director shall be eligible for reappointment.
11.3 Permanent representative
Where a legal person is appointed as a member of the Management Board (the Management Board Legal Entity), the
Management Board Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent)
who will represent the Management Board Legal Entity as a member of the Management Board in accordance with articles
60bis-4 of the Companies Act. The terms of this provision are applicable mutatis mutandis to the Sole Director.
11.4 Appointment, removal and co-optation
The members of the Management Board or the Sole Director shall be appointed by the Supervisory Board. The Super-
visory Board shall also determine the number of members of the Management Board, their remuneration (including any
variable remuneration under any form) and the terms of their office (including without limitation any notice period regarding
their resignation). A member of the Management Board or the Sole Director may be removed with or without cause and/
or replaced, at any time, by a resolution adopted by the Supervisory Board.
In the event of one or more vacancy in the office of members of the Management Board because of death, resignation
or otherwise, the remaining members of the Management Board may appoint one or more members of the Management
Board, as the case may be, to fill any such vacancy until the following meeting of the Supervisory Board.
12. Meetings of the management board.
12.1 Chairman
The Management Board shall appoint a chairman (the Chairman) from among its members and may choose a secretary,
who need not be a member of the Management Board, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the Management Board. The Chairman will chair all meetings of the Management Board. In his/her absence, the other
members of the Management Board will appoint another member of the Management Board as chairman pro tempore who
will chair the relevant meeting.
12.2 Procedure to convene a Management Board meeting
The Management Board meets as often as the business and interests of the Company require.
The Management Board shall meet upon call by the Chairman or any two members of the Management Board at the
place indicated in the meeting notice. Meetings of the Management Board must be held in Luxembourg and no meetings
of the Management Board may be held abroad.
Written meeting notice of the Management Board shall be sent to all the members of the Management Board at least 7
(seven) days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature
of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Management Board. Convening
notices may be sent by telefax or e-mail to the members of the Management Board.
No such written meeting notice is required if all the members of the Management Board are present or represented
during the meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting.
In addition, if all the members of the Management Board are present or represented during the meeting and they agree
unanimously to set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set
out above.
A member of the Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents
in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting
of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined in
a schedule previously adopted by a resolution of the Management Board; provided that all the members of the Management
Board that were not present or represented at such meeting must be informed reasonably in advance of any such scheduled
meeting.
12.3 Participation by conference call, video conference or similar means of communication
Only in circumstances of emergency, a meeting of the Management Board may be held by conference call, video
conference or by similar means of communication whereby (i) the members of the Management Board attending the meeting
can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the
meeting is performed on an on-going basis and (iv) the members of the Management Board can properly deliberate.
Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Management
Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.
12.4 Proceedings
(a) Quorum and majority requirements
The Management Board may validly deliberate and make decisions only if at least one half of its members is present or
represented. Decisions are made by the majority of the votes of the members present or represented. If a member of the
Board abstains from voting or does not participate to a vote in respect of a proposed resolution, this abstention or non-
participation is taken into account in calculating the majority as a vote against the proposed resolution.
(b) Participation by proxy
126776
L
U X E M B O U R G
A member of the Management Board may act at any meeting of the Management Board by appointing in writing another
member as his or her proxy. A member of the Management Board may represent more than one member of the Management
Board by proxy, under the condition however that at least two members of the Management Board are present at the meeting.
Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written proxies
at a meeting of the Management Board.
(c) Casting vote of Chairman
In the case of a tied vote, the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall not have a casting vote.
(d) Conflict of interest
In the event of a conflict of interest as described in Article 24, where at least one member of the Management Board is
conflicted with respect to a certain matter, (a) the Management Board may validly debate and make decisions on that matter
only if at least one-half of its members who are not conflicted are present or represented and (b) decisions are made by a
majority of the remaining members of the Management Board present or represented who are not conflicted. In the event
that the quorum requirement set out under item (a) cannot be reached because of the conflict of interests of members of
the Management Board in respect of any such matter, the Management Board may submit that matter to the General Meeting
and the General Meeting has the power to make a decision on such matter.
12.5 Written resolutions
Notwithstanding the foregoing, only in circumstances of emergency, a resolution of the Management Board may also
be passed in writing. Such resolution shall consist of one or more documents containing the resolutions, signed by each
member of the Management Board, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under
Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.
12.6 Sole Director
Article 12 does not apply where the Company is managed by a Sole Director.
13. Minutes of meetings of the management board or resolutions of the sole director.
13.1 Form of the resolutions of the Sole Director
The resolutions passed by the Sole Director shall be documented by minutes or by resolutions in writing. The minutes
or the resolutions in writing made by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.
13.2 Signature of Management Board minutes
The minutes of any meeting of the Management Board shall be signed by the Chairman or the chairman pro tempore,
as the case may be. In addition, any other member of the Management Board present or represented at such meeting may
sign the minutes.
13.3 Signature of copies or extracts of Management Board minutes and resolutions of the Sole Director
Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Management Board or the Sole Director, as the case
may be, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, or any two members
of the Management Board or the Sole Director, as the case may be.
14. Powers of the management board and the sole director. The Management Board is vested with the broadest powers
to perform or cause to be performed any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All
powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting or the Supervisory Board
fall within the authority of the Management Board.
At least every three months, the Management Board will submit a written report to the Supervisory Board, in which it
describes the status of the Company's business activities and the provisional development. In addition, the Management
Board will inform the Supervisory Board of any events that might have a noticeable influence on the Company's situation.
As long as the Company has only a Sole Director, the Sole Director has the same powers as those conferred on the
Management Board. In such a case, any reference in these Articles to decisions made or powers exercised by the Mana-
gement Board shall be a reference to decisions made or powers exercised by the Sole Director.
15. Prior consent matters. The Management Board must require the consent of the Supervisory Board for the following
transactions and measures. Such consent will generally have to be obtained by the Management Board from the Supervisory
Board in writing prior to the execution of the respective transaction or measure. However, in exceptional cases where the
Management Board is required to act immediately in order to prevent a significant harm to the Company, the Management
Board may execute such transactions and measures without the prior written consent of the Supervisory Board but must
obtain the written consent of the Supervisory Board as soon as possible after the execution of such transaction or measure.
The Supervisory Board may also release the Management Board in advance from obtaining its prior written consent for
certain individual or general business transactions or measures.
The Management Board shall procure that, with respect to the Company’s Subsidiaries, the consent of the Supervisory
Board is required and obtained via the Management Board and the management of its respective subsidiary for all trans-
actions and measures listed in this Article 15.
The transactions and measures subject to the prior consent of the Supervisory Board are the following:
126777
L
U X E M B O U R G
(a) the acquisition and disposal of participations in other companies or any consolidation or amalgamation with any
other company as well as the acquisition and disposal of businesses or enterprises or parts thereof which has or is expected
to have a significant effect on the business of the Group;
(b) the entry into any joint venture, partnership, consortium or other similar arrangement which has or is expected to
have a significant effect on the business of the Group;
(c) the entry into, surrender or material variation of any unusual or onerous contract which has or is expected to have a
significant effect on the business of the Group;
(d) the giving of any guarantee or indemnity which has or is expected to have a significant effect on the business of the
Group;
(e) the entry or amendment of any credit agreement or other financing transaction which has or is expected to have a
significant effect on the business of the Group;
(f) dealing in a way (including the acquisition or disposal, whether outright or by way of licence or otherwise howsoever)
with intellectual property other than in the ordinary course of business which has or is expected to have a significant effect
on the business of the Group; and
(g) real estate transactions which have an significant impact on the Group.
For the purpose of this Article 15,
Group means the Company and its Subsidiaries; and
and
Subsidiary shall have the meaning set out in article 309 (2) of the Companies Act, as applied in conjunction with article
310 of the Companies Act.
Notwithstanding the above, the Supervisory Board may include in internal regulations of the Supervisory Board a list
of transactions and measures of the Management Board (and the Companies’ Subsidiaries as set out in paragraph 2 above)
that require the prior consent of the Supervisory Board, and the Management Board shall be informed accordingly of those
restrictions. The restrictions set out in these internal regulations shall not be binding towards third parties.
16. Delegation of powers of the management board.
16.1 Daily management
The Management Board may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière), who may be a shareholder
or not, or who may be a member of the Management Board or not, to the exclusion of any member of the Supervisory
Board, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters pertaining to the daily management and
affairs of the Company.
16.2 Permanent representative of the Company
The Management Board may appoint a person, who may be a shareholder or not, and who may be a director or not, to
the exclusion of any member of the Supervisory Board, as permanent representative for any entity in which the Company
is appointed as a member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, in the name
and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as a member of the board of directors of any
such entity.
16.3 Delegation to perform specific functions and committees
The Management Board is also authorised to appoint a person, either a director or not, to the exclusion of any member
of the Supervisory Board, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.
The Management Board may also appoint committees or sub-committees in order to deal with specific tasks, to advise
the Management Board or to make recommendations to the Management Board and/or, as the case may be, the General
Meeting, the members of which may be selected either from among the members of the Management Board or not, to the
exclusion of any member of the Supervisory Board.
17. Binding signatures.
17.1 Signatory powers of directors
The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members of the
Management Board or (ii) in the case of a Sole Director, the sole signature of the Sole Director.
17.2 Signatory powers in respect of the daily management
In respect of the daily management, the Company will be bound by the sole signature of any person appointed to that
effect in accordance with Article 16.1.
17.3 Grant of specific powers of attorney
The Company shall be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to whom
specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.
18. Supervision.
18.1 Supervisory Board
The Company's management by the Management Board is supervised by the Supervisory Board.
126778
L
U X E M B O U R G
18.2 Minimum number of members of the Supervisory Board and term of office
The Supervisory Board must be composed of at least three members.
The members of the Supervisory Board shall be elected for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for
re-appointment.
18.3 Permanent representative
Where a legal person is appointed as a member of the Supervisory Board (the Supervisory Board Legal Entity), the
Supervisory Board Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who
will represent the Supervisory Board Legal Entity as a member of the Supervisory Board in accordance with article 60bis-14
and 51bis of the Companies Act.
18.4 Appointment, removal and co-optation
The members of the Supervisory Board shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall also
determine the number of members of the Supervisory Board, their remuneration and the terms of their office (including
without limitation any notice period regarding their resignation). A member of the Supervisory Board may be removed
with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.
The General Meeting may award a total sum as fees for the members of the Supervisory Board. In this case, the Super-
visory Board shall allocate the total sum awarded among its members.
In the event of one or more vacancy(ies) in the office of a member of the Supervisory Board because of death, resignation
or otherwise, the remaining members of the Supervisory Board may appoint one or more members of the Supervisory
Board, as the case may be, to fill any such vacancy until the following meeting of the General Meeting.
19. Meetings of the supervisory board.
19.1 Supervisory Board Chairman
The Supervisory Board shall appoint a chairman (the Supervisory Board Chairman) from among its members and may
choose a secretary, who need not be a member of the Supervisory Board, and who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the Supervisory Board. The Supervisory Board Chairman will chair all meetings of the Super-
visory Board. In his/her absence, the other members of the Supervisory Board will appoint another member of the
Supervisory Board as chairman pro tempore who will chair the relevant meeting.
19.2 Procedure to convene a Supervisory Board meeting
The Supervisory Board shall meet upon call by the Supervisory Board Chairman or any two members of the Supervisory
Board at the place indicated in the meeting notice. The Supervisory Board Chairman must call a meeting of the Supervisory
Board as soon as reasonably practicable upon receipt of a written request from the Management Board with an indication
of the agenda. Meetings of the Supervisory Board must be held in Luxembourg and no meetings of the Supervisory Board
may be held abroad.
The Supervisory Board meets as often as the business and interests of the Company require. In addition, meetings of
the Supervisory Board shall take place at least four times per accounting year.
Written meeting notice of the Supervisory Board shall be sent to all the members of the Supervisory Board at least 7
(seven) days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature
of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Supervisory Board. Convening
notices may be sent by telefax or e-mail to the members of the Supervisory Board.
No such written meeting notice is required if all the members of the Supervisory Board are present or represented during
the meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In
addition, if all the members of the Supervisory Board are present or represented during the meeting and they agree unani-
mously to set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out
above.
A member of the Supervisory Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies
of consents in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at
a meeting of the Supervisory Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and
at places determined in a schedule previously adopted by a resolution of the Board; provided that all the members of the
Supervisory Board that were not present or represented at such meeting must be informed reasonably in advance of any
such scheduled meeting.
19.3 Participation by conference call, video conference or similar means of communication
A meeting of the Supervisory Board may be held by conference call, video conference or by similar means of commu-
nication whereby (i) the members of the Supervisory Board attending the meeting can be identified, (ii) all persons
participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-
going basis and (iv) the members of the Supervisory Board can properly deliberate, only in circumstances of emergency,
except that the first meeting of the Supervisory Board after the incorporation of the Company may in any case be held by
conference call, video conference or by similar means of communication. Participation in a meeting by such means shall
constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Supervisory Board held by such means of communication
will be deemed to be held in Luxembourg.
126779
L
U X E M B O U R G
19.4 Proceedings
(a) Quorum and majority requirements
The Supervisory Board may validly deliberate and make decisions only if at least one half of its members is present or
represented. Decisions are made by the majority of the votes of the members present or represented. If a member of the
Supervisory Board abstains from voting or does not participate to a vote in respect of a proposed resolution, this abstention
or non-participation is taken into account in calculating the majority as a vote against the proposed resolution.
(b) Participation by proxy
A member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing another
director as his or her proxy. A member of the Supervisory Board may represent more than one member of the Supervisory
Board by proxy, under the condition however that at least two members of the Supervisory Board are present at the meeting.
Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written proxies
at a meeting of the Supervisory Board.
(c) Casting vote of Supervisory Board Chairman
In the case of a tied vote, the Supervisory Board Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall have
a casting vote.
(d) Conflict of interest
In the event of a conflict of interest as described in Article 24, where at least one member of the Supervisory Board is
conflicted with respect to a certain matter, (a) the Supervisory Board may validly debate and make decisions on that matter
only if at least one-half of its members who are not conflicted are present or represented and (b) decisions are made by a
majority of the remaining members of the Supervisory Board present or represented who are not conflicted. In the event
that the quorum requirement set out under item (a) cannot be reached because of the conflict of interests of members of
the Supervisory Board in respect of any such matter, the Supervisory Board may submit that matter to the General Meeting
and the General Meeting has the power to make a decision on such matter.
19.5 Written resolutions
Notwithstanding the foregoing, only in circumstances of emergency, a resolution of the Supervisory Board may also be
passed in writing. Such resolution shall consist of one or more documents containing the resolutions, signed by each member
of the Supervisory Board, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg
law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.
19.6 Minutes of meetings of the Supervisory Board
19.7 Signature of Supervisory Board minutes
The minutes of any meeting of the Supervisory Board shall be signed by the Supervisory Board Chairman or the chairman
pro tempore, as the case may be. In addition, any other member of the Supervisory Board present or represented at such
meeting may sign the minutes.
19.8 Signature of copies or extracts of Supervisory Board minutes
Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Supervisory Board which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the Supervisory Board Chairman, or any two members of the Supervisory
Board, as the case may be.
20. Powers of the supervisory board. The Supervisory Board permanently controls the management of the Company by
the Management Board without interfering in the management.
The Supervisory Board may require the Management Board to provide information of any kind which it needs to exercise
its supervision. The Supervisory Board may undertake or arrange for any investigations necessary for the performance of
its duties.
In addition, the Supervisory Board grants the Management Board or any Subsidiaries its consent to carry out the trans-
actions and measures set out in Article 15.
The Supervisory Board shall have the right to examine all the activities of the Company.
Its members shall have access, at the Company's registered office, to the Company's books, accounts, correspondence,
minutes and in general, to any documents of the Company. At the request of the Supervisory Board, the Management Board
shall give any information that is necessary for the Supervisory Board's control of the management. In addition, the Su-
pervisory Board can proceed to or require any verification in relation to its function.
21. Delegation of powers of the supervisory board. The Supervisory Board may appoint one or more of its members for
the performance of one or more specific tasks.
It may also decide to form committees within the Supervisory Board. The composition and the activities of such com-
mittees will be determined by the Supervisory Board and they will act under its control. However, the Supervisory Board
cannot delegate to any committee the powers which are expressly attributed to the Supervisory Board itself by the Com-
panies Act or the Articles, and such delegation to any committee cannot result in a reduction or limitation of the powers
of the Management Board.
126780
L
U X E M B O U R G
22. Membership of the management board and the supervisory board. No person can simultaneously be a member of
the Management Board and a member of the Supervisory Board.
However, in the event of any vacancy at the Management Board, the Supervisory Board may appoint one of its members
to act on the Management Board. During this period, the duties of this person in its capacity as a member of the Supervisory
Board will be suspended.
23. Conflict of interests.
23.1 Procedure regarding a conflict of interest
In the event that a member of the Management Board or a member of the Supervisory Board, as the case may be, has
an interest opposite to the interest of the Company in any transaction of the Company that is submitted to the approval of
the Management Board or the Supervisory Board, as the case may be, such member of the Management Board or the
Supervisory Board shall make known to the Management Board or the Supervisory Board, as the case may be, such opposite
interest at that meeting and shall cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. The member
of the Management Board or the member of the Supervisory Board may not take part in the deliberations relating to that
transaction and may not vote on the resolutions relating to that transaction. The transaction, and the member's interest
therein, shall be reported to the next following General Meeting.
In the case of a conflict of interest between a member of the Management Board and the Company in respect of a
transaction, the approval of the Supervisory Board is in addition required.
23.2 Exceptions regarding a conflict of interest
Article 24.1 does not apply to resolutions of the Management Board or the Sole Director or the Supervisory Board
concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length
terms.
23.3 Absence of conflict of interest
A member of the Management Board or the Supervisory Board who serves as director, officer or employee of any
company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such
affiliation with such other company or firm, be held as having an interest opposite to the interest of the Company for the
purpose of this Article 24.
23.4 Conflict of interest of the Sole Director
For so long as the Company has a Sole Director, in the event that the Sole Director has an opposite interest to the interest
of the Company with respect to a transaction entered into by the Company and the Sole Director, this conflict of interest
shall be set out in the minutes or the written resolutions of the Sole Director, as the case may be, recording the approval of
that transaction.
24. Statutory auditor(s) (commissaire(s)) - Independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision
agréé).
24.1 Statutory auditor (commissaire)
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s)). The statutory
auditor(s) shall be appointed for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for re-appointment.
The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting, which will determine their number, their remuneration
and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or
without cause.
24.2 Independent auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé)
However, no statutory auditor(s) shall be appointed if, instead of appointing statutory auditor(s), one or more independent
auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé) are appointed by the General Meeting to perform the
statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law. The independent auditor(s) shall be
appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered into from time to time
by the Company and the independent auditor(s). The independent auditor(s) may only be removed by the General Meeting
for just cause.
25. Accounting year. The accounting year of the Company begins on 1 January and ends on 31 December of each year.
26. Annual accounts.
26.1 Responsibility of the Management Board
The Management Board shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of
the annual General Meeting.
26.2 Submission of the annual accounts to the statutory auditor(s) and the Supervisory Board
At the latest 1 (one) month prior to the annual General Meeting, the Management Board will submit the annual accounts
together with the report of the Management Board (if any) and such other documents as may be required by law to (i) the
statutory auditor(s) of the Company (if any), who will thereupon draw up its (their) report(s) and (ii) the Supervisory Board,
who will present to the annual General Meeting its observations on the report of the Management Board and on the annual
accounts.
126781
L
U X E M B O U R G
26.3 Availability of documents at the registered office
At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the annual accounts, the report(s) of the Management
Board (if any) and of the statutory auditor(s) or the independent auditor(s), as the case may be, and such other documents
as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company, where they will be available for
inspection by the shareholders during regular business hours.
27. Allocation of results.
27.1 Allocation to the legal reserve
From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by
law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share
capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below 10% (ten per cent.) of the share
capital of the Company.
27.2 Allocation of results by the annual General Meeting
The annual General Meeting shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of
dividends, as the case may be.
27.3 Interim dividends
The Management Board may decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for
distribution, including share premium and capital surplus, under the conditions and within the limits laid down in the
Companies Act.
27.4 Payment of dividends
Dividends may be paid in euro or any other currency chosen by the Management Board and they may be paid at such
places and times as may be determined by the Management Board within the limits of any decision made by the General
Meeting (if any).
28. Dissolution and liquidation.
28.1 Principles regarding the dissolution and the liquidation
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required
for amendment of these Articles, as set out in Article 10. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation
shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General
Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the
liquidator(s).
28.2 Distribution of liquidation surplus
Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among shareholders
shall be distributed to the shareholders, by way of advance payments or after payment (or provisions, as the case may be)
of the Company's liabilities.
29. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with Lu-
xembourg law.
<i>Transitional provisionsi>
The first accounting year begins today and ends on 31 December 2015.
<i>Subscriptioni>
The Articles having thus been established, the Subscribers, represented as stated above, hereby declare that they subscribe
in cash to 1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand) shares, having a nominal value of EUR 0.02 (two cents of
an Euro) each, representing the total share capital of the Company, and having a subscription price of EUR 0.02 (two cents
of an Euro) per share, as follows:
Ralph Winter, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,124,108 (one million one hundred twenty-four thousand
one hundred eight) shares;
Thomas Landschreiber, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . 117,032 (one hundred seventeen thousand thirty-two) shares;
Intershop Holding AG, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . .
491,232 (four hundred ninety-one thousand two hundred
thirty-two) shares;
Christine Winter, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,333 (eleven thousand three hundred thirty-three) shares;
Silke Otto, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,295 (six thousand two hundred ninety-five) shares.
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand) shares
The subscription price of all these shares has been fully paid up by the Subscribers by way of contributions in cash in
an aggregate amount of EUR 35,000 (thirty-five thousand Euro), so that the amount of EUR 35,000 (thirty-five thousand
Euro) paid by the Subscribers is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to
the undersigned notary and the notary expressly bears witness to it.
The contributions in cash are allocated entirely to the share capital of the Company.
126782
L
U X E M B O U R G
<i>Statement - Costsi>
The undersigned notary declares that the conditions provided by articles 26, 26-3 and 26-5 (with article 26-1 paragraph
(2) being not applicable as no contribution for assets other than cash has been made at the incorporation of the Company)
of the Companies Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euros (1,500.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The Subscribers, represented as stated above, representing the whole of the share capital, have held an extraordinary
general meeting of the shareholders of the Company and passed the following resolutions by unanimous vote:
1. that the Supervisory Board will be composed of 3 (three) members;
2. the number of independent auditor (réviseur d’entreprises agréé or cabinet de révision agréé) is set at one (1);
3. that there be appointed as members of the Supervisory Board:
- Ralph Winter, self employed management consultant, whose professional address is at CORESTATE Capital AG,
Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Switzerland);
- Urs Felder, self employed tax and accounting expert, whose professional address is at FELUR Swiss Treuhand AG,
Sihlamtsstrasse 5 8001 Zurich (Switzerland); and
- Andreas Wirz, architect, member of executive board of Intershop Holding AG, whose professional address is at In-
tershop Holding AG, Puls 5 - Giessereistrasse 18, Postbox 1601, CH-8031 Zurich (Switzerland).
4. that there be appointed Ernst & Young, 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg,
as independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company;
5. that the terms of office of the members of the Supervisory Board will expire after the annual General Meeting that
will approve the annual accounts of the accounting year ending on 31 December 2017;
6. that the terms of office of the independent auditor will expire after annual General Meeting that will approve the
annual accounts of the accounting year ending on 31 December 2015; and
7. that the address of the registered office of the Company is set at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version. At the request of the same appearing persons
and in case of divergences between English and the German versions, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names,
civil status and residences, the said persons appearing signed the present deed together with the notary.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahr Zweitausendfünfzehn, am einundzwanzigsten August.
Vor mir, Notar Henri Hellinckx, mit Amtsstsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
Erscheinen:
1. Ralph Winter, mit Dienstanschrift bei CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Schweiz),
vertreten durch Herrn Régis Galiotto, privater Angestellter von Notar Henri Hellinckx, mit Dienstsitz in 101, rue cents,
L-1319 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vertretungsvollmacht.
2. Thomas Landschreiber, mit Dienstanschrift bei CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Schweiz),
vertreten durch Herrn Régis Galiotto, privater Angestellter, mit Dienstsitz in 101, rue cents, L-1319 Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vertretungsvollmacht.
3. Intershop Holding AG, eine gemäß dem Recht Schweiz bestehende Aktiengesellschaft mit eingetragenem Sitz in Puls
5 Giessereistrasse 18, Postfach 1601,CH-8031 Zürich, eingetragen in das Handelsregister des Kantons Zürich (Schweiz)
unter der Nummer CHE-103.878.436,
vertreten durch Herrn Régis Galiotto, privater Angestellter, mit Dienstsitz in 101, rue cents, L-1319 Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vertretungsvollmacht.
4. Christine Winter, mit Dienstanschrift bei CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Schweiz),
vertreten durch Herrn Régis Galiotto, privater Angestellter, mit Dienstsitz in 101, rue cents, L-1319 Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vertretungsvollmacht, und
5. Silke Otto, mit Dienstanschrift in Ortsstraße 29, 87746 Daxberg (Deutschland),
vertreten durch Herrn Régis Galiotto, privater Angestellter, mit Dienstsitz in 101, rue cents, L-1319 Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vertretungsvollmacht.
126783
L
U X E M B O U R G
Die genannten Vertretungsvollmachten wurden mit dem Vermerk keine Änderungen versehen und durch die Erschie-
nenen sowie den unterzeichneten Notar unterschrieben und werden dieser Urkunde als Anlage beigeheftet und gleichzeitig
mit ihr bei den Registerbehörden eingereicht.
Die unter Ziffern 1. bis 5. genannten Erschienenen werden hier als die Zeichner bezeichnet.
Die Zeichner haben, durch die oben genannten Vertretungen, den unterzeichneten Notar gebeten, die folgende Satzung
einer Gesellschaft zu beurkunden, die nach ihrem Bekunden mit den folgenden Merkmalen gründen:
1. Form, Name und Anzahl der Aktionäre.
1.1 Form und Name
Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit der Bezeichnung „Corestate Capital Holding S.A.“ (die Ge-
sellschaft).
1.2 Anzahl der Aktionäre
Die Gesellschaft kann einen Aktionär (der Einzelaktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird bei
Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Insolvenz, Abwicklung oder Bankrott des Einzelaktionärs nicht aufgelöst.
Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, bezieht sich das Wort Aktionäre in dieser Satzung der Gesellschaft (die
Satzung) auf den Einzelaktionär.
2. Eingetragener Sitz.
2.1 Ort und Verlegung des eingetragenen Sitzes
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch einen Beschluss des Vorstands der
Gesellschaft (der Vorstand) innerhalb dieser Gemeinde verlegt werden. Der eingetragene Sitz kann außerdem durch einen
Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (die Hauptversammlung), der in der in Artikel 10 für
Änderungen dieser Satzung vorgesehenen Weise gefasst wird, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.
2.2 Niederlassungen, Geschäftsstellen, Verwaltungsstätten und Agenturen
Der Vorstand ist außerdem befugt, Niederlassungen, Geschäftsstellen, Verwaltungsstätten und Agenturen einzurichten,
wo er dies für geeignet hält, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Großherzogtums Luxemburg.
3. Dauer.
3.1 Unbefristete Dauer
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.
3.2 Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in der in Artikel 10 für Änderungen
dieser Satzung vorgesehenen Weise gefasst wird, aufgelöst werden.
4. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, der Besitz und die Veräußerung in jeglicher Form, durch
jegliche Mittel, sei es direkt oder indirekt, von Anteilen, Rechten oder Beteiligungen an, sowie von Obligationen von
luxemburgischen und ausländischen Unternehmen oder anderen Vermögenswerten. Dazu gehören beispielsweise Liegen-
schaften, (ii) der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf jegliche andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf,
Tausch oder auf jegliche andere Weise, von Beteiligungstiteln, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheinen und
anderen Wertpapieren oder Finanzinstrumenten jeglicher Art (darunter von luxemburgischen oder ausländischen Invest-
mentfonds oder ähnlichen Organismen begebene Schuldscheine oder Anteile) sowie diesbezügliche Abrechnungsforde-
rungen, Forderungen oder Darlehen oder andere Kreditvereinbarungen und Verträge oder Kontrakte, und (iii) die
Eigentümerschaft, Administration, Entwicklung und Verwaltung eines Portfolios an Vermögenswerten (darunter, unter
anderem, die in (i) bis (iii) oben genannten Vermögenswerte.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Form leihweise Mittel aufnehmen. Sie kann jeden Darlehensvertrag abschließen und
Schuldscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate, Anteile, Bezugsscheine, Optionsscheine und jede Art von
Forderungs- oder Beteiligungstiteln begeben, unter anderem auch in einem oder mehreren Emissionsprogramm(en). Die
Gesellschaft kann Mittel verleihen, darunter die Erlöse aus Mittelaufnahmen und/oder Emissionen von Wertpapieren an
ihre Tochterunternehmen, verbundener Unternehmen oder an andere Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann außerdem Bürgschaften stellen und Sicherheitsrechte an einigen oder allen ihrer Vermögenswerte
gewähren, auch beispielsweise im Wege der Verpfändung, Übertragung oder Belastung zugunsten oder zum Nutzen von
Dritten, um ihre Obligationen oder die Obligationen ihrer Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder anderer
Unternehmen zu besichern.
Die Gesellschaft kann Swaps, Terminkontrakte (Futures, Forwards), Derivate, Optionen, Pensionsgeschäfte, Wertpa-
pierleihgeschäfte und ähnliche Transaktionen eingehen, abschließen, ausführen und liefern. Die Gesellschaft kann generell
alle Techniken einsetzen und alle Instrumente im Zusammenhang mit ihren Investments zum Zwecke ihrer effizienten
Verwaltung verwenden, darunter beispielsweise Techniken und Instrumente, die für den Schutz der Gesellschaft gegen
Kreditrisiken, Währungsschwankungen, Zinssatzschwankungen und andere Risiken entwickelt wurden.
126784
L
U X E M B O U R G
Die obigen Beschreibungen sind weit auszulegen und ihre Aufzählung ist nicht erschöpfend. Der Zweck der Gesellschaft
umfasst alle Transaktionen oder Verträge, die von der Gesellschaft geschlossen oder eingegangen werden, sofern sie nicht
im Widerspruch zu den vorgenannten Belangen stehen.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Maßnahmen für die Kontrolle und Überwachung ergreifen und alle Ge-
schäftsvorfälle oder Transaktionen ausführen, die sie in der Erreichung und Entwicklung ihres Zwecks für notwendig hält.
Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, industriellen und finanziellen Transaktionen ausführen, die direkt oder indirekt
mit ihrem Zweck zusammenhängen oder ihre Entwicklung unter Umständen begünstigen.
5. Grundkapital.
5.1 Im Umlauf befindliches Grundkapital
Das Grundkapital beläuft sich auf 35.000 EUR (fünfunddreißigtausend Euro), verbrieft durch 1.750.000 (eine Million
siebenhundertfünfzigtausend) Aktien im Nennwert von je 0,02 EUR (zwei Cent eines Euro).
5.2 Erhöhung des Grundkapitals und Herabsetzung des Grundkapitals
Das Grundkapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss, der durch die Hauptversammlung in der in Artikel 10
für Satzungsänderungen verlangten Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Vorkaufsrechte
Im Falle einer Emission von Aktien gegen Barzahlung oder einer Emission gegen Barzahlung von Instrumenten, die
unter Artikel 32 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in der jeweils geltenden Fassung
(das Gesellschaftsgesetz) fallen, darunter beispielsweise Wandelanleihen, die ihren Inhabern das Recht erteilen, Aktien zu
zeichnen oder zugeteilt zu bekommen, haben die Aktionäre das proportional anteilmäßige Vorkaufsrecht in Bezug auf
solche Emissionen gemäß dem Gesellschaftsgesetz.
6. Aktien.
6.1 Form der Aktien
Die Aktien der Gesellschaft sind auf den Namen lautende Aktien, Inhaberaktien oder buchmäßig verwaltete Aktien, je
nach Wahl des Aktionärs. Sie sind Namensaktien, solange sie nicht vollständig eingezahlt sind.
6.2 Aktienverzeichnis und Aktienzertifikate
Die Bestimmungen in diesem Artikel 6.2 gelten lediglich für Namensaktien.
Am eingetragenen Sitz wird ein Aktienverzeichnis geführt. Es steht dort zur Einsichtnahme durch jeden Aktionär zur
Verfügung. Dieses Verzeichnis hat den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Sitz oder gewählten Wohnsitz, die Anzahl
der von ihm gehaltenen Aktien, den Nennwert oder den für jede dieser Aktien rechnerischen Wert, die Emission von Aktien,
die Übertragung von Aktien und die Termine dieser Emissionen und Übertragungen anzugeben. Das Eigentum an den
Aktien wird durch die Eintragung in das Verzeichnis begründet.
Für die Aktionäre können Zertifikate über diese Eintragungen ausgestellt werden. Diese Zertifikate werden gegebe-
nenfalls durch den Vorsitzenden des Vorstands oder jeweils zwei Mitglieder des Vorstands unterschrieben.
6.3 Eigentum und Miteigentum an den Aktien
Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an. Falls eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, ist die
Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller mit der Aktie verbundenen Rechte auszusetzen, bis eine einzige Person als der
alleinige Eigentümer in der Beziehung zur Gesellschaft bestellt wurde.
6.4 Inhaberaktien
Inhaberaktien müssen bei einer Verwahrstelle hinterlegt und gemäß dem Gesellschaftsgesetz übertragen werden.
6.5 Buchmäßig verwaltete Aktien
Namens- und Inhaberaktien können in buchmäßig verwaltete Aktien gemäß dem Gesellschaftsgesetz umgewandelt
werden.
Buchmäßig verwaltete Aktien werden durch ihre Verbuchung auf einem Wertpapierkonto auf den Namen des Konto-
inhabers bei einer Abrechnungsstelle, einem zentralen Kontoführer, einem Kontoführer oder einem ausländischen Kon-
toführer verbrieft.
Übertragungen werden mittels Umbuchungen ausgeführt.
6.6 Rückkauf von Aktien
Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
7. Übertragung von Aktien.
7.1 Auf den Namen lautende Aktien
Eine Übertragung von Namensaktien kann durch eine schriftliche Feststellung der Übertragung im Aktienverzeichnis
der Gesellschaft erfolgen. Diese Feststellung der Übertragung muss durch den Übertragenden und den Übertragungsemp-
fänger oder durch entsprechend bevollmächtigte Personen und gemäß den Vorschriften für die Übertragung von Forde-
rungen in Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches ausgeführt werden.
Die Gesellschaft kann als Nachweis für die Übertragung andere Übertragungsurkunden akzeptieren, welche die Zu-
stimmung des Übertragenden und des Übertragungsempfängers in einer für die Gesellschaft überzeugenden Weise belegen.
126785
L
U X E M B O U R G
7.2 Inhaberaktien
Die Übertragung von Inhaberaktien erfolgt gemäß dem Recht Luxemburgs.
8. Befugnisse der Hauptversammlung. Sofern die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, besitzt der Einzelaktionär
dieselben Befugnisse, wie sie der Hauptversammlung zuerkannt sind. In diesem Fall stellt ein in dieser Satzung vorge-
nommener Verweis auf durch die Hauptversammlung gefasste Beschlüsse oder durch die Hauptversammlung ausgeübte
Befugnisse einen Verweis auf von dem Einzelaktionär gefasste Beschlüsse oder durch den Einzelaktionär ausgeübte Be-
fugnisse dar. Von dem Einzelaktionär gefasste Beschlüsse werden, je nach Fall, in Form von Niederschriften oder
schriftlichen Beschlüssen dokumentiert.
Wenn mehrere Aktionäre bestehen, verkörpert eine regelkonform konstituierte Hauptversammlung das Organ der Ak-
tionäre der Gesellschaft.
9. Jahreshauptversammlung der aktionäre - Sonstige Versammlungen. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre fin-
det gemäß luxemburgischen Recht in Luxemburg an der Adresse des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft oder an einem
anderen Ort in der Gemeinde des eingetragenen Sitzes statt, der in der Einberufung der Versammlung angegeben ist, am
letzten Freitag des Monats April eines jeden Jahres um 10:00 Uhr Luxemburger Zeit statt. Falls dieser Tag kein Geschäftstag
in Luxemburg ist, findet die Jahreshauptversammlung am nächsten folgenden Geschäftstag zur selben Uhrzeit statt.
Andere Hauptversammlungen der Aktionäre können an einem Ort und Termin stattfinden, die in den entsprechenden
Einberufungen angegeben sind.
10. Anzeigen, Quorum, Einberufungsanzeigen, Stimmrechtsvollmachten und Stimmabgabe.
10.1 Recht und Pflicht zur Einberufung einer Hauptversammlung
Der Vorstand, der Aufsichtsrat der Gesellschaft (der Aufsichtsrat) sowie gegebenenfalls die Rechnungsprüfer, können
eine Hauptversammlung einberufen. Sie sind verpflichtet, sie so einzuberufen, dass sie innerhalb eines Monats stattfindet,
wenn Aktionäre, die ein Zehntel des Kapitals repräsentieren dies schriftlich verlangen, mit Angabe der Tagesordnung.
10.2 Quorum, erforderliche Mehrheiten und Neueinberufung einer Hauptversammlung bei Nichterreichen des Quorums
Sofern nicht gesetzlich oder durch diese Satzung anderweitig vorgeschrieben, werden Beschlüsse der Hauptversamm-
lung durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der persönlich oder vertreten anwesenden Aktionäre gefasst. Für die
Beschlussfähigkeit (Quorum) ist keine Mindestanwesenheit erforderlich.
Allerdings bedürfen Beschlüsse zur Änderung dieser Satzung der Zustimmung durch eine Hauptversammlung, in der
mindestens eine Hälfte des Grundkapitals vertreten ist (die Mindestanwesenheit) und die Tagesordnung muss die vorge-
schlagenen Satzungsänderungen sowie gegebenenfalls den Text derjenigen Artikel der Satzung angeben, die sich auf den
Zweck oder die Form der Gesellschaft beziehen. Wenn die Mindestanwesenheit nicht erreicht ist, kann eine zweite Haupt-
versammlung gemäß dem geltenden Recht einberufen werden. Diese Einberufungsanzeige muss die Tagesordnung
enthalten und das Datum und die Ergebnisse der vorherigen Hauptversammlung angeben. Die zweite Hauptversammlung
beschließt wirksam, unabhängig von dem Anteil des vertretenen Kapitals. Auf beiden Versammlungen bedürfen Beschlüsse
für ihre Wirksamkeit der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der auf der entsprechenden Hauptversammlung ab-
gegebenen Stimmen.
Bei der Berechnung der Mehrheit in Bezug auf Beschlüsse einer Hauptversammlung werden Stimmen in Bezug auf
Aktien, in denen die Aktionäre sich der Stimme enthalten, einen leeren (blanc) oder ungültigen (nul) Stimmzettel abgeben
oder die nicht an der Abstimmung teilnehmen, nicht berücksichtigt.
Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft und die Erhöhung der Einschusspflichten ihrer Aktionäre bedürfen der
einstimmigen Zustimmung der Aktionäre und Anleiheinhaber.
10.3 Verzicht auf die Formvorschrift der Einberufungsanzeige
Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft in einer Hauptversammlung persönlich oder vertreten anwesend sind und sie sich
selbst als ordnungsgemäß einberufen und über die vom Vorstand oder gegebenenfalls die Rechnungsprüfer aufgestellte
Tagesordnung der Hauptversammlung betrachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Anzeige stattfinden. Zu-
sätzlich gilt, dass wenn alle Aktionäre der Gesellschaft in einer Hauptversammlung persönlich oder vertreten anwesend
sind und einstimmig beschließen, die Tagesordnung der Hauptversammlung aufzustellen, die Hauptversammlung statt-
finden kann, ohne dass sie durch den Vorstand oder gegebenenfalls die Rechnungsprüfer einberufen wurde.
10.4 Mit den Aktien verbundene Stimmrechte
Jede Aktie berechtigt ihren Inhaber zu einer Stimme.
10.5 Teilnahme durch Stimmrechtsvertreter
Ein Aktionär kann in einer Hauptversammlung agieren, indem er eine andere Person, die nicht unbedingt ein Aktionär
sein muss, schriftlich zu seinem Stimmrechtsvertreter bestellt. Kopien von schriftlichen Stimmrechtsvollmachten, die per
Telefax oder E-Mail übermittelt werden, können als Nachweis dieser schriftlichen Stimmrechtsvollmacht in einer Haupt-
versammlung akzeptiert werden.
10.6 Abstimmung per Brief
Wenn es in der entsprechend Einberufungsanzeige angegeben ist, können die Aktionäre schriftlich (mittels eines Ab-
stimmformulars) abstimmen, sofern die schriftlichen Abstimmformulare folgende Angaben enthalten: (i) Name, Vorname,
126786
L
U X E M B O U R G
Anschrift und Unterschrift des entsprechenden Aktionärs, (ii) Angabe der Aktien, für die der Aktionär dieses Recht ausüben
möchte, (iii) Tagesordnung gemäß der Angaben in der Einberufungsanzeige mit Beschlussvorlagen in Bezug auf jeden
Tagesordnungspunkt und (iv) das Votum (Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung) zu den Beschlussvorlagen in Bezug auf
jeden Tagesordnungspunkt. Abstimmformulare, in denen nicht angegeben ist, auf welche Weise die Voten gezählt werden
oder wenn das Votum einbehalten wird, gelten als nichtig. Kopien von Abstimmformularen, die per Telefax oder E-Mail
übermittelt werden, können als Nachweis dieser Abstimmformulare in einer Hauptversammlung akzeptiert werden.
Damit die Abstimmformulare berücksichtigt werden, müssen die Abstimmformulare 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor
der entsprechenden Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingegangen sein.
10.7 Teilnahme an einer Hauptversammlung mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikati-
onsmittel
Wenn dies in der entsprechenden Einberufungsanzeige angegeben ist, kann ein Aktionär an einer Hauptversammlung
mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen, bei denen (i) die an der Ver-
sammlung teilnehmenden Aktionäre identifiziert werden können, (ii) alle an der Versammlung teilnehmenden Personen
sich untereinander hören und miteinander sprechen können, (iii) die Übermittlung der Versammlung ohne Unterbrechung
stattfindet und (iv) die Aktionäre sich ordnungsgemäß aussprechen können. Eine Teilnahme an einer Versammlung mittels
dieser Medien gilt als persönliche Anwesenheit in dieser Versammlung.
10.8 Büro
Die Aktionäre wählen einen Vorsitzenden der Hauptversammlung. Der Vorsitzende bestellt den Schriftführer und die
Aktionäre bestellen einen Stimmenauszähler. Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenauszähler bilden zu-
sammen das Büro der Hauptversammlung.
10.1 Niederschriften und beglaubigte Ausfertigungen
Die Niederschriften der Hauptversammlung werden durch die Büromitglieder der Hauptversammlung sowie durch jeden
Aktionär, der dies tun möchte, unterschrieben.
Wenn jedoch die Beschlüsse der Hauptversammlung beglaubigt werden müssen, müssen Kopien oder Auszüge für die
gerichtliche oder anderweitige Verwendung durch den Vorsitzenden des Vorstands oder durch zwei andere Vorstands-
mitglieder unterschrieben werden.
11. Vorstand.
11.1 Geschäftsführung
Die Gesellschaft wird durch den Vorstand unter der Aufsicht des Aufsichtsrats geführt.
11.2 Mindestanzahl der Vorstandsmitglieder und Dauer des Mandats
Der Vorstand muss aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen. Solange die Gesellschaft jedoch einen Einzelaktionär
hat oder ihr Grundkapital weniger als 500.000 (fünfhunderttausend Euro) beträgt, kann die Gesellschaft durch einen Ein-
zelvorstand (der Einzelvorstand) geführt werden.
Die Vorstandsmitglieder werden für eine Dauer bestellt, die am letzten Tag des dritten Kalenderjahres endet, das auf
das Kalender folgt, in dem das Vorstandsmitglied bestellt wird (wenn zum Beispiel ein Vorstandsmitglied im Laufe des
Kalenderjahres 2015 bestellt wird, endet sein Mandat am 31. Dezember 2018).
Der Einzelvorstand wird für eine Mandatsdauer bestellt, die (a) am 30. September des Kalenderjahres endet, in dem der
Einzelvorstand bestellt wird, wenn der Einzelvorstand vor dem 30. September dieses Kalenderjahres bestellt wird (wenn
zum Beispiel der Einzelvorstand vor dem 30. September 2015 bestellt wird, dann endet sein Mandat am 30. September
2015) oder (b) am 31. Dezember des Kalenderjahres endet, in dem der Einzelvorstand bestellt wird, wenn der Einzelvorstand
nach dem 30. September und vor dem 31. Dezember dieses Kalenderjahres bestellt wird.
Die Vorstandsmitglieder und der Einzelvorstand können erneut bestellt werden.
11.3 Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Vorstandsmitglied bestellt wird (das Vorstandsmitglied als juristische Person), muss
das Vorstandsmitglied als juristische Personen eine natürliche Person zum ständigen Vertreter (représentant permanent)
bestellen, der das Vorstandsmitglied als juristische Person gemäß Artikel 60bis Absatz 4 Gesellschaftsgesetz vertritt. Die
Bestimmungen dieser Regelung gelten sinngemäß für den Einzelvorstand.
11.4 Bestellung, Abberufung und Ergänzungswahl
Die Vorstandsmitglieder oder der Einzelvorstand werden durch den Aufsichtsrat bestellt. Der Aufsichtsrat legt auch die
Anzahl der Vorstandsmitglieder, ihre Vergütung (einschließlich jeder Form einer variablen Vergütung) sowie die Dauer
ihres Mandats (beispielsweise auch eine Frist für ihren Rücktritt vom Mandat) fest. Ein Vorstandsmitglied oder der Ein-
zelvorstand kann jederzeit durch einen Beschluss des Aufsichtsrats fristlos oder unter Wahrung einer Frist abberufen und/
oder ersetzt werden.
Bei einem oder mehreren vakanten Mandat(en) im Vorstand aufgrund von Tod, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
können die verbleibenden Vorstandsmitglieder ein oder gegebenenfalls mehrere Vorstandsmitglied(er) bis zur nächsten
Aufsichtsratssitzung bestellen, um die Vakanz zu besetzen.
126787
L
U X E M B O U R G
12. Vorstandssitzungen.
12.1 Vorsitzender
Der Vorstand ernennt einen Vorsitzenden (den Vorsitzenden) aus dem Kreis seiner Mitglieder und kann einen Schrift-
führer ernennen, der nicht unbedingt Vorstandsmitglied sein muss. Er ist für die Erstellung der Niederschriften der
Vorstandssitzungen verantwortlich. Der Vorsitzende leitet alle Vorstandssitzungen. Bei Abwesenheit des Vorstandsvor-
sitzenden ernennen die anderen Vorstandsmitglieder ein anderes Vorstandsmitglied zum temporären Vorsitzenden, der die
entsprechende Sitzung leitet.
12.2 Verfahren für die Einberufung einer Vorstandssitzung
Der Vorstand tagt so oft, wie es der Betrieb und die Interessen der Gesellschaft erfordern.
Der Vorstand tagt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Vorstandsmitglieder am in der Einberu-
fungsanzeige der Sitzung angegebenen Ort. Vorstandssitzungen müssen in Luxemburg stattfinden. Vorstandssitzungen
dürfen nicht im Ausland stattfinden.
Eine schriftliche Anzeige der Vorstandssitzung wird an alle Vorstandsmitglieder spätestens 7 (sieben) Tage vor dem
für diese Sitzung angesetzten Termin gesendet, außer in dringenden Fällen, in denen die Art der Umstände kurz in der
Einberufungsanzeige für die Vorstandssitzung anzugeben sind. Einberufungsanzeigen können an die Vorstandsmitglieder
per Telefax oder E-Mail gesendet werden.
Eine derartige Einberufungsanzeige ist nicht erforderlich, wenn alle Vorstandsmitglieder persönlich oder vertreten in
der Sitzung anwesend sind und wenn sie feststellen, dass sie ordnungsgemäß informiert wurden und ihnen die Tagesordnung
der Sitzung vollständig bekannt war. Zusätzlich gilt, dass wenn alle Vorstandsmitglieder in der Sitzung persönlich oder
vertreten anwesend sind und einstimmig beschließen, die Tagesordnung der Sitzung aufzustellen, die Sitzung stattfinden
kann, ohne dass sie in der oben angegebenen Form einberufen wurde.
Ein Vorstandsmitglied kann durch seine schriftliche Zustimmung auf die schriftliche Einberufung verzichten. Kopien
von Zustimmungen, die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, können als Nachweis dieser schriftlichen Zustimmung
in einer Vorstandssitzung akzeptiert werden. Separate schriftliche Anzeigen sind nicht für Sitzungen erforderlich, die zu
Terminen und an Orten stattfinden, die in einem Zeitplan vorher durch Beschluss des Vorstands festgelegt wurden, wobei
gilt, dass alle Vorstandsmitglieder, die in dieser Sitzung nicht persönlich oder vertreten anwesend waren, angemessen
frühzeitig über eine solche planmäßige Sitzung informiert wurden.
12.3 Teilnahme mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel
Lediglich in dringenden Fällen kann eine Vorstandssitzung mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen
Kommunikationsmitteln teilnehmen, bei denen (i) die an der Sitzung teilnehmenden Vorstandsmitglieder identifiziert
werden können, (ii) alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich untereinander hören und miteinander sprechen können,
(iii) die Übermittlung der Sitzung ohne Unterbrechung stattfindet und (iv) die Vorstandsmitglieder sich ordnungsgemäß
aussprechen können. Eine Teilnahme an einer Versammlung mittels dieser Medien gilt als persönliche Anwesenheit in
dieser Versammlung. Eine Vorstandssitzung, die mittels dieser Kommunikationsmittel stattfindet, gilt als in Luxemburg
stattfindende Vorstandssitzung.
12.4 Arbeitsweise
(a) Quorum und Anforderungen an die Mehrheiten
Der Vorstand kann wirksam tagen und Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder persönlich oder
vertreten anwesend ist. Beschlüsse werden mit der Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Wenn ein Vorstandsmitglied sich der Stimme enthält oder nicht an einer Abstimmung über eine Beschlussvorlage teil-
nimmt, wird diese Enthaltung oder Nichtteilnahme bei der Berechnung der Stimmenmehrheit als Ablehnung der Be-
schlussvorlage gewertet.
(b) Teilnahme durch Stellvertreter
Ein Vorstandsmitglied kann in einer Vorstandssitzung durch die schriftliche Bestellung eines anderen Vorstandsmitg-
lieds zu seinem Stellvertreter agieren. Ein Vorstandsmitglied kann mehr als ein Vorstandsmitglied als Stellvertreter
vertreten, jedoch unter der Bedingung, dass mindestens zwei Vorstandsmitglieder persönlich in der Sitzung anwesend sind.
Kopien von schriftlichen Vertretungsvollmachten, die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, können als Nachweis
dieser schriftlichen Vertretungsvollmachten in einer Vorstandssitzung akzeptiert werden.
(c) Ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden
Im Falle der Stimmengleichheit hat der Vorsitzende oder gegebenenfalls der temporäre Vorsitzende keine ausschlag-
gebende Stimme.
(d) Interessenkonflikte
Bei einem Interessenkonflikt im Sinne von Artikel 24, in dem mindestens ein Vorstandsmitglied einen Interessenkonflikt
in Bezug auf einen bestimmten Belang hat, (a) kann der Vorstand nur dann wirksam beraten und Entscheidungen zu diesem
Belang treffen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, die keinen Interessenkonflikt haben, persönlich oder vertreten
anwesend sind, und (b) die Entscheidungen durch eine Mehrheit der verbleibenden, persönlich oder vertreten anwesenden
Vorstandsmitglieder, die keinen Interessenkonflikt haben, getroffen werden. Falls die in Punkt (a) angegebene Anforderung
an das Quorum aufgrund des Interessenkonflikts von Vorstandsmitgliedern in Bezug auf einen solchen Belang nicht erreicht
126788
L
U X E M B O U R G
werden kann, kann der Vorstand den Belang der Hauptversammlung vorlegen und die Hauptversammlung ist berechtigt,
eine Entscheidung zu diesem Belang zu treffen.
12.5 Schriftliche Beschlüsse
Unbeschadet der vorstehenden Regelung ist lediglich in dringenden Fällen ein schriftlicher Vorstandsbeschluss zulässig.
Dieser Beschluss hat aus einem oder mehreren Dokumenten mit Angabe der Beschlüsse zu bestehen, das/die von jedem
Vorstandsmitglied handschriftlich oder elektronisch mittels einer digitalen Signatur, die gemäß dem luxemburgischen
Recht wirksam ist, unterschrieben bzw. signiert ist/sind. Das Datum dieses Beschlusses ist das Datum der letzten Unter-
schrift bzw. Signatur.
12.6 Einzelvorstand
Artikel 12 gilt nicht, wenn die Gesellschaft durch einen Einzelvorstand geführt wird.
13. Niederschriften der Vorstandssitzungen oder Beschlüsse des Einzelvorstands.
13.1 Formen der Beschlüsse des Einzelvorstands
Die vom Einzelvorstand gefassten Beschlüsse sind durch Niederschriften oder durch schriftliche Beschlüsse zu doku-
mentieren. Die Niederschriften der durch den Einzelvorstand gefassten Beschlüsse sind durch den Einzelvorstand zu
unterschreiben.
13.2 Unterzeichnung der Niederschriften der Vorstandssitzungen
Die Niederschriften der Vorstandssitzungen sind durch den Vorsitzenden oder gegebenenfalls durch den temporären
Vorsitzenden zu unterschreiben. Zusätzlich kann jedes andere Vorstandsmitglied, das persönlich oder vertreten an dieser
Sitzung teilnimmt, die Niederschriften unterschreiben.
13.3 Unterschrift unter Kopien oder Auszügen der Niederschriften von Vorstandssitzungen und Beschlüssen des Ein-
zelvorstands
Kopien oder Auszüge aus Niederschriften oder schriftlichen Beschlüssen des Vorstands oder gegebenenfalls des Ein-
zelvorstands, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig eingereicht werden müssen, müssen durch den Vorsitzenden oder
durch zwei Vorstandsmitglieder oder gegebenenfalls durch den Einzelvorstand unterschrieben werden.
14. Befugnisse des Vorstands und des Einzelvorstands. Der Vorstand ist mit den weitesten Befugnissen ausgestattet,
um alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft notwendig oder zweckdienlich sind, durch-
zuführen oder ihre Durchführung zu veranlassen. Alle Befugnisse, die durch das Gesellschaftsgesetz oder durch die Satzung
nicht ausdrücklich der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Vor-
stands.
Mindestens einmal in drei Monaten legt der Vorstand dem Aufsichtsrat einen schriftlichen Bericht vor, in dem der Stand
des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft und die vorläufige Entwicklung beschrieben werden. Zusätzlich informiert der
Vorstand den Aufsichtsrat über alle Ereignisse, die einen spürbaren Einfluss auf die Lage der Gesellschaft haben können.
Sofern die Gesellschaft nur einen Einzelvorstand hat, besitzt der Einzelvorstand dieselben Befugnisse, wie sie dem
Vorstand zuerkannt sind. In diesem Fall bedeutet in dieser Satzung ein Verweis auf durch den Vorstand gefasste Beschlüsse
oder durch den Vorstand ausgeübte Befugnisse einen Verweis auf von dem Einzelvorstand gefasste Beschlüsse oder durch
den Einzelvorstand ausgeübte Befugnisse.
15. Bewilligungsvorbehalte. Der Vorstand muss für die folgenden Transaktionen und Maßnahmen die Bewilligung des
Aufsichtsrats einholen. Diese Bewilligung ist generell durch den Vorstand vom Aufsichtsrat schriftlich vor der Ausführung
der entsprechenden Transaktion oder Maßnahme einzuholen. In Ausnahmefällen, wenn der Vorstand verpflichtet ist, un-
verzüglich zu handeln, um einen erheblichen Schaden von der Gesellschaft abzuwenden, kann der Vorstand jedoch diese
Transaktionen und Maßnahmen ohne die vorherige Bewilligung durch den Aufsichtsrat ausführen, er muss jedoch die
schriftliche Genehmigung des Aufsichtsrats so bald wie möglich nach der Ausführung dieser Transaktion oder Maßnahme
einholen. Der Aufsichtsrat kann außerdem den Vorstand im Voraus von der Pflicht zur Einholung seiner vorherigen
schriftlichen Bewilligung für bestimmte einzelne oder allgemeine Geschäftsvorgänge oder Maßnahmen befreien.
Der Vorstand hat dafür Sorge zu tragen und tritt dafür ein, dass in Bezug auf Tochterunternehmen der Gesellschaft die
Bewilligung des Aufsichtsrats über den Vorstand und über das Management ihres jeweiligen Tochterunternehmens für alle
in diesem Artikel 15 genannten Transaktionen und Maßnahmen angefordert und eingeholt wird.
Die folgenden Transaktionen und Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der vorherigen Bewilligung durch den Auf-
sichtsrat:
(a) Der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen oder eine Zusammenlegung oder
Verschmelzung mit einem anderen Unternehmen sowie der Erwerb und die Veräußerung von Geschäftsbereichen oder
Unternehmen oder deren Teilen, die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben oder erwartungs-
gemäß haben könnten
(b) Der Eintritt in Gemeinschaftsunternehmen, Partnerschaften, Arbeitsgemeinschaften oder ähnlichen Vereinbarungen,
die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben oder erwartungsgemäß haben könnten
(c) Das Eingehen, die Aufgabe oder die wesentliche Änderung von unüblichen oder einseitig verpflichtenden Verträgen
die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben oder erwartungsgemäß haben könnten
126789
L
U X E M B O U R G
(d) Das Stellen von Sicherheiten oder Bürgschaften, die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe
haben oder erwartungsgemäß haben könnten
(e) Der Abschluss oder die Änderung von Kreditvereinbarungen oder anderen Finanztransaktionen, die eine wesentliche
Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben oder erwartungsgemäß haben könnten
(f) Die Vornahme von Geschäften (darunter der Erwerb oder die Veräußerung, sei es mit vollständiger Eigentumsüber-
tragung oder durch Lizenzen oder auf eine andere beliebige Art) mit gewerblichen Schutzrechten und geistigem Eigentum,
außer im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs, die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben
oder erwartungsgemäß haben könnten, und
(g) Immobilientransaktionen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Gruppe haben.
Im Sinne dieses Artikels 15 gelten folgende Begriffsbestimmungen:
Gruppe ist die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen, und
und
Tochterunternehmen hat die Bedeutung gemäß Artikel 309 Absatz 2 Gesellschaftsgesetz in Verbindung mit Artikel 310
Gesellschaftsgesetz.
Unbeschadet der vorstehenden Regelungen kann der Aufsichtsrat eine Liste von Transaktionen und Maßnahmen des
Vorstands (und der in Ziffer 2 weiter oben angegebenen Tochterunternehmen der Gesellschaft) in die Geschäftsordnung
des Aufsichtsrats aufnehmen, die der vorherigen Bewilligung durch den Aufsichtsrat bedürfen, und der Vorstand ist über
diese Einschränkungen entsprechend zu informieren. Die in dieser Geschäftsordnung angegebenen Einschränkungen sind
in der Außenwirkung nicht verbindlich.
16. Delegierung von Befugnissen des Vorstands.
16.1 Tagesgeschäft
Der Vorstand kann eine oder mehrere Personen (délégué à la gestion journalière) berufen, die Aktionäre sein können
oder nicht, oder die Vorstandsmitglied sind oder nicht, aber unter Ausschluss von Aufsichtsratsmitgliedern, die vollständig
ermächtigt sind, im Namen der Gesellschaft in allen Belangen zu handeln, die zum Tagesgeschäft der Gesellschaft und
dessen Verwaltung zählen.
16.2 Ständiger Vertreter der Gesellschaft
Der Vorstand kann eine Person, die ein Aktionär sein kann oder nicht und die ein Vorstandsmitglied sein kann oder
nicht, unter Ausschluss von Aufsichtsratsmitgliedern, zum ständigen Vertreter der Gesellschaft für einen Rechtsträger
bestellen, in dessen Verwaltungsrat die Gesellschaft zum Mitglied bestellt wird. Dieser ständige Vertreter handelt nach
eigenem Ermessen im Namen und für die Belange der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als
Verwaltungsratsmitglied dieses Rechtsträgers binden.
16.3 Delegierung für die Wahrnehmung bestimmter Funktionen und Ausschüsse
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, eine Person, die ein Vorstandsmitglied sein kann oder nicht, unter Ausschluss von
Aufsichtsratsmitgliedern, für die Wahrnehmung bestimmter Funktionen auf jeder Ebene in der Gesellschaft zu ernennen.
Der Vorstand kann ferner Ausschüsse oder Unterausschüsse einrichten, um bestimmte Aufgaben zu erledigen, den
Vorstand zu beraten oder Empfehlungen für den Vorstand und/oder gegebenenfalls für die Hauptversammlung zu erteilen.
Die Mitglieder dieser Ausschüsse können aus dem Kreis des Vorstands oder auch nicht ausgewählt werden, unter Aus-
schluss von Aufsichtsratsmitgliedern.
17. Verbindliche Unterschriften.
17.1 Unterschriftsvollmachten von Vorstandsmitgliedern
Im Außenverhältnis wird die Gesellschaft in allen Belangen durch (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Vor-
standsmitgliedern oder (ii) im Falle des Einzelvorstands, durch die Unterschrift des Einzelvorstands gebunden.
17.2 Unterschriftsvollmachten für das Tagesgeschäft
In Angelegenheiten des Tagesgeschäfts wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift einer Person verpflichtet, die
zu diesem Zweck gemäß Artikel 16.1 ernannt wurde.
17.3 Erteilung Sondervollmachten
Die Gesellschaft kann durch die gemeinsame Unterschrift von Personen oder durch die Einzelunterschrift der Person
verpflichtet werden, der von der Gesellschaft eine Sondervollmacht erteilt wurde, aber lediglich in den Grenzen dieser
Vollmacht.
18. Aufsicht.
18.1 Aufsichtsrat
Die Führung der Gesellschaft wird durch den Aufsichtsrat beaufsichtigt.
18.2 Mindestanzahl der Aufsichtsratsmitglieder und Dauer des Mandats
Der Aufsichtsrat muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen.
Die Aufsichtsratsmitglieder werden für eine Mandatsdauer von höchstens 6 (sechs) Jahren gewählt. Eine Wiederwahl
ist möglich.
126790
L
U X E M B O U R G
18.3 Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Aufsichtsratsmitglied bestellt wird (das Aufsichtsratsmitglied als juristische Person),
muss das Aufsichtsratsmitglied als juristische Personen eine natürliche Person zum ständigen Vertreter (représentant per-
manent) bestellen, der das Aufsichtsratsmitglied als juristische Person gemäß Artikel 60bis Absatz 14 und 51bis Gesell-
schaftsgesetz vertritt.
18.4 Bestellung, Abberufung und Ergänzungswahl
Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung legt auch die
Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder, ihre Vergütung sowie die Dauer ihres Mandats (beispielsweise auch eine Frist für ihren
Rücktritt vom Mandat) fest. Ein Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung fristlos
oder unter Wahrung einer Frist abberufen und/oder ersetzt werden.
Die Hauptversammlung kann eine Gesamtsumme als Entgelt für die Aufsichtsratsmitglieder gewähren. In diesem Fall
teilt der Aufsichtsrat die gewährte Gesamtsumme unter seinen Mitgliedern auf.
Bei einem oder mehreren vakanten Mandat(en) im Aufsichtsrat aufgrund von Tod, Rücktritt oder aus einem anderen
Grund können die verbleibenden Aufsichtsratsmitglieder ein oder gegebenenfalls mehrere Aufsichtsratsmitglied(er) bis
zur nächsten Hauptversammlung bestellen, um die Vakanz zu besetzen.
19. Aufsichtsratssitzungen.
19.1 Aufsichtsratsvorsitzender
Der Aufsichtsrat ernennt einen Vorsitzenden (den Aufsichtsratsvorsitzenden) aus dem Kreis seiner Mitglieder und kann
einen Schriftführer ernennen, der nicht unbedingt Aufsichtsratsmitglied sein muss. Er ist für die Erstellung der Nieder-
schriften der Aufsichtsratssitzungen verantwortlich. Der Aufsichtsratsvorsitzende leitet alle Aufsichtsratssitzungen. Bei
Abwesenheit des Aufsichtsratsvorsitzenden ernennen die anderen Aufsichtsratsmitglieder ein anderes Aufsichtsratsmit-
glied zum temporären Vorsitzenden, der die entsprechende Sitzung leitet.
19.2 Verfahren für die Einberufung einer Aufsichtsratssitzung
Der Aufsichtsrat tagt auf Einberufung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden oder durch zwei Aufsichtsratsmitglieder am
in der Einberufungsanzeige der Sitzung angegebenen Ort. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss so schnell wie praktisch
möglich eine Aufsichtsratssitzung einberufen, wenn diese bei Eingang einer schriftlichen Aufforderung durch den Vorstand
mit Angabe der Tagesordnung verlangt wird. Aufsichtsratssitzungen müssen in Luxemburg stattfinden. Aufsichtsratssit-
zungen dürfen nicht im Ausland stattfinden.
Der Aufsichtsrat tagt so oft, wie es der Betrieb und die Interessen der Gesellschaft erfordern. Zusätzlich finden Auf-
sichtsratssitzungen mindestens vier Mal in einem Bilanzjahr statt.
Eine schriftliche Anzeige der Aufsichtsratssitzung wird an alle Aufsichtsratsmitglieder spätestens 7 (sieben) Tage vor
dem für diese Sitzung angesetzten Termin gesendet, außer in dringenden Fällen, in denen die Art der Umstände kurz in
der Einberufungsanzeige für die Aufsichtsratssitzung anzugeben sind. Einberufungsanzeigen können an die Aufsichts-
ratsmitglieder per Telefax oder E-Mail gesendet werden.
Eine derartige Einberufungsanzeige ist nicht erforderlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder persönlich oder vertreten
in der Sitzung anwesend sind und wenn sie feststellen, dass sie ordnungsgemäß informiert wurden und ihnen die Tages-
ordnung der Sitzung vollständig bekannt war. Zusätzlich gilt, dass wenn alle Aufsichtsratsmitglieder in der Sitzung
persönlich oder vertreten anwesend sind und einstimmig beschließen, die Tagesordnung der Sitzung aufzustellen, die
Sitzung stattfinden kann, ohne dass sie in der oben angegebenen Form einberufen wurde.
Ein Aufsichtsratsmitglied kann durch seine schriftliche Zustimmung auf die schriftliche Einberufung verzichten. Kopien
von Zustimmungen, die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, können als Nachweis dieser schriftlichen Zustimmung
in einer Aufsichtsratssitzung akzeptiert werden. Separate schriftliche Anzeigen sind nicht für Sitzungen erforderlich, die
zu Terminen und an Orten stattfinden, die in einem Zeitplan vorher durch Beschluss des Aufsichtsrats festgelegt wurden,
wobei gilt, dass alle Aufsichtsratsmitglieder, die in dieser Sitzung nicht persönlich oder vertreten anwesend waren, ange-
messen frühzeitig über eine solche planmäßige Sitzung informiert wurden.
19.3 Teilnahme mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel
Eine Aufsichtsratssitzung kann mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmitteln ab-
gehalten werden, sofern (i) die an der Sitzung teilnehmenden Aufsichtsratsmitglieder identifiziert werden können, (ii) alle
an der Sitzung teilnehmenden Personen sich untereinander hören und miteinander sprechen können, (iii) die Übermittlung
der Sitzung ohne Unterbrechung stattfindet und (iv) die Aufsichtsratsmitglieder sich ordnungsgemäß aussprechen können,
dies nur in dringenden Fällen, wobei jedoch die erste Aufsichtsratssitzung nach der Gründung der Gesellschaft in jedem
Fall mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel stattfinden kann. Eine Teilnahme an
einer Sitzung mittels dieser Medien gilt als persönliche Anwesenheit in dieser Sitzung. Eine Aufsichtsratssitzung, die mittels
dieser Kommunikationsmittel stattfindet, gilt als in Luxemburg stattfindende Aufsichtsratssitzung.
19.4 Arbeitsweise
(a) Quorum und Anforderungen an die Mehrheiten
Der Aufsichtsrat kann wirksam tagen und Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder persönlich
oder vertreten anwesend ist. Beschlüsse werden mit der Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder
126791
L
U X E M B O U R G
gefasst. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied sich der Stimme enthält oder nicht an einer Abstimmung über eine Beschlussvor-
lage teilnimmt, wird diese Enthaltung oder Nichtteilnahme bei der Berechnung der Stimmenmehrheit als Ablehnung der
Beschlussvorlage gewertet.
(b) Teilnahme durch Stellvertreter
Ein Aufsichtsratsmitglied kann in einer Aufsichtsratssitzung durch die schriftliche Bestellung eines anderen Aufsichts-
ratsmitglieds zu seinem Stellvertreter agieren. Ein Aufsichtsratsmitglied kann mehr als ein Aufsichtsratsmitglied als
Stellvertreter vertreten, jedoch unter der Bedingung, dass mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder persönlich in der Sitzung
anwesend sind. Kopien von schriftlichen Vertretungsvollmachten, die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, können
als Nachweis dieser schriftlichen Vertretungsvollmachten in einer Aufsichtsratssitzung akzeptiert werden.
(c) Ausschlaggebende Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden
Im Falle von Stimmengleichheit hat der Aufsichtsratsvorsitzende oder gegebenenfalls der temporäre Vorsitzende die
ausschlaggebende Stimme.
(d) Interessenkonflikte
Bei einem Interessenkonflikt im Sinne von Artikel 24, in dem mindestens ein Aufsichtsratsmitglied einen Interessen-
konflikt in Bezug auf einen bestimmten Belang hat, (a) kann der Aufsichtsrat nur dann wirksam beraten und Entscheidungen
zu diesem Belang treffen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, die keinen Interessenkonflikt haben, persönlich
oder vertreten anwesend sind, und (b) die Entscheidungen durch eine Mehrheit der verbleibenden, persönlich oder vertreten
anwesenden Aufsichtsratsmitglieder, die keinen Interessenkonflikt haben, getroffen werden. Falls die in Punkt (a) ange-
gebene Anforderung an das Quorum aufgrund des Interessenkonflikts von Aufsichtsratsmitgliedern in Bezug auf einen
solchen Belang nicht erreicht werden kann, kann der Aufsichtsrat den Belang der Hauptversammlung vorlegen und die
Hauptversammlung ist berechtigt, eine Entscheidung zu diesem Belang zu treffen.
19.5 Schriftliche Beschlüsse
Unbeschadet der vorstehenden Regelung ist lediglich in dringenden Fällen ein schriftlicher Aufsichtsratsbeschluss zu-
lässig. Dieser Beschluss hat aus einem oder mehreren Dokumenten mit Angabe der Beschlüsse zu bestehen, das/die von
jedem Aufsichtsratsmitglied handschriftlich oder elektronisch mittels einer digitalen Signatur, die gemäß dem luxembur-
gischen Recht wirksam ist, unterschrieben bzw. signiert ist/sind. Das Datum dieses Beschlusses ist das Datum der letzten
Unterschrift bzw. Signatur.
20. Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen.
20.1 Unterzeichnung der Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen
Die Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen sind durch den Aufsichtsratsvorsitzenden oder gegebenenfalls durch den
temporären Vorsitzenden zu unterschreiben. Zusätzlich kann jedes andere Aufsichtsratsmitglied, das persönlich oder ver-
treten an dieser Sitzung teilnimmt, die Niederschriften unterschreiben.
20.2 Unterzeichnung von Kopien oder Auszügen von Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen
Kopien oder Auszüge aus Niederschriften oder schriftlichen Beschlüssen des Aufsichtsrats, die in Gerichtsverfahren
oder anderweitig eingereicht werden müssen, werden durch den Aufsichtsratsvorsitzenden oder durch zwei Aufsichtsrats-
mitglieder unterschrieben.
20.3 Befugnisse des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat kontrolliert dauerhaft die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Vorstand, ohne in die Ge-
schäftsführung einzugreifen.
Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand Informationen jeder Art verlangen, die er für die Durchführung seiner Aufsicht
benötigt. Der Aufsichtsrat kann Untersuchungen anstellen oder veranlassen, die für die Erfüllung seiner Pflichten notwendig
sind.
Darüber hinaus gewährt der Aufsichtsrat dem Vorstand und den Tochterunternehmen seine Bewilligung für die Aus-
führung von Transaktionen und Maßnahmen gemäß Angabe in Artikel 15.
Der Aufsichtsrat hat das Recht, alle Tätigkeiten der Gesellschaft zu prüfen. Seine Mitglieder haben am eingetragenen
Sitz der Gesellschaft Zugriff auf die Bücher, Konten, Korrespondenz, Niederschriften und generell auf alle Dokumente
der Gesellschaft. Auf Verlangen des Aufsichtsrats erteilt der Vorstand alle Informationen, die für die Kontrolle der Ge-
schäftsführung durch den Aufsichtsrat notwendig sind. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat Nachprüfungen zur Bestäti-
gung in Bezug auf seine Funktion durchführen oder verlangen.
21. Delegierung von Befugnissen des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat kann ein oder mehrere seiner Mitglieder für die
Erfüllung einer oder mehrerer spezifischer Aufgaben bestellen.
Er kann außerdem die Einrichtung von Ausschüssen innerhalb des Aufsichtsrats beschließen. Die Zusammensetzung
und die Tätigkeiten dieser Ausschüsse werden durch den Aufsichtsrat festgelegt und sie handeln unter seiner Kontrolle.
Der Aufsichtsrat kann jedoch diejenigen Befugnisse nicht an einen Ausschuss delegieren, die im Gesellschaftsgesetz oder
in der Satzung ausdrücklich dem Aufsichtsrat selbst übertragen sind. Eine Delegierung an einen Ausschuss kann die Be-
fugnisse des Vorstands nicht reduzieren oder einschränken.
126792
L
U X E M B O U R G
22. Mitgliedschaft im Vorstand und im Aufsichtsrat. Eine Person kann nicht gleichzeitig Vorstandsmitglied und Auf-
sichtsratsmitglied sein.
Wenn jedoch ein Mandat im Vorstand vakant ist, kann der Aufsichtsrat eines seiner Mitglieder bestellen, im Vorstand
tätig zu werden. Während dieses Zeitraums ruhen die Pflichten dieser Person in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied.
23. Interessenkonflikte.
23.1 Verfahren bei einem Interessenkonflikt
Falls ein Vorstandsmitglied bzw. ein Aufsichtsratsmitglied ein Interesse in einer Transaktion hat, die dem Vorstand
bzw. dem Aufsichtsrat zur Bewilligung vorgelegt wird, das im Gegensatz zum Interesse der Gesellschaft steht, hat dieses
Vorstandsmitglied bzw. Aufsichtsratsmitglied dieses gegenteilige Interesse dem Vorstand bzw. dem Aufsichtsrat in dieser
Sitzung mitzuteilen und zu veranlassen, dass diese Erklärung in die Niederschrift der Sitzung protokolliert wird. Das
Vorstandsmitglied bzw. Aufsichtsratsmitglied darf nicht an Beratungen in Bezug auf diese Transaktion teilnehmen und
darf nicht über die Beschlüsse abstimmen, die sich auf diese Transaktion beziehen. Die Transaktion und die daran beste-
henden Interessen des Mitglieds sind der nächsten stattfindenden Hauptversammlung zu melden.
Im Falle eines Interessenkonflikts zwischen einem Vorstandsmitglied und der Gesellschaft in Bezug auf eine Transaktion
ist zusätzlich die Genehmigung durch den Aufsichtsrat erforderlich.
23.2 Ausnahmen bei einem Interessenkonflikt
Artikel 24.1 gilt nicht für Beschlüsse des Vorstands oder des Einzelvorstands oder des Aufsichtsrats, die sich auf Trans-
aktionen beziehen, die im normalen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft stattfinden, die zu marktüblichen Konditionen wie
unter Dritten geschlossen werden.
23.3 Fehlen von Interessenkonflikten
Einem Vorstandsmitglied oder Aufsichtsratsmitglied, das als Verwaltungsratsmitglied, Führungskraft oder Angestellter
eines Unternehmens oder einer Firma tätig ist, das bzw. die die Gesellschaft beauftragen oder anderweitig geschäftlich
einsetzt, darf nicht allein aufgrund der Verbundenheit mit diesem anderen Unternehmen oder dieser anderen Firma unter-
stellt werden, dass es eine Interesse hat, das im Gegensatz zum Interesse der Gesellschaft im Sinne dieses Artikels 24 steht.
23.4 Interessenkonflikt des Einzelvorstands
Solange die Gesellschaft einen Einzelvorstand hat, gilt, dass wenn der Einzelvorstand ein zum Interesse der Gesellschaft
in Bezug auf eine durch die Gesellschaft und den Einzelvorstand eingegangene Transaktion gegenteiliges Interesse hat,
dass dieser Interessenkonflikt in der Niederschrift bzw. in dem schriftlichen Beschluss des Einzelvorstands, in der bzw.
dem die Genehmigung dieser Transaktion protokolliert wird, anzugeben ist.
24. Rechnungsprüfer (commissaire(s)) - Externer Wirtschaftsprüfer (reviseur d'entreprises agrée or cabinet de revision
agrée).
24.1 Rechnungsprüfer (commissaire)
Der Betrieb der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Der/die
Rechnungsprüfer wird/werden für eine Mandatsdauer von höchstens 6 (sechs) Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist mög-
lich.
Der/die Rechnungsprüfer wird/werden von der Hauptversammlung bestellt. Sie bestimmt ihre Anzahl, ihre Vergütung
und ihre Mandatsdauer. Der/die Rechnungsprüfer können jederzeit durch die Hauptversammlung fristlos oder unter Wah-
rung einer Frist abberufen werden.
24.2 Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé oder cabinet de révision agréé)
Ein oder mehrere Rechnungsprüfer werden jedoch nicht bestellt, wenn statt der Bestellung eines oder mehrerer Rech-
nungsprüfer ein oder mehrere Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé oder cabinet de révision agréé) durch
die Hauptversammlung bestellt wird/werden, um die vorgeschriebene Revision des Jahresabschlusses gemäß dem gelten-
den luxemburgischen Recht durchzuführen. Der/die unabhängigen Abschlussprüfer wird/werden von der Hauptversamm-
lung gemäß den Bedingungen eines Dienstleistungsvertrages bestellt, der zu gegebener Zeit zwischen der Gesellschaft und
dem/den unabhängigen Abschlussprüfern geschlossen wird. Der/die unabhängige(n) Abschlussprüfer können nur durch
die Hauptversammlung aus wichtigem Grund abberufen werden.
25. Bilanzjahr. Das Bilanzjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember jeden
Jahres.
26. Jahresabschluss.
26.1 Verantwortung des Vorstands
Der Vorstand erstellt einen Entwurf des Jahresabschlusses der Gesellschaft, welcher der Jahreshauptversammlung zur
Genehmigung vorzulegen ist.
26.2 Vorlage des Jahresabschlusses an den/die Rechnungsprüfer und den Aufsichtsrat
Spätestens 1 (einen) Monat vor der Jahreshauptversammlung hat der Vorstand den Jahresabschluss, gegebenenfalls
zusammen mit dem Lagebericht und anderen, gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen, (i) gegebenenfalls dem/den Rech-
nungsprüfer der Gesellschaft vorzulegen, der/die dann seinen/ihren Bericht(e) erstellt, (ii) und dem Aufsichtsrat, welcher
seine Bemerkungen zum Lagebericht und zum Jahresabschluss der Hauptversammlung vorstellt.
126793
L
U X E M B O U R G
26.3 Verfügbarkeit von Unterlagen am eingetragenen Sitz
Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der Jahreshauptversammlung sind der Jahresabschluss, der Lagebericht und gege-
benenfalls der Bericht des/der unabhängigen Abschlussprüfer(s) sowie die anderen gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen
am eingetragenen Sitz der Gesellschaft deponiert, wo sie zur Einsichtnahme durch die Aktionäre während der normalen
Geschäftszeiten ausliegen.
27. Verteilung der Ergebnisse.
27.1 Zuweisung in die gesetzliche Rücklage
Von den Jahresgewinnen der Gesellschaft (sofern vorhanden) sind 5 % (fünf Prozent) in die gesetzlich vorgeschriebene
Rücklage eingestellt. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald diese gesetzliche Rücklage sich auf 10 % (zehn Prozent)
des Grundkapitals der Gesellschaft beläuft. Sie wird jedoch wieder gesetzlich verpflichtend, wenn die Rücklage unter 10
% (zehn Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft fällt.
27.2 Verteilung der Ergebnisse durch die Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung beschließt über die Verteilung der Jahresergebnisse bzw. über die Ankündigung und
Auszahlung von Dividenden.
27.3 Abschlagsdividende
Der Vorstand kann beschließen, eine Abschlagsdividende aus den Gewinnen und für eine Ausschüttung zur Verfügung
stehenden Rücklagen, darunter das Emissionsagio und Gewinnrücklagen, anzukündigen und auszuzahlen, sofern die im
Gesellschaftsgesetz festgelegten Bedingungen erfüllt und die Grenzen eingehalten werden.
27.4 Dividendenzahlung
Dividenden können in Euro oder einer anderen, vom Vorstand gewählten Währung ausgezahlt werden. Sie können an
vom Vorstand, gegebenenfalls innerhalb der Grenzen und Entscheidungen der Hauptversammlung, festgelegten Orten und
Zeitpunkten ausgezahlt werden.
28. Auflösung und Abwicklung.
28.1 Grundsätze für die Auflösung und Abwicklung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hautversammlung, der auf eine Weise gefasst wird, die für
die Änderung dieser Satzung gemäß Artikel 10 erforderlich ist, aufgelöst werden. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft
erfolgt die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidator(en) (die natürliche der juristische Personen sein können), die
von der über diese Abwicklung beschließenden Hauptversammlung bestellt werden. Diese Hauptversammlung beschließt
auch die Befugnisse und die Vergütung des Liquidators bzw. der Liquidatoren.
28.2 Verteilung des Abwicklungsüberschusses
Im Rahmen der Abwicklung der Gesellschaft werden die überschüssigen Vermögenswerte der Gesellschaft, die für die
Ausschüttung an die Aktionäre zur Verfügung stehen, an die Aktionäre ausgeschüttet, entweder als Vorauszahlungen oder
nach der Begleichung (oder ggf. Zuweisung zu den Rückstellungen) der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
29. Anwendbares Recht. Für alle nicht ausdrücklich in dieser Satzung geregelten Belange gilt das luxemburgische Recht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt als Rumpfgeschäftsjahr heute und endet am 31. Dezember 2015
<i>Zeichnungi>
Nachdem die Satzung nunmehr erstellt ist, erklären die Zeichner, durch ihre oben angegebene Vertretung, dass sie
1.750.000 (eine Million siebenhundertfünfzigtausend) Aktien im Nennwert von je 0,02 EUR (zwei Cent eines Euro) in bar
zeichnen. Die Aktien verbriefen das gesamte Grundkapital der Gesellschaft und haben einen Zeichnungspreis von 0,02
EUR (zwei Cent eines Euro) je Aktie. Die Zeichnung erfolgt folgendermaßen:
Ralph Winter, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.124.108 (eine Million einhundertvierundzwanzigtausend
einhundertacht) Aktien
Thomas Landschreiber, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . .
117.032 (hundertsiebzehntausend zweiunddreißig) Aktien
Intershop Holding AG, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . .
491.232 (vierhunderteinundneunzigtausend
zweihundertzweiunddreißig) Aktien
Christine Winter, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.333 (elftausend dreihundertdreiunddreißig) Aktien
Silke Otto, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.295 (sechstausend zweihundertfünfundneunzig) Aktien
Summe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750.000 (eine Million siebenhundertfünfzigtausend) Aktien
Der Zeichnungspreis für alle diese Aktien wurde durch die Zeichner durch Leistung einer Bareinlage von insgesamt
35.000 EUR (fünfunddreißigtausend Euro) eingezahlt. Damit steht der von den Zeichnern eingezahlte Betrag von 35.000
EUR (fünfunddreißigtausend Euro) von jetzt an der Gesellschaft zur freien Verfügung. Der entsprechende Nachweis wurde
dem unterzeichneten Notar übergeben und der Notar bestätigt ausdrücklich diesen Umstand.
Die Bareinlagen werden vollständig dem Grundkapital der Gesellschaft zugerechnet.
126794
L
U X E M B O U R G
<i>Feststellung - Kosteni>
Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die in Artikel 26, 26 Absatz 3 und 26 Absatz 5 (wobei Artikel 26 Absatz 1
Nummer (2) beschriebenen Umstände nicht anwendbar sind, weil bei Gründung der Gesellschaft keine Sacheinlagen außer
der Bareinlage geleistet wurden) Gesellschaftsgesetz erfüllt wurden und bestätigt ausdrücklich deren Erfüllung.
Die Auslagen, Kosten, Vergütungen und Gebühren in jeder Form, die von der Gesellschaft aus dieser Beurkundung zu
tragen sind, werden auf rund eintausendfünfhundert Euros (1.500.- EUR) geschätzt.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Die Zeichner, durch ihre oben angegebene Vertretung, welche die Gesamtheit des Grundkapitals repräsentieren, haben
eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft abgehalten und die folgenden Beschlüsse ein-
stimmig gefasst:
1. Der Aufsichtsrat wird aus 3 (drei) Mitgliedern bestehen
2. Die Anzahl der externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises agréé oder cabinet de révision agréé) wird auf Eins
(1) festgelegt
3. Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden bestellt:
- Ralph Winter, selbstständiger Managementberater mit Dienstanschrift bei CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135,
CH-6300 Zug (Schweiz),
- Urs Felder, selbstständiger Steuer- und Buchhaltungsexperte, mit Dienstanschrift bei FELUR Swiss Treuhand AG,
Sihlamtsstrasse 5, 8001 Zürich (Schweiz) und
- Andreas Wirz, Architekt, Mitglied des Vorstands der Intershop Holding AG, mit Dienstanschrift bei Intershop Holding
AG, Puls 5 - Giessereistrasse 18, Postbox 1601, CH-8031 Zürich (Schweiz)
4. Bestellung von Ernst & Young, 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, zum
externen Wirtschaftsprüfer (cabinet de révision agréé) der Gesellschaft
5. Die Mandatsdauer der Aufsichtsratsmitglieder endet nach der Jahreshauptversammlung, die über den Jahresabschluss
des am 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Bilanzjahres beschließt
6. Die Mandatsdauer der unabhängigen Abschlussprüfer endet nach der Jahreshauptversammlung, die über den Jahres-
abschluss des am 31. Dezember 2015 abgeschlossenen Bilanzjahres beschließt
7. Die Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft ist 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der oben genannten
Erschienenen diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist und eine deutsche Version folgt. Auf Verlangen derselben
Erschienenen soll für den Fall von Abweichungen zwischen den englischen und deutschen Versionen die englische Version
vorrangig gelten.
Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg am im Rubrum dieser Urkunde angegebenen Tag verfasst.
Die Urkunde wurde den Erschienenen vorgelesen. Alle Erschienenen sind dem Notar nach ihren Namen, Vornamen,
Familienstand und Wohnorten bekannt. Die genannten Erschienenen haben diese Urkunde zusammen mit dem Notar
unterzeichnet.
Gezeichnet: R. GALIOTTO und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 28 août 2015. Relation: 1LAC/2015/27324. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 7. September 2015.
Référence de publication: 2015149519/1328.
(150164361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2015.
Adagio, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Das Verwaltungsreglement - Adagio - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l
Référence de publication: 2015151033/8.
(150165187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
LI-Invest Fonds, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de LI-INVEST FONDS a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
126795
L
U X E M B O U R G
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A / BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme / Société Anonyme
<i>Société de gestion / Banque Dépositaire
i>Dieter HEIN / Guy WAGNER / Florence WINFIELD-PILOTAZ / Nico THILL
<i>Directeur / Administrateur Directeur / Membre de la Direction / Directeuri>
Référence de publication: 2015151344/12.
(150166357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Quaesta Capital Umbrella SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 138.552.
In the year two thousand fifteen, on the ninth day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg
Was held
the extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Quaesta Capital Umbrella SICAV, a public limited
company (“société anonyme”) having its registered office at, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (the “Company”)
qualifying as an investment company with variable capital (“société d’investissement à capital variable”), incorporated by
a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, dated 9 May 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations (the “Mémorial”) on 4 June 2008, in the form of an investment company with variable capital - specialized
investment fund (“société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé”). By decision of an
extraordinary general meeting of shareholders held on 11 July 2014 before Maître Paul Decker, then notary residing in
Luxembourg, the minutes of which were published in the Mémorial on 15 October 2014, the Company was converted into
an undertaking for collective investments in transferable securities subject to part I of the Luxembourg law of 17 December
2010 on undertakings for collective investment with effect as of 11 July 2014.
The Meeting was opened at 9 September 2015 at 11.00 a.m., under the chairmanship of Marc Hirtz, lawyer, professionally
residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Corinna Schibgilla, lawyer, residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Janine Powierski, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is the following:
1. Decision to put the Company into liquidation and to initiate the voluntary liquidation procedure with immediate effect
in accordance with the articles 141 - 151 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;
2. Decision to appoint Mr. Alan Ridgway, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg as liquidator of the Company and
to determine his powers and remuneration;
3. Decision to appoint KPMG Luxembourg, société coopérative, 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg as
auditor of the liquidation of the Company.
II. All the shares being registered shares, the Meeting has been convened by notices sent by registered mail to the
shareholders on 31 August 2015;
III. That the names of the shareholders present at the Meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders
represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the Meeting and the notary.
The aforesaid list shall be attached to the present minutes and registered therewith. The proxies given shall be initialed "ne
varietur" by the members of the board of the Meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this
document;
IV. That the valid deliberation of the item 1. of the agenda requires according to articles 28 and 30 of the articles of
incorporation of the Company in conjunction with articles 99 and 67-1 of the Luxembourg law of 10 August 1915 con-
cerning commercial companies, as amended, (the “Law of 1915”) a quorum of presence of at least one half of the shares
of the Company and that the resolutions on the items of the agenda must be taken by a majority of at least two-thirds of
the votes cast;
V. That, pursuant to the attendance list of the Company, three (3) shareholders, holding 55’916.58 shares, that is to say
seventy two point two per cent (72.2%) of the issued capital of the Company, is present or represented;
VI. That, consequently, the present Meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the items of the
agenda;
After deliberation the Meeting took the following resolutions:
126796
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Meeting unanimously resolves to put the Company into liquidation and to initiate the voluntary liquidation procedure
with immediate effect in accordance with the articles 141 - 151 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial
companies as amended.
<i>Second resolutioni>
The Meeting unanimously resolves to appoint Mr. Alan Ridgway, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, as liquidator
with the powers determined by articles 144 and following of the Law of 1915.
The liquidator is therefore empowered, among other things, to accomplish all the acts provided for by article 145 of the
Law of 1915 without requesting the authorization of the shareholders.
The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.
The liquidator is authorized, under its responsibility, to delegate, with regards to special and determined operations, to
one or more proxyholders, such part of its authorities and for such duration as it may determine.
The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered by
liquidators.
<i>Third resolutioni>
The Meeting unanimously resolves to appoint KPMG Luxembourg, société coopérative, existing and incorporated under
the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg (Grand-Duchy of Luxembourg) and registered in the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B
149133, as auditor of the liquidation.
There being no further business, the Meeting was closed at 11.30 a.m.
Whereof the present minute is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request on the above appearing
parties, the present deed is worded in English.
The document having been read to the persons appearing above, the persons signed together with us, the notary, this
original deed.
Signé: M. HIRTZ, C. SCHIBGILLA, J. POWIERSKI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 14 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29174. Reçu douze euros (12.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 17 septembre 2015.
Référence de publication: 2015155068/82.
(150170378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.
Lglobal Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 160.733.
In the year two thousand and fifteen, on the eighth of September.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “LGLOBAL FUNDS” a société d’investissement à capital
variable, with registered office at Hesperange, incorporated by a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch/
Alzette, on May 3, 2011, December 18, 2013, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 1423 on
June 30, 2011.
The meeting is opened with Mrs Gwendoline Boone, residing professionally in Hesperange, in the chair.
Mrs Flore Sendegeya, residing professionally in Hesperange, is appointed secretary.
The meeting appoints as scrutineer Mr Emmanuel Gilson de Rouvreux, residing professionally in Hesperange.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- That all the shares being registered shares, the present extraordinary general meeting has been convened by notices
containing the agenda sent by registered mail to the shareholders on August 12, 2015.
II.- That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
126797
L
U X E M B O U R G
III.- That it appears from the attendance list, that out of 14,568,011 shares in circulation, 8,913,994 shares are present
or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda.
IV.- That the agenda of the present meeting is the following:
<i>Agenda.i>
1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33, rue de Gasperich, L-5826
Hesperange to 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
2. Amendment to the first paragraph of Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the
registered office. The first paragraph to be reworded as follows:
“The registered office of the Company is established in Hesperange, in the Grand-Duchy of Luxembourg. As from the
1
st
January 2016, the registered office of the Company will be established in Luxembourg. Wholly-owned subsidiaries,
branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the
Company (collectively referred to as the “Board” or the “Directors” and individually referred to as a “Director”). If permitted
by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board may transfer the registered office of
the Company to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg. (...)”
3. Amendment to the first paragraph of Article 10 of the articles of incorporation to be reworded as follows:
“The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office
of the Company, or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the third Wednesday of the month of May in each year at 10:00 a.m.(...)”
Then the meeting, after deliberation, took the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to transfer the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33, rue de
Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the
change of the registered office. The first paragraph to be reworded as follows:
“The registered office of the Company is established in Hesperange, in the Grand-Duchy of Luxembourg. As from the
1
st
January 2016, the registered office of the Company will be established in Luxembourg. Wholly-owned subsidiaries,
branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the
Company (collectively referred to as the “Board” or the “Directors” and individually referred to as a “Director”). If permitted
by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board may transfer the registered office of
the Company to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg. (...)”
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 10 of the articles of incorporation to be reworded as follows:
“The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office
of the Company, or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the third Wednesday of the month of May in each year at 10:00 a.m.(...)”
There being no further item on the agenda, the chairman closed the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons, appearing, they signed together with the notary the present deed.
Signé: G. BOONE, F. SENDEGEYA, E. GILSON DE ROUVREUX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 14 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29167. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 16 septembre 2015.
Référence de publication: 2015154084/71.
(150169249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2015.
126798
L
U X E M B O U R G
Syncro Funds (Lux), Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion consolidé effectif au 1
er
octobre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2015.
Gerifonds (Luxembourg) S.A.
Signature
Référence de publication: 2015157391/11.
(150173641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.
Knoxville Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 183.965.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Knoxville Investments S.à r.l.
Référence de publication: 2015134892/11.
(150145599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
Armador S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 173.755.
La Société a été constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-
sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n° 328 du 11 février 2013.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ARMADOR S.A. SPF
Signature
Référence de publication: 2015136319/15.
(150148371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.
RREEF Pan-European Infrastructure Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 117.671.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2015135170/10.
(150145265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
R42, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 180.971.
La convention de domiciliation du siège social de la société anonyme R42, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B180971 sis à L-8308 Capellen, 75, Parc d’activités, a été dénoncée avec effet
au 05 août 2015.
Partant, le siège social de la Société ne se trouve plus au L-8308 Capellen, 75, Parc d’activités.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
126799
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 06 août 2015.
Trident Trust Company (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2015135171/13.
(150146601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
S.C.I. Amavi, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5884 Hesperange, 404, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg E 5.708.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt et un juillet
Ont comparu:
1.- Monsieur BADOIL Philippe, gérant de société, né à Lyon (France) le 29 mai 1962, demeurant à F-89100 Malay-le-
Grand, RN60 - Les Grèves,
2.- Madame DOGARU Gheorghita, gérante de café, née à Slatina (Roumanie), le 1
er
septembre 1981, demeurant à
L-2230 Luxembourg, 57, rue du Fort Neipperg,
Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société civile qu'ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société civile immobilière prend la dénomination «S.C.I. AMAVI».
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la construction, l’aménagement, la gestion, l’administration et la mise
en valeur d’un ou de plusieurs immeubles, en dehors de toutes opérations commerciales ainsi que l’exercice de toutes
activités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet principal.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Hesperange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision des gérants.
Art. 5. Le capital social est fixé à mille euros (1.000,- €), représenté par cent (100) parts sociales de dix euros (10,00-
€) chacune, réparties comme suit:
1.- Mr BADOIL Philippe, quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- Mme DOGARU Gheorghita, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de mille euros (1.000,-
€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou
sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises
pour cause de mort par un associé à des non-associés (à l’exception des descendants en ligne directe) que moyennant
l’agrément unanime des autres associés.
Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société. Chaque part
d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les
gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société et faire et autoriser tous actes
et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.
La société est engagée à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe des gérants, soit par la signature individuelle
du gérant unique.
Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
Art. 10. Le vote des délibérations de l’assemblée des associations, sur tous les points y compris les modifications
statutaires, est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant
droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du ou
des gérant(s) et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour de l’as-
semblée.
Art. 12. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier
exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2015.
126800
L
U X E M B O U R G
Art. 13. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé ou du ou des
gérant(s).
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l’assemblée n’en décide
autrement.
Art. 15. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par
la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.
<i>Assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentants l’intégralité du capital social et se consi-
dérants comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale et prennent à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes:
1-) Nomination de Monsieur BADOIL Philippe, pré qualifié, au poste de gérant de la société pour une durée indéter-
minée.
2-) Le siège social est fixé à L-5884 Hesperange, 404, route de Thionville.
Fait et dressé à Hesperange, le 21 juillet 2015.
Philippe BADOIL / Gheorghita DOGARU
<i>Associé / Associéei>
Référence de publication: 2015135173/67.
(150146344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
Weblab S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Rose Lila S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3328 Crauthem, 1, rue Roger Krier.
R.C.S. Luxembourg B 131.506.
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre juillet,
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) Monsieur Samuel FABER, étudiant, né le 28 mars 1990 à Luxembourg, demeurant à L- 7349 Heisdorf, 11, rue des
Prunelles et
2) Monsieur Gilberto Fernandes CARDOSO, employé privé, né le 15 octobre 1984 à Luxembourg, demeurant à 1, Rue
Roger Krier, L-3328 Crauthem.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré être les seuls associés de la société à responsabilité
limitée Rose Lila S.à.r.l, ayant son siège social à L-7340 Heisdorf, 45, rue de la Forêt, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 13 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2299
du 13 octobre 2007. Les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500.-), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25€ (vingt-cinq euros)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Les comparants déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés actent que par acte de cession sous seing privé, les associés Amadala S.A. SPF et Madame Martine FABER-
VOGEL, chacun d'entre eux détenant 250 parts sociales, les ont cédés en date du 30 juin 2015, aux nouveaux associés
comme suit:
- Madame Martine FABER-VOGEL à Monsieur Samuel FABER, prénommé: 250 parts sociales
- La société Amadala S.A. SPF à Monsieur Gilberto Fernandes CARDOSO, prénommé: 250 parts sociales
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés actent la démission de Madame Martine FABERVOGEL, entant que gérant unique de la société et décident
de nommer avec effet rétroactif au 5 juillet 2015 et pour une durée indéterminée, entant que gérant unique Monsieur Gilberto
Fernandes CARDOSO, prénommé.
126801
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de changer la dénomination sociale de «Rose Lila S.à r.l.» en «Weblab S.àr.l.» et de modifier en
conséquence l'article 1
er
des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Weblab S. à r. l. (la
Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).»
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 3. La société a pour objet, à titre principal, mais non exhaustif, la réalisation de toutes activités liées à la création,
la diffusion, la distribution de services de communication et de publicité.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son
objet social.»
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident de modifier le siège social de son adresse actuelle au 45, rue de la Forêt Verte, L-7340 Heisdorf
à 1, Rue Roger Krier, L-3328 Crauthem et de modifier en conséquence l'article 2.1. des statuts qui aura dorénavant la teneur
suivante:
« 2.1. Le siège social est établi dans la commune de Roeser, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
les limites de la commune de Roeser par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'as-
semblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Faber, G. F. Cardoso et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 27 juillet 2015. Relation: 2LAC/2015/16931. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 4 août 2015.
Référence de publication: 2015135148/64.
(150145772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.
You immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1513 Luxembourg, 42, boulevard Prince Félix.
R.C.S. Luxembourg B 167.829.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 07/08/2015.
Référence de publication: 2015136241/10.
(150147326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
Yoseom s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7258 Helmsange, 2, rue des Pommiers.
R.C.S. Luxembourg B 176.052.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
126802
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015136244/12.
(150147131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.
Brevaco Succ., Société Anonyme.
Siège social: L-3318 Bergem, 5, Op Felsduerf.
R.C.S. Luxembourg B 27.026.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme «BREVACO SUCC.i>
<i>S.A..», avec siège social à L-3898 Foetz 16, rue du Commerce, constituée suivant acte notarié du 10 décembre 1987, eti>
<i>qui s'est tenu en date du 12 juin 2015i>
<i>Résolution:i>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-3898 Foetz 16, Rue du Commerce à L-3318 Bergem
5, Op Felsduerf
La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 12 juin 2015.
Référence de publication: 2015136371/15.
(150148575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.
Britanny Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 22.404.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2020:
- Monsieur Pierre LENTZ, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg,
Président;
- Monsieur Marc ALBERTUS, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Philippe PONSARD, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg,
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2020:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 août 2015.
Référence de publication: 2015136372/19.
(150148140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.
Cyaniris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.
R.C.S. Luxembourg B 125.554.
<i>Rectificatif du dépôt du 31/07/2015 numéro L150140752i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que les documents et informations qui s’y rapportent, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2015.
Référence de publication: 2015137214/12.
(150148570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
126803
L
U X E M B O U R G
Dîon, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 133.314.
<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associes en date du 31 juillet 2015 à Luxembourgi>
<i>Villei>
L'Associé décide:
- d'accepter la démission de Monsieur Stéphane BIVER de sa fonction de gérant B de la Société.
- de nommer à la fonction de gérant B de la Société, Monsieur Jean-Luc CLAUSE, employé privé, né à Dudelange
(Luxembourg), le 2 décembre 1969 résidant professionnellement à 128 boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg pour
une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015137215/18.
(150148981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
CVC Administration Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 164.537.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 août 2015.
Référence de publication: 2015137208/10.
(150149160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
CVC Investments Vista II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 178.143.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 août 2015.
Référence de publication: 2015137209/10.
(150149171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Consultlux GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9191 Welscheid, 2, Waarkstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 166.186.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
SOAK TRUST S.A.
Signature
Référence de publication: 2015137205/12.
(150148789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
126804
L
U X E M B O U R G
Com-Pass S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 87.910.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015137202/10.
(150148895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
C G M C, Compagnie Générale de Matériaux et Construction S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 58.594.
L'an deux mille quinze, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
S'est réunie:
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (l'Assemblée) de «COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE MATERIAUX ET CONSTRUCTION S.A.», en abrégé «C G M C» (la «Société»), une société anonyme, établie et
ayant son siège social à L-2529 Howald, 30, rue des Scillas,
constituée originairement sous la dénomination de «BUSCEMI A.G.», suivant acte notarié dressé en date du 07 mars
1997, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 350 du 04 juillet
1997.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte dressé par le notaire soussigné à la date du
27 septembre 2011, publié au Mémorial, en date du 15 novembre 2011, numéro 2779.
inscrite au registre de commerce sous le numéro B 58.594;
La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Monsieur François CONTESSI, indépendant, demeurant à
L-1429 Luxembourg, 39, rue Tony Dutreux,
L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que le présent acte a pour objet de:
1. Transfert du siège social de la société de L-2529 Howald, 30, rue des Scillas, vers L-8399 Windhof, 11, rue des Trois
Cantons et modification du 1
er
alinéa de l'article 2 des statuts.
2. Démission et nomination de commissaire aux comptes
Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur»
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Qu'il résulte de ladite liste de présence que les deux mille six cent (2.600) actions, représentatives du capital social, sont
toutes représentées à la présente assemblée et qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires
présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre de jour qui
leur a été communiqué au préalable.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-
tration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-2529 Howald, 30, rue des Scillas, vers L-8399 Windhof,
11, rue des Trois Cantons et de modifier par conséquent le 1
er
alinéa de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur
suivante:
« Art. 2. (1
er
alinéa). Le siège de la société est établi dans la commune de Koerich».
126805
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale révoque le commissaire aux comptes actuel et nomme en son remplacement la société à respon-
sabilité limitée FIDEOM Luxembourg TRUST, ayant son siège social à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons, RCS
B 161.475, pour une durée de six ans.
<i>Déclaration des comparantsi>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du
capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction
visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 850,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: François CONTESSI, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 29 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12659. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 10 août 2015.
Référence de publication: 2015137203/67.
(150148702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Cofinimmo Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 100.044.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Cofinimmo
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015137197/11.
(150148744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Coldod S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 188.034.
EXTRAIT
Et il est à noter également que le siège social du gérant unique:
Colony Luxembourg S.à r.l. a été transféré du 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, au 121 avenue de la
Faïencerie L-1511 Luxembourg, avec effet au 1
er
août 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Najat Mokhnache
<i>Mandataire habilitéi>
Référence de publication: 2015137199/16.
(150149391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
126806
L
U X E M B O U R G
Chambertin S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.
R.C.S. Luxembourg B 28.747.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of July.
Before the undersigned notary Me Jean SECKLER, residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersi-
gned;
THERE APPEARED:
BALFOUR INTERNATIONAL S.A., with registered office in L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München, re-
gistered with the Luxembourg Trade and Companies' Register at section B, under the number 27.319,
here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, professionally residing in Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to record his declarations and statements
as follows:
I.- That the public limited company “CHAMBERTIN S.A.H.”, having its registered office in L-2172 Luxembourg, 29,
rue Alphonse München, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register at section B, under the number
28.747, has been incorporated on 24 August 1988, pursuant to a deed of Maître Léon Thomas genannt Tom METZLER,
then notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number
302 of 16 November 1988.
II.- That the subscribed capital is fixed at thirty thousand nine hundred eighty-six Euros and sixty-nine Cents (30,986.69
EUR), divided into one thousand two hundred fifty (1,250) shares.
III.- That the appearing party is the sole shareholder of the company.
IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the company.
V.- That the appearing party is perfectly aware of the financial situation and the company's articles of association.
VI.- That the appearing party, acting as liquidator, declares having settled all of the company's liabilities and that he
will be answerable, for all of the company's debts and undertakings, even currently unknown.
VII.- That fully discharge is given to the board of directors and the statutory auditor for the performance of their mandates
up to this date.
VIII.- That the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
IX.- That the records and documents of the dissolved company will be kept for a period of five years at least at the
former registered office in L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at one thousand Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status
and residence, the said appearing party signed together with Us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den achtundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
BALFOUR INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München, eingetragen beim
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 27.319
hier vertreten durch Herrn Henri DA CRUZ, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Junglinster, auf Grund einer ihr
erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
126807
L
U X E M B O U R G
Die Vollmacht, vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwär-
tigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar seine Erklärungen und Feststellungen
zu beurkunden wie folgt:
I.- Dass die Aktiengesellschaft „CHAMBERTIN S.A.H.”, mit Sitz in L2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 28.747, gegründet
wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den Maître Léon Thomas genannt Tom METZLER, damals Notar, mit dem
Amtssitz in Luxemburg, am 24. August 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Nummer 302 vom 16. November 1988,
II.- Dass das Gesellschaftskapital auf dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro und neunundsechzig Cents
(30.986,69, EUR) festgelegt ist, eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien.
III.- Dass der Komparent alleiniger Aktieninhaber der Gesellschaft ist.
IV.- Dass der Komparent beschließt, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.
V.- Dass der Komparent die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.
VI.- Dass der Komparent, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und
dass er persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt
sind, gewährleistet.
VII.- Dass den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Aufsichtskommissar volle Entlast für die Ausübung ihrer
Mandate erteilt wird.
VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
IX.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am frü-
heren Gesellschaftssitz in L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München, aufbewahrt werden.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausend Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der
Gesellschaft.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Person gegen-
wärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben Person und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, Errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 juillet 2015. Relation GAC/2015/6593. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015137192/91.
(150149111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Co.Re.Mont S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
R.C.S. Luxembourg B 90.645.
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 03 juin 2015i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 juin 2015.
<i>Pour Co.Re.Mont S.A.
Les administrateursi>
Référence de publication: 2015137195/13.
(150148838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
126808
L
U X E M B O U R G
CVC Investments Vista S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 140.890.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 août 2015.
Référence de publication: 2015137210/10.
(150149174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Crescent European Specialty Lending (Unlevered) A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 186.696.
Les comptes annuels de la Société pour la période du 22 avril 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2015.
Malcolm Wilson
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015137168/13.
(150148905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Crescent European Specialty Loan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 186.682.
Les comptes annuels de la Société pour la période du 24 avril 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2015.
Malcolm Wilson
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015137169/13.
(150148903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Comifar Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 76.345.
IM JAHRE ZWEITAUSENDFÜNFZEHN, AM DREIUNDZWANZIGSTEN JULI.
Bevor Uns, der unterzeichneten Maître Cosita DELVAUX, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Lu-
xemburg.
Ist erschienen:
Herr Pierre LENTZ, „licencié en sciences économiques“, beruflich wohnhaft in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxemburg,
in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der Gesellschaft deutschen Rechts PHOENIX International Beteiligungs
GmbH, mit Sitz in Pfingstweidstr. 10-12, D-68199 Mannheim, Deutschland, eingetragen beim Amtsgericht Mannheim
unter der Nummer HRB 6884, nachfolgend die «PHOENIX» oder die «Übernehmende Gesellschaft», alleiniger Aktionär
der Gesellschaft Comifar Holding S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg,
eingetragen beim Handelsregister Luxemburg am Sektion B unter der Nummer 76345, nachfolgend die «COMIFAR» oder
die «Übertragende Gesellschaft»,
126809
L
U X E M B O U R G
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche nach ne varietur Zeichnung durch den Bevollmächtigten und die
beurkundende Notarin zum Zwecke der Registrierung an der vorliegenden Urkunde beigefügt bleibt.
Der Erschienene ersucht die Notarin, die folgenden Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden:
1. Ein gemeinsamer Verschmelzungsplan wurde durch die Geschäftsführung der PHOENIX und den Verwaltungsrat
der COMIFAR aufgestellt. Dieser Verschmelzungsplan sieht die grenzüberschreitende Verschmelzung der COMIFAR als
übertragende Gesellschaft auf die PHOENIX als übernehmende Gesellschaft vor und wurde am 11. Mai 2015 beim Han-
delsregister Luxemburg hinterlegt. Der Verschmelzungsplan wurde am 13. Mai 2015 im Mémorial C, Nummer 1244,
veröffentlicht.
2. Da PHOENIX alleiniger Aktionär der COMIFAR ist, ist Artikel 266 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom
10. August 1915 (nachfolgend das „Gesetz“) nicht anwendbar, sodass eine Überprüfung des Verschmelzungsplans durch
einen Sachverständigen nicht erforderlich ist.
3. Die im Artikel 267 des Gesetzes aufgeführten Unterlagen und Dokumente wurden für einen Monat am Sitz der
aufnehmenden Gesellschaft und der übertragenden Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre zur Verfügung gestellt.
4. Da das Abhalten einer Versammlung der COMIFAR gemäss Artikel 279 (2) des Gesetzes nicht erforderlich ist, erklärt
der Erschienene, dass nur eine Generalversammlung der Übernehmenden Gesellschaft heute abgehalten wird, um die
Verschmelzung zu bestätigen und der Verschmelzung zuzustimmen. Die Verschmelzung zwischen der Übernehmenden
Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft erfolgt für deutsche und luxemburgische steuerliche Zwecke mit Wirkung
zum 31. Januar 2015, so dass die Gesellschaft COMIFAR durch die Verschmelzung ohne Liquidation aufgelöst wird und
definitiv aufhört zu existieren.
5. Die Löschung der Übertragenden Gesellschaft beim Handelsregister Luxemburg erfolgt in Übereinstimmung mit
Artikel 273ter (3) des Gesetzes erst wenn das Handelsregister Luxemburg vom Handelsregister der Übernehmenden Ge-
sellschaft benachrichtigt wird, dass die Verschmelzung wirksam geworden ist.
<i>Erklärungi>
Die Notarin bestätigt die Existenz und die Rechtmässigkeit der Rechtshandlungen, die der Übertragenden Gesellschaft
obliegen, und des Verschmelzungsplans gemäss Artikel 271 (2) des Gesetzes.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, die der Gesellschaft anlässlich gegenwärtiger Urkunde entstehen, wer-
den auf ungefähr EUR geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienene, den der Notarin nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, hat dieser mit der Notarin gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: P. LENTZ, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/23295. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 10. August 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015137160/57.
(150149177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Concrete Settlement Agent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 185.609.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé unique de la Société en date du 31 juillet 2015i>
Il a été décidé:
- de prendre acte de la démission de son mandat de gérant de la Société par Mme Preeti Kotwani Khitri à compter de
ce jour;
- de nommer aux fonctions de gérant de la Société M. Antonio José Lopes, né le 29 septembre 1967 à Dos Pombas, Cap
Vert, demeurant professionnellement 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, à compter de ce jour et pour
une durée indéterminée. Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Mme Zamyra H. Cammans,
- M. Antonio José Lopes.
126810
L
U X E M B O U R G
Pour extrait certifié conforme
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015137164/19.
(150148725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
General Marva S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 192.456.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 10 août 2015.
Référence de publication: 2015137351/10.
(150148916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
GFI Software IP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 176.600.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 5 août 2015i>
En date du 5 août 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter les démissions de Monsieur Walter SCOTT et Monsieur Paul GOODRIDGE de leurs mandats de gérant de
classe A de la Société avec effet au 28 mai 2015;
- d'accepter la démission de Monsieur Ingo BEDNARZ de son mandat de gérant de classe B de la Société avec effet au
28 mai 2015;
- de nommer Monsieur Josef CALLEJA, né le 15 janvier 1974 à Pieta, Malte, résidant à l'adresse suivante: 28, Gaspare
Pace Street, Siggiewi, Malte, en tant que nouveau gérant unique de la Société avec effet au 28 mai 2015 et ce pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2015.
GFI Software IP S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015137352/21.
(150149156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Gregelvi S.à.r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 194.599.
<i>Extrait des décisions prises par les associés de la Société du 31 juillet 2015i>
Le 31 Juillet 2015, les associés de Gregelvi S.à r.l. SPF ont pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Mr. David Dion en qualité de Gérant de la Société avec effet au 6 Juillet 2015;
- De nommer Mr. Julien Ansay, ayant son adresse professionnelle à 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
en qualité de Gérant de la Société avec effet au 6 Juillet 2015 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 11 Août 2015.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015137336/16.
(150149596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
126811
L
U X E M B O U R G
Grosvenor Continental Europe Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 109.165.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2015.
Référence de publication: 2015137337/10.
(150149484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Fitness Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 106.478.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FITNESS PROJECT S.A.
Référence de publication: 2015137326/10.
(150149073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Fleet Renting SC, Société Civile.
Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg E 4.991.
DISSOLUTION
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 03 Août 2015i>
Ce jour, il a été décidé la dissolution de la Société Civile FLEET RENTING SC avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2015137327/12.
(150148732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Grana Companies, Société Anonyme.
Siège social: L-1937 Luxembourg, 1, rue Auguste Liesch.
R.C.S. Luxembourg B 128.311.
<i>Rectificatif de la première publication au RCSL L130139596i>
Les comptes annuels au 31/12/12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015137361/10.
(150148601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
GRE Spirit S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Valore Credit S.à r.l.).
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 174.936.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
126812
L
U X E M B O U R G
Pétange, le 29 juin 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015137365/13.
(150148965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Grosvenor First European Property Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 60.935.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2015.
Référence de publication: 2015137367/10.
(150149491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Harlequin Enterprises II B.V./ S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège de direction effectif: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 117.523.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 29 juin 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015137371/13.
(150148925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Henderson Joint Ventures Property Funds Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 131.972.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société prissent le 4 Août 2015i>
L'associé unique de la Société décide conformément aux statuts de la Société:
D'accepter la démission de Monsieur Jeremy Vickerstaff en qualité de gérant de la Société avec effet au 4 Août 2015.
De nommer M. Olivier Mortelmans né le 25 Août 1957 à Wilrijk, Belgique et domicilié au 37c avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet au 4 Août 2015.
Référence de publication: 2015137379/13.
(150149593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Hines-Laser Brindley 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 153.955.
Les statuts coordonnés au 23/07/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/08/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015137385/12.
(150149309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
126813
L
U X E M B O U R G
Hamamelis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 181.800.
<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société eni>
<i>date du 30 juin 2015i>
L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- d'accepter la démission de Mr. Stéphane BIVER né le 03.08.1968 à Watermael-Boitsfort en tant qu'administrateur de
la société
- de nommer Mr. Jean-Pierre HIGUET, né le 23.11.1960 à Couvin (Belgique) demeurant à L-2330 Luxembourg, 128,
boulevard de la Pétrusse, en tant que nouvel administrateur de la société, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires se
tenant en 2018.
- DATA GRAPHIC S.A., société anonyme, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le
numéro B 42 166, informe que son adresse a été transférée au 8 rue Heinrich Heine L-1720 Luxembourg en date du 9
décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015137390/21.
(150149424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Harvey Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 187.512.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 Août 2015.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015137391/11.
(150149312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
HBS Invest, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand Rue.
R.C.S. Luxembourg B 189.910.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HBS INVESTi>
Référence de publication: 2015137392/10.
(150148951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Hôtel MEYER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6310 Beaufort, 120, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 98.318.
L'an deux mille quinze, le quatre août.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbrück,
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HÔTEL MEYER S.A., une société anonyme établie et ayant son
siège social à L-6310 Beaufort, 120, Grand'rue, (matr: 1991 2201 522) inscrite au registre de commerce et des sociétés de
et à Luxembourg, section B sous le numéro 98.318, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker de résidence à
Echternach, en date du 29 mars 1991, publié au Mémorial C numéro 345 de l'année 1991
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul GIERTEN, hôtelier, demeurant à L-6310 Beaufort, 120,
Grand'rue.
126814
L
U X E M B O U R G
L'assemblée renonce à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l'assemblée constate
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Changement de l'article 3 des statuts.
2. -Divers
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Unique résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer l'article 3 des statuts qui aura dorénavant la
teneur suivante:
Art. 3. La Société est créée pour une durée illimitée.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
<i>Déclarationi>
Les actionnaires déclarent que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles
506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (fi-
nancement du terrorisme).
<i>Fraisi>
Les frais des présentes évalués à 750.- euros sont à charge de la société.
Dont procès-verbal, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes,
Et après lecture faite, les actionnaires comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Paul GIERTEN, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 5 août 2015. Relation: DAC/2015/13115. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 11 août 2015.
Référence de publication: 2015137396/51.
(150149026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
HV. Com International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 73.704.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 2015i>
L'assemblée décide à l'unanimité de retransférer le siège social avec effet au 1
er
août 2015 au 10, rue Willy Goergen,
L-1636 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2015.
<i>Pour le conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2015137412/13.
(150148667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
126815
L
U X E M B O U R G
Merck-Finanz AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 9.108.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 11. August 2015.
<i>Für: MERCK-FINANZ AG
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015137570/14.
(150149220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Meyrin Investments, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 82, Boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 150.881.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015137571/10.
(150149504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Michael Page International (Luxembourg), Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 124.884.
Les comptes annuels au 31/12/2014 de MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM), Place du Champs de Mars,
5 à B-1050 Bruxelles ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
conformément aux dispositions des articles 160-2, 160-3 et 9 de la loi modifiée du 10/08/1915 sur les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015137572/12.
(150149568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Quilvest Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 183.533.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2015.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015137684/14.
(150148856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
126816
Adagio
Armador S.A. SPF
Brevaco Succ.
Britanny Investment
Chambertin S.A.H.
Cofinimmo Luxembourg S.A.
Coldod S.à r.l.
Comifar Holding S.A.
Compagnie Générale de Matériaux et Construction S.A.
Com-Pass S.A.
Concrete Settlement Agent S.à r.l.
Consultlux GmbH
Co.Re.Mont S.A.
Corestate Capital Holding S.A.
Crescent European Specialty Lending (Unlevered) A S.à r.l.
Crescent European Specialty Loan S.à r.l.
CVC Administration Services S.à r.l.
CVC Investments Vista II S.C.A.
CVC Investments Vista S.C.A.
Cyaniris S.A.
Dîon
Fitness Project S.A.
Fleet Renting SC
General Marva S.à r.l.
GFI Software IP S.à r.l.
Grana Companies
Gregelvi S.à.r.l. SPF
GRE Spirit S.à r.l.
Grosvenor Continental Europe Holdings S.A.
Grosvenor First European Property Investments S.A.
Hamamelis S.A.
Harlequin Enterprises II B.V./ S.à.r.l.
Harvey Invest S.A.
HBS Invest
Henderson Joint Ventures Property Funds Management S.à r.l.
Hines-Laser Brindley 9 S.à r.l.
Hôtel MEYER S.A.
HV. Com International S.A.
Knoxville Investments S.à r.l.
Lglobal Funds
LI-Invest Fonds
Merck-Finanz AG
Meyrin Investments
Michael Page International (Luxembourg)
Quaesta Capital Umbrella SICAV-SIF
Quilvest Asset Management S.A.
R42
Rockspring TransEuropean Properties V FIG S.à r.l.
Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l.
Rose Lila S.à r.l.
RREEF Pan-European Infrastructure Lux S.à r.l.
S.C.I. Amavi
Syncro Funds (Lux)
Valore Credit S.à r.l.
Weblab S.à r.l.
Yoseom s.à r.l.
You immo S.A.