This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2565
21 septembre 2015
SOMMAIRE
Camo-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123079
Case Lobaio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123078
Caulfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123077
CBC AcquiCo1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123078
CEB Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123078
CERE II F Co-invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
123079
Cicerone s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123078
CoDeLux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123079
Digital Services Holding XXII S.à r.l. . . . . . . .
123100
DRED SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123099
DV III General Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . .
123097
Leipziger Strasse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123082
Pariter Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123074
Perfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123076
Prince AcquiCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123075
PUBLICHIC & PROMOCHOC s.à r.l. une
idée différente de la publicité par l'objet s.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123075
Quercia Stwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123074
SHCO 50 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123082
SKaLux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123083
Spinelle Investments II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
123079
Sports and Leisure Brands . . . . . . . . . . . . . . . .
123081
SSCP Eleanor Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
123088
Sydney Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123077
Tac O Tac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123076
TA EU Acquisitions IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
123074
TA EU Luxembourg III S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
123075
TA EU Luxembourg II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
123074
TA EU Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
123075
TA EU Luxembourg V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
123076
Tai Tai Limited S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123081
Tamar International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
123081
Taxis Flanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123086
TENALA Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123081
Teufel Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123080
THEOLIA Management Company S.à r.l. . . .
123120
Thesis Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123080
Thierry Linster & Ivan Stupar Architectes, S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123096
Tompkins Square Park S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
123080
Trio Trans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123080
Waldeck Capital (Luxembourg) S.A. . . . . . . .
123077
Wants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123074
WRI Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123120
XI Callisto Luxco II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
123075
123073
L
U X E M B O U R G
Wants, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2268 Luxembourg, 30, rue d'Orchimont.
R.C.S. Luxembourg B 184.365.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126933/9.
(150138473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
TA EU Acquisitions IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.212.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 171.219.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Référence de publication: 2015126828/10.
(150138316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
TA EU Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 160.502.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Référence de publication: 2015126835/10.
(150138415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
Quercia Stwo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.
R.C.S. Luxembourg B 133.234.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange.
Carlo GOEDERT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015131023/12.
(150142488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.
Pariter Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 26.951.
Le soussigné Laurent JACQUEMART, avec adresse au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, démis-
sionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société PARITER HOLDING S.A., 3A, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B 26.951.
Luxembourg, le 29 juillet 2015.
Laurent JACQUEMART
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015130991/13.
(150140950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.
123074
L
U X E M B O U R G
XI Callisto Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 179.460.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126943/9.
(150138053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
TA EU Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.212.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.382.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Référence de publication: 2015126836/10.
(150138414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
TA EU Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.212.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.380.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Référence de publication: 2015126837/10.
(150138416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
PUBLICHIC & PROMOCHOC s.à r.l. une idée différente de la publicité par l'objet s.à r.l., Société à responsabilité
limitée.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 38, rue du Golf.
R.C.S. Luxembourg B 22.894.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015129813/11.
(150139217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.
Prince AcquiCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 166.030.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 23. Juli 2015.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2015132204/14.
(150142981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2015.
123075
L
U X E M B O U R G
TA EU Luxembourg V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.212.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 175.426.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Référence de publication: 2015126838/10.
(150138413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
Tac O Tac, Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 87.119.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015126843/10.
(150137393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
Perfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 95.870.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue en date du 23 juillet 2015i>
L'Assemblée Générale des Actionnaires a pris connaissance et a approuvé la démission avec effet immédiat de:
- Monsieur Jean LAMBERT, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, de son
mandat d'Administrateur.
- Madame Claudia HERBER, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, de son
mandat d'Administrateur.
- Monsieur Patrice YANDE, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, de son
mandat d'Administrateur.
- D'EXAUDIT SA, dont le siège social est situé à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert de son mandat de
commissaire aux comptes.
L'Assemblée Générale des Actionnaires a pris connaissance et a approuvé la nomination avec effet immédiat de:
- Monsieur Didier MORIN, né le 3 juillet 1979 à Boulogne-Billancourt (France) et demeurant professionnellement à
L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur au Conseil d'Administration en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée
générale approuvant les comptes au 31 décembre 2015 qui se déroulera en 2016.
- M. Eric CHINCHON, né le 22 Janvier 1980 à Fontenay-sous-bois (France) et demeurant professionnellement à L-1258
Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur au Conseil d'Administration en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée gé-
nérale approuvant les comptes au 31 décembre 2015 qui se déroulera en 2016.
- M. Claude BIRNBAUM, né le 25 Avril 1961 à Luxembourg (Luxembourg) et demeurant professionnellement à L-1258
Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur au Conseil d'Administration en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée gé-
nérale approuvant les comptes au 31 décembre 2015 qui se déroulera en 2016.
- M. Didier MORIN, né le 3 juillet 1979 à Boulogne-Billancourt (France) et demeurant professionnellement à L-1258
Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur en tant que Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée générale approuvant
les comptes au 31 décembre 2015 qui se déroulera en 2016.
L'Assemblée Générale des Actionnaires a pris connaissance et a approuvé le transfert du siège social de la société du
19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg au 16, rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg
Luxembourg, le 23 juillet 2015.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015132208/34.
(150142516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2015.
123076
L
U X E M B O U R G
Caulfield, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 192.699.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue le 3 juillet 2015i>
<i>Résolution uniquei>
Renouvellement du mandat des Administrateurs avec effet rétroactif au 28/05/15
L’Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d’Administrateurs de Monsieur Marc AUGIER, de Monsieur
Jean-Patrick TRAN-PHAT et de Madame Anne-Lyse GILLES avec une date d’effet rétroactive au 28 mai 2015, date de
l’Assemblée générale Statutaire, et ce, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale 2021 approuvant les comptes arrêtés au 31
décembre 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 août 2015.
CAULFIELD
Référence de publication: 2015133635/17.
(150144995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
Sydney Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 104.019.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2015 que celle-ci a:
- approuvé le rapport du liquidateur, les comptes de liquidation en date du 13 juillet 2015 et renoncé à la nomination
d’un commissaire à la liquidation. Puis elle a donné décharge aux administrateurs et au liquidateur pour l’exécution de
leurs mandats respectifs. Pour finir, elle a entériné la clôture de la liquidation.
- que les livres comptables et documents sociaux seront conservés durant 5 ans au siège de la société, au 12D Impasse
Drosbach, L-1882 Luxembourg.
- que le boni de liquidation a été totalement distribué et aucune somme n’a été consignée sur le compte tiers du liquidateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015126805/18.
(150138698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
Waldeck Capital (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 140.185.
La, soussignée,
La société Luxiglobal Management S.à r.l.,
domiciliée au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg,
démissionne, par la présente, du mandat d'administrateur de la société anonyme:
Waldeck Capital (Luxembourg) S.A.
ayant son siège social au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 140.185
Le, soussigné,
Hendrik H.J. KEMMERLING, démissionne en tant que représentant permanent de la société Luxglobal Management
S.à r.l.
Date effective: le 24 juillet 2015.
Hendrik H.J. KEMMERLING.
Référence de publication: 2015126932/19.
(150138230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
123077
L
U X E M B O U R G
CEB Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 111.493.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2015133639/10.
(150144559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
Case Lobaio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 58.204.
Les Comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 04/08/2015.
<i>Pour CASE LOBAIO S.à r.l.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2015133633/12.
(150144839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
CBC AcquiCo1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 178.996.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 04 août 2015i>
Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique en date du 04 août 2015 que:
- Monsieur Andrew Henton avec adresse professionnelle au Queen's Road, bâtiment Raglan House, GB-BGU-GT1 1PU
St Peter Port a démissionné de son poste de gérante de la société, avec effet immédiat;
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015133636/15.
(150145329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
Cicerone s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 113.068.
Suite à la dissolution anticipée de la société CORDELL INVESTMENTS S.A. et au transfert de tous les actifs de cette
dernière à son actionnaire unique, la société TIKAL PRIMA S.A., en date du 10 décembre 2012, les associés de la société
CICERONE S.à r.l. se présentent comme suit:
- 495 parts sociales détenues par la société PORTA VITTORIA S.P.A., ayant son siège social à I-20135 Milan, Viale
Umbria angolo Via Cena, numéro REA: MI-1915285, d’une valeur nominale de vint-cinq euros (25,- EUR) chacune;
- 5 parts sociales détenues par la société TIKAL PRIMA S. A., ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 44, rue
de la Vallée, R.S.C. Luxembourg numéro B156391, d’une valeur nominale de vint-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Luxembourg, le 10 décembre 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour le gérant uniquei>
Référence de publication: 2015133646/17.
(150144713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
123078
L
U X E M B O U R G
Camo-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3441 Dudelange, 10, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 85.472.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CAMO-LUX S.A.
Référence de publication: 2015133629/10.
(150145056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
CoDeLux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 74.166.
EXTRAIT
Il résulte des lettres recommandées du 31 juillet 2015 que Madame Martina Humartus et Monsieur Didier Deilise ont
démissionné de leur poste d'administrateur avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2015.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015133653/13.
(150145306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
CERE II F Co-invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 44.200,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 128.641.
En date du 23 juillet 2015, l'associé CERE II F Co-Invest Finance S.à r.l., avec siège social au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, a cédé son unique part sociale, à Carlyle Europe Real Estate Master Co-Investment II-F, LP,
avec siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle County, Delaware, Etats-Unis, qui les acquiert.
En conséquence, l'associé unique de la société est Carlyle Europe Real Estate Master Co-Investment II-F, LP, précité
avec 884 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2015.
Référence de publication: 2015133641/15.
(150145391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
Spinelle Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.789.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique avec effet au 15 juillet 2015i>
1. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet immédiat.
2. Monsieur David BURGOS, né à Saragosse (Espagne), le 21 septembre 1978, demeurant professionnellement à L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
Luxembourg, le 4 août 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SPINELLE INVESTMENTS II S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015134236/16.
(150145085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
123079
L
U X E M B O U R G
Trio Trans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 48.
R.C.S. Luxembourg B 92.217.
Les comptes annuels du 01/01/2011 au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015134256/10.
(150144422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
Thesis Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 142.895.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015126856/10.
(150137942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
Tompkins Square Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 113.281.
<i>Rectificatif des comptes annuels révisés au 30 septembre 2014 et déposés au registre de commerce et des sociétés le 26i>
<i>mars 2015 sous la référence L150053525i>
Les comptes annuels révisés au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015134254/12.
(150144596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
Teufel Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 900.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 153.971.
EXTRAIT
Suite aux résolutions prises en date du 30 juillet 2015 par les associés de la Société, il a été décidé:
- d’accepter la démission de M. Sascha Kaumann de son poste de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat;
et
- de nommer M. Stefan Margolis, né le 9 septembre 1978 à Regensburg, Allemagne, et ayant son adresse professionnelle
au 3, Salvatorstrasse, 80333 Munich, Allemagne, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et ce
pour une durée indéterminée;
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais constitué des personnes suivantes:
- Mme Nadia Dziwinski, gérant de catégorie B;
- M. François Champon, gérant de catégorie B;
- M. Stefan Margolis, gérant de catégorie A; et
- M. Martin Block, gérant de catégorie A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 août 2015.
Référence de publication: 2015134253/22.
(150144704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
123080
L
U X E M B O U R G
Sports and Leisure Brands, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 43.612.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015134237/9.
(150144393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
Tai Tai Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.803.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 août 2015.
Référence de publication: 2015134245/11.
(150144294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
Tamar International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 19.269,00.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 103.345.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés, en date du 15 juillet 2015:i>
- acceptation de la démission de Monsieur Peter Müller de son poste de gérant B en date du 15 juillet 2015;
- nomination de Madame Céline Malpertuis, administrateur de sociétés, née le 03 Octobre 1985 à Martigny Combe
(Suisse), demeurant professionnellement au 36 Boulevard Helvétique, CH -1207 Genève, comme nouveau gérant B de la
société, pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015134267/14.
(150145283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
TENALA Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 175.977.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2015i>
1. L’Assemblée prend note des rapports du liquidateur et du commissaire vérificateur sur la liquidation de la Société,
et approuve les comptes de liquidation arrêtés au 28 juillet 2015.
2. L’Assemblée décide de donner décharge au liquidateur, C.G. Consulting, ayant son siège social au 40, avenue Mon-
terey à L-2163 Luxembourg, ainsi qu’au commissaire vérificateur, Co-Ventures S.A., ayant son siège social au 40, avenue
Monterey à L-2163 Luxembourg, relativement à l’exécution de leur mandat.
3. L’Assemblée décide de clôturer la liquidation.
4. L’Assemblée décide que les documents et registres de la société seront conservés pendant une période de cinq ans
suivant la publication de la présente résolution au Journal officiel au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juillet 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015134271/20.
(150145290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
123081
L
U X E M B O U R G
Leipziger Strasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SHCO 50 S.à r.l.).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 176.276.
In the year two thousand and fifteen.
On the twenty fourth day of July.
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing at Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organized under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 103123,
represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Pétange (Grand-
Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
The appearing party, through its attorney, declared and requested the notary to act:
that the appearing party is the sole present partner of the private limited company (société à responsabilité limitée)
"SHCO 50 S.à r.l.", having its registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section
B and number 176276, incorporated by deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing at Diekirch (Grand-Duchy of
Luxembourg), on March 26, 2013, published in the Mémorial C number 1253 of May 28, 2013,
and that the appearing party has taken the following resolution:
<i>Resolutioni>
The name "Leipziger Strasse S.à r.l." is adopted by the company, article four of the articles of association is amended
and will have henceforth the following wording:
« Art. 4. The company will assume the name of "Leipziger Strasse S.à r.l.", a private limited liability company».
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg), on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze
Le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B numéro 103123,
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à
Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte
avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée "SHCO 50 S.à r.l.", ayant
son siège à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous la section B numéro 176276, constituée par acte de Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à
Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 26 mars 2013, publié au Mémorial C numéro 1253 du 28 mai 2013,
et que la comparante a pris la résolution suivante:
123082
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutioni>
La dénomination sociale "Leipziger Strasse S.à r.l." est adoptée par la société, l’article quatre des statuts est modifié et
aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 4. La société prend la dénomination de "Leipziger Strasse S.à r.l.", société à responsabilité limitée».
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la personne
comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne com-
parante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 juillet 2015. Relation: EAC/2015/17866. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015133304/71.
(150144051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.
SKaLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9540 Wiltz, 21, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 198.969.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Samir KALABIC, employé privé, né le 12 décembre 1971 à Zavidovici (Bosnie-Herzégovine), demeurant
à L-9558 Wiltz, 26, rue des Sports;
2. Monsieur Mirsudin SKRIJELJ, ouvrier, né le 15 janvier 1972 à Javorova (Monténégro), demeurant à L-3755 Rume-
lange, 43, rue Batty Weber.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient devenir
associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet des travaux de façonnage de fer pour béton armé (Eisenbiegerarbeiten für Stahlbeton),
elle peut effectuer des travaux de terrassement, des travaux publics (Tiefbauarbeiten) et des travaux de fouille, ainsi que
tout qui se rapporte directement ou indirectement à des travaux de canalisation.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l'extension ou le développement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifi-
cations des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «SKaLUX S.à r.l.».
Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Wiltz.
123083
L
U X E M B O U R G
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par
assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d’autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé
unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
En cas d’associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, soit
par la signature individuelle du gérant technique soit par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par
le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration.
Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou
communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de com-
munication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou
par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment,
sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les
questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution
sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circons-
tances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
123084
L
U X E M B O U R G
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième lundi du mois de
juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de
Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Disposition transitoire:i>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libération:i>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, déclare souscrire les cent (100) parts sociales
comme suit:
- Monsieur Samir KALABIC, pré-qualifié,
cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
- Monsieur Mirsudin SKRIJELJ, pré-qualifié,
cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné,
qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont
constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
2.- Est nommée gérant technique pour une durée indéterminée:
123085
L
U X E M B O U R G
Monsieur Samir KALABIC, employé privé, né le 12 décembre 1971 à Zavidovici (Bosnie-Herzégovine), demeurant à
L-9558 Wiltz, 26, rue des Sports.
3.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Mirsudin SKRIJELJ, ouvrier, né le 15 janvier 1972 à Javorova (Monténégro), demeurant à L-3755 Rumelange,
43, rue Batty Weber.
4.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du gérant technique soit
par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
4.- L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-9540 Wiltz, 21, Avenue de la Gare.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les parties comparantes au fait qu'avant toute activité commerciale de la société,
celles-ci doivent être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l’objet social
tel que modifié ci-dessus, ce qui est expressément reconnu par les parties comparantes.
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. KALABIC, M. SKRIJELJ, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12725. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 03 août 2015.
Référence de publication: 2015133307/162.
(150143652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.
Taxis Flanel, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9047 Ettelbruck, 13B, rue Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 199.002.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt-et-un juillet.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
A comparu:
1. Monsieur Paulo José PEREIRA RIBEIRO, chauffeur de taxis, né le 5 août 1965 à Meca Alenquer (P), demeurant à
L-9047 Ettelbruck, 13b, rue Prince Henri.
2. Madame Maria Isabel HENRIQUES FRAZÃO MENDONÇA RIBEIRO, salariée, née le 17 février 1968 à Abrigada
(P), demeurant à L-9047 Ettelbruck, 13b, rue Prince Henri.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils
vont constituer, comme suit:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «TAXIS FLANEL»
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune d'Ettelbruck.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège
social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de taxis ainsi que la location de voitures et taxis.
D'une manière générale, elle pourra exécuter toutes opérations commerciales et industrielles qu'elle estimera dans l'ac-
complissement et le développement de son objet.
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rat-
tachant directement et indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entreprises
similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires. En général, la société
pourra faire toutes les autres opérations et transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet ou é tout autres objet social similaires ou susceptible d'en favoriser
l'exploitation et le développement sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.
La prestation de services sous quelque forme que ce soit, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature
à en faciliter l'extension ou le développement.
123086
L
U X E M B O U R G
La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises
ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi
que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de
toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations,
à différentes sociétés (filiales ou non).
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales, d'une
valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros, chacune.
Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent
être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.
Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues par
l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans
limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.
Art. 10. L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.
Dans tous les cas, les décisions à prendre par les associés ne seront valablement prises qu'à la majorité des trois quarts.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation
personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l'exception du
premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille quinze.
Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice
net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre d'amortissement
et de réserves sera réparti comme suit:
a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale des associés.
Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que
toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.
Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.
Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions
légales en vigueur.
Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert le cas échéant
l'autorisation préalable des autorités compétentes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont toutes été souscrites de la manière suivante:
Paulo José PEREIRA RIBEIRO, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Maria Isabel HENRIQUES FRAZAO MENDONCA RIBEIRO, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.
123087
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à 800.-€.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant, les associés représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués.
Les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité des voix:
- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Paulo José PEREIRA RIBEIRO, préqualifié.
- Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée, Madame Maria Isabel HENRIQUES FRAZAO
MENDONCA RIBEIRO, préqualifiée.
- La société sera valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative.
- L'adresse du siège de la société est fixée à L-9047 Ettelbruck, 13b, rue Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. I. HENRIQUES FRAZÃO MENDONCA RIBEIRO, P.J. PEREIRA RIBEIRO, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 22 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12264. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 4 août 2015.
Référence de publication: 2015133350/105.
(150144176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.
SSCP Eleanor Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 198.976.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of July.
Before the undersigned Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
SSCP Eleanor Holdings S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, having its
registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process
of registration with the Trade and Companies Registry of Luxembourg;
represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal given on July 22, 2015.
The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which
will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association
(hereafter the “Articles”).
Art. 2. Corporate object. The objects of the Company are:
2.1 The Company's object is to directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Luxem-
bourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or participations;
2.2 The Company may acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole
of or any part of the stocks, shares, participations, debentures, debenture stocks, bonds, debt and debt instruments, loans,
securities and other financial assets made, issued or guaranteed by any person or entity whatsoever and any other asset of
any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same. The Company may also
directly or indirectly, make, purchase or invest in loans, securities or any other financial assets;
2.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means;
123088
L
U X E M B O U R G
2.4 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations
in subsidiaries of the Company owning such investments;
2.5 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Compa-
nies") or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it
to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector;
2.6 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not
enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited
to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible
or not, the use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued
by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of
and in accordance with the provisions of the 1915 Law.
2.7 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,
all transactions which are necessary to fulfill its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “SSCP Eleanor Parent S.à r.l.”.
Art. 5. Registered office.
5.1 The registered office is established in Luxembourg-Findel (commune Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg.
5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole director
(gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gérance).
5.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed Share Capital
6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares (parts sociales) of one euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely
paid up.
6.1.2 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company
(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him and
the Company represented by him shall have to be established in writing.
6.2 - Modification of Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders’
meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.
6.3 - Profit Participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 - Transfer of Shares
6.5.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of Article 189 and 190 of the Law.
6.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-
quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
123089
L
U X E M B O U R G
6.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company
or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of
Article 1690 of the Civil Code.
6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in accordance
with Article 185 of the Law.
Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and Removal
7.1.1 The Company is managed by a sole director (gérant) or more directors (gérants). If several directors (gérants) have
been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not to be
shareholder(s).
7.1.2 The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3 A director (gérant) may be dismissed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted
by the shareholders.
7.1.4 The sole director (gérant) and each of the members of the board of directors (conseil de gérance) shall not be
compensated for his/their services as director (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders.
The Company shall reimburse any director (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office,
including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of directors
(gérants).
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors (conseil de
gérance).
7.3 - Representation and Signatory Power
7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors
(gérants), the board of directors (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this Article 7.3 shall have been complied with.
7.3.2 The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of directors
(gérants), by the joint signature of any two members of the board of directors (conseil de gérance).
7.3.3 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)
may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
7.3.4 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)
will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures
7.4.1 The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It
may also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meeting of the board of directors and of the shareholders.
7.4.2 The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the
chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Company.
7.4.3 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed
by the chairman, by the secretary or by any director (gérant).
7.4.4 The board of directors (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors
(gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance).
7.4.5 In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors
(gérants) present or represented at such meeting.
7.4.6 Any director (gérant) may act at any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by appointing in writing
another director (gérant) as his proxy. A director (gérant) may also appoint another director (gérant) to represent him by
phone to be confirmed at a later stage.
7.4.7 Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) shall have the same effect as resolutions
passed at the directors’ (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
7.4.8 Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by
telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.
7.5 - Liability of Directors (gérants)
123090
L
U X E M B O U R G
Any director (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him in the name of the Company.
Art. 8. General shareholders’ meeting.
8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.
Decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.
8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous
vote, may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s
share capital, subject to the provisions of the Law.
8.4 The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed
twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to
be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 9. Annual general shareholders’ meeting.
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in
accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as
may be specified in the notice of meeting, on the third Friday of the month of June, at 14:45.
9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director
(gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance), exceptional circumstances
so require.
Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised
by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is
more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal Year
The Company’s fiscal year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
11.2 - Annual Accounts
11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board
of directors (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be
made.
11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered
office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s) set-up in accordance with Article 200.
Art. 12. Distribution of profits.
12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and taxes represent the net profit.
12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,
until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to
a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to
the Articles.
13.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-
holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
Art. 15. Modification of articles. The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders,
by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
123091
L
U X E M B O U R G
<i>Transitional dispositioni>
The first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31 December
2015.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the appearing party, represented as stated above, declares to subscribe to
twelve thousand five hundred (12,500) shares, being the entire share capital of the Company, for an amount of twelve
thousand five hundred euros (EUR 12,500.-).
All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1. The Company will be administered by the following director(s) (gérants) for an unlimited period:
- Chris Black, born on 16 September 1976 in Chertsey, United Kingdom, with professional address at 2, Basil Street,
London SW3 1AA, United Kingdom;
- Anke Jager, born on 22 April 1968 in Salzgitter, Germany, with professional address at 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg - Findel, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Alexander James Bermingham, born on 19 December 1972 in Sheffield, United Kingdom, with professional address
at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The registered office of the Company shall be established at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, Grand Duchy
of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with the
notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-deux juillet.
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
SSCP Eleanor Holdings S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg, non encore immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;
ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 22 juillet 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci - avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après
la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. Objet social.
Les objets de la Société sont:
2.1 L'objet de la Société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations
dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts et
participations.
123092
L
U X E M B O U R G
2.2 La Société pourra acquérir (par souscription dès l’origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie
des titres, actions, debentures, debenture stocks, obligations dettes et instruments de dette et tout autre instrument financier
émis ou garantis par toute personne ou entité quelconque et tous autres biens de toutes sortes et de détenir les mêmes
instruments pour des besoins d'investissement, et de vendre, échanger et disposer des mêmes instruments. La Société peut
aussi, directement ou indirectement, accorder, acquérir, ou investir dans des prêts, des titres ou tout autre instruments
financiers.
2.3 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes
d'avoirs par tous moyens.
2.4 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou
indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.
2.5 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties
ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient
actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-
après reprises comme les "Sociétés Apparentées") ou toute autre entité, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur
financier.
2.6 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera
dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment,
par l’émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments convertibles ou
non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette,
avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, selon des termes qu'elle jugera opportuns;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces méthodes, pour
l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la Loi
de 1915;
2.7 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: SSCP Eleanor Parent S.à r.l..
Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Findel (commune Niederanven), Grand-Duché de Luxembourg.
5.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand - Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
5.3 L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou
en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), toutes entièrement souscrites et libérées.
6.1.2 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par
lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2 - Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de
l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article 199
de la Loi.
6.3 - Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre
des parts sociales existantes.
6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
123093
L
U X E M B O U R G
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire est admis par part sociale. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 - Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
6.5.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect
des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non - associés qu’après approbation préalable
en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts
ne peuvent être opposables à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de leur notification à la Société ou
de leur acceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
6.6 - Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés
conformément à l’article 185 de la Loi.
Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-
tueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).
7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par
les associés.
7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n’est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/leurs
services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l’assemblée générale des associés. La Société pourra
rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de son mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de
pluralité de gérants.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
7.3 - Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.
7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour
des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
7.3.4 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du man-
dataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un
secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.
7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et le
secrétaire ou par un notaire, seront déposées dans les livres de la Société.
7.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par
le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.
7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance.
7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les
gérants présents ou représentés à ladite réunion.
7.4.6 Tout gérant pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son
représentant. Un gérant pourra également désigner un autre gérant pour le représenter par téléphone, cela sera confirmé
par écrit par la suite.
7.4.7 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise lors d’une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents distincts.
123094
L
U X E M B O U R G
7.4.7 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par “conference call” via
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.
7.5 - Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-
lièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
8.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre
de parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital.
8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel
un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra
son vote par écrit.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, confor-
mément à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, troisième vendredi du mois de juin, à 14:45.
9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable
suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de l’avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de
pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont
contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas
qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former
le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice Social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
11.2 - Comptes Annuels
11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse
un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social
de la Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits.
12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et impôts, constituent le bénéfice net.
12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi
longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital
de la Société.
Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
13.2 Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l’assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.
13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
123095
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux
dispositions de la Loi.
Art. 15. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l’assemblée des associés
selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts ainsi établis, la partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales, étant 100% du capital social de la Société, pour un montant de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-).
Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400).
<i>Résolution de l'associé uniquei>
1. La Société est administrée par les gérants suivants pour une période illimitée:
- Chris Black, né le 16 septembre 1976 à Chertsey, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle à 2, Basil Street, Londres
SW3 1AA, Royaume-Uni;
- Anke Jager, née le 22 avril 1968 à Salzgitter, Allemagne, avec adresse professionnelle à 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Alexander James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle à 7,
rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi à 7, rue Lou Hemmer, L1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l’a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte français fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, le jour,
mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 24 juillet 2015. GAC/2015/6431. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 31 juillet 2015.
Référence de publication: 2015133318/456.
(150143122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.
Thierry Linster & Ivan Stupar Architectes, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.
R.C.S. Luxembourg B 100.021.
Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126859/10.
(150138777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
123096
L
U X E M B O U R G
DV III General Partner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 153.463.
In the year two thousand and fifteen on the seventh day of July,
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr Christophe Daum, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in his capacity as a special attorney-in-fact of DV III General Partner S.A., a société anonyme incorporated in
accordance with and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 21, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the
undersigned notary of 21 May 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1387 of 6
July 2010 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.463 (the
"Company"), whose articles of incorporation have been amended for the last time following a deed of the undersigned
notary dated 11 June 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1974 of 8
August 2012.
by virtue of the authority conferred on him by the resolutions adopted by the board of directors of the Company on 28
April 2015, a copy of which resolutions, signed "ne varietur" by the attorney-in-fact and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed with which it shall be formalised.
The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
I. The issued share capital of the Company is presently set at three hundred seventy-eight thousand sixty-five euro (EUR
378,065.-) divided into three hundred seventy-eight thousand sixty-five (378,065.-) shares with a nominal value of one
euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.
II. Pursuant to Article 7 of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company has been set at
ten million euro (EUR 10,000,000.-) divided into ten million (10,000,000) shares, each with a nominal value of one euro
(EUR 1.-) and pursuant to the same Article 7, the board of directors of the Company has been authorised to increase the
issued share capital of the Company. The article 5 of the Company's articles of association shall then be amended so as to
reflect the increase of share capital.
III. The board of directors of the Company, by the resolutions of 28 April 2015, and in accordance with the authority
conferred on him pursuant to Article 7 of the Company's articles of association, has decided subject to the confirmation by
anyone director of the Company of the receipt of the relevant subscription moneys, which confirmation has occurred on
01 July 2015, an increase of the issued share capital by an amount of two hundred seventy-six thousand euro (EUR
276,000.-) in order to raise the issued share capital to the amount of six hundred fifty-four thousand sixty-five euro (EUR
654,065.-) by the creation of two hundred seventy-six thousand (276,000) new shares with a nominal value of one euro
(EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as the already existing ordinary shares.
IV. The board of directors of the Company, by the resolutions of 28 April 2015, has accepted subject to the confirmation
by anyone director of Company of the receipt of the relevant subscription moneys, which confirmation has occurred on 01
July 2015, and following the cancellation of the preferential subscription rights in respect of this issue of the new shares,
the subscription of the new shares, together with a total share premium of two million four hundred eighty-four thousand
euro (EUR 2,484,000.-) as follows:
- AXA Real Estate Investment Managers France, a company governed by the laws of France, with registered office at
Coeur Défense, Tour B, La Défense 4, 100 Esplanade du Général de Gaulle, F-92400 Courbevoie, France registered with
the Registre du Commerce et des Sociétés of Nanterre under number 397 991 670: two hundred seventy-six thousand
(276.000) shares.
V. All these new shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscriber and fully paid up, together with the
share premium, by contribution in cash to the Company on 13 May 2015, so that the total amount of two million seven
hundred sixty thousand euro (EUR 2,760,000.-), representing the amount of the above mentioned capital increase and
comprising the payment of a share premium in an amount of two million four hundred eighty-four thousand euro (EUR
2,484,000.-), has been on 13 May 2015 at the free disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary
by presentation of the supporting documents for the relevant payment.
VI. As a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of 13 May 2015, paragraph
one of Article 5 of the Company's articles of association is therefore amended and shall read as follows:
" Art. 5. Issued Capital. The Issued Capital of the Company is set at six hundred fifty-four thousand sixty-five euro
(EUR 654,065.-) divided into six hundred fifty-four thousand sixty-five (654,065.-) shares with a nominal value of one
euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.”
123097
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately
three thousand euros (3,000.-EUR).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le sept juillet,
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
M. Christophe Daum, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de DV III General Partner S.A., une société anonyme régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du [notaire soussigné] du 21 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations sous le numéro 1387 du 6 juillet 2010, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 153463 (la «Société»), dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du
notaire soussigné du 11 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1974 du 8
août 2012,
en vertu d'une procuration lui conférée par les résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en date
du 28 avril 2015, une copie desdites résolutions, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elles seront formalisées.
Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et
constatations suivantes:
I. Le capital social de la Société s'élève actuellement à trois cent soixante dix-huit mille soixante-cinq euros (EUR
378.065,-) divisé en trois cent soixante dix-huit mille soixante-cinq (378.065) actions ayant chacune une valeur nominale
d'un euro (EUR 1,-), chacune étant entièrement libérée.
II. En vertu de l'article 7 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à dix millions d'euros (EUR
10.000.000,-) divisé en (10.000.000) d'actions, ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et en vertu du même
Article 7, le conseil d'administration de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations du capital social de la
société. L'article 5 des statuts devra alors être modifié de manière à refléter les augmentations de capital ainsi réalisées.
III. Le conseil d'administration de la Société, par résolutions du conseil d'administration de la Société du 28 avril 2015,
et en conformité avec les pouvoirs lui conférés en vertu de l'article 7 des statuts de la Société, a décidé sous réserve de la
confirmation par un administrateurs du conseil d'administration de la Société de la réception des fonds de souscription,
laquelle confirmation est intervenue le 01 juillet 2015, une augmentation du capital social émis à concurrence de deux cent
soixante-seize mille euros (EUR 276.000,-) en vue de porter le capital social émis à six cent cinquante-quatre mille soixante-
cinq euros (EUR 654.065,-) par la création et l'émission de six cent cinquante-quatre mille soixante-cinq (654.065)
nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.
IV. Le conseil d'administration de la Société, par résolutions du 28 avril 2015, a accepté, sous réserve de la confirmation
par un administrateur de la Société de la réception des fonds de souscription, laquelle confirmation est intervenue le 01
juillet 2015, et à la suite de l'annulation des droits de souscription préférentiels relatifs à l'émission des nouvelles actions,
la souscription des souscription des nouvelles actions, ensemble avec une prime d'émission totale de deux million quatre
cent quatre vingt quatre mille euros (EUR 2.484.000,-), comme suit:
- AXA Real Estate Investment Managers France, un société anonyme régit par le droit français, avec siège social au
Coeur Défense, Tour B, La Défense 4, 100 Esplanade du Général de Gaulle, F-92400 Courbevoie, France, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 337 991 670: deux cent soixante-seize mille
(276.000) actions.
V. Toutes les nouvelles actions ont été entièrement souscrites par le souscripteur susnommé et libérées intégralement,
ensemble avec la prime d'émission par un versement en numéraire à la Société le 13 mai 2015, de sorte que la somme de
deux millions sept cent soixante mille euros (EUR 2.760.000,-) représentant le montant de la susdite augmentation du
capital social et incluant le paiement de la prime d'émission pour un montant de deux millions quatre cent quatre vingt
quatre mille euros (EUR 2.484.000,-), se trouvait le 13 mai 2015 à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de libération.
123098
L
U X E M B O U R G
VI. A la suite de la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit avec effet le 13 mai 2015, le premier
alinéa de l'article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital Emis. Le capital émis de la Société est fixé à six cent cinquante-quatre mille soixante-cinq euros (EUR
654.065,-) divisé en six cent cinquante-quatre mille soixante-cinq (654.065) actions ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1,-), chacune étant entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme
de trois mille euros (EUR 3.000,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant a
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. DAUM, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/21659. Reçu soixante-quinze euros
75,00 EUR.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2015.
Référence de publication: 2015132808/135.
(150143264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.
DRED SCS, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1246 Luxemburg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 199.025.
Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft
1. Name der Gesellschaft. DRED SCS
2. Rechtsform. Kommanditgesellschaft (Société en commandite simple)
3. Unbeschränkt Haftender Gesellschafter. DRED - Real Estate Deutschland GP S.à r.l., eine Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend unter Luxemburger Recht, mit eingetragenem
Sitz in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B198.915, (der "Komplementär").
4. Haftung der Gesellschafter. In seiner Eigenschaft als Komplementär haftet der Komplementär unbegrenzt und ge-
samtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten und Verluste des Fonds, die nicht aus dem Fondsvermögen bedient werden
können.
Im Rahmen des Gesetzes von 1915 und des Gesellschaftsvertrags haften die Kommanditisten für die Verbindlichkeiten
und Verluste des Fonds nicht über ihre Einlage bzw. noch offene Kapitalzusage hinaus, solange sie nicht für den Fonds
handeln. Hiervon unberührt sind Handlungen in Ausübung ihrer Rechte als Kommanditisten des Fonds.
5. Kapital. Das Kapital der Gesellschaft beträgt eintausend (1.000,-) EUR.
6. Gesellschaftszweck. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist
a) der direkte Erwerb von Immobilien und die Bebauung, Verwaltung, Vermietung und der Verkauf der von ihr gehal-
tenen Immobilien;
b) der Erwerb und das Halten von Anteilen an einer oder mehreren Immobiliengesellschaften; und/oder
c) die Finanzierung einer oder mehrerer Immobiliengesellschaften, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft unmittelbar oder
mittelbar an der finanzierten Immobiliengesellschaft beteiligt ist
mit dem Ziel, den Kommanditisten Erträge aus der Verwaltung, Vermietung und Veräußerung der Immobilien zukom-
men zu lassen. Die Gesellschaft ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die sie zur Erfüllung
und Entwicklung ihres Geschäftszwecks für nützlich hält, wie z.B. Geschäfte zur Absicherung von Währungs- und/oder
Zinsrisiken oder die Gewährung von Sicherheiten (z.B. Garantien oder Patronatserklärungen) zugunsten von Immobilien-
gesellschaften, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar an der entsprechenden Immobiliengesell-
schaft beteiligt ist.
123099
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft kann im größten gesetzlich zulässigen Umfang alle Maßnahmen ergreifen und alle Transaktionen
ausführen, die sie für die Erfüllung und Entwicklung ihres Geschäftszwecks für zweckdienlich hält, jedoch immer unter
der Voraussetzung, dass die Gesellschaft keine Transaktionen tätigt, die eine beaufsichtigte Aktivität des Finanzsektors
begründen oder eine Geschäftserlaubnis nach Luxemburger Recht erfordern würde, ohne dass eine ordnungsgemäße Be-
rechtigung nach Luxemburger Recht vorliegt.
7. Eingetragener Sitz. 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg
8. Geschäftsführung / Vertretungsbefugnisse. Der Fonds wird von dem Komplementär DRED - Real Estate Deutschland
GP S.à r.l. in seiner Funktion als Verwalter (gérant) des Fonds verwaltet. Der Komplementär hat mindestens drei Ge-
schäftsführer.
Der Komplementär hat in seiner Funktion als Verwalter (gérant) des Fonds die umfassenden Befugnisse, im Namen des
Fonds sämtliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen innerhalb des Geschäftszwecks des Fonds und im Rahmen der
Anlagestrategie vorzunehmen, sowie im Namen des Fonds aufzutreten und zu handeln. Er hat insbesondere die Befugnis,
die Anlageziele, -richtlinien und -beschränkungen sowie die generelle Verwaltungs- und Geschäftspolitik des Fonds fes-
tzulegen und Verwaltungs-, Beratungs- und sonstige Verträge im Namen des Fonds zu schließen, die er für die Ausübung
seiner Funktion im Sinne des Geschäftszwecks des Fonds für notwendig oder nützlich hält, jeweils im Rahmen der Vor-
gaben des Gesellschaftsvertrages und der anwendbaren Gesetze und Vorschriften.
Sämtliche Befugnisse, die nicht gemäß anwendbarem Recht oder dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversamm-
lung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Komplementärs in seiner Funktion als Verwalter (gérant)
des Fonds.
Die Kommanditisten dürfen nicht an der Leitung bzw. Verwaltung des Fonds teilnehmen oder sein Geschäft bzw. seine
Handlungen beeinflussen und haben keine Befugnis und kein Recht, auf die Geschäftsführung des Fonds Einfluss zu
nehmen oder daran teilzuhaben, sofern dies nicht durch das Gesetz von 1915 und/oder den Gesellschaftsvertrag ausdrüc-
klich vorgesehen ist, aber in diesem Fall jeweils in den Grenzen des Gesetzes von 1915.
Dritten gegenüber wird der Fonds rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern des
Komplementärs verpflichtet oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von Personen, die durch den Komple-
mentär mit entsprechender Vertretungsbefugnis ausgestattet sind.
Kein Kommanditist darf den Fonds nach außen vertreten.
9. Gründungsdatum / Laufzeit. Die Gesellschaft wurde am 31. Juli 2015 gegründet. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte
Laufzeit.
Référence de publication: 2015132807/62.
(150144544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.
Digital Services Holding XXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.602.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of June,
before us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet SE, (formerly: Rocket Internet AG), a European Company (Societas Europaea) with its statutory seat
in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amts-
gericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 165662 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany (hereinafter “Rocket”),
being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, professionally residing in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 23 and 25 June 2015;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability business enterprise (Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Han-
delsregister) at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 126893 B, having
its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “Bambino 53. V V”),
being the holder of one (1) common share,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, professionally residing in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 22 and 25 June 2015;
3. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands, registered with
the commercial register of the Dutch Trade Register, under number 60628022, having its business address at Schiphol
Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands (hereinafter “Eiffel”),
being the holder of six hundred twenty-five (625) series A1 shares,
123100
L
U X E M B O U R G
here represented by Mr Frank Stolz-Page, professionally residing in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 24 and 25 June 2015;
4. Mercura Capital GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of Ger-
many with its statutory seat in Starnberg, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local
court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRB 200948, having its business address at Schießstättstraße
22, 82319 Starnberg (hereinafter “Mercura”),
becoming the holder of one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A2 shares,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, professionally residing in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 22 and 25 June 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties under 1., 2. and 3. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Digital Services Holding XXII
S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 188.602 and incorporated pursuant to
a deed of the notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, on 1 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2559 dated 22 September 2014. The articles of incorporation have been last modified
pursuant to a notarial deed of the notary Marc Loesch, on 14 January 2015, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1035 of 20 April 2015.
The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement. The meeting of
the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Mercura participates
and votes for the purpose of Agenda point 4 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Decision to create a new class of shares, referred to as the series A2 shares (the “Series A2 Shares”), in addition to
the existing common shares (hereinafter the “Common Shares”) and the series A1 shares (hereinafter the “Series A1
Shares”).
2. Acceptance of Mercura Capital GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under
the laws of Germany with its statutory seat in Starnberg, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister)
at the local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRB 200948, having its business address at
Schießstättstraße 22, 82319 Starnberg, as new shareholder of the Company.
3. Increase of the Company's share capital by an amount of one thousand five hundred sixty-three euro (EUR 1,563) so
as to raise it from its current amount of thirteen thousand one hundred twenty-five euro (EUR 13,125) up to fourteen
thousand six hundred eighty-eight euro (EUR 14,688) by issuing one thousand five hundred sixty-three (1,563) Series A2
Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
4. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read
as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fourteen thousand six hundred eighty-eight Euros (EUR 14,688.00), represented
by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of
one Euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 six hundred twenty-five (625) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), with a nominal value of one Euro
(EUR 1.00) each, and
5.1.3 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
5. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services
Holding XXII S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
123101
L
U X E M B O U R G
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may
be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fourteen thousand six hundred eighty-eight Euros (EUR 14,688.00), represented
by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of
one Euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 six hundred twenty-five (625) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), with a nominal value of one Euro
(EUR 1.00) each, and
5.1.3 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
123102
L
U X E M B O U R G
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet SE ("Roc-
ket"), the shareholder Netris B.V., ("Eiffel") and the shareholder MERCURA CAPITAL GmbH (“Mercura”, jointly with
Rocket and Eiffel the "Investors" and each also an "Investor"), to a company affiliated to such Investor within the meaning
of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is
directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct
or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Controlled” or
“Controlling”) shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as
managing shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means
of a contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management
and policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective
Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified
employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;
7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation proce-
dures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company,
if the shareholders of the Company hold more than 50 % in any surviving legal entity after such transformation procedure.
7.5 In the cases provided for in Articles 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of
first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased
shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is
rejected for lack of assets;
8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such
enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration of
redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its share
register and to proceed with the relevant filings required by law.
8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one person;
independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way through
one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.
8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).
Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
123103
L
U X E M B O U R G
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date
is the date before the redemption resolution.
9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding amounts
including interest.
9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert arbitrator
shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the Company. The
decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company and the
requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the redemption price and
the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption
price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a person
named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or partial
assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
11.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also
be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a
shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of
managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
11.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must
state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must
be sent to each shareholder in writing without undue delay.
11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be
specified in the respective convening notices of meeting.
12.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or registered
letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of notice of
at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary shareholders'
meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders' meeting is not
counted in the calculation of the period of notice.
12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another shareholder
authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.
123104
L
U X E M B O U R G
12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders'
resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders' meeting (for
purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.
Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders are
only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is no
quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with Article
12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this was
pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.
Art. 16. Shareholders' resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders' Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of shareholders
(ii) who also constitute a Super Majority:
16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company;
16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company;
16.1.3 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq. German
Stock Corporation Act (AktG));
16.1.4 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of
any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation in
the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners.
16.1.5 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
16.1.6 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and
transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.
16.2 Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold all
the issued shares of that class.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
123105
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-
ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
21.8 The managers shall require the consent of the advisory board for the legal transactions and measures specified
below in accordance with § 24.5. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined
and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board (as defined below):
21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros
(EUR 200,000.00) in aggregate;
21.8.2 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case;
21.8.6 transfer of industrial property rights or documented knowhow by the Company to a third party, excluding, ho-
wever, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;
123106
L
U X E M B O U R G
21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such
shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or
indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent
requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business of
the Company and is at arm's length;
21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options) outside
the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders' agreement, if
any.
21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also required
for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further transactions
and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also in advance for
certain groups and kinds of transactions and measures.
21.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in the
future.
Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and
class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 24. Advisory Board.
24.1 The Company shall have an Advisory Board. It shall consist of four (4) voting members. The shareholders may by
way of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members of the Advisory Board.
24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous
shareholders' consent.
24.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's respective
appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
24.3.1 Two (2) voting members of the Advisory Board, each having two (2) votes, shall be nominated by Rocket in its
sole discretion;
24.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by Eiffel in its sole
discretion; and
24.3.3 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by Mercura in its sole
discretion.
24.4 Each member of the Advisory Board may be represented by another member of the Advisory Board or any other
representative of the respective Party. In this case a written proxy must be presented at the respective Advisory Board
meeting. For this purpose, Rocket, Eiffel and Mercura - if applicable - are entitled to appoint one substitute member for
each Advisory Board member.
24.5 The advisory board may have non-voting members of the advisory board as observers.
24.6 The advisory board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall be
the chairman of the advisory board. The rules of procedure of the advisory board may provide for further provisions in
particular on the self organization of the advisory board. The advisory board shall adopt resolutions with the simple majority
of votes cast. The advisory board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.
24.7 The advisory board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
123107
L
U X E M B O U R G
E. Audit and supervision
Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
27.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities
of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with the
provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted
by Luxembourg law.
30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
6. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr. Julien De
Mayer, Mr. Ruediger Trox and Ms. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to
sign solely, the shareholders register of the Company.
123108
L
U X E M B O U R G
7. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned
notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create a new class of shares, referred to as the Series A2 shares, in
addition to the existing Common Shares and Series A1 Shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts Mercura Capital GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) under the laws of Germany with its statutory seat in Starnberg, Germany, registered with the com-
mercial register (Handelsregister) at the local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRB 200948,
having its business address at Schießstättstraße 22, 82319 Starnberg, as new shareholder of the Company.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the Company's share capital by an amount of one thousand
five hundred sixty-three euro (EUR 1,563) so as to raise it from its current amount of thirteen thousand one hundred twenty-
five euro (EUR 13,125) up to fourteen thousand six hundred eighty-eight euro (EUR 14,688) by issuing one thousand five
hundred sixty-three (1,563) Series A2 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The one thousand five hundred sixty-three (1,563) Series A2 Shares have been duly subscribed by Mercura, aforemen-
tioned, represented as stated above, for the price of one thousand five hundred sixty-three euro (EUR 1,563).
<i>Paymenti>
The one thousand five hundred sixty-three (1,563) Series A2 Shares, subscribed by Mercura, aforementioned, have been
entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand five hundred sixty-three euro (EUR 1,563).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of one thousand five hundred sixty-three euro (EUR 1,563) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article five (5) of
the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fourteen thousand six hundred eighty-eight Euros (EUR 14,688.00), represented
by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of
one Euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 six hundred twenty-five (625) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), with a nominal value of one Euro
(EUR 1.00) each, and
5.1.3 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
<i>Fifth Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of association
of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Sixth Resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well
as Mr. Julien De Mayer, Mr. Ruediger Trox and Ms. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power
of substitution, to sign solely, the shareholders register of the Company.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately two thousand euros (EUR 2,000).
123109
L
U X E M B O U R G
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünfundzwanzigsten Juni,
vor uns, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet SE (vormals: Rocket Internet AG), eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea) mit satzungs-
mäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRB 165662 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),
Inhaberin von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen,
hier vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, geschäftsansässig in Bad-Mondorf,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht mit Untervollmacht ausgestellt am 23. und 25. Juni 2015;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und be-
stehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der
Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),
Inhaberin eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, geschäftsansässig in Bad-Mondorf,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht mit Untervollmacht ausgestellt am 22. und 25. Juni 2015;
3. Netris B.V., eine Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, eingetragen im Handels-
register des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz in Schiphol Boulevard 127, 1118BG
Schiphol, Niederlande („Eiffel“),
Inhaberin von sechshundertfünfundzwanzig (625) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, geschäftsansässig in Bad-Mondorf,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht mit Untervollmacht ausgestellt am 24. und 25. Juni 2015;
4. Mercura Capital GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem
Sitz in Starnberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Num-
mer HRB 200948, mit Geschäftssitz in Schießstättstraße 22, 82319 Starnberg („Mercura“),
zukünftige Inhaberin von eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, geschäftsansässig in Bad-Mondorf,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht mit Untervollmacht ausgestellt am 22. und 25. Juni 2015.
Besagte Vollmachten, welche vom Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur paraphiert
wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien unter 1., 2. und 3. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Digital Services Holding
XXII S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, einge-
tragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188.602, gegründet am 1. Juli 2014 gemäß
einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 22. September 2014 im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2559, veröffentlicht wurde. Die Gründungssatzung der Gesellschaft wurde
zuletzt am 14. Januar 2015 gemäß einer Urkunde des Notars Marc Loesch geändert, welche am 20. April 2015 im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1035 veröffentlicht wurde.
Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
Tagesordnung verhandeln, wobei Mercura ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmbe-
rechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer neuen Klasse von Anteilen, welche als Anteile der Serie A2 bezeichnet
werden (die „Anteile der Serie A2“), zusätzlich zu den bestehenden Stammanteilen (die „Stammanteile“) und den Anteilen
der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“).
2. Aufnahme der Mercura Capital GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit sat-
zungsmäßigem Sitz in Starnberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
123110
L
U X E M B O U R G
unter der Nummer HRB 200948, mit Geschäftssitz in Schießstättstraße 22, 82319 Starnberg, als neue Gesellschafterin der
Gesellschaft.
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von dreizehntausendeinhundert-
fünfundzwanzig Euro (EUR 13.125) um einen Betrag von eintausendfünfhundertdreiundsechzig Euro (EUR 1.563) auf
einen Betrag von vierzehntausendsechshundertachtundachtzig Euro (EUR 14.688) durch die Ausgabe von eintausend-
fünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
4. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt vierzehntausendsechshundertachtundachtzig Euro (EUR
14.688,00), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1,00),
5.1.2 sechshundertfünfundzwanzig (625) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.3 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
5. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Digital Services Holding XXII S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sons-
tige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
123111
L
U X E M B O U R G
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt vierzehntausendsechshundertachtundachtzig Euro (EUR
14.688,00), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1,00),
5.1.2 sechshundertfünfundzwanzig (625) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.3 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-
gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung von
Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter
Rocket Internet SE („Rocket“), den Gesellschafter Netris B.V. („Eiffel“) und den Gesellschafter MERCURA CAPITAL
GmbH („Mercura“, gemeinschaftlich mit Rocket und Eiffel die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine
mit einem solchen Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen
Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder
indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von diesem
Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert
Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a) die Leitung der
Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten
der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder
indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberech-
123112
L
U X E M B O U R G
tigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere
Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten, welcher
Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen
Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;
7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Umwand-
lungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmel-
zung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als
fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.
7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten
gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters
für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an
Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen
Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile ent-
spricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
123113
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.
10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschrif-
ten des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschaf-
terversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der
entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
12.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mit
einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
123114
L
U X E M B O U R G
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals
vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
12.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 15. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.
Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit
der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:
16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-
gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.1.3 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.1.4 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-
teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;
16.2.5 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
16.1.6 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.
16.2 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.
17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
19.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
123115
L
U X E M B O U R G
Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
20.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der
Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der für die
Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maß-
nahmen im Einklang mit Artikel 24.5. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und
Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats (wie
unten definiert) genehmigt wurden:
21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-
hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;
21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transak-
tionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streitwert
von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;
21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft
an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
123116
L
U X E M B O U R G
21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen. Als
solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt 15
der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam -direkt oder indirekt eine Mehrheitsbetei-
ligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum gewöhnlichen
Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;
21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung
jeglicher Anteils- oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.
21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,
so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und Maßnah-
men auch im Voraus erteilen.
21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Ver-
treter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine
Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus vier (4) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafter
können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats er-
höhen oder herabsetzen.
24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-
schafter festlegen und/oder verändern.
24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
24.3.1 Zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats mit je zwei (2) Stimmen werden von Rocket nach eigenem
Ermessen ernannt;
24.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von Eiffel nach eigenem Ermessen
ernannt; und 24.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von Mercura nach eigenem
Ermessen ernannt.
24.4 Jedes Mitglied des Beirats kann von einem anderen Mitglied des Beirats oder einem anderen Vertreter der jeweiligen
Partei vertreten werden. In diesem Fall muss bei der jeweiligen Sitzung des Beirats eine schriftliche Vollmacht vorgelegt
123117
L
U X E M B O U R G
werden. Zu diesem Zweck sind Rocket, Eiffel und Mercura - gegebenenfalls - dazu berechtigt, ein Ersatzmitglied für jedes
Beiratsmitglied zu ernennen.
24.5 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimmbe-
rechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.
24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der
Gesellschaft.
25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
27.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die
Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
123118
L
U X E M B O U R G
Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Andwendbares Recht
Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
6. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie
Herrn Julien De Mayer, Herrn Rüdiger Trox und Frau Magdalena Staniczek dazu zu ermächtigen, das Anteilsinhaberregister
der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unter-
zeichnen.
7. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, zusätzlich zu den bestehenden Stammanteilen und den Anteilen der Serie
A1 eine neue Klasse von Anteilen zu schaffen, welche als Anteile der Serie A2 bezeichnet werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung akzeptiert Mercura Capital GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach
deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Starnberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
München, Deutschland, unter der Nummer HRB 200948, mit Geschäftssitz in Schießstättstraße 22, 82319 Starnberg, als
neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von dreizehntausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 13.125) um einen Betrag von eintausendfünfhundertdreiund-
sechzig Euro (EUR 1.563) auf einen Betrag von vierzehntausendsechshundertachtundachtzig Euro (EUR 14.688) durch
die Ausgabe von eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteile der Serie A2 wurden ordnungsgemäß von Mercura, vorbe-
nannt, vertreten wie vorgenannt, zu einem Preis von eintausendfünfhundertdreiundsechzig Euro (EUR 1.563) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Mercura, vorbenannt, gezeichneten eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteile der Serie A2 wurden
vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendfünfhundertdreiundsechzig Euro (EUR 1.563).
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde der unterzeichnenden Notarin
erbracht.
Die Einlage in Höhe von eintausendfünfhundertdreiundsechzig Euro (EUR 1.563) wird vollständig dem Gesellschafts-
kapital zugeführt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt infolge des vorhergehenden Beschlusses, Artikel fünf (5) der Satzung der
Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt vierzehntausendsechshundertachtundachtzig Euro (EUR
14.688,00), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1,00),
5.1.2 sechshundertfünfundzwanzig (625) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.3 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“).
123119
L
U X E M B O U R G
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt hiermit, jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie,
sowie Herrn Julien De Mayer, Herrn Rüdiger Trox und Frau Magdalena Staniczek dazu zu ermächtigen, das Anteilsinha-
berregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine
zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000) geschätzt.
Worüber Urkunde Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dem Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.
Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 30 juin 2015. GAC/2015/5489. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 31 juillet 2015.
Référence de publication: 2015132794/1107.
(150143659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.
THEOLIA Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 163.192.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Référence de publication: 2015126855/10.
(150137638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
WRI Nominees Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 152.021.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2014 de sa société
mère, H&F Wings Lux 3 S.à r.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Référence de publication: 2015131249/12.
(150140693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
123120
Camo-Lux S.A.
Case Lobaio S.à r.l.
Caulfield
CBC AcquiCo1 S.à r.l.
CEB Capital S.A.
CERE II F Co-invest S.à r.l.
Cicerone s.à r.l.
CoDeLux S.A.
Digital Services Holding XXII S.à r.l.
DRED SCS
DV III General Partner S.A.
Leipziger Strasse S.à r.l.
Pariter Holding S.A.
Perfin S.A.
Prince AcquiCo S.à r.l.
PUBLICHIC & PROMOCHOC s.à r.l. une idée différente de la publicité par l'objet s.à r.l.
Quercia Stwo
SHCO 50 S.à r.l.
SKaLux S.à r.l.
Spinelle Investments II S.à r.l.
Sports and Leisure Brands
SSCP Eleanor Parent S.à r.l.
Sydney Properties S.A.
Tac O Tac
TA EU Acquisitions IV S.à r.l.
TA EU Luxembourg III S.à r.l.
TA EU Luxembourg II S.à r.l.
TA EU Luxembourg S.à r.l.
TA EU Luxembourg V S.à r.l.
Tai Tai Limited S.à r.l.
Tamar International S.à r.l.
Taxis Flanel
TENALA Spf S.A.
Teufel Holdco S.à r.l.
THEOLIA Management Company S.à r.l.
Thesis Investment S.A.
Thierry Linster & Ivan Stupar Architectes, S.à r.l.
Tompkins Square Park S.à r.l.
Trio Trans S.A.
Waldeck Capital (Luxembourg) S.A.
Wants
WRI Nominees Limited
XI Callisto Luxco II S.à r.l.