logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2563

21 septembre 2015

SOMMAIRE

Caelum Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123004

Coral Portfolio S.C.A. SICAV-SIF  . . . . . . . . .

122982

DSK Systems S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123021

GEOPF Langenfeld G.P. S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

122983

GM Investissement S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

122980

IPone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122985

Jalyne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122984

JM Topert Mondial S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122988

Landforse I SCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122982

Lee Cooper Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

122982

Madison Trianon S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122979

Merion Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122982

Public Safety Luxembourg, S.à r.l.  . . . . . . . . .

123012

Quilvest AM S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122979

Raphael Magic Inc.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122978

Rapides International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

122978

Rarecars Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122978

Rasini SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122991

RDA Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122978

Real Constructions Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122978

REI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122981

Reka S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122978

RINNEN Constructions Générales S.àr.l.  . . . .

122981

Rock Ridge RE 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123022

Romafi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122981

Romains S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122980

Roné S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122981

Simpleet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123014

Six Continents Development . . . . . . . . . . . . . . .

122979

Smalland Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122979

Société Immobilière Fraenzebach II S.A.  . . . .

123024

Sofrane Business S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122984

Sophronia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122990

Sotogrande LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

122980

Soudoplast S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123024

SPCGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123024

Square Churchill 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122981

Stenfalken S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122983

Sulfuron Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122983

TA EU Acquisitions III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

123020

TA EU Acquisitions II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

122980

TFP Royal S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122984

Thorenc PV Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

122979

Towers Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

122984

Trans Real Estate Development S.à r.l. . . . . . .

122980

Tricel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122983

122977

L

U X E M B O U R G

Raphael Magic Inc.S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 97.968.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126688/9.
(150138430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Rapides International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 97.966.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126689/9.
(150138779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Rarecars Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 190.822.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126690/9.
(150137425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

RDA Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 175.078.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126692/9.
(150137349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Real Constructions Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, Z.A.E. Solupla.

R.C.S. Luxembourg B 112.260.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126693/9.
(150138656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Reka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4385 Ehlerange, 2A, ZARE Ilot EST.

R.C.S. Luxembourg B 70.362.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126696/9.
(150137834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

122978

L

U X E M B O U R G

Six Continents Development, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 151.380.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126737/9.
(150137356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Smalland Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5852 Hesperange, 4, rue d'Itzig.

R.C.S. Luxembourg B 165.565.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126770/9.
(150138115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Thorenc PV Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.521.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2015.

Référence de publication: 2015126818/10.
(150138599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Quilvest AM S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 300.000,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 183.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Quilvest AM S.A.

Référence de publication: 2015132229/11.
(150143648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2015.

Madison Trianon S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 167.964.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2015.

M. Robert Kimmels
<i>Gérant

Référence de publication: 2015129589/13.
(150138906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

122979

L

U X E M B O U R G

Sotogrande LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.312.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11/13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 189.084.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126745/9.
(150138365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Trans Real Estate Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 39, rue des Etats-Unis.

R.C.S. Luxembourg B 178.790.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015126823/10.
(150138400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

TA EU Acquisitions II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.079.088,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 161.379.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015126826/10.
(150138288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

GM Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 175.069.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2014 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2015127387/11.
(150136524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

Romains S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5810 Hesperange, 43, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 165.217.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015129881/14.
(150139465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

122980

L

U X E M B O U R G

Romafi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J-F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 118.507.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015129880/10.
(150139430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

Roné S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2416 Howald, 6, rue de la Redoute.

R.C.S. Luxembourg B 23.659.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015129882/10.
(150139739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

RINNEN Constructions Générales S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9946 Binsfeld, 25, Ëlwenterstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.657.

La liste des signataires autorisées valable à partir du 26 juin 2015 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RINNEN CONSTRUCTIONS GENERALES S.à r.l.

Référence de publication: 2015129877/11.
(150139668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

REI, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 105.316.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2015.

<i>Pour REI

Référence de publication: 2015129868/11.
(150139708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

Square Churchill 5, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 4.132.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 juillet 2015

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’assemblée générale approu-

vant les comptes de l'exercice 2015 et qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme
Paul LAPLUME

Référence de publication: 2015129909/12.
(150140138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

122981

L

U X E M B O U R G

Lee Cooper Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.001,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 142.381.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015130774/10.
(150140810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Landforse I SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 141.639.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 26 juin 2015

En date du 26 juin 2015, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean-Marie Bondioli, en tant

que membre du Conseil de Surveillance de la Société avec effet immédiat pour une durée de 6 années.

La Société vous informe par ailleurs que l'adresse professionnelle de Monsieur Bondioli est désormais à 70 route d'Esch;

L-1470 Luxembourg.

Référence de publication: 2015130765/12.
(150140891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Coral Portfolio S.C.A. SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 144.034.

EXTRAIT

Le rapport annuel audité au 31 décembre 2014, tel qu’approuvé par l’assemblée générale annuelle en date du 31 juillet

2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le fonds
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2015132704/15.
(150144081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

Merion Finance, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 182.388.

<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société du 27 juillet 2015

Le 27 Juillet 2015, l'actionnaire unique de Merion Finance a pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Mr. David Dion en qualité de Gérant de catégorie B de la Société avec effet au 6 Juillet

2015;

- De nommer Mr. Julien Ansay, ayant son adresse professionnelle à 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

en qualité de Gérant de catégorie B de la Société avec effet au 6 Juillet 2015 et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 Juillet 2015.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015130852/17.
(150140774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

122982

L

U X E M B O U R G

Stenfalken S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 47.500,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 163.708.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015129912/10.
(150140045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

GEOPF Langenfeld G.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 123.679.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2015.

GEOPF Langenfeld GP S.à r.l
M. Doherty / J.C. Ehlinger
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2015131794/13.
(150141807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2015.

Sulfuron Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: ZAR 250.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 3A, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 184.888.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 29 juillet 2015.

Stonehage Corporate Service Luxembourg S.A.
3A, Val Ste Croix
L-1371 Luxembourg
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015129917/15.
(150139564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

Tricel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 127.977.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 23 juillet 2015 que Mme Samia

AOUCHAR, née à 54350 Mont St. Martin (France) le 4 décembre 1970, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommée avec effet immédiat aux fonctions d'Administrateur de la Société en rem-
placement de Mme Annie SWETENHAM, démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance, en même temps que celui de ses co-Administrateurs à l'issue de l'Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2019.

Sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l.

Référence de publication: 2015133373/16.
(150143663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

122983

L

U X E M B O U R G

Sofrane Business S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 115.050.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126783/9.
(150138678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

TFP Royal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.272.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TFP Royal S.à r.l.

Référence de publication: 2015130023/10.
(150139071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

Towers Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 125.809.

Il résulte des décisions de l'associé unique de la Société en date du 27 juillet 2015:
1. Nomination de Monsieur Chaim Shechter, né le 8 mai 1968 à Haifa, Israel, ayant son adresse professionnelle à rue

Argand 2, 1201 Genève, Suisse, en tant que gérant de la Société avec effet au 27 Juillet 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2015.

<i>Pour La société

Référence de publication: 2015133341/14.
(150143971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

Jalyne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 158.952.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 17 juillet 2015 à 10.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée Générale ratifie à l'unanimité la nomination par le Conseil d'Administration du 16 décembre 2014 de M.

Jean-Charles Thouand au poste d'Administrateur B en remplacement de Monsieur Joseph Winandy, démissionnaire, dont
il terminera le mandat.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur A de Monsieur Jacques BONNIER

et les mandats d'Administrateur B de Messieurs Jean-Charles THOUAND et Koen LOZIE.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la société THE CLOVER, 6, rue d'Arlon, L-8399

Windhof, Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs A et B ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes, viendront donc à échéance

à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administration A / Administrateur B

Référence de publication: 2015132987/20.
(150144061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

122984

L

U X E M B O U R G

IPone, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Hautcharage, 5, rue Bommel.

R.C.S. Luxembourg B 198.966.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfunfzehn, am dreiundzwanzigsten Tag des Monats Juli.
Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch (Grosherzogtum Luxem-

burg).

Sind erschienen:

1. Herr Peter GRAF, technischer Fachwirt, geboren am 29. Oktober 1958 in Andernach (Deutschland), wohnhaft in

D-56626 Andernach, Im Römergraben 10 (Deutschland);

2. Herr Peter-Alexander KRAMS, Jurist, geboren am 15. Juli 1961 in Mayen (Deutschland), wohnhaft in D-56645

Nickenich, Hauptstrasse 43 (Deuschland);

3. Frau Agnès APPEL, Musiklehrerin, geboren am 31. Januar 1959 in Wiβmar (Deutschland), wohnhaft in D-35435

Wettenberg, Mittelmark 5 (Deutschland);

4. Herr Jean-Luc SCHMIT, Ingenieur, geboren am 3. Januar 1968 in Ettelbruck, wohnhaft in L-6155 WEYER, Maison

2 (Luxemburg).

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile

werden, besteht eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die eins-
chlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft tragt die Bezeichnung «IPone».

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Bascharage und kann durch Beschluss der Geschäfts-

führung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des

Groβherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Forschung und Entwicklung neuer Substanzen im chemischen Bereich, teils

aufbringbar, teils für die Veredelung von Glas, Kunststoffen, Textilien, Papier und Pappe, sowie anderer Materialien und
der Schutz der jeweiligen Zusammensetzung und der Schutz des jeweiligen Herstellungsverfahrens.

Des Weiteren hat die Gesellschaft zum Zweck Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an jeglichen Unterneh-

men, ob in Luxemburg oder im Ausland, zu erwerben, durch Beteiligung an deren Kapital, durch Titel und Stimmrechte,
durch Einbringen von Werten, durch Zeichnung, durch Option, Ankauf, Tausch, Aushandeln, oder auf jegliche andere Art
und Weise.

Des Weiteren hat die Gesellschaft zum Zweck den Erwerb und die Verwertung von Rechten des geistigen Eigentums,

insbesondere Patenten, Urheberrechten, Markenrechten, Designrechten, Lizenzkonzessionen, sowie deren Verwaltung und
Verkauf. Sie kann auch den Unternehmen in denen sie Interessen erwirbt, sowie Dritten, jegliche Unterstützung und fi-
nanzielle Hilfestellungzuwenden, dies auch unter der Form von Darlehen, Vorschüssen, Garantien, sowie sie auch Mittel
leihen kann, sogar durch Ausgabe von Anleihen, oder sich anders verschulden um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen.
Sie kann generell jegliche Maßnahmen nehmen, sowie alle Transaktionen ausfuhren, welche der Erfüllung ihres Gesell-
schaftszweckes dienen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und

unbewegliche Guter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur
nutzlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital betragt siebzehntausendfunfhundert Euros (EUR 17.500,-), aufgeteilt in siebenhundert

Anteile (700) von je funfundzwanzig Euros (EUR 25,-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

122985

L

U X E M B O U R G

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen

Gesellschafter, welche neunzig Prozent (90%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls des alleinigen Gesellschafters oder

eines der Gesellschafter bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des übrigen Gesell-
schaftskapitals vertreten.

Diese Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile, sei es an Reservaterben, sei es an Überlebende Ehegatten

oder an die anderen gesetzlichen Erben, übertragen werden.

Die Erben sowie die durch Verfügung von Todeswegen eingesetzten Vermächtnisnehmer, welche diese Zustimmung

nicht erhalten, sowie auch keinen Abnehmer gefunden haben, welcher die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, können
die vorzeitige Auflosung der Gesellschaft veranlassen und zwar drei Monate nach einer Invollzugsetzung die dem oder
den Geschäftsführern durch den Gerichtsvollzieher zugestellt und den Gesellschaftern durch Einschreibebrief durch die
Post zur Kenntnis gebracht wird.

Innerhalb dieser Frist von drei Monaten können die Gesellschaftsanteile im Wege eines Rückkaufrechts des Verstor-

benen jedoch erworben werden, entweder durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsanteile zueinander oder
durch einen von Ihnen genehmigten Dritten oder auch durch die Gesellschaft selbst, wenn sie die Bedingungen erfüllt,
welche von einer Gesellschaft zum Erwerb ihrer durch sie verausgabten Wertpapiere verlangt werden.

Der Ruckkaufpreis der Gesellschaftsanteile des Verstorbenen wird auf Grund der Durchschnittbilanz der drei letzten

Jahre, und wenn die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre aufzuweisen hat, auf Grund der Bilanz des letzten oder
derjenigen der zwei letzten Jahre berechnet.

Soweit gesetzlich zulässig, ist der Ruckkaufpreis in fünf gleichen Jahresraten zahlbar, von denen die erste Rate am ersten

Januar des auf den Zeitpunkt des Todes des Gesellschafters folgenden Jahres zu zahlen ist. Der jeweils geschuldete Rest-
betrag ist vom Zeitpunkt des Todes an mit 3% über dem Basiszinssatz der EZB zu verzinsen, fällig mit der jeweiligen Rate.
Der Ruckkaufpreis kann auch ganz oder teilweise vorzeitig gezahlt werden. Zinsen fallen in diesem Fall nur bis Zahldatum
an.

Wenn keine Einigung über die Anwendung der im vorhergehenden Absatz angegebenen Rückkaufgrundlage zustande

kommt, wird der Preis im Uneinigkeitsfalle gerichtlich festgesetzt.

Die den Gesellschaftsanteilen des Erblassers zustehenden Rechte können nicht ausgeübt werden, bis deren Übertragung

der Gesellschaft gegenüber rechtswirksam ist. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen muss durch eine notarielle Be-
scheinigung oder durch eine privatschriftliche Urkunde beurkundet werden.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäß Artikel 1690

des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäß Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August

1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Vertrage zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechts-

wirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als sechzig Prozent des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen
werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung wurden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig

bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter funfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter, die nur stattfinden muss, wenn die Zahl der Gesellschafter fun-

fundzwanzig (25) übersteigt, tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten
Ort zusammen und zwar am dritten Dienstag des Monats Juni jeden Jahres um 11.00 Uhr. Falls der vorbenannte Tag ein
gesetzlicher oder tarifvertraglicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht
vertreten lassen.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als sechzig Prozent des

Kapitals  vertreten,  angenommen  wird.  Ist  diese  Zahl  in  einer  ersten  Versammlung  oder  schriftlichen  Befragung  nicht
erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und
die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Beschlüsse betreffend eine Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrages sind mit der Zustimmung der Mehrheit

der Gesellschafter zu fassen, die mindestens achtzig Prozent (80%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

122986

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesell-

schaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter bezugsweise durch die Gesellschafter,

welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von

ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr

als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, gebunden.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter wahrend der

Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.

Diese äuβern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter bezugsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, son-

dern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflosung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit

beschrankter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert

Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Gesellschafter

Gezeichnetes

Kapital

Anzahl

der Anteile

Eingezahlter

Betrag

Herr Peter GRAF, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 4.900,-

196

EUR 4.900,-

Herr Peter-Alexander KRAMS, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 4.900,-

196

EUR 4.900,-

Frau Agnes APPEL, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 4.900,-

196

EUR 4.900,-

Herr Jean-Luc SCHMIT, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 2.800,-

112

EUR 2.800,-

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 17.500,-

700

EUR 17.500,-

Die Summe von siebzehntausendfunfhundert Euro (EUR 17.500,-) stand der Gesellschaft daher von dem Moment an

zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen
des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung,
gewahrt wurden.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar sie darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

122987

L

U X E M B O U R G

a) zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Peter-Alexander KRAMS, Jurist, geboren am 15. Juli 1961 in Mayen (Deutschland), wohnhaft in D-56645 Nic-

kenich, Hauptstrasse 43 (Deuschland).

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-4940 Hautcharage, rue Bommel, 5.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. GRAF, P.-A. KRAMS, A. APPEL, J.-L. SCHMIT, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 31 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12824. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C.

Diekirch, den 03. August 2015.

Référence de publication: 2015132973/176.
(150143451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

JM Topert Mondial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 198.956.

STATUTS

L’an deux mille quinze, le seize juillet.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbrück

Ont comparu:

1. La société à responsabilité civile Société de Révision et d’Expertises SàRL, immatriculée au RC Luxembourg B

86.145, avec siège social à L-8211 Mamer, 53 route d’Arlon,

Ici représentée par Madame Stéphanie PACHE, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer 53

route d’Arlon,

En vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 22 juin 2015.
Lequel pouvoir, après avoir été signé «ne varietur» par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

2. La société anonyme FGA (Luxembourg) S.A., immatriculée au RCS Luxembourg B 61.096, avec siège social à

L-8211 Mamer, 53 route d’Arlon,

Ici représentée par Madame Stéphanie PACHE, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer 53

route d’Arlon,

En vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 22 juin 2015.
Lequel pouvoir, après avoir été signé «ne varietur» par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu'ils dé-

clarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions ci-

après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de
JM TOPERT MONDIAL S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toutes autres

manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes.

122988

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Le capital social de la société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-EUROS) représenté par

MILLE (1.000) actions d’une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31.-EUROS) chacune.

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Il est tenu au siège social un

registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues
à l’article trente neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le

droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire
à l’égard de la société.

Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles.
Cependant si un actionnaire désire céder tout ou partie de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres

actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société. En cas de
désaccord sur le prix de cession, celui-ci sera fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les
actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’en-
tendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai d’un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Ses décisions
sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou autres

agents. La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur délégué et d’un autre administrateur.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée

du  10  août  1915  concernant  les  sociétés  commerciales,  le  conseil  d’administration  pourra  procéder  à  des  versements
d’acomptes sur dividendes.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l’affectation
ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’assemblée, en personne
ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois d’avril à 14 heures, et pour la première fois en l’an deux mille seize.
Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2 et

suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout ou il n’y est pas dérogé

par les présents statuts.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:
Société de Révision et d’Expertises SàRL, prénommée détient 1 action.
FGA (Luxembourg) S.A., prénommée, détient 999 actions
Total: MILLE (1.000) actions.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme

de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-EUROS) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.

122989

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille quinze.
La première assemblée générale se tiendra en deux mille seize.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Déclaration des comparants

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-5
du Code Pénal (financement du terrorisme). Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprise, né le 06 février 1962 à Torre Annunziata, demeurant à L-8211 Mamer,

Route d’Arlon, 53

- Madame Mireille Masson, administrateur de sociétés, née le 13 juin 1966 à Ougree, demeurant à L-8211 Mamer, Route

d’Arlon, 53

- Madame Monique POPEL, administrateur de sociétés, née le 19 juin 1955 à Amnéville, demeurant à L-8550 NOER-

DANGE, Dikrecherstrooss, 47.

3.  Est  nommé  administrateur-délégué  et  président  du  Conseil  d’Administration  pour  une  durée  de  6  ans:  Madame

Monique POPEL, prénommée.

Elle sera chargée de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
FGA (Luxembourg) S.A. avec siège social à Mamer, RCS B 61.096.
5. Le siège social est fixé à 53 Route d’Arlon L-8211 Mamer
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Stéphanie PACHE, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 17 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12101. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 3 août 2015.

Référence de publication: 2015132991/134.
(150143137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

Sophronia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 109.604.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126787/9.
(150138110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

122990

L

U X E M B O U R G

Rasini SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 198.971.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of July.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Luxembourg).

There appeared:

Rasini Fairway Capital Ltd, a private company, incorporated in England and Wales, under number 3757526 with re-

gistered office 1 

st

 Floor North, 4-5 Grosvenor Place, London SW1X 7HJ, United Kingdom,

duly represented by Mrs Candice Mayembo, residing professionally in Mamer, by virtue of a proxy given in London

on July 8, 2015.

The proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such  appearing  party,  in  the  capacity  in  which  he  acts  has  requested  the  notary  to  state  as  follows  the  Articles  of

Incorporation (the "Articles") of a company which he declares to constitute as sole shareholder.

Art. 1. Establishment and name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become

owners of shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme qualifying as "société d'investissement à
capital variable" under the name of “RASINI SICAV” (hereinafter the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time. The Company may be dissolved by a

resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of these articles of
incorporation (the “Articles of Incorporation”) as defined in Article 30 hereafter.

Art. 3. Object. The exclusive object of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities as

well as in any other assets and financial instruments authorized by the law of 17 December 2010 concerning undertakings
for collective investment, as amended (the “Law of 2010”) with the purpose of spreading investment risks and affording
its shareholders the results of the management of its assets.

Generally, the Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful in the accom-

plishment and development of its purpose to the largest extent permitted by Part I of the Law of 2010.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Mamer, in the Grand Duchy of Lu-

xembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad,
by resolution of the board of directors of the Company (the “Board of Directors”).

The registered office of the Company may be transferred by resolution of the Board of Directors to any other place in

the municipality of Mamer. If and to the extent permitted by law, the Board of Directors may decide to transfer the registered
office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political events have occurred or are imminent,

that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be transferred temporarily abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall have no effect on the natio-
nality of the Company which, the temporary transfer of its registered office notwithstanding, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 5. Share capital, Sub-Funds, Classes of shares. The capital of the Company shall be represented by shares of no par

value. At any time, the share capital of the Company shall be equal to the total net asset value of the different Sub-Funds
(as defined hereafter). The minimum share capital of the Company shall be as required by the Law of 2010 the equivalent
of EUR 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand euro). The initial capital is set at EUR 31,000 (thirty one
thousand euro) represented by thirty-one (31) fully paid up Shares of no par value.

As the Board of Directors shall determine, the capital of the Company, which has an umbrella structure, may be divided

into different portfolios of securities and other assets permitted by law with specific investment objectives and various risk
or  other  characteristics  (the  “Sub-Funds”  and  each  a  “Sub-  Fund”).  The  Sub-Funds  may  be  denominated  in  different
currencies as the Board of Directors shall determine. With regard to third parties, there is no cross liability between Sub-
Funds and each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities reasonably attributable to it. Within each Sub-
Fund, the Board of Directors may decide to issue different classes of Shares (the “Classes” and each a “Class”) which may
differ, inter alia, with respect to their charging structure, dividend policies, hedging policies, investment minima, currency
of denomination or other specific features, as the Board of Directors may decide to issue. The Board of Directors may
decide if and from what date Shares of any such Classes shall be offered for sale, those shares to be issued on the terms
and conditions as shall be decided by the Board of Directors. Where the context so requires, references in these Articles
of Incorporation to “Sub-Fund(s)” shall be references to “Class(es)”.

122991

L

U X E M B O U R G

The Company is incorporated with multiple sub-funds as provided for in article 181 of the Law of 2010. The assets of

a specific Sub-Fund are exclusively available to satisfy the rights of creditors whose claims have arisen in connection with
the creation, the operation or the liquidation of that Sub-Fund.

The proceeds of any issue of shares of a specific Class shall be invested in the Sub-Fund corresponding to that Class of

shares, in various transferable securities, as well as in any other assets and financial instruments authorized by the Law of
2010 and according to the investment policy as determined by the Board of Directors for a given Sub-Fund, taking into
account the investment restrictions foreseen by the Law of 2010 and regulations.

Consolidated accounts of the Company, including all Sub-Funds, shall be expressed in the reference currency of the

share capital of the Company, the Euro.

Art. 6. Form of the shares. The Board of Directors shall decide, for each Sub-Fund, whether to issue shares registered

form. In the case of registered shares, unless a shareholder elects to obtain share certificates, he will receive instead a
confirmation of his shareholding.

Upon decision of the Board of Directors, fractions of shares may be issued for registered shares which shall be registered

to the credit of the shareholders’ securities account at the custodian bank or at correspondent banks dealing with the financial
services of the shares of the Company. For each Sub-Fund, the Board of Directors shall restrict the number of decimals
which shall be mentioned in the prospectus (the “Prospectus”) of the Company. Portions of shares shall be issued with no
voting rights but shall give right to a distribution of the net assets of the relevant Sub-Fund, if any, for the portion represented
by these fractions.

All registered shares issued by the Company shall be entered in the register of shareholders which shall be kept by the

Company or by one or more persons designated to this effect by the Company. The register of shareholders will indicate
the name of each shareholder, his residence or elected domicile and the number of registered shares held by him. Every
transfer of (a) registered share(s) shall be entered in the register of shareholders.

Every shareholder wishing to receive registered shares must provide the Company with one address to which all notices

and announcements may be sent. This address shall be entered in the register of shareholders as the elected domicile. In
the event that the shareholder does not provide such an address, a notice to this effect may be entered in the register of
shareholders and the shareholder’s address shall be deemed to be at the registered office of the Company until another
address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may at any time change his address as entered
in the register of shareholders by means of a written notification sent to the registered office of the Company, or at such
other address as may be set by the Company from time to time.

Every share shall be fully paid-up.
The Company will recognise only one holder in respect of a share in the Company unless otherwise determined by the

Board of Directors and disclosed in the Prospectus of the Company. In the event of joint ownership or bare ownership and
usufruct, the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person
shall have been designated to represent the joint owners or bear owners and usufructaries vis-à-vis the Company.

In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or other

payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint holders,
or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.

Art. 7. Issue of shares. The Board of Directors is authorized without limitation to issue at any time new and fully paid-

up shares in the Company without reserving to existing shareholders of the Company any preferential right to subscribe to
shares to be issued.

The Board of Directors may reduce the frequency at which shares shall be issued in a Sub-Fund. The Board of Directors

may, in particular, decide that shares of a Sub-Fund shall only be issued during one or several determined periods or at
such other frequency as provided for in the Prospectus of the Company, but at least twice a month.

Whenever the Company offers shares for subscription, the subscription price per share shall be equal to the net asset

value per share of the relevant Class (the “Net Asset Value”), as determined in compliance with Article 12 hereunder, on
the applicable valuation day (the “Valuation Day”) (as defined in the Prospectus of the Company). Such price may be
increased by any applicable sales commissions as described in the Prospectus of the Company. The subscription price so
determined shall be payable as stipulated in the Prospectus of the Company.

Subscription requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 14 of these

Articles of Incorporation.

The Board of Directors may delegate to any director, officer or any duly authorized agent the power to accept subscrip-

tions, to receive in payment the subscription price of new shares to be issued and to deliver them to the shareholders.

In the event that the subscription price of the shares to be issued will not be paid by the shareholder concerned, the

Company may cancel the issue of such shares thereby reserving the right to claim expenses and commissions in relation
to such issue.

The Company may accept to issue shares against a contribution in kind of securities in compliance with the conditions

set forth by Luxembourg law and in particular, the obligation to deliver a valuation report by the auditor of the Company

122992

L

U X E M B O U R G

if and to the extent required by Luxembourg law or by the Board of Directors of the Company, and provided that such
securities comply with the investment objectives, policies and restrictions of the relevant Sub-Fund.

Art. 8. Redemption of shares. Any shareholder may request the Company to redeem all or part of his shares in accordance

with the requirements set forth by the Board of Directors in the Prospectus of the Company and within the limits provided
by the Law of 2010 and by these Articles of Incorporation.

Unless otherwise provided for in the sales documents, any shareholder may request the redemption of all or part of his

shares by the Company under the terms, conditions and limits set forth by the Board in the sales documents and within the
limits provided by law and these Articles. Any redemption request must be filed by such shareholder in written form, subject
to the conditions set out in the sales documents of the Company, at the registered office of the Company or with any other
person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of shares, together with the delivery of the certificate
(s) for such shares in proper form (if issued).

The redemption price per share shall be payable within a period as determined by the Board of Directors and mentioned

in the Prospectus of the Company, in accordance with a policy determined by the Board of Directors from time to time,
provided that the redemption form have been received by the Company subject to the provisions hereunder.

The redemption price shall be equal to the Net Asset Value per share of the relevant Class, as determined by the provisions

of Article 12 of these Articles of Incorporation less any redemption charges and/or commissions at the rate as may be
provided by the Prospectus of the Company. The redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the
relevant currency as the Board of Directors shall determine. From the redemption price there may further be deducted any
deferred sales charge if such shares form part of a Class in respect of which a deferred sales charge has been contemplated
in the sales documents.

The Board may determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of any specific Class

or Classes.

The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person,

the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.

With the consent of or upon request from the shareholder(s) concerned, the Board may (subject to the principle of

equitable treatment of shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating to the redeeming
shareholders investments from the portfolio in value equal to the Net Asset Value attributable to the shares to be redeemed
as described in the sales documents.

If, as a result of any request for redemption, the number or the total Net Asset Value of shares held by a shareholder in

a Class of shares shall fall below such number or such value as determined by the Board of Directors and disclosed in the
Prospectus of the Company from time to time, the Company may request such shareholder to redeem the total number or
the full amount of his shares belonging to such Class of shares.

The Company may accept to deliver transferable securities and money market instruments against a request for re-

demption  in  kind,  provided  that  the  relevant  shareholder  formally  agrees  to  such  delivery,  that  all  Luxembourg  law
provisions have been respected, and in particular the obligation to present an evaluation report from the auditor of the
Company. The value of such transferable securities and money market instruments shall be determined according to the
principle used for the calculation of the Net Asset Value. The Board of Director must make sure that the redemption in
kind of such shares shall not be detrimental to the other shareholders of the Company. The specific costs for such redemp-
tions in kind, in particular the costs of the special audit report, will have to be borne by the shareholder requesting the
redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless the Board considers that the redemption
in kind is in the interest of the Company or made to protect the interests of the Company.

All redeemed shares of the Company shall be cancelled.
No redemption or conversion by a single shareholder may, unless otherwise decided by the Board, be for an amount of

less than that of the minimum holding amount as determined from time to time by the Board.

If a redemption or conversion would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one Sub-Fund

or Class below the minimum holding amount as the Board shall determine from time to time, then such shareholder may
be deemed to have requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his shares of such Sub-Fund or Class.

The  Board  may  in  its  absolute  discretion  compulsory  redeem  or  convert  any  holding  with  a  value  of  less  than  the

minimum holding amount to be determined from time to time by the Board and to be published in the sales documents of
the Company.

Redemption requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 14 of these

Articles of Incorporation.

If the aggregate total number of redemption/conversion requests received for one relevant Sub-Fund at a given Valuation

Day exceeds a percentage of the Net Asset Value of the concerned Sub-Fund as determined by the Board of Directors and
set out in the Prospectus of the Company, the Board of Directors may decide to proportionally reduce and/or postpone such
redemption/conversion requests, so as to reduce the number of shares redeemed/converted as at that day down to the relevant
percentage of the Net Asset Value of the concerned Sub- Fund. Any redemption/conversion request so reduced or postponed
shall be received in priority to other redemption/conversion requests received at the next applicable Valuation Day, subject
to the above mentioned limit of the relevant percentage % of the Net Asset Value.

122993

L

U X E M B O U R G

In normal circumstances the Board of Directors will maintain an adequate level of liquid assets in every Sub-Fund in

order to meet redemption requests.

Art. 9. Conversion of shares. Except when specific restrictions are decided by the Board of Directors and mentioned in

the Prospectus of the Company, any shareholder is authorized to request the conversion within the same Sub-Fund or
between Sub-Funds of all or part of his shares of one Class into shares of the same or of another Class.

The price for the conversion of shares shall be calculated at the Net Asset Value by reference to the two relevant Classes,

on the same Valuation Day and taking into account of the conversion charges, if any, applicable to the relevant Classes.

The Board of Directors may set such restrictions that it shall deem necessary as to the frequency, terms and conditions

of conversions of shares.

If, as a result of a conversion of shares, the number or the total Net Asset Value of the shares held by a shareholder in

a specific Class of shares should fall under such number or such value as determined by the Board of Directors, the Company
may request that such shareholder convert all of his shares of such Class. The shares which have been converted shall be
cancelled.

Conversion requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 14 of these

Articles of Incorporation.

Art. 10. Restrictions to the ownership of shares in the Company. The Company may restrict or prevent the ownership

of shares in the Company to any individual person or legal entity if such ownership is a breach of the Law or is in other
ways jeopardizing the Company.

More specifically, the Company shall have the power to restrict or prevent the ownership of shares by “US persons”

such as defined hereunder and, for such purposes, the Company may:

A) decline to issue shares and register the transfer of shares where it results or may result that the issue, or the transfer

of such share would lead to the beneficial ownership of such shares by a US person;

B) request any person who is entered in the shareholders’ register, or any other person who wishes to register the transfer

of shares, to provide the Company with all the necessary information which it shall deem appropriate and supported by
affidavit in order to determine whether or not these shares are owned or shall be owned by US persons, and

C) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of

shareholders of the Company;

D) proceed with a compulsory redemption of all or part of such shares if it appears that a US person, whether alone or

together with other persons, is the owner of shares in the Company or has provided the Company with forged certificates
and guarantees or has omitted to provide the information and guarantees as determined by the Board of Directors. In this
event, the following procedure shall be applied:

1) The Company shall send a notice (the “Redemption Notice”) to the shareholder entered in the register as the owner

of the shares; the Redemption Notice shall specify the shares to be redeemed, the redemption price to be paid and the place
at  which  the  redemption  price  is  payable.  The  Redemption  Notice  shall  be  sent  by  registered  mail  addressed  to  the
shareholder’s last known address or to the address entered in the register of the shareholders. Immediately after the close
of business on the date specified in the Redemption Notice, the shareholder shall cease to be the owner of the shares
mentioned in such notice, his name shall no longer appear in the shareholders’ register and the relevant shares shall be
cancelled. The said shareholder shall thereupon forthwith obliged to deliver to the Company the share certificate or certi-
ficates (if issued) representing the shares specified in the Redemption Notice.

2) The price at which the shares mentioned in the Redemption Notice shall be redeemed, shall be an amount equal to

the net asset value of the shares of the Company according to Article 12 hereof, less any redemption charge payable in
respect thereof.

Where it appears that, due to the situation of the shareholder, payment of the redemption price by the Company, any of

its agents and/or any other intermediary may result in either the Company, any of its agents and/or any other intermediary
to be liable to a foreign authority for the payment of taxes or other administrative charges, the Company may further
withhold or retain, or allow any of its agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the Redemption Price
an amount sufficient to cover such potential liability until such time that the shareholder provide the Company, any of its
agents and/or any other intermediary with sufficient comfort that their liability shall not be engaged, it being understood
(i) that in some cases the amount so withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign authority, in which
case such amount may no longer be claimed by the shareholder, and (ii) that potential liability to be covered may extend
to any damage that the Company, any of its agents and/or any other intermediary may suffer as a result of their obligation
to abide by confidentiality rules;

3) Payment of the redemption price shall be made to the shareholder appearing as the owner of the shares in the currency

of denomination of the relevant Sub-Fund or Class except in times of exchange rates restrictions, and such price shall be
deposited with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice). Such bank shall thereafter
transfer such price to the relevant shareholder as indicated in the Redemption Notice.

Upon payment of the price pursuant to these conditions, no person interested in the shares specified in the Redemption

Notice shall have any future interest in these shares and shall have no power to make any claim against the Company and

122994

L

U X E M B O U R G

its assets, except the right for the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price deposited (with no interest)
at the bank.

4) The exercise by the Company of the powers conferred by the present Article shall not be questioned or invalidated

in any case, on the ground that there is insufficient evidence of ownership of shares or that a share was owned by another
person than appeared to the Company when sending the Redemption Notice, provided that the Company exercised its
powers in good faith; and

E) Decline to accept the vote of any US person at any meeting of shareholders of the Company:
Whenever used in these Articles, the term “US person” shall mean a national or resident of the United States of America,

a partnership organized or existing under the laws of any state, territory, possession of the United States of America (“USA”)
or a corporation organized under the laws of the USA or any other state, territory or possession of the USA or any trust
other than a trust the income of which arising from sources outside the United States of America is not included in the gross
income for the purposes of computing of United States federal income tax. In addition to the foregoing, the Board of
Directors may restrict the issue and transfer of Shares of a Sub-Fund to the institutional investors within the meaning of
Article 174 (2) of the Law of 2010 ("Institutional Investor(s)"). The Board of Directors may, at its discretion, delay the
acceptance of any subscription application for Shares of a Sub-Fund reserved for Institutional Investors until such time as
the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any
time that a holder of Shares of a Sub-Fund reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board of
Directors  will  convert  the  relevant  Shares  into  Shares  of  a  Sub-Fund  which  is  not  restricted  to  Institutional  Investors
(provided that there exists such a Sub-Fund with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant Shares in
accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board of Directors will refuse to give effect to any
transfer of Shares and consequently refuse for any transfer of Shares to be entered into the register of shareholders in
circumstances where such transfer would result in a situation where Shares of a Sub-Fund restricted to Institutional Investors
would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under
applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds Shares in a Sub-Fund
restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board of Directors, the other
shareholders of the relevant Sub-Fund and the Company’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or
connected to such holding circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation
or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed
to notify the Company of its loss of such status.

Art. 11. Termination and merger of Sub-Funds or Classes.
A) A Sub-Fund or a Class may be terminated by resolution of the Board of Directors under the following circumstances:
- if the Net Asset Value of a Sub-Fund or a Class is below a level at which the Board of Directors considers that its

management may not be easily ensured; or

- in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies; or
- if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that

may adversely affect the ability of a Sub-Fund or a Class to operate in an economically efficient manner, and with due
regard to the best interests of shareholders, that a Sub-Fund or a Class should be terminated.

In such event, the assets of the Sub-Fund or the Class shall be realized, the liabilities discharged and the net proceeds

of realization distributed to shareholders in proportion to their holding of shares in that Sub-Fund or Class against such
evidence of discharge as the Board of Directors may reasonably require. The Company shall send a notice to the shareholders
of the relevant Sub- Fund or Class of shares before the effective date of such termination. Such notice shall indicate the
reasons for such termination as well as the procedures to be enforced. Unless otherwise stated by the Board of Directors,
shareholders of such Sub-Fund or Class of shares may continue to apply for the redemption or the conversion of their shares
free of charge, but on the basis of the applicable Net Asset Value, taking into account the estimated liquidation expenses.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the general meeting of

shareholders of any one or all Classes of shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the power,
upon proposal from the Board of Directors, to redeem all the shares of the relevant Class or Classes and refund to the
shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization
expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements
for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or
represented and voting at such meeting.

The assets that were not distributed to their owners upon redemption shall be deposited with the “Caisse de Consignation”

in Luxembourg on behalf of their beneficiaries.

B) The Board of Directors may decide to allocate the assets of any Sub- Fund to those of another existing Sub-Fund

within the Company (the "new Sub- Fund") and to redesignate the shares of the class or classes of shares concerned as
shares of the new Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding
to any fractional entitlement to shareholders). The Board of Directors may also decide to allocate the assets of the Company
or any Sub-Fund to another undertaking for collective investment organised under the provisions of Part I of the Law of

122995

L

U X E M B O U R G

2010 or under the legislation of a Member State of the European Union, or of the European Economic Area, implementing
Directive 2009/65/EC or to a sub-fund within such other undertaking for collective investment.

The mergers will be undertaken within the framework of the Law of 2010.
Any merger shall be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to submit the decision for

a merger to a meeting of shareholders of the Sub-Fund concerned. No quorum is required for such a meeting and decisions
are taken by a simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Sub-Fund where, as a result, the Company ceases
to exist, the merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority
requirements for changing these Articles of Incorporation as further provided under Article 29 hereof.

C) In the event that the Board of Directors believes it is required in the interests of the shareholders of the relevant Sub-

Fund or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred which would
justify it, the reorganization of one Sub-Fund, by means of a division into two or more Sub-Funds, may be decided by the
Board of Directors. Such decision will be notified in the same manner as described above under A) and in accordance with
applicable laws and regulations.

D) The Board of Directors may also decide to consolidate or split Classes or split or consolidate different Classes of

shares within a Sub-Fund. Such decision will be notified in the same manner as described above under A) and in accordance
with applicable laws and regulations.

E) If within a Sub-Fund different Classes of shares have been issued as described in Article 5 of these Articles of

Incorporation, the Board of Directors may decide that the shares of one Class be converted into shares of another Class at
the time where the features applicable to the shares of a given Class are no more applicable to such Class. Such conversion
shall be carried out without costs for the shareholders, based on the applicable Net Asset Values. Any shareholder of the
relevant Class shall have the possibility to request for redemption of his shares without any cost for a period of one month
before the effective date of such compulsory conversion.

Art. 12. Net Asset Value. The Net Asset Value of the shares of each Sub-Fund and Class of shares of the Company as

well as the issue and redemption prices shall be determined by the Company, or by any third party entrusted by the Company
to calculate the Net Asset Value pursuant to a periodicity to be defined by the Board of Directors, but at least twice a month.
Such Net Asset Value shall be calculated in the reference currency of the relevant Sub-Fund or Class or in any other currency
as the Board of Directors may determine. The Net Asset Value shall be calculated by dividing the net assets of the relevant
Sub-Fund by the number of shares issued in such Sub-Fund taking into account, if needed, the allocation of the net assets
of this Sub-Fund into the various Classes of shares in this Sub-Fund (as described in Article 6 of these Articles).

The day on which the Net Asset Value shall be determined (“the Valuation Day”) will be defined in the Prospectus of

the Company.

I. The assets of the Company shall include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants,

options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided
that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (a) below with regards to fluctuations
in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);

4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon

is reasonably available to the Company;

5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is included

or reflected in the principal amount of such assets;

6) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,

insofar as the same have not been written off;

7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The assets of each Sub-Fund shall be valued in the following manner:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes and accounts receivables, prepaid expenses, dividends

and interests matured but not yet received shall be represented by the par-value of these assets except however if it appears
that such value is unlikely to be received. In the latter case, the value shall be determined by deducting a certain amount
to reflect the true value of these assets.

2) The value of transferable securities, money market instruments and/or financial derivative instruments listed on an

official Stock Exchange or dealt in on a regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public
(a “Regulated Market”) as defined by laws and regulations in force is based on the latest known price and if such transferable
securities are dealt in on several markets, on the basis of the latest known price on the main market for such securities. If
in the opinion of the Board of Directors the latest known price is not representative, the value shall be determined based
on a reasonably foreseeable sales price to be determined prudently and in good faith.

3) In the event that any transferable securities or/and money market instruments are not listed or dealt in on any stock

exchange or any other Regulated Market operating regularly, recognized and open to the public as defined by laws and

122996

L

U X E M B O U R G

regulations in force, the value of such assets shall be assessed on the basis of their foreseeable sales price estimated prudently
and in good faith.

4) The liquidating value of derivative contracts not traded on exchanges or on other Regulated Markets shall mean their

net liquidating value determined by the Board of Directors in a fair and reasonable manner, on a basis consistently applied
for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward and options contracts traded on exchanges
or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and
Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded by the Company; provided that
if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being
determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Board of Directors
may deem fair and reasonable.

5)  Credit  default  swaps  will  be  valued  at  their  present  value  of  future  cash  flows  by  reference  to  standard  market

conventions, where the cash flows are adjusted for default probability. Interest rate swaps will be valued at their market
value established by reference to the applicable interest rates’ curve. Other swaps will be valued at fair market value as
determined in good faith pursuant to the procedures established by the board of directors and recognised by the auditor of
the Company.

6) The value of money market instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other Regulated Market

and with remaining maturity of less than 12 months and of more than 90 days is deemed to be the nominal value thereof,
increased by any interest accrued thereon. Money market instruments with a remaining maturity of 90 days or less will be
valued by the amortized cost method, which approximates market value.

7) Units of UCITS and/or other UCI will be evaluated at their last available net asset value per unit or, if such price is

not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the Board of Directors on
a fair and equitable basis.

8) All other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to

procedures established by the Board of Directors.

The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a Sub-Fund will be converted into the

reference currency of such Sub-Fund at rates last quoted by major banks. If such quotations are not available, the rate of
exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the Board of Directors.

The Board of Directors, or any appointed agent, at its sole discretion, may permit some other method of valuation to be

used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

Every other asset shall be assessed on the basis of the foreseeable realization value which shall be estimated prudently

and in good faith.

II. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3) all accrued or payable expenses (including but not limited to administrative expenses, management fees, including

incentive fees -if any-, custodian fees, and corporate agents’ fees);

4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;

5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day as determined from time

to time by the Company, and other reserves (if any) authorized and approved by the Board of Directors, as well as such
amount (if any) as the Board of Directors may consider appropriate.

6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted

accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses
payable by the Company which shall comprise but not be limited to fees (investment management fees and performance
fees, if any) payable to its investment managers, fees and expenses payable to its Auditor and accountants, Custodian (as
defined in Article 28 herein below) and its correspondents, administrative agent and paying agent, any listing agent, do-
miciliary  agent,  any  distributor(s)  and  permanent  representatives  in  places  of  registration,  as  well  as  any  other  agent
employed by the Company, the remuneration of the Directors and officers of the Company and their reasonable out-of-
pocket expenses, insurance coverage, and reasonable travelling costs in connection with board meetings, fees and expenses
for legal and auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Com-
pany with any governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country,
reporting and publishing expenses including the costs of preparing, printing, advertising and distributing prospectuses,
explanatory memoranda, periodical reports or registration statements, and the costs of any reports to shareholders, all taxes,
duties, governmental and similar charges, the costs for the publication of the issue, conversion, if any, and redemption
prices and all other operating expenses, the costs for the publication of the issue and redemption prices, including the cost
of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may accrue
administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount payable for yearly or other
periods.

III. The assets shall be allocated as follows:

122997

L

U X E M B O U R G

1) the proceeds from the issue of each Share are to be applied in the books of the relevant Sub-fund to the pool of assets

established for such Sub-fund and the assets and liabilities and incomes and expenditures attributable thereto are applied
to such Sub-Fund subject to the provisions set forth hereafter;

2) where any asset is derived from another asset, such asset will be applied in the books of the relevant Sub-fund from

which such asset was derived, meaning that on each revaluation of such asset, any increase or diminution in value of such
asset will be applied to the relevant Sub-Fund;

3) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken in

connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability will be allocated to the relevant Sub-Fund;

4) where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Sub-Fund, such

asset or liability will be allocated to all Sub-funds prorata to the Sub-fund’s respective net asset value at their respective
launch dates;

5) upon the payment of dividends to the Shareholders in any Sub-fund, the net asset value of such Sub-fund shall be

reduced by the gross amount of such dividends.

IV. For the purpose of valuation under this article:
(a) shares of the relevant Sub-fund in respect of which the Board has issued a redemption notice or in respect of which

a redemption request has been received, shall be treated as existing and taken into account on the relevant Valuation Day,
and from such time and until paid, the redemption price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(b) all investments, cash balances and other assets of any Sub-fund expressed in currencies other than the currency of

denomination in which the net asset value of the relevant Sub-fund is calculated, shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of shares;

(c) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company on

such Valuation Day, to the extent practicable; and

(d) where the Board is of the view that any conversion or redemption which is to be effected will have the result of

requiring significant sales of assets in order to provide the required liquidity, the value may, at the discretion of the Board
be effected at the actual bid prices of the underlying assets and not the last available prices. Similarly, should any sub-
scription or conversion of shares result in a significant purchase of assets in the Company, the valuation may be done at
the actual offer price of the underlying assets and not the last available price.

All valuation principles and calculations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting

principles.

If the Board of Directors considers that the Net Asset Value calculated on a given Valuation Day is not representative

of the true value of the Company’s shares, or if, since the calculation of the Net Asset Value, there have been significant
fluctuations on the stock exchanges concerned, the Board of Directors may decide to take into account these circumstances
and to actualize the Net Asset Value on that same day. In these circumstances, all subscription, redemption and conversion
requests received for that day will be handled on the basis of the actualized Net Asset Value with care and good faith.

Art. 13. Pooling of assets. The Board of Directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner

described in the sales documents of the shares of the Company, that (i) all or part of the assets of the Company or of any
Sub-Fund be co-managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other undertakings for
collective investment and/or their sub-funds, or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-Funds of the Company
be comanaged amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.

Art. 14. Suspension of calculation of the Net Asset Value per share, of the issue, conversion and redemption of sha-

res. Without prejudice to the legal causes of suspension, the Board of Directors of the Company may suspend at any time
the determination of the Net asset Value per share of one or several Sub-Funds and the issue, redemption and conversion
of shares in the following cases:

a) when any of the principal stock exchanges, on which a substantial portion of the assets of one or more Sub-Funds is

quoted, is closed other than for ordinary holidays, or during which dealings therein are suspended or restricted;

b) when the market of a currency, in which a substantial portion of the assets of one or more Sub-Fund(s) or Class(es)

is denominated, is closed other than for ordinary holidays, or during which dealings therein are suspended or restricted;

c) when any breakdown arises in the means of communication normally employed in determining the value of the assets

of one or more Sub-Fund(s) or Class(es) of the Company or when for whatever reason the value of one of the Company's
investments cannot be rapidly and accurately determined;

d) when exchange restrictions or restrictions on the transfer of capital render the execution of transactions on behalf of

the Company impossible, or when purchases or sales made on behalf of the Company cannot be carried out at normal
exchange rates;

e) when political, economic, military, monetary or fiscal circumstances which are beyond the control, responsibility and

influence of the Company prevent the Company from disposing of the assets, or from determining the Net Asset Value, of
one or more Sub-Fund(s) or Class(es) in a normal and reasonable manner;

f) as a consequence of any decision to liquidate or dissolve the Company or one or several Sub-Fund(s);

122998

L

U X E M B O U R G

g) in the event of the publication (i) of the convening notice to a general meeting of shareholders at which a resolution

to wind up the Company or any Sub-Fund or a class of Share is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors
to wind up one or more Sub-Funds or a class of Share, or (ii) to the extent that such a suspension is justified for the protection
of the shareholders, of the notice of the general meeting of shareholders at which the merger of the Company or a Sub-
Fund or a class of Share is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors to merge one or more Sub-Funds
or a class of Share;

h) where the master UCITS of a feeder Sub-Fund temporarily suspends the repurchase, redemption or subscription of

its units/shares, whether on its own initiative or at the request of its competent authorities, or

i) In any other circumstances beyond the control of the Board of Directors as determined by the Directors in their

discretion.

In case of suspension of such calculation, the Company shall immediately inform in an appropriate manner the share-

holders who have requested the subscription, redemption or conversion of shares in this or these Sub-Funds.

Any suspension of the calculation of the Net Asset Value of the shares in one or several Sub-Funds shall be published,

if appropriate, by any appropriate ways.

During the suspension period, shareholders may cancel any application filed for the subscription, redemption or con-

version of shares. In the absence of such cancellation, the shares shall be issued, redeemed or converted by reference to
the first calculation of the Net Asset Value carried out following the close of such suspension period.

In exceptional circumstances which may be detrimental to the shareholders’ interests (for example large numbers of

redemption, subscription or conversion requests, strong volatility on one or more markets in which the Sub-Fund(s) or
Class(es) is (are) invested), the Board of Directors reserves the right to postpone the determination of the Net Asset Value
of this (these) Sub-Fund(s) or Class(es) until the disappearance of these exceptional circumstances and if the case arises,
until any essential sales of securities on behalf of the Company have been completed.

In such cases, subscriptions, redemption requests and conversions of shares, which were suspended simultaneously, will

be satisfied on the basis of the first Net Asset Value calculated thereafter.

Art. 15. General meetings of shareholders.
1. The meeting of shareholders of the Company validly set up shall represent all the shareholders of the Company. Its

resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of the Sub-Fund and Classes of Shares held
by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

2. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office

of the Company or at any such other place in the municipality of the registered office, as shall be specified in the notice of
meeting, on the last Thursday in the month of April at 15.00 p.m. If this day is not a bank business day in Luxembourg,
the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The annual general
meeting can be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances
require this relocation.

3. The other general meetings of shareholders shall be held at a date, time and place specified in the convening notices.
4. Decisions concerning the general interest of the Company’s shareholders are taken during a general meeting of all

the shareholders and decisions concerning specific rights of the shareholders of one Sub-Fund or Class of Shares shall be
taken during a general meeting of this Sub-Fund or of this Class of Shares. Two or several Sub-Funds or Classes may be
treated as one single Sub-Fund or Class if such Sub-Funds or Classes are affected in the same way by the proposals requiring
the approval of shareholders of the relevant Sub-Funds or Classes.

5. The quorum and notice periods required by law shall govern the convening and the conduct of the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the general

meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on the fifth
day prior to the general meeting (referred to as "Record Date"). The rights of a shareholder to attend a general meeting and
to exercise the voting rights attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder
at the Record Date.

6. Each whole share of each Sub-Fund and of each Class, regardless of its net asset value, is entitled to one vote, subject

to the restrictions contained in these Articles of Incorporation. Shareholder may vote either in person or through a written
proxy to another person who needs not to be a shareholder and may be a Director, or by means of a dated and duly completed
form which must include the information as set out herein.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

7. Shareholders may also vote by proxy. The Board of Directors may in its absolute discretion indicate in the convening

notice that the form must include information in addition to the following information: the name of the Company, the name
of the shareholder as it appears in the register of shareholders; the place, date and time of the meeting; the agenda of the
meeting; an indication as to how the shareholder has voted.

122999

L

U X E M B O U R G

In order for the votes expressed by such form to be taken into consideration for the determination of the quorum, the

form must be received by the Company or its appointed agent before the date specified therein.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

8. Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing

their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.

Co-owners, usufructuaries and bare-owners, creditors and secured debtors shall be respectively represented by a single

and same person. Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at meetings of share-
holders shall be passed by a simple majority of the validly cast votes of shareholders, which for the avoidance of doubt
shall not include abstention, nil vote and blank ballot paper.

9. Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors, pursuant to a notice setting forth the name of the Company,

the location, date, and time of the meeting, presence and quorum requirements and the agenda.

The agenda is prepared by the Board of Directors which, if the meeting is convened following a written demand from

the shareholders, as it is foreseen by law, shall take into account the items that shall be asked to be examined by the meeting.

If all shareholders are present or represented and if they state that they know the agenda, the meeting may be held without

prior publication.

10. The minutes of general meetings are signed by the members of the bureau and by the shareholders who so request.

Copies or extracts of such minutes, which need to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by:

- either 2 directors;
- or by the persons authorized by the Board of Directors.

Art. 16. Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members.

The members of the Board of Directors shall not necessarily be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected at the annual general meeting of shareholders and for the first time after the incorporation

of the Company, for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify.
The Directors shall be eligible for re-election.

If a legal entity is appointed as Director, such legal entity must designate a physical person as its permanent representative

who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its
permanent representative if it appoints his successor at the same time.

In this respect, a third party shall have no right to demand the justification of powers; the mere qualification of repre-

sentative or of delegate of the legal entity being sufficient.

The  term  of  office  of  outgoing  directors  not  re-elected  shall  end  immediately  after  the  general  meeting  which  has

proceeded to their replacement.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general

meeting of the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement, dismissal or otherwise, the remaining

Directors  may  appoint,  at  the  majority  of  votes,  a  Director  to  temporarily  fill  such  vacancy  until  the  next  meeting  of
shareholders which shall ratify such appointment.

Art. 17. Chairmanship and Board Meetings. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman

and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also appoint a secretary who need not be a
Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two Directors, at the place, date and time indicated

in the notice of meeting.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
Any Director may act at any meeting by appointing another Director as his proxy, in writing, by telefax or any other

similar written means of communication. Any director may represent one or more of his colleagues. Directors may also
cast their vote in writing by telefax or any other similar written means of communication.

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company

by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors meets under the presidency of its chairman, or in his absence, the Board of Directors may appoint

another director to chair such meetings.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least half of the total number of directors is present or

represented. Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented at such meeting. In the event
that, at any Board of Directors meeting, the number of votes for and against a resolution are equal, the chairman or in his
absence the chairman pro tempore of the meeting shall have a casting vote.

123000

L

U X E M B O U R G

Any Director may participate at a meeting of the Board of Directors by conference call or video-conference or by other

similar means of communication whereby all persons participating in a meeting can hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation of all such persons at the meeting. The participation to a meeting by such means of
communication is equivalent to a physical presence at such meeting. A meeting held through such means of communication
is deemed to be held at the registered office of the Company.

Notwithstanding the clauses mentioned here above, a resolution from the Board of Directors may also be passed via a

circular resolution. This resolution shall be approved by all the Directors whose signatures shall be either on a single
document or on several copies of it. Such a resolution shall have the same validity and force as if it had been taken during
a meeting of the Board of Directors, legally convened and held.

The minutes of the meetings of the Board of Directors shall be signed by the chairman or in his absence, by the chairman

pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes, intended to be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary, or by any two Directors or by any person authorized by the
Board of Directors.

Art. 18. Powers of the Board of Directors. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or

by the joint or single signature of any Director or officer to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders
are within the scope of competence of the Board of Directors.

Art. 19. Investment Policy. The Board of Directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine

the corporate and the investment policies to be applied in respect of each Sub-Fund and the course of conduct of the
management and business affairs of the Company.

In particular, the investments of the Company may include transferable securities admitted to official listing on a stock

exchange or dealt in on another Regulated Market located within any other country of Western or Eastern Europe, Asia,
Oceania, the American continents or Africa and any other assets permitted by and within the restrictions of the Law of
2010.

Each Sub-Fund is allowed to invest, in accordance with the principle of risk spreading, 100% of its net assets in trans-

ferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a member state of the European Union, one or
more  of  its  local  authorities,  a  non-member  state  of  the  European  Union,  accepted  by  the  CSSF  and  specified  in  the
Prospectus, or public international body to which one or more member states of the European Union belong, provided that
in such case, the Sub-Fund concerned holds securities or money market instruments from at least six different issues, and
the securities or money market instruments of any single issue shall not exceed 30% of the Sub-Fund's total assets.

Unless specified otherwise in the Prospectus, no Sub-Fund may in aggregate invest more than 10% of its net assets in

units of other UCITS and/or UCIs. The Company will also be entitled to adopt master-feeder investment policies and thus
a Sub-Fund may invest at least 85% of its assets in other UCITS or Sub-Funds of other UCITS in compliance with the
provisions of the Law of 2010 and under the condition that such policy is specifically permitted by the investment policy
applicable to the relevant Sub-Fund as disclosed in the Prospectus.

Any Sub-Fund may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in applicable Luxembourg laws

and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents for the shares of the Company,
subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more Sub-Funds of the Company. In this case and
subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these
shares are suspended for as long as they are hold by the Sub- Fund concerned. In addition and for as long as these shares
are held by a Sub- Fund, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company
for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Law of 2010.

Should a Sub-Fund invest in shares of another Sub-Fund of the Company, no subscription, redemption, management or

advisory fee will be charged on account of the Sub-Fund's investment in the other Sub-Fund.

Art. 20. Daily Management. The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Company, including

a general manager, a secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered ne-
cessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the
Board of Directors. Officers need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise
stipulated in these Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given them by the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its

powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which
need not be members of the Board of Directors. The Board of Directors may also delegate any of its powers, authorities
and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board of
Directors or not) as it thinks fit.

Art. 21. Representation - Judicial acts and actions - Commitments of the Company.  The  Company  will  be  legally

represented:

- either by the chairman of the Board of Directors; or
- jointly by two Directors; or

123001

L

U X E M B O U R G

- by the representative(s) in charge of the daily management and/or the general manager and/or the general secretary

acting together or separately, up to the limit of their powers as determined by the Board of Directors.

Besides, the Company will be validly committed by specially authorized agents within the limits of their mandates.
Legal actions, in a capacity as either claimant or defendant, shall be followed up in the name of the Company by a

member of the Board of Directors or by the representative appointed to that effect by the Board of Directors.

The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or single signature of any Director

or officer to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 22. Invalidation Clause and Transactions with Connected Persons. No contract or other transaction between the

Company and other companies or firms shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors
or officers of the Company is interested in such other firm or company or by the fact that he would be a director, partner,
manager or employee of it. Any Director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any
company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not be prevented, by reason of
such an affiliation with such other company or firm but subject as hereinafter provided, from considering, voting and acting
upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company would have a personal interest in a transaction of the Company,

such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and he shall not consider or vote
on any such transaction; and such transaction and such Director’s or manager’s personal interest shall be reported to the
next general meeting of shareholders.

The term “personal interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any

matter, position or transaction involving Rasini Fairway Capital Ltd or any subsidiary or affiliate thereof or such other
corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors unless such a “personal interest”
is considered to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.

All transactions carried out by or on behalf of the Company must be at arm's length and executed on the best available

terms.

Art. 23. Indemnifications. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and adminis-

trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be
made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such
person shall be indemnified in all circumstances except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in
such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, any indemnity
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by
its counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnity shall
not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 24. Auditor. In accordance with the Law, the Company shall appoint an independent auditor (“Réviseur d’Entre-

prises agréé”). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and serve until its
successor shall have been elected and shall be remunerated by the Company.

Art. 25. Custody of the assets of the Company. The Company shall enter into a custodian agreement with a bank which

shall satisfy the requirements of the Luxembourg laws and the Law of 2010 (the "Custodian"). All securities, cash and
other assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and
its shareholders the responsibilities provided by the laws.

In the event of the Custodian desiring to retire, the Board of Directors shall use their best endeavours to find within two

months a corporation to act as custodian and upon doing so the Board of Directors shall appoint such corporation to be
custodian in place of the retiring Custodian. The Board of Directors may terminate the appointment of the Custodian but
shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this
provision to act in the place thereof.

Art. 26. Investment advisers and managers. The Company may conclude under its overall control and responsibility one

or several management or advisory agreements with any Luxembourg or foreign entity by which such entity or any other
previously approved company shall provide the Company with advice, recommendations and management services re-
garding  the  investment  policy  of  the  Company  in  accordance  with  the  Law  of  2010  and  with  the  present  Articles  of
Incorporation. In the event of termination of said agreements in any manner whatsoever, the Company will, if applicable,
change its name forthwith upon the request of any investment adviser(s) or manager(s) to another name not resembling the
one specified in Article 1 hereof.

Art. 27. Accounting year - Annual and periodical report. The accounting year of the Company shall begin on 1 

st

 January

of each year and shall terminate on the last day of December of same year. The consolidated accounts of the Company
shall be expressed in Euros.

123002

L

U X E M B O U R G

Where there shall be different Sub-Funds, as provided for by Article 5 of these Articles of Incorporation, and if the

accounts within such sub-funds are kept in different currencies, such accounts shall be converted into Euros and added
together for the purpose of determining the accounts of the Company.

Art. 28. Allocation of the annual result. Upon the Board of Directors’ proposal and within legal limits, the general

meeting of shareholders of the Class(es) issued in any Sub-Fund shall determine how the results of such Sub-Fund shall
be allocated and may from time to time declare or authorize the Board of Directors to declare distributions.

For each Class or Classes of shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends

in compliance with the conditions set forth by law.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses recorded

in the register of shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place as the Board of
Directors shall determine.

The Board of Directors may decide to distribute dividends in the form of new shares in lieu of cash dividends upon such

terms and conditions as may be set forth by the Board of Directors.

Any declared distribution that has not been claimed by its beneficiary within five years of its attribution may not be

subsequently reclaimed and shall revert to the Sub-Fund relating to the relevant Class(es) of shares.

The Board of Directors has all powers and may take all measures necessary for the implementation of this provision.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
The payment of revenues shall be due for payment only if the currency regulations enable to distribute them in the

country where the beneficiary lives.

Art. 29. Dissolution. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting subject to the

quorum and majority requirements referred to in Article 30 of the present Articles of Incorporation.

In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may

be physical persons or legal entities represented by physical persons, designated by the general meeting of shareholders
which shall determine their powers and their compensations.

If the capital of the Company falls below two thirds of the minimum legal capital, the Directors must submit the question

of the dissolution of the Company to the general meeting for which no quorum shall be prescribed and which shall decide
by simple majority of the shares present or represented at the meeting. If the capital falls below one fourth of the minimum
legal capital, no quorum shall be prescribed but the dissolution may be resolved by shareholders holding one fourth of the
shares presented at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets have

fallen below respectively two thirds or one fourth of the minimum capital.

The net proceeds of liquidation corresponding to each Class shall be distributed by the liquidators to the holders of

shares of each Class of each Sub- Fund in proportion of the rights attributable to the relevant Class of shares.

Art. 30. Amendments to the Articles of Incorporation. The present Articles of Incorporation may be amended from time

to time by a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements required by Luxembourg
law and by the provisions of the present Articles of Incorporation. Any amendment affecting the rights of the holders of
Shares of any Class or Sub-Fund vis-à-vis those of any other Class or Sub-Fund shall be subject, to the said quorum and
majority requirements in respect of each such relevant Class or Sub-Fund.

Art. 31. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be subject to the 1915 Law

amended and to the Law of 2010.

<i>Transitional provisions

The first business year begins today and ends on December 31 

st

 , 2015.

The first annual general meeting of shareholders will be held in 2016.

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes all the

thirty-one (31) shares for EUR 31,000 (thirty one thousand euro) in EUR I share class of the Rasini Diamonds Funds sub
fund.

All these shares have been fully paid up by the Shareholder by payment in cash, so that the sum of EUR 31,000 (thirty-

one thousand euro), paid by the Shareholder is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having
been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the 1915

Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

123003

L

U X E M B O U R G

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 3,000.

<i>Extraordinary general meeting of shareholder

The above named party, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened,

has proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly constituted,
has passed the following resolutions by unanimous vote:

1. the number of directors is set at three;
2. the following persons are appointed as directors for a period ending at the next annual general meeting:
- Mr Piernicola Diamanti Lelli, Portfolio Manager at Rasini Fairway Capital Ltd.,1 

st

 Floor North, 4-5 Grosvenor Place,

London SW1X 7HJ, United Kingdom, born on 21 March 1966 in Milan (Italy);

- Mr Malcolm Reid, Chief Financial Officer and Compliance Officer at Rasini Fairway Capital Ltd., 1 

st

 Floor North,

4-5 Grosvenor Place, London SW1X 7HJ, United Kingdom, born on 31 August 1973 in Glasgow (United kingdom);

-  Mr  Marco  Sagramoso,  General  Manager  at  Lemanik  Asset  Management  S.A.  Lugano  Branch,  Via  Trevano  2/A,

CH-6900 Lugano, Switzerland, born on 16 December 1968 in Milan (Italy);

3. that there be appointed Ernst &amp; Young S.A., with registered office 7 Rue Gabriel Lippmann Parc d'Activité Syrdall

2, L-5365 Munsbach Grand Duchy of Luxembourg as independent auditor of the Company;

4. that the terms of office of the members of the Board and of the independent auditor will expire after the annual general

meeting of shareholders approving the accounts for the year ended on December 31 

st

 , 2015; and

5. that the address of the registered office of the Company is at 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer, Grand Duchy of

Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read by the proxy-holder of the person appearing, known to the notary by the surnames,

names, civil status and residences, said proxy-holder signed the present deed together with the notary.

Signé: C. MAYEMBO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/23162. Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 juillet 2015.

Référence de publication: 2015133249/775.
(150143655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

Caelum Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.

R.C.S. Luxembourg B 198.985.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn,
Am zwanzigsten Juli,
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz zu Düdelingen (Großherzogtum Luxemburg)

Sind erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft (société anonyme) „Illustro Caelum S.A.“, mit Sitz in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der

Heckmill, gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 7. Juli 2015, noch nicht eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg,

hier vertreten durch ihre Verwalter
1. Herr Omar Alberto Soliman EL GOHARY DE VALLE, CEO, geboren in Mexico D.F. (Mexico) am 23. April 1972,

wohnhaft in D-80802 München, Ungererstraße 38,

hier vertreten durch Herrn Philippe STANKO, nachfolgend benannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift,
welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

2. Herr Philippe STANKO, Privatbeamter, geboren in Wittlich (Deutschland) am 15. Januar 1977, geschäftsansässig in

L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill,

123004

L

U X E M B O U R G

2) Die Aktiengesellschaft (société anonyme) „K &amp; K Investment Luxembourg S.A.“, mit Sitz in L-6783 Grevenmacher,

31, Op der Heckmill, gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 7. Juli 2015, noch nicht
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg,

hier vertreten durch ihre Verwalter
1. Herr Karsten NEUGEBAUER, CEO, geboren in Schleswig (Deutschland) am 16. Dezember 1966, geschäftsansässig

in D-80807 München, CAELUM Group GmbH, Georg-Muche-Strasse 5, hier vertreten durch Herrn Philippe STANKO,
nachfolgend benannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift,

welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

2. Herr Philippe STANKO, Privatbeamter, geboren in Wittlich (Deutschland) am 15. Januar 1977, geschäftsansässig in

L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

Die vorbenannten Komparenten, wie hiervor vertreten, handelnd in ihrer angegebenen Eigenschaft, ersuchen den un-

terzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Bezeichnung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine

Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Caelum Holding S.A.“ gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in Esch-sur-Alzette.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates, der
Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann
durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unab-
hängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Entwicklung von Software und der Forschung im Bereich der Software

sowie Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an jeglichen Unternehmen, ob in Luxemburg oder im Ausland, zu
erwerben, durch Beteiligung an deren Kapital, durch Titel und Stimmrechte, durch Einbringen von Werten, durch Zeich-
nung, durch Option, Ankauf, Tausch, Aushandeln, oder auf jegliche andere Art und Weise, sowie auch den Erwerb von
Patenten, Urheberrechten, Markenrechten, Lizenzkonzessionen, sowie deren Verwaltung und Verkauf.

Des Weiteren hat die Gesellschaft zum Zweck den Erwerb und die Verwertung von Rechten des geistigen Eigentums,

insbesondere Patenten, Urheberrechten, Markenrechten, Designrechten, Lizenzkonzessionen, sowie deren Verwaltung und
Verkauf.

Sie kann auch den Unternehmen in denen sie Interessen erwirbt, sowie Dritten, jegliche Unterstützung und finanzielle

Hilfestellung zuwenden, dies auch unter der Form von Darlehen, Vorschüssen, Garantien, sowie sie auch Mittel leihen
kann, sogar durch Ausgabe von Anleihen, oder sich anders verschulden um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen.

Sie kann generell jegliche Maßnahmen nehmen, sowie alle Transaktionen ausführen, welche der Erfüllung ihres Ge-

sellschaftszweckes dienen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt ZWEIUNDDREIßIGTAUSEND EURO (32.000.-€) ein-

geteilt in ZWEIHUNDERTSECHSUNDFÜNFZIG (256) Aktien der Kategorie A und VIERUNDSECHZIG (64) Vor-
zugsaktien der Kategorie B mit Nominalwert von HUNDERT EURO (100.-€) pro Aktie.

Die Vorzugsaktien der Kategorie B verfügen über kein Stimmrecht, jedoch bei Gewinnausschüttung geben sie Recht

auf eine zusätzliche und privilegierte Dividende von 5% der normalen Dividende.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend bezeichnete Dauer, auf fünf Millionen (5.000.000) Euro festgesetzt,

eingeteilt in fünfzigtausend (50.000) Aktien mit einem Nominalwert von einhundert (100) Euro pro Aktie.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden, durch Bes-

chluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Des Weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, das gezeichnete Aktienkapital

ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitale-
rhöhungen  können  durch  Zeichnung,  mit  oder  ohne  Emissionsprämie,  durchgeführt  werden  mittels  Einzahlung  durch

123005

L

U X E M B O U R G

Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Gu-
thaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprä-
mien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jede
andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zah-
lungen für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist der erste Absatz

dieses Artikels automatisch anzupassen.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche das

Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Generalversammlung der

Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats
auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung
der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die ernannten

verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, den frei gewordenen Posten vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsi-

tzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein

Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, per E-Mail oder per Telefax abge-

ben. Fernschreiben, E-Mail und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein  schriftlich  gefasster  Beschluss,  der  von  allen  Verwaltungsratsmitgliedern  genehmigt  und  unterschrieben  ist,  ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit

ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die  Beglaubigung  von  Kopien  oder  Auszügen  erfolgt  durch  ein  Verwaltungsratsmitglied  oder  durch  einen  Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz vom 10. August 1915 sowie es abgeändert wurde, und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversamm-
lung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird gegenüber von Dritten in allen Fällen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift

von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, davon wenigstens eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Ka-
tegorie B oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des
Verwaltungsrates.

Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.
Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwal-

tungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kom-

missaren überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt; sie können beliebig
abberufen werden.

123006

L

U X E M B O U R G

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Generalversammlung der Aktionäre

zufallenden Befugnisse aus.

Im Falle von mehreren Aktionären, vertritt die Generalversammlung alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehend Voll-

machten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt
gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungss-

chreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Freitag des Monats Mai jeden Jahres um 13:00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der Alleingesellschafter oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche

Generalversammlung einberufen. Sie muss auf schriftlichen Antrag von Aktionären, die mindestens 10% Gesellschafts-
kapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Das Stimmrecht der B-Aktien ist jedoch beschränkt auf

Entscheidungen  welche  sie  selbst  betreffen  sowie  auf  solche  von  besonderer  Wichtigkeit,  gemäß  der  Aufzählung  des
Artikels 46 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.

Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen gehört,

hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange
bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung hört auf, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-

tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die

natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und
Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendfünfzehn.
1. Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2016 statt.
2. Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die anschließend an die Gründung abgehalten wird.

<i>Kapitalzeichnung - Einzahlung

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die Aktien wie folgt zu zeichnen:

1) Die Aktiengesellschaft Illustro Caelum S.A., vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 A- Aktien; 32 B-Aktien
2) Die Aktiengesellschaft K &amp; K Investment Luxembourg S.A., vorgenannt, . . . . . . . . . 128 A- Aktien; 32 B-Aktien
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 A- Aktien; 64 B-Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von zweiunddreißigtausend Euro (EUR 32.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

123007

L

U X E M B O U R G

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des geänderten Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger

Gründung entstehen, auf eintausendfünfhundert Euro (1.500.- EUR).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann  erklären  die  Gesellschafter,  handelnd  an  Stelle  einer  außerordentlichen  Hauptversammlung,  folgende  Bes-

chlüsse zu nehmen:

1) Die Zahl der Verwaltungsratmitglieder wird auf drei, die der Kommissare auf eins festgelegt.
2)  Zu  Verwaltungsratsmitgliedern  werden  nachfolgende  Personen  ernannt;  ihr  Mandat  läuft  ab  in  der  ordentlichen

Generalversammlung, die im Jahre 2021 abgehalten wird:

<i>Verwalter der KATEGORIE A:

1. Herr Karsten NEUGEBAUER, CEO, geboren in Schleswig (Deutschland) am 16. Dezember 1966, geschäftsansässig

D-80807 München, CAELUM Group GmbH, Georg-Muche-Strasse, 5,

2. Herr Omar Alberto Soliman EL GOHARY DE VALLE, CEO, geboren in Mexico D.F. (Mexico) am 23. April 1972,

wohnhaft in D-80802 München, 38 Ungererstraße

<i>Verwalter der KATEGORIE B:

3. Herr Thorsten KLÄS, Privatbeamter, geboren in Trier (Deutschland) am 5. Oktober 1977, wohnhaft in D-54290 Trier,

Weidegasse 7

3) Zum Kommissar wird ernannt; sein Mandat läuft ab in der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2021

abgehalten wird:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUDWIG &amp; MALDENER Sàrl, mit Sitz in L-6783 Grevenmacher, 31, Op

der Heckmill, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 48 947.

4) Der Gesellschaftssitz befindet sich in L- 4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die admi-

nistrative Genehmigung zu erhalten, zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen, ge-

genwärtige Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in englischer Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, hat die deutsche Fassung Vorrang.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde in Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, dem Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.

Folgt die Englische Übersetzung der Vorgenannten Urkunde

In the year two thousand fifteen,
On the twentieth day of July,
Before us Maître Carlo GOEDERT, notary residing in Dudelange (Luxembourg),

There appeared:

1) The joint stock company (société anonyme) „Illustro Caelum S.A.“, having its registered office in L-6783 Greven-

macher, 31, Op der Heckmill, incorporated according to a deed taken by the undersigned notary on 7 

th

 July 2015, not yet

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by its directors:
1. Mister Omar Alberto Soliman EL GOHARY DE VALLE, CEO, born in Mexico D.F. (Mexico) on 23 

rd

 April 1972,

residing in D-80802 Munich, Ungererstraße 38,

duly represented by Mister Philippe STANKO, named hereinafter, by virtue of a proxy under private seal.
The prenamed proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder and the notary executing, remains

attached to the present deed for the purpose of registration.

2. Mister Philippe STANKO, private employee, born in Wittlich (Germany) on 15 

th

 January 1977, residing professio-

nally in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

2) The joint stock company (société anonyme) „K &amp; K Investment Luxembourg S.A.“, having its registered office in

L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill, incorporated according to a deed taken by the undersigned notary on 7 

th

 July

2015, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, Here represented by its directors:

123008

L

U X E M B O U R G

1. Mister Karsten NEUGEBAUER, CEO, born in Schleswig (Germany) on the 16 

th

 December 1966, residing profes-

sionally in D-80807 München, CAELUM Group GmbH, Georg-Muche-Strasse 5, duly represented by Mister Philippe
STANKO, named hereinafter, by virtue of a proxy under private seal.

The prenamed proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder and the notary executing, remains

attached to the present deed for the purpose of registration.

2. Mister Philippe STANKO, private employee, born in Wittlich (Germany) on 15 

th

 January 1977, residing professio-

nally in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital.

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of "Caelum Holding S.A.".

Art. 2. The registered office is in Esch-sur-Alzette.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The company’s purpose is the development of software and research in the field of software such as to take

participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely the
acquisition of patents, copyrights, trademarks, license concessions, to manage and develop them.

The Company also has the purpose of acquisition and exploitation of intellectual property rights, especially patents,

copyrights, trademarks, design rights, license concessions, and the management and sale.

The  company  may  also  grant  enterprises  in  which  the  company  has  an  interest,  any  assistance,  loans,  advances  or

guarantees, finally perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at THIRTY TWO THOUSAND EURO (EUR 32.000.-) divided

into TWO HUNDRED FIFTY SIX (256) shares of category A and SIXTY FOUR (64) preferential shares of category B
with a par value of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each.

The preferential shares of category B have no voting right, but at profit distribution rights to an additional and privileged

dividend of 5% of the normal dividend.

The authorized capital will be fixed, for the period specified below, to five million (5.000.000.-€) Euro, divided into

fifty thousand (50.000) shares with a nominal value of one hundred (100) Euro.

The authorized and issued share capital of the Company may be increased or decreased by resolution of the General

Meeting of Shareholders, voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

In addition, the Board is authorized for a period of five years, to increase the subscribed share capital in whole or in

part, within the framework of the authorized capital by issuing new shares. These capital increases may be carried out, with
or without an issue premium, through cash contributions, contributions in kind or through conversion of uncontested, certain
and immediately exigible claims against the Company, or through incorporation of non-distributed profits, reserves or issue
premiums or through conversion of bonds as mentioned below.

The Board may delegate to any director or any other duly authorized person, the reception of the subscriptions of the

new shares and the payments for the shares, representing the capital increase in whole or in part.

After each capital increase carried out by the Board of Directors and legally notarized, the first paragraph of this article

is to be adjusted.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions provided by law.

123009

L

U X E M B O U R G

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors.

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected

for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time
by the general meeting.

In case the company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is

established that the company has only one shareholder left, the company can be managed by a board of directors consisting
of either one director until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one
shareholder.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place

will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors'

meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10

th

 , 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence

of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of

the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is
subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any two

directors, obligatorily one director of category A and one director of category B or by the sole signature of the delegate of
the board acting within the limits of his powers.

In case of a sole director, the company is committed by his sole signature.
In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature

legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the

general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding

six years.

General meeting.

Art. 14. If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of

shareholders.

In case of plurality of shareholders, the general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most

extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the
form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the second Friday of the month of May, at 01:00 pm.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the sole director or the auditor may convene an extraordinary general meeting. It must be

convened at the written request of shareholders representing at least 10% of the company's share capital.

123010

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. However, the voting rights of B shares are limited to decisions

which affect themselves as well as those of particular importance, according to the list in Article 46 of the Law on Com-
mercial Companies.

The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner
in relation to the company.

Business year - Distribution of profits.

Art. 18. The business year begins on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution

will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation.

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions.

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions.

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31 

st

 , 2015.

1. The first annual general meeting shall be held in 2016.
2. The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take

place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment.

The articles of incorporation having been duly approved and adopted, the shares have been subscribed to as follows:

1) The joint stock company Illustro Caelum S.A., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 A- shares; 32 B-shares
2) The joint stock company K &amp; K Investment Luxembourg S.A., prenamed, . . . . . . . . . 128 A- shares; 32 B-shares
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 A- shares; 64 B-shares

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty-two

thousand Euro (EUR 32.000), as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification.

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial companies

of August 10 

th

 , 1915, as subsequently amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses.

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand five hundred euro (1.500.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting.

The shareholders, prenamed, representing the whole of the share capital, passed the following resolutions:
1) The number of directors is fixed at three, the number of auditor is fixed at one.
2) The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the

year 2021:

<i>Directors of CATEGORY A:

1. Mister Karsten NEUGEBAUER, CEO, born in Schleswig (Germany) on 16 

th

 December 1966, residing professionally

D-80807 München, CAELUM Group GmbH, Georg-Muche-Strasse 5,

123011

L

U X E M B O U R G

2. Mister Omar Alberto Soliman EL GOHARY DE VALLE, CEO, born in Mexico D.F. (Mexico) on 23 

rd

 April 1972,

residing in D-80802 Munich, Ungererstraße 38,

<i>Director of CATEGORY B:

3. Mister Thorsten KLÄS, private employee, born in Trier (Germany) on 5 

th

 October 1977, residing in D-54290 Trier,

Weidegasse 7.

3) The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be held

in the year 2021:

The limited liability company LUDWIG &amp; MALDENER Sàrl, having its registered office at L-6783 Grevenmacher,

31, Op der Heckmill, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 48 947.

4) The company's registered office is located at L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.
The notary drew the attention of the appearing parties on the fact that the company will have to obtain an administrative

authorisation in order to pursue its objects.

The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in German, followed by an English version; upon the request of the same
appearing persons, in case of divergences between the English and German text, the German version will prevail.

WHEREOF, The present notary deed was drawn up in Grevenmacher, On the day indicated at the beginning of this

deed.

The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the persons appearing, known

to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said proxy holder signed together with us,
Notary, the present original deed.

Signé: P. STANKO, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 juillet 2015. Relation: EAC/2015/17299. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 28 juillet 2015.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2015132687/422.
(150143862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

Public Safety Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 117.722.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of July,
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

PSE Newco II Limited, a limited company existing under the laws of the United Kingdoms, having its registered office

at Britax, Bessingby Industrial Estate, YO16 4SJ Bridlington, United Kingdoms, and registered under number 07248807
with the Companies House in the United Kingdom (the “Sole Member”),

duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Cho Conde, private employee, professionally residing in Pétange, Grand-

Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal,

The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:
- the Sole Member holds all the shares in PUBLIC SAFETY LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its
registered address at 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 117722, and incorporated pursuant
to a notarial deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary public then residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg, on
July 6, 2006, which deed was published in the Official gazette, (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) on
September 15, 2006 under number 1725 (the “Company”). The articles of Association of the Company have been lastly

123012

L

U X E M B O U R G

amended pursuant to a notarial deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, on December 12, 2014, which deed was published in the Official gazette on March 5, 2015 under number 616;

- the Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by five hundred

(500) shares having a nominal value of twenty five Euros (EUR 25) each;

- the Sole Member hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect as from today;
- the Sole Member assumes the role of liquidator of the Company;
- the Sole Member as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known

liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Member is vested with all the assets and
hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular
those hidden or any known but unpaid and any unknown liabilities of the Company;

- the Sole Member waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and to

hear a report of an auditor to the liquidation;

- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Member has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial

situation of the Company;

- the Sole Member grants full discharge to the managers of the Company for their mandates from the date of their

respective appointments up to the date of the present meeting; and

- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting

at the following address: c/o PricewaterhouseCoopers LLP, Benson House, 33 Wellington Street, Leeds, LS1 4JP, The
United Kingdom.

Whereof the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary this

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour de juillet.
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

PSE Newco II Limited, une société privée existant sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social à Britax,

Bessingby Industrial Estate, YO16 4SJ Bridlington, Royaume-Uni, et enregistrée au registre des sociétés (Companies
House) du Royaume-Uni sous le numéro 07248807 (l’«Associé Unique»),

ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Pétange, en vertu d'une

procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au

présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement,

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- l’Associé Unique détient toutes les parts sociales de PUBLIC SAFETY LUXEMBOURG S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 283, route
d’Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 117722, et constituée suivant un acte notarié de Maître Jean-Joseph Wagner, alors notaire
résident à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, le 6 juillet 2006 et publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions le 15 septembre 2006 sous le numéro 1725 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois en vertu d’un acte notarié de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
et publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 5 mars 2015 sous le numéro 616.

- le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12 500 EUR) représenté par cinq cents (500)

parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 EUR) chacune;

- par la présente l’Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- l’Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
- l’Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif

connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa
charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour
avant tout paiement à sa personne;

- l’Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un

rapport du commissaire à la liquidation;

123013

L

U X E M B O U R G

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;
- la comparante donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat à compter de la date de

leurs nominations respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la

présente assemblée à l’adresse suivante: c/o PricewaterhouseCoopers LLP, Benson House, 33 Wellington Street, Leeds,
LS1 4JP, Royaume-Uni.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi

en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les
versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 juillet 2015. Relation: EAC/2015/17419. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015133228/100.
(150143140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

Simpleet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 55, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 198.968.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour de juillet.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Linc S.A., une société anonyme, régie selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-4391 Pontpierre, 55,

rue de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.207, ici
représentée par son administrateur délégué Monsieur Marc NEUEN, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 16
mai 1972, demeurant à L-4391 Pontpierre, 29, rue de Luxembourg, et son administrateur Monsieur Daniel SCHNEIDER,
administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 15 septembre 1964, demeurant à L-2533 Luxembourg, 40, rue de la Semois;

- Monsieur Julien GRAS, informaticien, né à Mons (Belgique), le 29 septembre 1982, demeurant à B-6782 Bébange,

36, rue de Panorama; et

- Monsieur Benjamin DOSOGNE, informaticien, né à Namur (Belgique), le 7 juillet 1984, demeurant à B-6700 Arlon,

85, avenue de la Gare Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient devenir

associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La société a pour objet le développement et la commercialisation, à travers la concession de licences, d’une

plateforme internet de prise de rendez-vous en ligne, ainsi que la détention et la gestion de tous droits de propriété intel-
lectuelles relatifs à cette plateforme.

Elle a également pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés

luxembourgeoises  ou  étrangères;  l’acquisition  par  voie  d’achat,  d’échange,  de  souscription,  d’apport  et  de  toute  autre
manière,  ainsi  que  l’aliénation  par  voie  de  vente,  d’échange  et  de  toute  autre  manière  de  parts  sociales  et  de  valeurs
mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds, la création, la gestion, la
mise en valeur et la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par
voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la
réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets.

Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d’invention et de perfectionnement, licences, procédés,

marques commerciales et marques de fabrique, dessins, modèles, logiciels informatiques, noms de domaines et plus gé-
néralement tous droits de propriété intellectuelles et en exploiter, en céder et en concéder toutes les licences.

123014

L

U X E M B O U R G

La Société pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participations ou autre manière, dans toute société

ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.

La société a également pour objet l’acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d’immeubles situés tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, accorder des prêts, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution

personnelle et/ou réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles

ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution

de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifi-
cations des statuts.

Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «Simpleet S.à r.l.».

Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Mondercange.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité

de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par
assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d’autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,

ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-) divisé en mille (1.000) parts sociales de soixante

euros (EUR 60,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé

unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune

d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même

personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
En cas d’associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions

énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les associés Julien GRAS et Benjamin DOSOGNE reconnaissent que leur contribution personnelle respective est es-

sentielle au développement de l'application et de la Société dans le court terme et s'interdisent de céder tout ou partie de
leurs participations respectives pendant une durée de 2 (deux) ans à partir de la constitution de la Société sans l'accord écrit
préalable de tous les associés.

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, aucun transfert de parts sociales de la Société ne peut intervenir au profit d'un tiers quel qu'il soit, et
dans tous les cas, ne peut être opposable aux associés, et ce quelle que soit la nature et/ou la cause de ce transfert (y compris,
mais pas uniquement, pour cause de mort ou de dissolution d'une communauté de biens suite à un divorce), en l'absence
d'adhésion préalable du tiers cessionnaire au pacte d’associés.

Dérogations aux règles générales en matière de transfert de parts sociales - transferts libres
Nonobstant l'ensemble des restrictions au transfert de parts sociales prévues par le pacte d’associés, tout associé pourra

librement transférer tout au partie de ses parts sociales à toute entité qu'il contrôle via (i) la détention de la majorité des
droits de vote de ladite entité ou (ii) la détention du droit de nommer ou de désigner une majorité des membres de l'organe
d'administration de ladite entité et dont il est en même temps actionnaire ou associé sous réserve des conditions suivantes:

- L'associé cédant aura l'obligation de notifier aux autres associés le transfert envisagé en indiquant l'identité du ces-

sionnaire et le nombre de parts sociales cédées dans les 15 (quinze) jours ouvrables avant la date prévue pour la réalisation
du transfert;

- Le cessionnaire devra adhérer sans réserve au pacte d’associés.

123015

L

U X E M B O U R G

Droit de préemption des associés
Sauf les exceptions prévues par la loi et sauf les exceptions prévues ci-avant, un associé ne peut céder ses parts sociales

sans les avoir préalablement offertes aux autres associés. Ce processus se fait en une ou en deux étapes selon les modalités
suivantes:

«Right of first offer»
L'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit en aviser le Conseil de Gérance de la Société en

indiquant le nombre des parts sociales qu'il envisage de céder. Dans les 15 (quinze) jours, le Conseil de Gérance transmet
cette offre aux autres associés.

Dans les 30 (trente) jours de cette information par le Conseil de Gérance, les associés doivent faire savoir au Conseil

de Gérance s'ils exercent ou non leur droit de préemption de type «right of first offer», en mentionnant le nombre de parts
sociales qu'ils désirent acquérir et le prix par part sociale qu'ils proposent de payer. L'absence de réponse dans ledit délai
de 30 (trente) jours vaut renonciation au droit de préemption de type «right of first offer».

Si les prix proposés par plusieurs associés acquéreurs intéressés sont différents, le prix le plus élevé est pris en compte

pour la cession éventuelle de toutes lesdites parts sociales et est communiqué endéans les 5 (cinq) jours ouvrables par le
Conseil de Gérance à tous les associés.

L'associé dispose alors d'un délai de 5 (cinq) jours pour informer le Conseil de Gérance et tous les autres associés s'il

accepte ou refuse ce prix.

En cas de refus du prix par l'associé cédant, la procédure décrite ci-dessus est initiée.
En cas d'acceptation du prix par l'associé cédant, les associés intéressés peuvent acquérir les parts sociales offertes à

hauteur de leur participation alors existante respective et au-delà, si certains associés devaient ne pas être intéressés par
cette acquisition ou uniquement pour un nombre de parts sociales inférieur au nombre auquel ils pourraient prétendre
compte tenu de leur participation existante.

«Right of first refusal»
L'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers acquéreur («candidat cessionnaire») doit en aviser

préalablement le Conseil de Gérance de la Société, en indiquant le nombre des parts sociales qu'il envisage de céder, le
prix offert, l'identité du candidat cessionnaire, personne physique ou morale (le nom, le prénom et le domicile s'il s'agit
d'une personne physique, sa dénomination et son siège social s'il s'agit d'une personne morale) ainsi que toutes les autres
conditions de la cession, en justifiant la réalité de l'offre.

Dans les 15 (quinze) jours, le Conseil de Gérance transmet cette offre aux autres associés.
Dans les 30 (trente) jours de cette information par le Conseil de Gérance, les associés doivent faire savoir au Conseil

de Gérance s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre de parts sociales qu'ils désirent acquérir.

L'absence de réponse dans ledit délai de 30 (trente) jours vaut renonciation au droit de préemption de type «right of first

refusal» Les associés peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption (de type «right of first offer» et/ou
a «right of first refusal») par lettre recommandée adressée au Conseil de Gérance dans le même délai.

Ces droits de préemption ne sont pas cessibles.
Les droits de préemption des associés s'exercent sur la totalité de l'offre mais au prorata de leur participation dans le

capital de la Société et sans fractionnement de parts sociales.

Le non-exercice total ou partiel par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres associés qui en font

usage toujours au prorata du nombre de parts sociales dont ces associés sont déjà propriétaires.

Si le nombre de parts sociales pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de parts sociales

offertes, celles-ci sont réparties entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fraction-
nement de parts sociales. Le Conseil de Gérance en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre de parts sociales pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de parts sociales

offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le cédant pourra à son choix:

- soit céder au cessionnaire tiers la totalité des parts sociales offertes nonsouscrites par les autres associés au titre de leur

droit de préemption,

- soit retirer son offre et renoncer à la cession.
En cas d'exercice du droit de préemption de type «right of first refusal», les parts sociales sont acquises au prix offert

et aux conditions identiques proposées par le tiers candidat-cessionnaire.

L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les soixante jours suivant la notification de la préemption, à moins que les

parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dit par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal
majoré de trois points, de plein droit et sans mise en demeure. Le transfert de propriété effectif se fait à la date du paiement
du prix par l'acquéreur.

Obligation de cession forcée des parts sociales («Drag Along»)
Dans l'hypothèse d'une offre de rachat portant sur au moins 75 (soixante-quinze) % des Parts Sociales de la Société, que

des  Associés  représentant  au  moins  75%  du  capital  social  de  la  Société  souhaiteraient  accepter,  ou  en  cas  de  fusion,
absorption, ou toute autre opération portant sur 100% des Parts Sociales de la Société, les associés restant s'engagent à

123016

L

U X E M B O U R G

céder leurs Parts Sociales à l'acquéreur potentiel aux mêmes conditions que celles accordées aux Associés représentant au
moins 75% du capital social et souhaitant accepter l'offre d'achat de l'acquéreur tiers.

Les termes de l'offre susmentionnée devront être notifiés aux associés restants par lettre recommandée avec accusé de

réception, 30 (trente) jours au moins avant la date prévue pour la réalisation, afin de les mettre en demeure d'exécuter leur
obligation de cession de leurs parts sociales.

Cette notification devra préciser la nature de l'opération projetée, le prix retenu dans le cadre de ladite opération, les

conditions de paiement, l'identité précise et l'adresse des acquéreurs et des personnes qui les contrôlent si nécessaire ainsi
que toute autre condition ou modalité importante de la transaction.

Droit de sortie conjointe des associés («Tag Along»)
Dans l'hypothèse où des associés représentant au moins 75 (soixante-quinze) % du capital social communiquent leur

intention de vendre ensemble ou séparément tout ou partie de leurs parts sociales à une tierce partie, les associés représentant
le restant du capital social aura un droit de vente sur tout ou partie de leurs parts sociales selon les mêmes termes et conditions
que celles des associés représentant au moins 75% du capital social et souhaitant vendre.

Le projet de cession à une tierce partie devra être notifié à l'ensemble des associés, par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception, 30 (trente) jours au moins avant la date prévue pour la réalisation.

Cette notification devra préciser la nature de l'opération projetée, le nombre de titres concernés par celle-ci, leur prix ou

leur valeur, telle que retenue dans le cadre de ladite opération, les conditions de paiement, l'identité précise et l'adresse des
bénéficiaires de celle-ci et des personnes qui les contrôlent si nécessaire ainsi que toute autre condition ou modalité im-
portante de la transaction.

Les associés restants auront à compter de la réception de cette notification un délai de 15 (quinze) jours pour répondre

sur leur intention de vendre ou non à la tierce partie tout ou partie de ses parts sociales selon les mêmes termes et conditions
que celles des associés ayant reçu l'offre de la partie tierce

Par conséquent, les associés notifiant la vente ne pourront être admis à céder leurs parts sociales à la partie tierce que

si les associés restants (i) ne souhaitent pas vendre leurs parts sociales dans les conditions prévues dans cet article ou (ii)
souhaitent vendre à la partie tierce celle-ci acceptant ladite acquisition aux conditions prévues dans cet article.

Application du pacte d’associés
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, il est convenu que toute cession de parts sociales à un tiers ou souscription de parts sociales par un tiers
devra impérativement être assortie de l'adhésion préalable du cessionnaire ou du souscripteur au pacte d’associés.

Anti-dilution
Chaque partie aura le droit à tout moment de souscrire à toute émission de parts sociales de la Société à hauteur du

pourcentage de la participation qu'elle détient alors dans le capital et les droits de vote de la Société.

Chaque partie renoncera à son droit préférentiel de souscription (le cas échant) pour autant que la souscription au prorata

sera assurée.

Les parties conviennent que les rachats de parts sociales de la Société par la Société en vue de leur annulation devront

faire l'objet d'un accord préalable du Conseil de Gérance statuant à l'unanimité et s'effectuer au prorata de la participation
de chaque associé.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique

de parts sociales.

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir

tous  les  actes  nécessaires  ou  utiles  à  l'accomplissement  de  l'objet  social  de  la  Société,  à  l'exception  de  ceux  qui  sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, la

Société sera engagée par la signature individuelle d’un gérant technique ou par la signature conjointe de deux gérants, dont
obligatoirement celle d’un gérant technique.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par

le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne

peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration.

123017

L

U X E M B O U R G

Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés dont

obligatoirement ceux d’un gérant technique et d’un gérant administratif pour:

- La conclusion, la modification ou la résiliation d’une convention liant directement ou indirectement la Société à un

associé ou à une entité contrôlée par un associé

- L’établissement et l’approbation du budget annuel d’exploitation (bilan, compte de profits et pertes, cash flow) et

d’investissement

- Les décisions d’investissement non budgétées d’un montant dépassant de plus de 10% le budget d’investissement

prévisionnel

- Les souscriptions de financements non budgétés.
Dans les autres matières, les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou

représentés y inclus dans tous les cas le vote du gérant technique.

En cas d’égalité de votes sur une résolution et en vue d’éviter toute situation de blocage, le conseil de gérance devra

tout d’abord obtenir l’avis non contraignant d’un expert désigné à l’unanimité des voix des gérants présents ou représentés
et,  dans  un  second  temps,  dans  le  cas  où  une  telle  unanimité  devait  faire  défaut  ou  l’égalité  de  votes  demeurer  après
l’obtention dudit avis, accorder à la voix de président du conseil de gérance, un caractère prépondérant.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement

passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou
communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de com-

munication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou
par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment,
sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les
questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution
sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins

qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circons-
tances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts

qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,

les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)

associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième lundi du mois de
juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable

suivant.

Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de

Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de

l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

123018

L

U X E M B O U R G

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en

réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et au pacte
d’associés.»

<i>Disposition transitoire:

Par dérogation, le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.

<i>Souscription et libération:

Les mille (1.000) parts sociales, d’une valeur nominale soixante euros (EUR 60.-) chacune, sont intégralement libérées

à concurrence:

1. Linc S.A., pré-qualifiée, représentée par Monsieur Marc NEUEN, et Monsieur Daniel SCHNEIDER, pré-qualifiés;
déclare souscrire 500 parts sociales (500) et de libérer les parts sociales souscrites intégralement moyennant un versement

en espèces à concurrence de la somme de trente mille euros (EUR 30.000.-);

cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

2. Monsieur Julien GRAS, pré-qualifié;
déclare souscrire deux cent cinquante parts sociales (250) et de libérer les parts sociales souscrites partiellement moyen-

nant un versement en espèces à concurrence de la somme de quatre mille euros (EUR 4.000.-), et le solde moyennant apport
en nature telle que décrit ci-après;

deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

3. Monsieur Benjamin DOSOGNE, pré-qualifié;
déclare souscrire deux cent cinquante parts sociales (250) et de libérer les parts sociales souscrites partiellement moyen-

nant un versement en espèces à concurrence de la somme de quatre mille euros (EUR 4.000.-), et le solde moyennant apport
en nature telle que décrit ci-après;

deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Les mille (1.000) parts sociales sont dès lors intégralement libérées à concurrence d’une somme de trente-huit mille

euros (EUR 38.000,-) par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire au moyen d’un certificat
bancaire et à concurrence de vingt-deux mille euros (EUR 22.000,-) par un apport en nature telle que décrit ci-après.

<i>Description de l'apport

L’actif apporté (l’«Apport») est composé comme suit:
-  Une  plate-forme  informatique  sous  la  dénomination  de  Simpleet  (accessible  sous  les  noms  de  domaines:

www.simpleet.lu; www.simpleet.fr; www.simpleet.be au moment du présent acte mais sans préjudice d’autres déclinaisons
futures éventuelles de noms et de noms de domaines), qui constitue une plateforme web de prise de rendez-vous, ainsi que
la propriété intellectuelle y afférente.

L’actif apporté (l’ «apport») est composé comme suit:
1. Monsieur Julien GRAS, pré-qualifie, fait un apport en nature telle que décrit ci-après à concurrence de:
- onze mille euros (EUR 11.000.-);
2. Monsieur Benjamin DOSOGNE, pré-qualifié, fait un apport en nature telle que décrit ci-après à concurrence de:
- onze mille euros (EUR 11.000.-),
(ci-après les «Souscripteurs»).
L’apport en nature représente un montant total de vingt-deux mille euros (EUR 22.000,-).

<i>Preuve de l’existence de l’apport

La preuve par les souscripteurs de la propriété de l’apport a été rapportée au notaire soussigné moyennant contrat d’apport

signé par les associés et souscripteurs.

Les souscripteurs ont déclaré encore que l’apport est libre de tout privilège ou gage ou charge et qu'il ne subsiste aucune

restriction au libre transfert de l’apport à la société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes
notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’apport à la société.

<i>Evaluation

Les souscripteurs ont déclaré encore qu'un rapport d’évaluation a été établi en date du 27/07/2015 par la Société Fidu-

ciaire Cabexco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, sous les signatures de Monsieur Paolo CREA et Monsieur
Oliver MURRU, ayant son siège social à L-8399 Windhof, 2, rue d’Arlon, dans lequel l’apport est décrit et évalué (le
«rapport»).

Les conclusions du rapport sont les suivantes:

123019

L

U X E M B O U R G

«Nous confirmons que l’apport en nature de la plate-forme informatique «Simpleet» en vue de la constitution de la

société Simpleet S.à r.l. peut être évalué à un montant de vingt-deux mille euros (22.000,00 EUR) correspondant au moins
à la valeur des parts émises en contrepartie de cet apport en nature.

Cet apport est fait pour moitié, soit pour une contre-valeur de onze mille euros (11.000,00 EUR) par Monsieur Julien

GRAS et pour l’autre moitié, soit une contre-valeur de onze mille euros (11.000,00 EUR) par Monsieur Benjamin DO-
SOGNE.»

Le rapport d’évaluation restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille trois cents euros (EUR
1.300.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-qualifiés, représentants l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment con-

voqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à quatre (4).
2.- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Marc NEUEN, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 16 mai 1972, demeurant à L-4391 Pontpierre,

29, rue de Luxembourg.

3.- Sont nommés gérants administratifs pour une durée indéterminée:
- Monsieur Julien GRAS, informaticien, né à Mons (Belgique), le 29 septembre 1982, demeurant à B-6782 Bébange,

36, rue de Panorama; et

- Monsieur Benjamin DOSOGNE, informaticien, né à Namur (Belgique), le 7 juillet 1984, demeurant à B-6700 Arlon,

85, avenue de la Gare;

- Monsieur Philippe BOYER, employé privé, né à Saint-Lô (France), le 13 avril 1979, demeurant à F-57365 Ennery,

10, rue des Jardins.

4.- L’adresse du siège social de la société est fixée à L-4391 Pontpierre, 55, rue de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les parties comparantes au fait qu’avant toute activité commerciale de la société,

celles-ci doivent être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l’objet social
tel que modifié ci-dessus, ce qui est expressément reconnu par les parties comparantes.

DONT ACTE, fait et passé à Windhof, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. NEUEN, D. SCHNEIDER, J. GRAS, B. DOSOGNE, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12730. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 03 août 2015.

Référence de publication: 2015133267/354.
(150143626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

TA EU Acquisitions III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.212.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 161.383.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015126827/10.
(150138317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

123020

L

U X E M B O U R G

DSK Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8311 Capellen, 92, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 40.371.

L'an deux mille quinze, le premier juillet,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «DSK SYSTEMS S.A.», une société anonyme de

droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.371, constituée suivant acte notarié en date du 13 mai 1992, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 10 octobre 1992, numéro 455.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 26 janvier 2006, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 13 mai 2006, numéro 943.

L'assemblée est ouverte à 15.20 heures sous la présidence de Monsieur Charles Krombach, ingénieur, demeurant au

131, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Rita Meyer épouse Krombach, licenciée en biologie, demeurant au 131, rue des

Aubépines, L-1145 Luxembourg

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Krombach, ingénieur, demeurant au 8, rue du Parc, L-8031

Strassen.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société vers L-8311 Capellen, 92, route d'Arlon;
2. Suppression du droit de préemption et par conséquent suppression des cinq derniers paragraphes de l'article 5 des

statuts de la société;

3. Modification de l'article 16 des statuts de la société;
4. Modification de l'article 11 des statuts relatif aux pouvoirs de signature.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers L-8311 Capellen, 92, route d'Arlon et par

conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société, afin de lui donner désormais la teneur
suivante:

« Art. 2. Siège. (premier alinéa). Le siège social est établi à Capellen.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le droit de préemption et par conséquent de supprimer les cinq derniers

paragraphes de l'article 5 des statuts de la société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 16 des statuts de la société, afin de lui donner désormais la teneur

suivante:

« Art. 16. Année Sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque

année.»

123021

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts de la société, afin de lui donner désormais la teneur

suivante:

« Art. 11. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs. Toutefois,

chaque administrateur délégué peut engager la Société sous sa seule signature à hauteur de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-).»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: C. KROMBACH, R. MEYER-KROMBACH, T. KROMBACH et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 3 juillet 2015. 1LAC/2015/20705. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015131624/70.
(150142101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2015.

Rock Ridge RE 15, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.248.

In the year two thousand and fifteen, on twenty-eighth day of the month of July.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of shareholders of Rock Ridge RE 15 S.à r.l. (the “Company”), a

société à responsabilité limitée, established under the laws of Luxembourg, having its registered office in 22, Grand-Rue,
L-1660 Luxembourg and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 129.248,
incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on 23 May 2007, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of 8 August 2007, number C-1676. The articles of association
of the Company. The articles of association of the Company have not yet been amended.

The Meeting was presided over by Joost Mees, private employee, professionally residing in 48, Boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Nathalie Chevalier, private employee, professionally residing in 48,

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list, signed

by the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. This list and the proxies signed ne varietur will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. All shareholders represented have declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the Meeting and

waived their rights to any prior convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items on the agenda.

III. It appears from the attendance list that all the five hundred (500) Shares in issue are represented at the Meeting so

that the Meeting is duly constituted, is quorate and may validly deliberate on the agenda set out below:

1) Decision on the liquidation of the Company;
2) Appointment of Exequtive Services S.à r.l. as liquidator and determination of the powers of the liquidator;
3) Miscellaneous.
After the foregoing has been approved the Meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolved to dissolve and to put the Company into liquidation.

123022

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Meeting resolved to appoint Exequtive Services S.à r.l.., a société à responsabilité limitée, with registered office in

48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, and registered with Register of Trade and Companies of
Luxembourg under number B 196.987 as liquidator.

The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial

companies (as amended), are granted to the liquidator by the Meeting. The Meeting resolved to authorise the liquidator in
advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation
from the Meeting if such authorisation is required by law.

The Meeting resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and the liquidator may refer to the books

of the Company. The liquidator may delegate, under his responsibility, all or part of his powers to one or more proxies with
respect to specific acts or deeds.

The Meeting resolved that the liquidator may bind the Company under his sole signature.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges are borne by the Company as a result of the present deed.
There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this

deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of inconsistencies
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the Members of the Bureau, who are known to the undersigned notary by their

surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale des associés (l’«Assemblée») de Rock Ridge RE 15 S.à r.l. (la "Société"), une société à res-

ponsabilité limitée ayant son siège social 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.248 constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg en date du 23 mai 2007 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), du 8
août 2007 numéro C-1676. Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés.

L’Assemblée a désigné Joost Mees, employé privé, demeurant professionnellement à 48, Boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1330 Luxembourg, comme président.

Nathalie  Chevalier,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  48,  Boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,

L-1330 Luxembourg a été nommée secrétaire et scrutateur.

Le président a déclaré et requis le notaire d’acter:
I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sont renseignés sur une liste de présence signée par le président,

le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné et les procurations signées ne varietur par les parties comparantes resteront
annexées au présent document pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

II. Tous les associés représentés ont déclaré avoir été préalablement suffisamment informés de l’ordre du jour de l’as-

semble générale et ont renoncé à leurs droits à un avis de convocation y relatif, de sorte que l’assemblée générale peut se
prononcer valablement sur tous les points inscrits à l’ordre du jour.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les cinq cent (500) parts sociales sont représentées et que la présente

assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour fixé ci-dessous:

1) Décision concernant la liquidation de la Société;
2) Nomination de Exequtive Services S.à r.l.. comme liquidateur et fixation des pouvoirs du liquidateur;
3) Divers
Ayant approuvé ce qui précède, l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée a décidé de nommer Exequtive Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à

48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.987 en tant que liquidateur.

123023

L

U X E M B O U R G

L’Assemblée a décidé de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles

144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).

L’Assemblée a décidé d’autoriser par avance le liquidateur à signer les actes et conclure les contrats prévus à l’article

145 de la même loi sans devoir recourir à l’autorisation spéciale de l’Assemblée dans le cas où celle-ci est requise par la
loi.

L’Assemblée a décidé de dispenser le liquidateur de dresser un inventaire et le liquidateur peut se référer aux écritures

de la Société. Le liquidateur peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs manda-
taires pour des actes ou contrats spécifiques.

L’Assemblée a décidé que le liquidateur pourra engager la Société sous sa seule signature.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature sont payables par la Société en raison du présent acte.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande des parties comparantes, le présent a

été rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, la version
anglaise fera foi en cas de divergences entre les textes français et anglais.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux Membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: J. MEES, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12733. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 03 août 2015.

Référence de publication: 2015133246/112.
(150143544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

Soudoplast S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 146.719.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126789/9.
(150138674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

SPCGE, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 42.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 160.305.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126793/9.
(150138437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Société Immobilière Fraenzebach II S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon, Belle Etoile.

R.C.S. Luxembourg B 80.552.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015126778/10.
(150138207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

123024


Document Outline

Caelum Holding S.A.

Coral Portfolio S.C.A. SICAV-SIF

DSK Systems S.A.

GEOPF Langenfeld G.P. S.à r.l.

GM Investissement S.à r.l.

IPone

Jalyne S.A.

JM Topert Mondial S.A.

Landforse I SCA

Lee Cooper Group S.à r.l.

Madison Trianon S.à.r.l.

Merion Finance

Public Safety Luxembourg, S.à r.l.

Quilvest AM S.A.

Raphael Magic Inc.S.A.

Rapides International S.A.

Rarecars Sàrl

Rasini SICAV

RDA Holding

Real Constructions Sàrl

REI

Reka S.A.

RINNEN Constructions Générales S.àr.l.

Rock Ridge RE 15

Romafi S.A.

Romains S.A.

Roné S.à r.l.

Simpleet S.à r.l.

Six Continents Development

Smalland Sàrl

Société Immobilière Fraenzebach II S.A.

Sofrane Business S.à r.l.

Sophronia S.à r.l.

Sotogrande LuxCo S.à r.l.

Soudoplast S.à r.l.

SPCGE

Square Churchill 5

Stenfalken S.à r.l.

Sulfuron Holding S.à r.l.

TA EU Acquisitions III S.à r.l.

TA EU Acquisitions II S.à r.l.

TFP Royal S.à r.l.

Thorenc PV Holding S.à r.l.

Towers Investments S.à r.l.

Trans Real Estate Development S.à r.l.

Tricel S.A.