This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2494
15 septembre 2015
SOMMAIRE
Agence Générale Deckenbrunnen Sàrl . . . . . .
119669
Aries Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
119666
Aries Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
119667
Aries Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
119668
A.T.S. LU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119666
Benelux Mezzanine 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
119666
Brif Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119667
Brif Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119667
Brif Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119668
Brif Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119668
Caulus Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
119666
Caulus Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
119667
Caulus Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
119669
Eltec Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119691
Goodhart Partners Longitude Fund Sicav-SIF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119691
Halcor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119670
Hathor Participations SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
119671
Health Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
119671
Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119666
Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119667
Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119669
Highwind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119672
Holgoun International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
119675
Hubs S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119670
Ifore SICAV-SIF S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119678
Igorance Les Créateurs S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
119705
Igorance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119673
Immobilix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119672
Implex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119671
Information Technology for Translational Me-
dicine (ITTM) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119670
International Strategic Advisory S. à r. l. . . . .
119670
Invenergy Clean Power Mexico S.à r.l. . . . . . .
119672
IVG Luxembourg S.à r.l. International Institu-
tional Fund SCA SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . .
119672
Kléber Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . . . .
119668
Mazarine 60 SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119690
Panthera/Funding Lux 1 S. à r.l. . . . . . . . . . . .
119668
Phimac Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119673
Platinium Advisory Services Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119673
Real Estate Property Management . . . . . . . . .
119673
Sagoma Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
119669
Soins de Jardin Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119712
Somaf Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119712
Sycomore Fund Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119677
Sycomore Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119675
Thunderbolt Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
119706
Tyson Global Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
119708
Ufilug S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119674
United Investors Synergy . . . . . . . . . . . . . . . . .
119677
United Investors Synergy . . . . . . . . . . . . . . . . .
119675
119665
L
U X E M B O U R G
Aries Invest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.206.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015079029/9.
(150091643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
A.T.S. LU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8476 Steinfort, 2A, rue de Steinfort.
R.C.S. Luxembourg B 166.318.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015078988/10.
(150091446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Benelux Mezzanine 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 254.050,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 111.941.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2015.
Référence de publication: 2015079125/10.
(150091497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Caulus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 147.443.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2015.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015079193/11.
(150090400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 88.847.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14
août 2002 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 596 du 22 octobre 2002.
Les comptes au 31 octobre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2015.
<i>Pour Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l.
i>Liudmila Gorodnikova
Référence de publication: 2015079474/14.
(150091478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
119666
L
U X E M B O U R G
Aries Invest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.206.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015079030/9.
(150091644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Brif Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 113.694.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BRIF MANAGEMENT S.A.
Référence de publication: 2015079176/10.
(150091535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Brif Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 113.694.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BRIF MANAGEMENT S.A.
Référence de publication: 2015079177/10.
(150091558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Caulus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 147.443.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2015.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015079194/11.
(150090406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 88.847.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14
août 2002 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 596 du 22 octobre 2002.
Les comptes au 31 octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2015.
<i>Pour Hewlett-Packard Luxembourg Enterpises S.à. r.l.
i>Liudmila Gorodnikova
Référence de publication: 2015079475/14.
(150091479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
119667
L
U X E M B O U R G
Aries Invest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 155.206.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015079031/9.
(150091645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Brif Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 113.694.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BRIF MANAGEMENT S.A.
Référence de publication: 2015079178/10.
(150091560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Brif Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 113.694.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BRIF MANAGEMENT S.A.
Référence de publication: 2015079179/10.
(150091566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Panthera/Funding Lux 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 140.296.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015126641/12.
(150138441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
Kléber Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 129.391.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II, 38
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015126368/13.
(150137685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
119668
L
U X E M B O U R G
Agence Générale Deckenbrunnen Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9010 Ettelbruck, 3, rue de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 153.548.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015079062/9.
(150091472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Caulus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 147.443.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2015.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015079195/11.
(150090469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 88.847.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14
août 2002 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 596 du 22 octobre 2002.
Les comptes au 31 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2015.
<i>Pour Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à. r.l.
i>Liudmila Gorodnikova
Référence de publication: 2015079476/14.
(150091480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Sagoma Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 162.825.
<i>Extrait des résolutions des associés de la Sociétéi>
Il résulte de la décision prise par les associés de la Société en date du 30 Juin 2015 qu'a été acceptée:
- la nomination de Mme Donna McCrorie, née le 02 Juin 1971 à Jersey, résidant professionnellement à Elizabeth House,
9 Castle Street, JE2 3RT Jersey, en tant que gérant de la Société avec effet au 30 Juin 2015;
- la démission de Mme Saffron Harrop en tant que gérant de la Société;
- le changement d'adresse du siège social de la Société qui se situe désormais au 68-70 Boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg;
- le changement d'adresse des gérants de la Société, Mme Miranda Lansdowne et Mme Pamela Valasuo, qui désormais,
résident professionnellement au 68-70 Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2015.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015126714/20.
(150138643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
119669
L
U X E M B O U R G
International Strategic Advisory S. à r. l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 138.010.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015079522/10.
(150091590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Information Technology for Translational Medicine (ITTM) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, rue des Hauts-Fourneaux.
R.C.S. Luxembourg B 179.199.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2015.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2015079518/13.
(150091624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Hubs S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3313 Bergem, 73, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 143.813.
<i>Extrait de l'Assemblée générale des associés tenue à Bergem le 13 juillet 2015i>
1) Monsieur Stephan BÖHMIG, souhaite vendre les 10 parts sociales qu'il détient dans la société HUBS S.à r.l.
2) Madame Françoise DI BETTA, exprime sa volonté d'acquérir les 10 parts sociales de Monsieur Stephan BÖHMIG.
Après cette résolution, les parts sociales de la société sont détenues comme suit:
Madame Françoise DI BETTA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015127434/15.
(150137077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Halcor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 105.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.130.
La Société constate le changement d’adresse de l’associé Fonsicar S.A. Sicar avec effet au 15 juin 2015. L’associé siège
désormais au 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
La Société prend également note du changement de résidence de Monsieur Alberto Berdusco gérant de la Société.
Monsieur Alberto Berdusco réside depuis le 05.05.2015 au 20, rue Charles Bernhoeft, L-1240 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HALCOR S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Signatures
Référence de publication: 2015127416/16.
(150136939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.
119670
L
U X E M B O U R G
Implex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 81.509.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 14 juillet 2015i>
Il résulte du jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
Chambre, siégeant en matière com-
merciale que les opérations de liquidation de la société IMPLEX S.à r.l. (jugement n°844/15), avec siège social à L-2444
Luxembourg, 14, Rue des Romains, de fait inconnue à cette adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 81.509 ont été déclarées closes pour absence d’actif.
Luxembourg, le 15 juillet 2015.
Pour extrait conforme
Me Gilles BOILEAU
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015127457/17.
(150136281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Hathor Participations SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 140.133.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société tenue de manière exceptionnellei>
<i>le 30 juin 2015i>
<i>Quatrième résolutioni>
Approbation de la nomination d’un nouveau Réviseur d’Entreprises.
L'Assemblée Générale décide de nommer Ernst & Young, demeurant au 7 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach,
et portant le n° RCS Luxembourg B 47.771, aux fonctions de Réviseur d’Entreprises de la société pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 2015. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale de 2016 approuvant
les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2015.
HATHOR PARTICIPATIONS S.A.
Référence de publication: 2015127421/18.
(150136585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Health Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 88.704.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 22 juillet 2015i>
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration tenu en date du 22 juillet 2015, que:
Après avoir constaté que Monsieur Nicolas Mille s'est démis de ses fonctions d'administrateur en date du 1
er
juillet
2015, les administrateurs restants décident, conformément à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, de coopter Monsieur Jérémy Lequeux, employé privé, né le 17 juillet 1981 à Virton (Belgique), résidant
professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, comme administrateur de la Société, avec effet au
1
er
juillet 2015, en remplacement de Monsieur Nicolas Mille, administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HEALTH MANAGEMENT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015127423/19.
(150136421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.
119671
L
U X E M B O U R G
Highwind, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 179.343.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015127426/9.
(150136391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Immobilix S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 151.207.
<i>Document rectificatif du dépôt initial au RCS, remplaçant la 1 i>
<i>èrei>
<i> version déposée sous le numéro L150133414i>
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015127454/11.
(150137800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.
IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund SCA SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions
sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 174.707.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, établis en Euros, ainsi que les autres documents et informations qui s'y
rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Référence de publication: 2015127475/12.
(150136794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Invenergy Clean Power Mexico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: MXN 230.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 180.686.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 21 juillet 2015i>
En date du 21 juillet 2015, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
- D’accepter les démissions de Madame Mounira MEZIADI, de Monsieur Tobias STEMMLER et de Monsieur Tamas
MARK, de leur mandat de gérant de classe B avec effet au 3 juillet 2015.
- De nommer Monsieur François-Xavier GOOSSENS, né le 8 mai 1976 à Bruxelles (Belgique), résidant au 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Monsieur Michael VERHULST né le 25 août 1969, à Almelo (Pays-Bas), résidant au 6,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée
au RCS Luxembourg sous le numéro B 103336 en tant que gérants de classe B avec effet au 3 juillet 2015. Leur mandat
aura une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2015.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015127449/22.
(150136919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.
119672
L
U X E M B O U R G
Platinium Advisory Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 127.972.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126677/9.
(150138359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
Igorance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7217 Bereldange, 71, rue de Bridel.
R.C.S. Luxembourg B 82.162.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PINHEIRO Samantha.
Référence de publication: 2015079537/10.
(150091431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Real Estate Property Management, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 164.097.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique à Luxembourg le 14 juillet 2015i>
Acceptation de la démission de la société Fiduciary Tucci & Partners SA de son mandat de Commissaire aux Comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2015.
<i>L'administrateur uniquei>
Référence de publication: 2015126694/12.
(150137662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
Phimac Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 118.630.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 30 juin 2015:i>
- acceptation de la démission de Monsieur Ingor Meuleman de son poste d'administrateur, avec effet au 09 juin 2015;
- nomination de Madame Catherine Zoller, administrateur de société, née à Arlon (Belgique) le 08 avril 1967, résidant
professionnellement 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société pour une
période de 6 ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2020;
- nomination de Madame Stéphanie Marion, administrateur de société, née à Thionville (France) le 08 octobre 1978,
résidant professionnellement 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société pour
une période de 6 ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2020;
- transfert du siège social de la société au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg;
- changement d'adresse professionnelle des autres administrateurs, Monsieur Marc Schintgen et Monsieur Michal Witt-
mann au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg et reconduction de leurs mandats pour une période de 6 ans prenant
fin à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2020;
- transfert du siège social du commissaire aux comptes, la société Alpha Expert S.A. au 76, route de Thionville L-2610
Luxembourg et reconduction de son mandat pour une période de 6 ans prenant fin à la date de la tenue de l'assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015126670/23.
(150138012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.
119673
L
U X E M B O U R G
Ufilug S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 143.632.
L’an deux mille quinze, le vingtième jour de juillet.
Par-devant nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés (l’Assemblée) d’Ufilug S.A., une société anonyme constituée et
régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social à 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.632, constituée suivant
acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 102 en date du 16 janvier 2009 (la Société).
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 23 juillet 2009, suivant un acte par-devant le notaire soussigné, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nº 1747 du 10 septembre 2009 (la «Société»)
L’Assemblée est présidée par Madame Rachida El Farhane, salariée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président nomme Madame Emilie Cartier, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg comme secrétaire.
L’Assemblée choisit Monsieur Mustafa Nezar, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg comme scrutateur.
(Le président, le secrétaire et le scrutateur sont collectivement définis comme le Bureau de l’Assemblée).
Le Bureau de l’Assemblée ayant été constitué, le président déclare que:
I. L’associé unique de la Société (l’Associé) représenté et le nombre d’actions qu'il détient sont indiqués sur une liste
de présence. Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l’Associé, après avoir été signées ne varietur par les
personnes comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte.
II. Il apparaît de la liste de présence que les mille quatre cent six (1.406) actions, représentant l’intégralité du capital
social de la Société sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que l’Assemblée peut valablement décider sur tous
les points portés à l’ordre du jour et dont les participants ont été préalablement informés.
III. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel d’un million quatre cent six mille euros (EUR
1.406.000,-) représenté par mille quatre cent six (1.406) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune, jusqu'à celui de vingt-et-un millions quatre cent six mille euros (EUR 21.406.000,-), par l’émission de vingt mille
(20.000) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.
2. Modification de l’article 5 alinéa premier des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation du
capital social adoptée sous le point 1;
3. Divers.
Après que chaque point de l’agenda ait dûment été examiné et après délibération, l’Assemblée adopte à l’unanimité et
requiert le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de vingt millions d’euros (EUR
20.000.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million quatre cent six mille euros (EUR 1.406.000,-) à un montant
de vingt-et-un millions quatre cent six mille euros (EUR 21.406.000,-) et d’émettre, à cet effet, vingt mille (20.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Les vingt-mille (20.000) nouvelles actions ont été souscrites par l’Associé, pour le prix de vingt millions d’euros (EUR
20.000.000,-).
Les actions ainsi souscrites ont été intégralement payées par un apport en numéraire de telle manière que le montant de
vingt millions d’euros (EUR 20.000.000,-) est maintenant à la disposition de la Société ainsi qu'il l’a été justifié au notaire
soussigné.
L’apport global d’un montant de 20 millions d’euros (EUR 20.000.000) est entièrement affecté au capital social.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver la modification de l’article 5 alinéa premier des Statuts afin de refléter l’augmentation
du capital social conformément à la résolution précédente, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. alinéa 1
er
. Le capital social souscrit de la Société est fixé à vingt-et-un millions quatre cent six mille euros
(EUR 21.406.000,-) représenté par vingt-et-un mille quatre cent six (21.406) actions d’une valeur nominale de mille euros
(EUR 1.000,-) chacune.»
119674
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent
acte sont évalués à environ sept mille euros (EUR 7.000,-).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état et demeure,
ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: El Farhane, Cartier, Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/22962. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Référence de publication: 2015127936/68.
(150136435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Holgoun International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.478.
Les comptes annuels en date du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015079500/10.
(150091406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Sycomore Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. United Investors Synergy).
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 166.946.
In the year two thousand fifteen, on the twenty-eighth of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There was held
an extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) of United Investors Synyergy (the”Company”), an
investment company with variable capital (société d’investissement à capital variable) under the form of a public limited
liability company (société anonyme) with registered office at 33, rue de Gasperich, L-5829 Hesperange, incorporated under
the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary dated February 13, 2012, published in the Mémorial
C, number 593 of March 7, 2012, registered with the Luxembourg trade and company register (Register de Commerce et
des Sociétés) under B 166946.
The Meeting is opened at under the chair of Aline Biej, employee, residing professionally in Hesperange.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Nathalie Finet, employee, residing profes-
sionally in Hesperange.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
A. All the shares being registered shares, the present meeting has been convened by notices containing the agenda sent
to all the shareholders by registered mail on July 15, 2015.
B. The agenda of the Meeting is the following:
1. Amendment of the Articles of Association:
1.1 Replacing Article 1 to amend the name of the Company from “United Investors Synergy” to “SYCOMORE SICAV”,
as follows:
An Investment Company with Variable Capital (SICAV) is established pursuant to the Luxembourg law of 17 December
2010 relating to Undertakings for collective investment (the “2010 Law”). This SICAV shall have the corporate name
“SYCOMORE SICAV”
1.2 Replacing the first sentence of Article 4 to amend the registered office of the Company, as follows:
The registered office is established in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.
119675
L
U X E M B O U R G
As from the 1
st
January 2016, the registered office will be established in Luxembourg. The registered office may be
transferred to any other commune in the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the extraordinary general meeting
of the shareholders.
1.3 Replacing the second paragraph of Article 14 as follows:
The Annual General Meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company or at any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg that shall be stipulated in the convocation, the fourth Thursday in March at
11.am.. In the event that this day is a public holiday or a bank holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting shall
be held the first subsequent day that banks are open. The Annual General Meeting may be held abroad if the Board of
Directors states without appeal that exceptional circumstances require such a move.
1.4 Amending the seventh paragraph of Article 14 as follows:
Any share of any sub-fund, category or class, whatever its value, provides the right to a single vote.
Every shareholder may take part in General Meetings of Shareholders appointing another person in writing as proxy or
by telefax message or any other electronic means capable of evidencing such proxy, who cannot themselves be a share-
holder. Such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders’ meeting.
2. Change of the registered office of the Company to 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
3. Miscellaneous.
C. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance list; this attendance list and the proxies of the represented shareholders, being signed by the
shareholders, the board of the Meeting and by the public notary, will remain annexed to the present deed;
D. It appears from the attendance list that out of the 35,096 issued shares representing the whole share capital of the
Company, 20,015 shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting may validly
deliberate on all the items of the agenda.
After deliberation the meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to replace Article 1 to amend the name of the Company from “United Investors Synergy” to
“SYCOMORE SICAV”, as follows:
«An Investment Company with Variable Capital (SICAV) is established pursuant to the Luxembourg law of 17 De-
cember 2010 relating to Undertakings for collective investment (the “2010 Law”). This SICAV shall have the corporate
name “SYCOMORE SICAV”.»
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to replace the first sentence of Article 4 to amend the registered office of the Company, as follows:
„The registered office is established in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg. As from the 1
st
January 2016, the
registered office will be established in Luxembourg. The registered office may be transferred to any other commune in the
Grand Duchy of Luxembourg by decision of the extraordinary general meeting of the shareholders.“
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to replace the second paragraph of Article 14 as follows:
“The Annual General Meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company or at any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg that shall be stipulated in the convocation, the fourth Thursday in March at
11.am..
In the event that this day is a public holiday or a bank holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting shall be
held the first subsequent day that banks are open.
The Annual General Meeting may be held abroad if the Board of Directors states without appeal that exceptional
circumstances require such a move.“
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to amend the seventh paragraph of Article 14 as follows:
«Any share of any sub-fund, category or class, whatever its value, provides the right to a single vote.
Every shareholder may take part in General Meetings of Shareholders appointing another person in writing as proxy or
by telefax message or any other electronic means capable of evidencing such proxy, who cannot themselves be a share-
holder. Such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders’ meeting.»
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to change of the registered office of the Company to 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
with effect as from 1
st
January 2016.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
119676
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English.
The document having been read to the members of the bureau of the meeting, known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.
Signé: A. BIEJ, N. FINET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/23986. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 26 août 2015.
Référence de publication: 2015145137/94.
(150158071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.
Sycomore Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. United Investors Synergy).
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 166.946.
RECTIFICATIF
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth of August.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1) Aline Biej, employee, residing professionally in Hesperange.
2) Nathalie Finet, employee, residing professionally in Hesperange.
The appearing persons acted as Chairman, Secretary, Scrutineer and proxyholder of the shareholders at the extraordinary
general meeting of shareholders held before the undersigned notary on the 28
th
July 2015 (the "Meeting") of United
Investors Synyergy (the”Company”), an investment company with variable capital (société d’investissement à capital
variable) under the form of a public limited liability company (société anonyme) with registered office at 33, rue de
Gasperich, L-5826 Hesperange, incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary
dated February 13, 2012, published in the Mémorial C, number 593 of March 7, 2012, registered with the Luxembourg
trade and company register (Register de Commerce et des Sociétés) under B 166946.
The appearing persons request the notary to state that the extraordinary general meeting of July 28
th
, 2015 has decided
to change the name of the Company into SYCOMORE SICAV. The appearing parties hereby declare to rectify the name
and to change it into SYCOMORE FUND SICAV with effect on July 28, 2015.
Therefore the appearing parties declare to rectify the first resolution of the extraordinary general meeting of July 28
th
, 2015 as follows:
<i>“First resolutioni>
The meeting resolves to replace Article 1 to amend the name of the Company from “United Investors Synergy” to
“SYCOMORE FUND SICAV”, as follows:
«An Investment Company with Variable Capital (SICAV) is established pursuant to the Luxembourg law of 17 De-
cember 2010 relating to Undertakings for collective investment (the “2010 Law”). This SICAV shall have the corporate
name “SYCOMORE FUND SICAV”.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons the present deed is only worded in English.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the present deed.
This deed having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names,
civil status and residence, the said persons appearing, signed together with us, the notary, the present deed.
Signé: A. BIEJ, N. FINET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 21 août 2015. Relation: 1LAC/2015/26819. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 26 août 2015.
Référence de publication: 2015145136/41.
(150158071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.
119677
L
U X E M B O U R G
Ifore SICAV-SIF S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 199.829.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the fourth day of the month of September.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The public limited liability company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg IFORE General Partner
S.à r.l., having its registered office at 20 boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxem-
bourg), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under number 199531,
here represented by Me Sze-Suen LI, Avocat, having his professional address at 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such
proxy, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
Such proxy holder, acting in the name and on behalf of the founding shareholder, has requested the notary to state the
articles of incorporation (the "Articles") of a société en commandite par actions (S.C.A.) with variable capital, qualifying
as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (SICAV-SIF) as follows:
Art. 1. Name. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares of
IFORE SICAV-SIF S.C.A. (the "Company"), a Luxembourg company under the form of a "société en commandite par
actions", qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (SICAV-SIF) subject
to the law of 13 February 2007, as amended (the "SIF Law") relating to specialized investment funds ("SIF"). The Company
is an Alternative Investment Fund within the meaning of the law of 12
th
July 2013 on alternative investment fund managers
(the "AIFM Law") and is registered as an Alternative Investment Fund falling under the exemption provided by Article
3.2(a) of the AIFM Law. The Company shall be governed by the SIF Law, the AIFM Law and the law of August 10, 1915
on Commercial Companies (the "Law of 1915").
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
The general partner of the Company (the "General Partner") is authorized to transfer the registered office of the Company
within the City of Luxembourg by taking the appropriate resolution. Branches, subsidiaries or other offices may be esta-
blished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the General Partner.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company deliberating in the manner required for the amend-
ments to the Articles.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
or interfere with the normal activity at the registered office of the Company or with the ease of communication between
such office and abroad, the registered office of the Company may be, by decision of the General Partner, temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have any effect
on the Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Lu-
xembourg Company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time. It may be dissolved by a decision of the
general meeting of its shareholders deliberating in the manner required for the amendments to the Articles.
Art. 4. Object. The purpose of the Company is to invest the funds raised from its investors in a pool of assets with the
aim of spreading the investment risks and providing to its Shareholders the results of management of its portfolio within
the widest meaning as permitted under the SIF Law, while reducing investment risk through diversification.
The Company is an umbrella fund and as such provides investors with the choice of investment in a range of several
separate Sub-Funds each of which relates to a separate portfolio of assets permitted by the SIF Law with specific investment
objectives, as described in the relevant Appendix to the Offering Document.
A separate portfolio of assets is maintained for each Sub-Fund and is invested in accordance with the investment objective
and policy applicable to that Sub-Fund as further described in the relevant Appendix.
The Company may take all measures and perform all operations which it shall judge to be expedient in terms of achieving
or furthering its object in the broadest sense within the framework of the SIF Law.
Art. 5. Share capital, Compartments, Classes of shares
Share capital
119678
L
U X E M B O U R G
The share capital of the Company shall be represented by shares (the "Shares") of no par value and shall at any time be
equal to the total net assets of the Company. The minimum capital of the Company, which must be reached within twelve
(12) months as from the date on which the Company has been authorized as a société d'investissement à capital variable-
fonds d'investissement spécialisé (SICAV-SIF) under Luxembourg law, is one million two hundred fifty thousand Euros
(EUR 1,250,000.-).
The share capital of the Company shall be represented by the following classes of Shares (the Classes or individually a
Class) of no par value:
- one (1) management share (the “Management Share”), which shall be reserved to the General Partner, as unlimited
shareholder (actionnaire gérant commandité) of the Company and which gives its holder the right to receive a remuneration
in accordance with the provisions of the Issuing Document), and
- the ordinary shares (the "Ordinary Shares") which shall be subscribed by limited shareholders (actionnaires comman-
ditaires), i.e., any shareholder and, as the case may be, the General Partner.
The initial capital is thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into one (1) Management Share and into thirty
thousand nine hundred ninety-nine (30,999.-) Ordinary Share(s) of no par value.
For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each class of shares shall,
if not expressed in EUR, be converted into EUR and the share capital shall be the total of the net assets of all the classes
of shares.
The Company may have one or several Shareholders.
Compartments
The General Partner may establish several portfolios of assets, each constituting a compartment of the Company (each
a “Compartment” or “Compartments”) within the meaning of Article 71 of the SIF Law.
Within each Compartment, the Shares to be issued pursuant to Article 10, as the General Partner shall determine, be of
different classes (each a “Class” or “Class of Shares”). The proceeds of the issue of each Class of Shares shall be invested
pursuant to the investment policy determined by the General Partner for the Compartment established in respect of the
relevant Class or Classes of Shares, subject to the investment restrictions and eligibility of assets provided by the SIF Law
and Luxembourg applicable Grand-Ducal Decree and regulations and as determined by the General Partner. The features
of the classes of shares offered are detailed in the Issuing Document.
The Company constitutes one single legal entity. However, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive
benefit of the relevant Compartment. In addition, each Compartment shall only be responsible for the liabilities which are
attributable to it.
Classes of shares
The General Partner may create each Compartment or Class of Shares for an unlimited or limited period of time; in the
latter case at the expiry of the initial period of time, the General Partner may extend the duration of the relevant Compartment
or Class of Shares once or several times. At expiry of the duration of the Compartment, the Company shall redeem all the
Shares in the relevant Class(es) of Shares, in accordance with Article 11.
At each prorogation of a Compartment or Class(es) of Shares, the registered Shareholders shall be duly notified in
writing, by a notice sent to the registered address as recorded in the register of Shares of the Company. The Company shall
inform the bearer Shareholders by a notice published in newspapers to be approved by the General Partner, unless these
Shareholders and their addresses are known to the Company. The sales documents of the Company (the “Sales Documents”)
shall indicate the duration of each Compartment and if appropriate, its prorogation.
The General Partner, acting in the best interest of the Company, may decide that all or part of the assets of two or more
Compartment be co-managed, as described in the Sales Documents.
The shares to be issued pursuant to Article 10 hereof may, as the General Partner shall determine, be of different classes.
The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested in securities of any kind and other assets permitted by
law pursuant to the investment policy determined by the General Partner established in respect of the relevant class or
classes of shares, subject to the principle of risk spreading provided by law and any investment restriction determined by
the General Partner.
The shares of the various classes shall confer upon their holders the right to one vote on all matters coming before general
meetings of shareholders. Rights conferred on fractional shares shall be exercised pro rata of the fraction held by the holder
of the share, except for voting rights, which can only be exercised for whole shares.
The shares have no mention of value and bear no preference right or right of preemption.
Art. 6. Restrictions to the subscription for shares. Shares may only be subscribed and held by investors which comply
with the provisions of the SIF Law (the "Eligible Investors"), being:
- institutional investors; or
- professional investors, or
- any other investor who has declared in writing that he adheres to the status of a "well- informed investor" and
* either invest a minimum of the equivalent in the currency of the class of shares of one hundred twenty-five thousand
(EUR 125,000.-) Euros in the Company (or its equivalent in the reference currency of the Company or
119679
L
U X E M B O U R G
* provide an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, by an investment
firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or by a management company within the meaning of Directive 2009/65/
EC, certifying his expertise, his experience and his knowledge in adequately appraising an investment in the Company.
The requirements set forth in the SIF Law shall not be applicable to the General Partner and other persons who are
involved in the management of the Company.
The General Partner or, as the case may be the entities appointed by the General Partner to receive subscription orders
for shares of the Company, may request all information and documents required or necessary in order to assess the status
as Eligible Investor of an investor.
The Company will not give effect to any transfer of shares to an investor who does not comply with the above provisions
of this Article.
Art. 7. Restrictions on the ownership of shares. The General Partner may restrict or prevent the ownership of shares in
the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to
the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign; or if as a result thereof
the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise
incurred.
Furthermore, the General Partner shall decline to issue any Shares to specified U.S. persons, non-participating Foreign
Financial Institutions (FFIs), or passive Non-Foreign Financial Entities (NFFEs) with one or more substantial U.S. owners,
as each defined by the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Shareholders are explicitly prohibited to sell or
otherwise transfer any Shares in the Company to specified U.S persons, non-participating FFIs, or passive NFFEs with one
or more substantial U.S owners, as each defined by FATCA. In the case a Shareholder appears to be specified U.S person,
non-participating FFI, or passive NFFE with one or more substantial U.S owners, as each defined by FATCA, the Company
may charge such Shareholder with any taxes or penalties imposed on the Company attributable to such Shareholder’s non-
compliance under FATCA or any applicable intergovernmental agreement, and the General Partner may, in its sole
discretion, redeem such Shares. Any Distributor is required to notify the Company of a change in the Distributor’s FATCA
status within 90 days of such change.
Such persons, firms or corporate bodies to be determined by the General Partner being herein referred to as ("Prohibited
Persons").
For such purposes the Company may:
(A) decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry or
transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and
(B) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares in
the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by an affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person,
or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and
(C) decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and
(D) where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is
a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Company evidence of the sale
within thirty (30) days of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Company may compulsorily
redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:
(1) The Company shall serve a second notice (the “Purchase Notice") upon the shareholder holding such shares or
appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased
as aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.
Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed
to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall
thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the shares spe-
cified in the purchase notice.
Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be
the owner of the shares specified in such notice and his/her name shall be removed from the register of shareholders.
(2) The price at which each such share is to be purchased (the "purchase price") shall be an amount based on the Net
Asset Value (as defined hereinafter) per share of the relevant class of shares as at the Valuation Day (as defined in Article
14 below) specified by the General Partner for the redemption of such shares in the Company next preceding the date of
the purchase notice or next succeeding the surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified
in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with the provisions of the present Articles, less any
service charge provided therein.
(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency
fixed by the General Partner for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be deposited
for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice)
upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates specified in such
notice and un-matured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former
119680
L
U X E M B O U R G
owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect
thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank following effective surrender of
the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable by a shareholder under this paragraph,
but not collected within a period of six months from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed
and shall be deposited with the "Caisse de Consignation".
The General Partner shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to
authorize such action on behalf of the Company.
(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such case the
said powers were exercised by the Company in good faith.
Art. 8. Payment - Late and default of payment.
Payment
By subscribing for or purchasing Shares in the Company, each Shareholder commits irrevocably to meet the capital
calls of the General Partner within the limit of the amount of its commitment and to comply with the other provisions of
the Issuing Document, the Articles and its Subscription Agreement. Any delay or default of payment will be penalized in
accordance with this Article.
The commitment of each Shareholder to the Company consists of an initial drawdown equal to at least one (5) % of its
commitment and several further drawdowns called from time to time by the General Partner depending on the financial
needs of the Fund.
Late and default of payment
If a Shareholder does not make, in full or in part, a payment corresponding to a capital call or any other amount required
to be funded pursuant to the Offering Document, the relevant Sub-Fund Appendix or the Shareholder’s Subscription Form,
in each case on the date on which such payment must be made (the "Payment Date"), the General Partner shall provide
such Shareholder with a written notice on such Payment Date of such failure to meet its drawdown obligations (the "Warning
of Default").
The Shareholder will then have a five (5) Business Day period following the sending of the Warning of Default to meet
its drawdown obligation without penalty. If such Shareholder meets its drawdown obligation within this required time-
frame, the General Partner will not consider such Shareholder as a Defaulting Shareholder (as such term is defined in the
following paragraph) and the amounts due by the Shareholder will not bear any interest and such Shareholder will be
entitled to receive distributions made, if any, between the Payment Date and expiry of such five (5) Business Day period
following the date of sending of the Warning of Default.
In the event of a default in payment or a failure to cure a default after the five (5) Business Day period following the
sending of the Warning of Default, the Shareholder shall be deemed to be a defaulting investor (a "Defaulting Shareholder")
with retroactive effect from the Payment Date and will not be entitled to receive any distributions made between the Payment
Date and expiry of such five (5) Business Day period following the date on which the Warning of Default was sent.
In the event that the default is not remedied within the five (5) Business Day period following the date on which the
Warning of Default was sent, the General Partner will be entitled to send a default letter to the Defaulting Shareholder (the
"Default Letter") to such Defaulting Shareholder and may proceed in the following manner.
The General Partner will be entitled to decide that (i) the Defaulting Shareholder will not receive any distribution of any
kind whatsoever until the date on which the Company has realised or distributed all its assets and may make a final
distribution of all remaining assets to the Shareholders, (ii) the voting rights attached to the Shares held by such Shareholder
will be suspended, and (iii) if the Defaulting Shareholder is a member of the Investment Advisory Board, it will automa-
tically be dismissed from its functions in this respect.
If the default is remedied in full within fifteen (15) Business Days of the sending of the Default Letter, the Defaulting
Shareholder shall recover (i) its rights to receive distributions made, including any distributions which took place between
the Payment Date and the date on which the default was remedied in full, (ii) its rights to exercise the voting rights attached
to its Shares, and (iii) as the case may be, its functions of member of the Investment Advisory Board.
If the default is not remedied within fifteen (15) Business Days of the sending of the Default Letter, the General Partner
may enforce collection of the unpaid amounts against the Defaulting Shareholder.
If the General Partner decides not to enforce collection of the unpaid amounts against the Defaulting Shareholder, the
General Partner may exercise, at its sole discretion, one or more of the options set out below:
(a) terminate the Defaulting Shareholder’s Undrawn Commitment; and/or
(b) redeem the Shares of the Defaulting Shareholder at a redemption price equal to the lesser amount of (i) 70% of its
Capital Contribution paid with respect to its Commitment or (ii) 70% of the latest calculated Net Asset Value per Share
(or the Initial Subscription Price if no Net Asset Value has been calculated yet) in respect of the Shares actually subscribed
and paid for by such Defaulting Shareholder (the "Compulsory Purchase Price"). Such redemption price shall further be
subject to reduction if so determined by the General Partner; and/or
119681
L
U X E M B O U R G
(c) exercise, on account of the Company, an option to buy the Shares of the Defaulting Shareholder at the Compulsory
Purchase Price, in which case, the General Partner will, after having acquired the Shares of the Defaulting Shareholder
pursuant to the exercise of its option, offer the Shares of the Defaulting Shareholder to a third party (or parties) identified
by the General Partner at the Compulsory Purchase Price provided that before offering the Shares of the Defaulting Sha-
reholder to any third party, the General Partner will offer them to the non-Defaulting Shareholders at the Compulsory
Purchase Price, who will have a period of ten (10) Business Days to accept the offer. Any non-Defaulting Shareholders
expressing an interest in such a purchase will be offered the Shares of the Defaulting Shareholder pro rata based on their
existing Commitments to the relevant Sub-fund. Any Transfer of Shares of the Defaulting Shareholder pursuant to this
Section will be subject to the terms and provision of Section 13 and will result in the transfer of the Defaulting Shareholder's
Undrawn Commitments and/or
(d) deliver an additional Drawdown Notice to the Shareholders to make up any shortfall of a Defaulting Shareholder
providing that their additional contribution shall not exceed the amount of their Undrawn Commitments; and/or
(e) borrow on a short term basis in order to make up any shortfall of a Defaulting Shareholder.
The General Partner may decide on other solutions as far as legally allowed if it believes such solutions to be more
adequate to the situation. The General Partner may, in its discretion but having regard to the interests of the other Share-
holders, waive any of these remedies against a Defaulting Shareholder.
Any exercise of any or none of the remedies set out under this Section will not prejudice the right of the Company to
pursue any other available legal remedies against any Defaulting Shareholder. The Company for the account of the relevant
Sub-fund will have the right to set-off any of its obligations to pay any amount to the Defaulting Shareholder as a result of
the exercise of any of its rights under this Section against any obligation of the Defaulting Shareholder owed to the relevant
Sub-fund.
Art. 9. Form of shares, Register and voting rights.
(1) Form of shares
Shares are issued without par value and are fully paid-up. All shares, whatever class into which they fall, will be issued
in registered form in the name of the subscriber, evidenced by entry of the subscriber in the register of shareholders. The
General Partner is entitled to decide on the issue of registered share certificates (or decide not to issue registered share
certificates), in which case a registered share certificate may be provided at the express request of the shareholder. If a
shareholder requires more than one registered certificate for his shares, the cost of additional certificates may be charged
to him.
(2) Register
The register of shareholders shall be held by the Company or by one or several persons appointed to such effect by the
Company. The entry in the register must indicate the name of each holder of registered shares, their elected place of
residence, domicile or registered office, the number of registered shares which they hold, and the amount paid on each of
the shares. Any transfer of registered shares, whether inter vivos or causa mortis, shall be entered in the register of share-
holders, whereby such entry must be signed by one or several executives or authorized agents of the Company, or by one
or several other persons appointed to such effect by the General Partner.
In the case that certificates have been issued, the transfer of registered shares shall be undertaken by submitting to the
Company certificates representing such shares, together with all other transfer documents required by the Company or, if
no certificate has been issued, by way of a written transfer declaration entered in the register of shareholders, dated and
signed by the transferor and the transferee or by their agents providing evidence of the required powers.
In the case that the issue of registered share certificates has been decided by the General Partner, any shareholder wishing
to obtain registered share certificates must provide to the Company an address to which all communications and information
may be sent. Such address shall also be entered in the register of shareholders.
In the event that a registered shareholder does not provide any address to the Company, mention may be made to this
effect in the register of shareholders, and the address of the shareholder shall be deemed to be at the registered office of
the Company or any other address which shall be fixed by the Company until such time as another address shall be supplied
by the shareholder. The shareholder may at any time causes the address to be entered in the register of shareholders to be
changed by way of written declaration sent to the registered office of the Company, or to any other address which may be
stipulated by the Company.
Shares shall only be issued upon acceptance of subscription and receipt of the price payable in accordance with Article
11 of the present Articles.
Shares may be issued in fractions of shares up to 5 decimals, as the General Partner may decide.
(3) Voting rights
Each Share grants the right to one (1) vote at every meeting of Shareholders and at separate Class meetings of the holders
of Shares of the relevant Class.
Fractional shares will be issued to the nearest 1,000
th
of a share. Such fractional shares will not be entitled to vote
(except where their number is so that they represent a whole share, in which case they confer a voting right) but will be
119682
L
U X E M B O U R G
entitled to a participation in the net results and in the proceeds of liquidation attributable to the relevant Class in the relevant
Compartment on a pro rata basis.
Art. 10. Issue of shares. The General Partner is authorized, at any time and without limitation, to issue additional shares,
fully paid-up, without reserving to the former shareholders any preferential subscription right.
The General Partner may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares; the
General Partner may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering periods
or at such other periodicity as provided for in the Issuing Document.
Whenever the Company offers shares for subscription, the subscription price per share at which such shares are offered
will be the Net Asset Value per share of the relevant class as determined in compliance with Article 13 hereof as of the
relevant Valuation Day, as is determined in accordance with such policy as the General Partner may from time to time
determine. Such subscription price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the
Company (if any) when investing the proceeds of the issue and by applicable sales commissions, as approved from time
to time by the General Partner. The subscription price as the case may be increased by the foregoing percentage shall be
payable within a period as determined from time to time by the General Partner and disclosed in the Issuing Document.
The General Partner may delegate to any manager, manager, officer or other duly authorized agent the power to accept
subscriptions and to receive payment of the subscription price of the new shares to be issued and to deliver them.
If subscribed shares are not paid for, the Company may redeem the shares issued whilst retaining the right to claim its
issue fees, commissions and any other fees.
Subject to applicable law, the General Partner may, at its discretion, agree to issue Shares as consideration for a con-
tribution in kind of securities or other assets provided that such securities or assets comply with the investment objective
and policy of the Company. The General Partner will only exercise its discretion if: (i) the relevant Shareholder consents
thereto; and (ii) the transfer would not adversely affect the other Shareholders. Any costs incurred in connection with a
contribution in kind of other securities or assets shall be borne by the relevant Shareholder.
Art. 11. Redemption of shares. Except if prohibited by the General Partner for or a class of shares in the Issuing Docu-
ment, each shareholder shall be entitled, subject to any terms, conditions and restrictions imposed by the General Partner,
to ask the Company to redeem all or part of the shares the shareholders holds; it being understood that the General Partner
may impose restrictions as to the frequency at which shares may be redeemed in any class.
Shares shall be redeemed compulsorily in the cases and conditions described in the Issuing Document. Shares may also
be redeemed compulsorily upon express request of the General Partner whether it considers compulsory redemption to be
in the best interest of the Shareholders.
Shares may also be redeemed upon express proposal of the General Partner and in other circumstances, as provided for
in the Issuing Document. The redemption price of a share will be equal to the Net Asset Value per share of the relevant
class of shares, as determined in accordance with the provisions of Article 13 hereinafter, less any percentage estimate of
costs and expenses to be incurred by the Company (if any) as disclosed in the Issuing Document. The redemption price
will be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the General Partner may determine.
In the event of significant redemption applications relating to one share class, the Company may, but has no obligation
to, decide that part or all of such redemption request be deferred and process such redemption requests at a redemption
price determined further to selling the necessary securities in the shortest time possible and once the Company is able to
have disposal in respect of the proceeds of such sales. In order to ensure an equal treatment of investors, such a delay in
the processing of the redemptions will apply to all investors requesting the redemption and will apply to the entirety of
shares presented for redemption. A single redemption price shall be calculated for all redemption applications presented
at the same time. On the next Valuation Day, these redemption requests will be treated in priority to later requests.
All redemption applications must be presented by the shareholder in writing to the registered office of the Company or
to another legal entity authorized with regard to the redemption of shares. Applications must state the name of the share-
holder, the class of shares, the number of shares or the amount to be redeemed, as well as the instructions for paying the
redemption price.
The General Partner may delegate to any manager or any executive or other authorized agent of the Company duly
authorized to such effect the task of accepting redemptions and of paying or receiving payment of the redemption price of
the shares to be redeemed.
The redemption price shall be payable within a period as determined from time to time by the General Partner and
disclosed in the Issuing Document.
Subject to applicable law, the General Partner may, at its discretion, pay the redemption price to the relevant Shareholder
by means of a contribution in kind of securities and other assets of the relevant class of shares up to the value of the
redemption amount. The General Partner will only exercise this discretion if: (i) the relevant Shareholder consents thereto;
and (ii) the transfer would not adversely affect the remaining Shareholders. Any costs incurred in connection with a re-
demption in kind of securities or other assets shall be borne by the relevant Shareholder.
Neither the General Partner nor the custodian bank of the Company may be held liable for any failure to pay redemption
proceeds resulting from the application of any exchange control or other circumstances that are outside their control, which
would restrict transfer of the proceeds from the redemption of the shares or make it impossible.
119683
L
U X E M B O U R G
Before the redemption price can be paid, redemption applications must be accompanied by the share certificate(s) (when
issued) in the due and proper form and the documents required in order to effect their transfer. Shares repurchased by the
Company may be cancelled.
Art. 12. Transfer of shares - Non conversion.
Transfer of shares
The Transfer of all or any part of any Shares in any Sub-Fund of the Company is subject to the provisions of the present
Articles and the Issuing Document.
In the event of a proposed transfer of Shares (a "Proposed Transfer"), the transferor shall make a declaration thereof to
the General Partner by registered letter with return receipt requested (the "Notification Letter"), (i) indicating the full name,
mailing address and tax domicile of the transferor and of the transferee, the identification number and the number of Shares
which the transferor plans to transfer (the "Proposed Shares"), and the price offered for the Proposed Shares, and (ii)
including a representation and warranty given by the transferee that such transferee is a Well-Informed Investor.
In order to maintain the consistency of the Company's Shareholders, it is agreed to that transfer of any Share, for any
reason whatsoever, is subject to the prior written approval of the General Partner.
The General Partner will have twenty (20) Business Days as from the reception of the Notification Letter to decide
whether it does or does not approve and to notify such decision to the transferor. If the General Partner does not notify its
refusal within the twenty (20) Business Day period aforementioned, it shall be deemed to have approved the contemplated
transfer. The General Partner has full discretion in making this decision, is not subject to any restrictions and is not required
to make the reasons for its decision known.
Where approval is given, the completion of the transfer of Shares shall take place according to the notified conditions
within fifteen (15) Business Days following the notification of such approval or the expiration of the period of twenty (20)
Business Days provided in the above paragraph.
Non-conversion
Investors are not allowed to convert all, or part of the Shares of a given Class into Shares of the same Class of another
Compartment. Likewise, conversions from Shares of one Class of a Compartment to Shares of another Class of either the
same or a different Compartment are prohibited.
Art. 13. Net asset value. The net asset value (the "Net Asset Value") of a share, irrespective of the class of shares for
which it is issued, shall be determined in the currency chosen by the General Partner, as disclosed in the Issuing Document,
by way of a figure obtained by dividing on the Valuation Day the net assets of the class of shares in question by the number
of shares issued in this class of shares.
The Net Asset Value per share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the General
Partner shall determine. If, since the time of determination of the Net Asset Value, there has been a material change in the
quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant class of shares are
dealt in or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company, cancel the
first valuation and carry out a second valuation, in which case all relevant subscription and redemption requests will be
dealt with on the basis of that second valuation.
The net assets of the Company shall be formed by the assets of the Company as defined below, less the liabilities of the
Company as defined below, on the Valuation Day on which the Net Asset Value of the shares is determined.
(1) The assets of the Company comprise the following:
a) all cash in hand or held at banks, including interest accrued and not paid;
b) all bills and notes payable at sight and accounts receivable, including proceeds from the sale of securities, the price
of which has not yet been collected;
c) all securities, units, shares, bonds, option or subscription rights, and other investments and transferable securities
which are the property of the Company;
d) all dividends and distributions due to the Company in cash or securities insofar as the Company could reasonably
have knowledge thereof (the Company may however make adjustments in view of fluctuations in the market value of
transferable securities on the basis of operations such as ex dividend and ex rights trading);
e) all interest accrued and not paid produced by the securities which are the property of the Company, unless however
such interest is included in the principal amount of such securities;
f) the costs of incorporation of the Company insofar as they have not been amortized;
g) all other assets, whatever the nature thereof, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined according to the following principles:
(i) In the event that assets are not listed or dealt in on a Regulated Market, stock exchange or other regulated markets,
the value of such assets will be defined by the Company based on the acquisition price thereof including all costs, fees and
expenses connected with such acquisition or, if such acquisition price is not representative, on the reasonable price thereof
determined prudently and in good faith by the General Partner or by Independent Valuator(s).
119684
L
U X E M B O U R G
(ii) Transferable securities will be valued at the most representative price on the markets and / or of trades made on these
markets by the managers or other market intermediaries. This may involve the last available price or the price at any other
time on markets deemed by the General Partner to be most representative, taking into account liquidity criteria and trades
that have been made on the markets in question. If no price is available, securities will be valued, prudently and in good
faith, on the basis of their estimated sale price.
(iii) Liquid assets will be valued at their face value, plus accrued interest.
(iv) For each class of shares, securities whose value is expressed in a currency other than the currency of the Company
will be converted to the relevant currency based on the average price between the last available bid / ask price in Luxembourg
or, failing that, on the market that is most representative for these securities.
(v) All other assets will be valued on the basis of the acquisition price thereof including all costs, fees and expenses
connected with such acquisition or, if such acquisition price is not representative, on the reasonable price thereof determined
prudently and in good faith by the General Partner or by Independent Valuator(s);
(vi) In order to detect any decline in value below the acquisition price of the investments, the value of the investments
may be determined (i) at lower of the acquisition price or market value and assessed at their fair value, or (ii) at acquisition
price less permanent impairment and assessed at their permanent reduction in value.
(The General Partner is authorized to adopt any other appropriate principles for valuing the Company's assets if ex-
traordinary circumstances make it impossible or inappropriate to calculate the values based on the aforementioned criteria.
In the event of high levels of subscription or redemption applications, the General Partner may calculate the value of
the shares based on prices in the stock exchange or market trading session during which it was able to carry out the necessary
purchases or sales of securities for the Company. In such cases, a single method of calculation will be applied to all
subscription or redemption applications received at the same time.
(2) The liabilities of the Company comprise the following:
a) all loans, bills outstanding and accounts payable;
b) all administration costs outstanding or due, including remuneration to investment advisors, managers, the custodian
bank, representatives and agents of the Company;
For the valuation of the amount of these liabilities, the Company shall take into account prorata temporis the expenses,
administrative and other, that occur regularly or periodically;
c) all known obligations, whether outstanding or not yet payable, including all contractual obligations due which relate
to payments either in cash or in kind, including the amount of the dividends announced by the Company but not yet paid,
when the Valuation Day coincides with the date on which determination of the person entitled thereto is undertaken;
d) an appropriate provision for tax on share capital and income, accrued to the Valuation Day and fixed by the General
Partner, and other provisions authorized or approved by the General Partner;
e) all other obligations of the Company, whatever the nature thereof, with the exception of the liabilities represented by
the Company's own funds. With regard to valuation of the amount of such liabilities, the Company may take account of
administrative and other expenses which are regular or periodic in nature by way of an estimate for the year or any other
period, allocating the amount pro rata over the fractions of such period.
(3) For the requirements of this Article:
a) each share of the Company which is in the process of being redeemed pursuant to Article 11 of the present Articles
shall be considered as a share which is issued and existing until the time of close of business on the Valuation Day applying
to redemption of such share and the price thereof shall, with effect from and until such time as the price thereof is paid, be
considered as a liability of the Company;
b) each share to be issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be treated as
being issued with effect from close of business on the Valuation Day during which its issue price has been determined, and
the price thereof shall be treated as an amount due to the Company until the Company has received the same;
c) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than in the respective
currency of the Company, as the case may be, shall be valued taking account of the exchange rates in force on the date and
at the time of determination of the Net Asset Value of the shares; and
d) on the Valuation Day, effect shall be given insofar as possible to any purchase or sale of securities contracted by the
Company.
(4) In the absence of significant error as defined by Luxembourg regulation, every decision in calculating the Net Asset
Value taken by the General Partner or by any bank, company or other organization which the General Partner has appointed
for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future
shareholders.
Art. 14. Frequency and temporary suspension of calculation of the net asset value of shares, Issues and redemption.
(1) Frequency of calculation of Net Asset Value
The Net Asset Value of the shares of the Company, including the relevant issue price and redemption price, shall be
determined periodically by the Company or by a third party appointed by the Company, in accordance with applicable laws
119685
L
U X E M B O U R G
and regulations at a frequency as the General Partner shall decide (whereby each such day of calculation of the Net Asset
Value of the assets shall be referred to in the present Articles as a "Valuation Day").
If a Valuation Day falls on a statutory public or bank holiday in Luxembourg, the Net Asset Value of the shares shall
be determined on the date as specified in the Issuing Document.
(2) Temporary suspension of calculation of Net Asset Value
The calculation of the net asset value per share, as well as the issue and redemption of the shares of one or more class
of shares may be suspended by the General Partner in the following instances:
(i) When one or more stock exchanges or markets on which a significant percentage of the Company's assets are valued
or one or more foreign exchange markets, in the currencies in which the net asset value of shares is expressed or in which
a substantial portion of the Company’s assets is held, are closed, for a reason other than for normal holidays or if dealings
on them are suspended, restricted or subject to major fluctuations in the short term;
(ii) When, as a result of political, economic, military, monetary or social events, strikes or any other cases of force
majeure outside the responsibility and control of the Company, the disposal of the Company's assets is not reasonably or
normally practicable without being seriously detrimental to Shareholders' interests;
(iii) When there is a breakdown in the normal means of communication used to calculate the value of an asset in the
Company or if, for whatever reason, the value of an asset in the Company cannot be calculated as promptly or as accurately
as required;
(iv) When, as a result of currency restrictions or restrictions on movement of capital, transactions for the Company are
rendered impracticable, or purchases or sales of the Company's assets cannot be carried out at normal rates of exchange;
(v) following the occurrence of an event entailing the liquidation of the Company.
In case of suspension of the calculation of the Net Asset Value of shares, the issue and redemption of the shares, the
Company shall give notification of such suspension to the shareholders seeking subscription and redemption of the shares,
whereby shareholders may cancel their instructions.
The suspension of the calculation of the Net Asset Value, of the issue and redemption of shares will be notified to the
other shareholders through any appropriate means.
The Company may, at any time and at its discretion, temporarily discontinue, permanently cease or limit the issue of
shares in one or more class of shares to natural or legal entities resident or domiciled in certain countries or territories. It
may also prohibit them from acquiring Shares if such a measure is deemed necessary to protect all Shareholders and the
Company.
Moreover, the Company has the right to:
(i) reject any application to subscribe for Shares at its discretion;
(ii) redeem Shares acquired in breach of an exclusion measure at any time.
Art. 15. General partner. The Company is managed by its general partner, the Luxembourg public limited liability
company IFORE General Partner S.à r.l. (the "General Partner"), with registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais,
L-2535 Luxembourg and who shall be the liable partner (actionnaire - gérant - commandité) and who shall be personally,
jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.
The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the
Company's interest which are not expressly reserved by law or by these Articles to the meeting of Shareholders.
The General Partner shall namely have the power on behalf and in the name of the Company to carry out any and all of
the purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that
it may deem necessary or advisable or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the General Partner shall
have, and shall have full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and
powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.
Art. 16. Powers of the general partner. The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of
administration and disposition within the purpose of the Company. In particular, the General Partner shall determine the
investment objectives and policies of the Company as well as the course of conduct of the management and the business
affairs of the Company in relation thereto, as set forth in the Issuing Document, in compliance with applicable laws and
regulations.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the
competence of the General Partner.
The General Partner may, under its responsibility, appoint special committees in order to conduct certain tasks and
functions expressly delegated to such committee or grant special powers by notarized proxy or private instrument.
Art. 17. Indemnification of managers. The Company may indemnify, to the maximum extent permitted by applicable
laws and regulations, the managers, and their respective managers, officers, partners, employees, affiliates and assigns,
against any liabilities, claims and related expenses including attorneys fees, incurred by reason of his being a manager of
the Company or having any action performed or omitted any action in connection with the activities of the Company or in
dealing with third parties on behalf of the Company, provided such action or decision not to act was taken in good faith,
119686
L
U X E M B O U R G
and does not constitute gross negligence, intentional misconduct, knowing violation of applicable laws or regulations or
an intentional or material breach of these Articles.
Art. 18. Corporate signature. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of two managers
of the General Partner or the single signature of any other person to whom such power has been delegated by the General
Partner.
Art. 19. Delegation of powers. The General Partner may delegate its powers to conduct the daily management and affairs
of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical
persons or corporate entities, which need not be members of the General Partner, and who shall have the powers determined
by the General Partner and who may, if the General Partner so authorizes, sub-delegate their powers.
The General Partner may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
The General Partner will determine any such officers or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration
of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. The General Partner may in particular
appoint, under its responsibility investment advisors and managers, as well as administrative agents. The General Partner
may enter into agreements with such persons or companies for the provision of their services, the delegation of powers to
them and the determination of their remuneration to be borne by the Company.
Art. 20. Conflicts of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested
in, or is a manager, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any manager or officer of the Company
who serves as a manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract
or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any manager or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest opposite
to the interests of the Company, such manager or officer shall make known to the General Partner such opposite interest
and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein
shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
Art. 21. Depositary. The Company shall enter into a depositary agreement with a banking or saving institution as defined
by the Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the "Law of 1993"). The custodian bank shall
fulfill the duties and responsibilities as provided for by the SIF Law and the AIFM Law. If the custodian bank desires to
retire, the General Partner shall use its best endeavours to find a successor custodian and will appoint it in replacement of
the retiring custodian bank. The General Partner may terminate the appointment of the custodian bank but shall not remove
the custodian bank unless and until a successor custodian shall have been pointed to act in the place thereof. The functions
and responsibilities of the custodian bank in accordance with the SIF Law and the AIFM Law shall be transferred to the
successor custodian within 2 months’ time.
Art. 22. Independent auditor. The Company shall appoint an independent and external auditor ("réviseur d'entreprises
agréé") who shall carry out the duties prescribed by the SIF Law. The independent auditor shall be elected by the general
meeting of shareholders and shall hold office until his or her successor is elected.
Art. 23. Representation of the General meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of
the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.
Art. 24. Date of the annual general meeting. The annual general meeting of shareholders will be held each year on the
third Thursday of May at 2 p.m. at the Company's registered office or any other location in Luxembourg specified in the
convening notice, except for the first general meeting of the Company which will be held on February, 28, 2017 at 2 p.m.
The meeting must be held within six months after the end of the accounting year. If such say is not a Business Day, the
meeting will be held on the following Business Day.
Art. 25. Other general meetings. The General Partner may convene other general meetings of the shareholders. Such
meetings must be convened if shareholders representing one tenth of the Company's share capital so require.
Such other general meetings will be held at such places and times as may be specified in the respective notices convening
the meeting.
Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles.
Shareholders may act either in person or by giving a written proxy to another person who needs not be a shareholder
and may be a manager of the Company.
Art. 26. Convening notice. The general meeting of shareholders is convened by the General Partner in compliance with
applicable law.
Notices to shareholders shall set out the agenda of the meeting, the conditions for admission and the quorums and
majorities required, in accordance with the provisions of the Law of 1915, and indicate the time and place of such meeting.
Notices for each General Meeting will be sent to the Shareholders by post at least eight calendar days prior to the relevant
General Meeting.
119687
L
U X E M B O U R G
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting priorily, they may unanimously waive all convening requirements and forma-
lities.
Art. 27. Presence, Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings of the sha-
reholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing, in writing or by telefax, as his proxy,
another person who need not be a shareholder himself.
Art. 28. Votes. Each share entitles the holder thereof to one vote. With regards to fractions of shares, voting rights can
only be exercised for whole shares.
Unless otherwise provided by applicable law or by these Articles, all resolutions of the annual or ordinary general
meeting of shareholders shall be taken by simple majority votes of validly cast votes, regardless of the proportion of the
capital present and represented.
Art. 29. Proceedings. The general meeting of shareholders shall be chaired by a person designated by the general meeting
of shareholders.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or represented.
They together form the office of the general meeting of shareholders.
Art. 30. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting,
the secretary and the scrutineer.
Art. 31. Financial year. The Company's financial year begins the 1
st
January and closes on the 31
st
December the same
year, except the first accounting year which will begin on the date of incorporation of the Company and will end on 31
December 2016.
Art. 32. Distributions. Within the conditions and limits laid down by applicable law and herein, the general meeting of
shareholders shall, upon proposal of the General Partner, determine how the profits of the Company shall be treated and
may declare distributions and/or dividends. In addition to the aforementioned distributions, the General Partner may decide
to pay interim dividend within the conditions and limits laid down by the SIF Law.
In any cases the above distributions and payments will be made after payment of or making appropriate provision (if
any) for any Company's expenses and fees due, inter alia, to the other service providers.
Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the relevant
class or classes of shares issued.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
All distributions will be made net of any income, withholding and similar taxes payable by the Company, including, for
example, any withholding taxes on interest or dividends received by the Company and capital gains taxes, withholding
taxes on the Company's investments.
Art. 33. Costs to be borne by the company. The Company shall bear all of its formation and operating costs, and expenses
as further described in the Issuing Document.
Art. 34. Merger, Dissolution and liquidation of compartments and the company.
Liquidation or Merger of Compartments or Classes of Shares
In the event that, for any reason, the value of the total net assets in any Compartment or Class has decreased to, or has
not reached, an amount determined by the General Partner and/or in the Issuing Document to be the minimum level for
such Compartment or Class to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in
the political, economic or monetary situation, or as a matter of economic rationalisation, the General Partner may decide
to offer to the relevant Shareholders the conversion of their Shares into Shares of another Compartment under terms fixed
by the General Partner or to redeem all the Shares of the relevant Compartment or Class at the net asset value per share
(taking into account projected realisation prices of investments and realisation expenses calculated on the Valuation Date
immediately preceding the date at which such decision will take effect). The Company will serve a notice to the holders
of the relevant Shares prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons for and
the procedure for the redemption operations.
Any request for subscription shall be suspended as from the moment of the announcement of the termination, the merger
or the transfer of the relevant Compartment.
In addition, the general meeting of any Class or of any Compartment will, in any other circumstances and without quorum
and by simple majority, have the power, subject to the approval of the General Partner, to redeem all the Shares of the
relevant Compartment or Class and refund to the Shareholders the Net Asset Value of their Shares (taking into account
actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated on the Valuation Date immediately preceding
the date at which such decision will take effect. Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the im-
plementation of the redemption will be deposited with a bank or credit institution as defined by the Law of 1993 for a period
119688
L
U X E M B O U R G
of six months; after such period, the assets will be deposited with the Caisse des Consignations on behalf of the persons
entitled thereto.
Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this article, the General Partner may decide to
allocate the assets of any Compartment to those of another existing Compartment or to another undertaking for collective
investment organised under the provisions of the SIF or the law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective
investment (the "Law of 2010"), as amended, or to another Compartment within such other undertaking for collective
investment and to redesignate the Shares of the concerned Compartment as shares of another Compartment (following a
split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to Share-
holders). Such decision will be communicated in the same manner as described in the first paragraph of this article one
month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new Compart-
ment), in order to enable Shareholders to request redemption of their Shares, free of charge, during such period.
Subject to the approval of the General Partner, a contribution of the assets and liabilities attributable to any Compartment
to another Compartment within the Company may, in any other circumstances, be decided upon by a general meeting of
the Shareholders of the Compartment or Class concerned for which there will be no quorum requirements and which will
decide upon such an amalgamation by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at
such meeting.
Furthermore, a contribution of the assets and liabilities attributable to any Compartment to another undertaking for
collective investment referred in this article or to another Compartment within such other undertaking for collective in-
vestment require a resolution of the Shareholders of the Class or Compartment concerned taken with 50% quorum
requirement of the Shares in issue and adopted at a 2/3 majority of the Shares present or represented, except when such an
amalgamation is to be implemented with a Luxembourg undertaking for collective investment of the contractual type (fonds
commun de placement) or a foreign based undertaking for collective investment, in which case resolutions will be binding
only on such Shareholders who have voted in favour of such amalgamation.
Winding Up
The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting, subject to the quorum and majority
requirements for amendment to these Articles and subject to the consent of the General Partner. If the assets of the Company
fall below two-thirds of the minimum capital indicated in article 5, the question of the dissolution of the Company will be
referred to the meeting of the Shareholders by the General Partner. Subject to the consent of the General Partner, the meeting
of the Shareholders, for which no quorum will be required, will decide by simple majority of the votes of the Shares
represented at the meeting.
The question of the dissolution of the Company will further be referred to the meeting of the Shareholders whenever
the share capital falls below one-fourth of the minimum capital set by article 5; in such event, the meeting will be held
without any voting quorum requirements and the dissolution may be decided, upon the consent of the General Partner, by
the Shareholders holding one-quarter of the votes of the shares represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from the ascertainment that the net assets
of the Company have fallen below two-thirds or one-quarter of the legal minimum, as the case may be.
Should the Company be voluntarily liquidated, then its liquidation will be carried out in accordance with the provisions
of the Law of 1915 and the SIF Law. In the event of a voluntary liquidation, the Company shall, upon its dissolution, be
deemed to continue to exist for the purposes of the liquidation. The operations of the Company shall be conducted by one
or several liquidators, who, after having been approved by the competent regulatory body, shall be appointed by a meeting
of the Shareholders, which shall determine their powers and compensation.
The decision to dissolve the Company will be published in the Mémorial and two newspapers with adequate circulation,
one of which must be a Luxembourg newspaper.
If the Company were to be compulsorily liquidated, the provision of the SIF Law will be exclusively applicable.
The issue of new Shares by the Company shall cease on the date of publication of the notice of the meeting of the
Shareholders, to which the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.
The liquidator(s) will realise each Compartment's assets in the best interests of the Shareholders and apportion the
proceeds of the liquidation of each Compartment, net of all liquidation expenses, shall be distributed by the liquidators
among the holders of shares in each Class in accordance with their respective rights. Any amounts unclaimed by the
Shareholders at the closing of the liquidation of the Company will be deposited with the Caisse des Consignations in
Luxembourg for a duration of thirty (30) years. If amounts deposited remain unclaimed beyond the prescribed time limit,
they shall be forfeited.
Art. 35. Amendments of these articles. These Articles may be amended by a general meeting of shareholders subject to
the quorum and majority requirements provided by the Law of 1915.
Art. 36. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of
1915 the SIF Law and the AIFM Law, as may be amended from time to time.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first accounting year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2016.
119689
L
U X E M B O U R G
2) The first annual general meeting of shareholders will be held on February 28, 2017.
<i>Subscription and paymenti>
The share capital of the Company is subscribed as follows:
1) The General Partner subscribes for one (1) Management Share, resulting in a total payment of one Euro (EUR 1.-);
2) The General Partner subscribes for thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999.-) shares of the Ordinary
Shares, resulting in a total payment of thirty thousand nine hundred and ninety-nine Euros (EUR 30,999.-);
Evidence of the above payment, totaling thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) was given to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law
of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfillment.
<i>Expensesi>
The formation and preliminary expenses of the Company, amount to approximately two thousand four hundred Euros
(EUR 2,400.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
The aforementioned appearing person, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
<i>First resolutioni>
The following is elected as independent auditor until the next annual general meeting: MAZARS LUXEMBOURG,
with registered office at 10A rue Henri M Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register section B under number 159962.
<i>Second resolutioni>
The registered office is established at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named persons,
this deed is worded in English only, as authorised by Article 26(2) of the Law of 13 February 2007 relating to specialised
investment funds, as amended.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Signé: S-S LI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 8 septembre 2015. 2LAC/2015/20077. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Référence de publication: 2015151551/726.
(150165912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Mazarine 60 SARL, Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 34.539.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2015.
<i>POUR LE GERANT
i>Signatures
Référence de publication: 2015079678/12.
(150090392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
119690
L
U X E M B O U R G
Goodhart Partners Longitude Fund Sicav-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.360.
Faisant suite au conseil d'administration en date du 29 juin 2015 de Goodhart Partners S.à r.l., actionnaire commandité
de Goodhart Partners Longitude Fund SICAV-SIF,
est réélu réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 Juillet 2015.
<i>Pour State Street Bank Luxembourg S.A.i>
Référence de publication: 2015129343/15.
(150138967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.
Eltec Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 97.899.
PROJET COMMUN DE FUSION
Dépot rectificatif du projet commun de fusion déposé le 1
er
juillet 2015 sous le numéro L150113369
Fait à Strassen, le 10 septembre 2015.
<i>Pour Eltec Management SAi>
PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES:
Madame Françoise AULAGNE, agissant en qualité de Président de la société dénommée SELTEC, société par actions
simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siège social est Parc Avenir II - Lot A1 - 313 avenue Marcel Mérieux - Zone
d'Activité commerciale de Sacuny 69530 BRIGNAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous
le numéro 453 820 664,
et comme spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires
Ci-après dénommée la «Société Absorbante»
D'une part,
ET
Madame Cornelia METTLEN, dûment autorisée à représenter le Conseil d'administration de la société dénommée
ELTEC MANAGEMENT S.A., société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 31 000 euros, dont le siège social
est 163 rue du Kiem L-8030 STRASSEN (Luxembourg), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B97899,
et comme spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du Conseil d'administration
Ci-après dénommée la «Société Absorbée»
D'autre part,
Il a été arrêté en vue de la fusion de SELTEC et de ELTEC MANAGEMENT par voie d'absorption de la seconde par
la première, les conventions qui vont suivre réglant ladite fusion, laquelle est soumise aux conditions suspensives ci-après
stipulées.
Ce projet commun de fusion transfrontalière (ci-après le «Projet de Fusion») propose que la Société Absorbée fusionne
avec et dans la Société Absorbante par le biais d'une fusion transfrontalière au sens de la Directive CE 2005/56 du Parlement
européen et du Conseil en date du 26 octobre 2005, transposés en droit français aux articles L236-25 à L.236-32 et R.
236-13 à R236.20 du Code de commerce et transposés en droit luxembourgeois à la section XIV de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée.
Il résultera de cette fusion transfrontalière (la «Fusion») que:
- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée sera transféré à la Société Absorbante;
- la Société Absorbée cessera d'exister;
- les actions de la Société Absorbante, détenues par la Société Absorbée, seront annulées; les actionnaires de la Société
Absorbée recevront des parts sociales de la Société Absorbante en échange de leurs actions dans la Société Absorbée qui
seront annulées par l'effet de la fusion.
119691
L
U X E M B O U R G
Première partie. Indications sur le projet de fusion
I. Informations sur les sociétés participantes.
(a) La Société Absorbée est la société ELTEC MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège
social est au 163 rue du Kiem L-8030 STRASSEN, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B97899.
La Société Absorbée a, conformément à l'article 4 de ses statuts, l'objet suivant:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement
La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les
compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter di-
rectement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»
La Société Absorbée est associée de la Société Absorbante et détient 2200 actions représentant 55% du capital de cette
société.
(b) La Société Absorbante est la société SELTEC, société par actions simplifiée de droit français au capital de 40 000
euros, dont le siège social est Parc Avenir II - Lot A1 - 313 avenue Marcel Mérieux - Zone d'Activité commerciale de
Sacuny 69530 BRIGNAIS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 453 820 664.
La Société Absorbante a, conformément l'article 2 de ses statuts, l'objet suivant:
- «l'importation, l'exportation, la distribution et la vente de tous produits, sous produits, marchandises et matériels tels
que décoration, matériel électrique et électronique, ameublement, outillages.
- La signature de contrats d'agent commercial pour la distribution de tous types de produits, et particulièrement ceux se
rapportant au paragraphe précédent
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à:
* La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'instal-
lation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus.
* La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle con-
cernant lesdites activités.
* La participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.»
(c) La société issue de la Fusion est la Société Absorbante et la Société Absorbée cessera d'exister après la prise d'effet
de la Fusion. La Société Absorbante ne modifiera pas sa forme juridique, sa dénomination, son objet ou son siège social,
tels que mentionnés au point (b) ci-dessus, suite à la Fusion.
II. Liens de capital existants entre les sociétés parties à l'opération. ELTEC MANAGEMENT détient 2200 actions de
SELTEC représentant 55 % du capital social et des droits de vote de cette dernière.
III. Motifs et but de la fusion. L'opération de fusion envisagée poursuit principalement l'objectif de simplification du
groupe.
IV. Comptes utilisés pour déterminer les conditions de la fusion. Les comptes de SELTEC et de ELTEC MANAGE-
MENT SA. utilisés pour établir les conditions de l'opération sont ceux arrêtés à la date du 31 décembre 2014, date de clôture
du dernier exercice social de chacune des sociétés intéressées.
V. Informations concernant le patrimoine transféré et son évaluation. La présente opération de fusion entre dans le
champ d'application du règlement CRC n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations
assimilées. Le règlement CRC, traitant de la comptabilisation des apports reçus par la Société Absorbante, est applicable
à toute société commerciale absorbante quelle que soit la forme juridique et la nationalité de la Société Absorbée.
La Société Absorbante et la Société Absorbée étant sous contrôle commun, les apports seraient effectués à leur valeur
comptable.
L'actif apporté comprenait, à la date du 31 décembre 2014, sans que cette désignation puisse être considérée comme
limitative, les biens et droits ci-après désignés et évalués à leur valeur comptable:
A- ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations financières (parts dans des entreprises liées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 000 €
ACTIF CIRCULANT
119692
L
U X E M B O U R G
Créances, avoirs en banque, en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.676,75 €
COMPTES DE REGULARISATION (Charges à reporter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.666,35 €
TOTAL DES ÉLÉMENTS D'ACTIF APPORTÉS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 343,10 €
D'une manière générale, l'apport à titre de fusion par ELTEC MANAGEMENT S.A. à SELTEC comprend l'ensemble
des biens et droits ci-dessus désignés, ceux qui en sont la représentation à ce jour, comme aussi au jour de la réalisation
définitive de l'apport-fusion, sans aucune exception ni réserve.
B- PRISE EN CHARGE DU PASSIF
La Société Absorbante prendra en charge et acquittera au lieu et place de la Société Absorbée la totalité du passif de
cette dernière dont le montant au 31 décembre 2014 est ci-après indiqué.
Il est précisé, en tant que de besoin, que la stipulation ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance de dette au profit
de prétendus créanciers, lesquels sont au contraire tenus d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres.
Sous réserve des justifications prévues à l'alinéa qui précède, le passif de la Société Absorbée, au 31 décembre 2014
ressort à:
Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.660,85 €
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.778,75 €
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.548,47 €
TOTAL DU PASSIF DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE AU 31 DÉCEMBRE 2014: . . . . . . . . . . . . . . . . 25.988,07 €.
Le représentant de la Société Absorbée certifie:
- que le chiffre total ci-dessus mentionné du passif de la Société au 31 décembre 2014 et le détail de ce passif, sont exacts
et sincères,
- qu'il n'existait, dans la Société Absorbée, à la date susvisée du 31 décembre 2014 aucun passif non comptabilisé ou
engagement hors bilan,
- plus spécialement que la Société Absorbée est en règle à l'égard de ses obligations fiscales et envers les organismes
de sécurité sociale, d'allocations familiales, de prévoyance et de retraites,
- et que toutes les déclarations requises par les lois et règlements en vigueur ont été faites régulièrement en temps utile.
C- ACTIF NET APPORTÉ
L'actif net apporté par la Société Absorbée s'élève à 124 355,03 €.
VI. Rapport d'échange. A l'effet de réaliser la fusion objet des présentes, SELTEC procédera à une augmentation de
capital par voie de création d'actions nouvelles, lesquelles seront attribuées aux divers ayants droit de la Société Absorbée.
Il est rappelé que la Société Absorbée détient 2200 actions du capital de la Société Absorbante. En conséquence, cette
dernière réduira son capital en vue d'annuler les actions émises par elle-même qu'elle recevra à l'occasion des apports
effectués par la Société Absorbée.
1) Évaluation des apports
Il est rappelé que dans le cadre de la présente fusion, les apports sont valorisés à leur valeur comptable.
Cependant, pour la détermination du rapport d'échange, les apports sont valorisés à leur valeur réelle.
L'actif apporté par la société ELTEC MANAGEMENT est valorisé de la façon suivante:
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations financières (parts dans des entreprises liées) (cf. Annexe I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 163 132,37 €
ACTIF CIRCULANT
Créances, avoirs en banque, en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . . . . . . . . . . . .
120.676,75 €
COMPTES DE REGULARISATION (Charges à reporter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.666,35 €
TOTAL DES ÉLÉMENTS D'ACTIF APPORTÉS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 291 475,47 €
Le passif pris en charge par SELTEC au titre de la fusion s'élève à la somme de 25.988,07 €.
Balance faite, la valeur nette réelle des biens et droits apportés ressort à la somme de 1 265 487,40 €.
2) Rémunération des apports
Pour rémunérer les apports effectués à SELTEC, il sera procédé par cette société à la création de 2393,60 actions
nouvelles, arrondies à 2393 actions, l'actionnaire unique de la société ELTEC MANAGEMENT S.A., attributaire, décidant
de faire son affaire des rompus et renoncer à la fraction d de 0,60 action.
Ces 2393 actions, d'une valeur nominale de 10 euros chacune, seront toutes entièrement libérées et destinées à être
attribuées à l'actionnaire unique de la société ELTEC MANAGEMENT S.A. à raison de 23,93 de ces actions pour une
action de ELTEC MANAGEMENT S.A. détenue.
La rémunération ci-dessus convenue correspond à la parité de fusion arrêtée de façon forfaitaire, en sorte qu'elle ne
saurait être changée à moins d'un mutuel assentiment des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés qui seront
appelées à statuer sur l'opération, au motif que la consistance ou l'importance du patrimoine de l'une ou de l'autre société,
ayant servi à établir cette parité, aurait été modifiée depuis la date de référence utilisée pour établir la consistance des
éléments d'actif et de passif.
119693
L
U X E M B O U R G
Les actions nouvelles à créer par SELTEC seront soumises à toutes les dispositions statutaires de cette société et porteront
jouissance à compter de la date de réalisation définitive de la fusion.
Ces actions nouvelles seront immédiatement négociables dans les délais légaux.
3) Prime de fusion-réduction du capital de l'absorbante
La différence entre la valeur nette comptable des biens et droits apportés (soit 124 355,03 euros) et la valeur nominale
des actions qui seront créées par la Société Absorbante au titre de l'augmentation du capital social susvisée (soit 23 930
euros), différence par conséquent égale à 100 425,03 euros, constituera une prime de fusion qui sera inscrite au passif du
bilan de SELTEC et sur laquelle porteront les droits de tous les actionnaires anciens et nouveaux de la société.
Toutefois, ELTEC MANAGEMENT S.A. est actuellement propriétaire de 2.200 actions de SELTEC, de sorte que si la
fusion se réalisait, la société SELTEC recevrait 2.200 de ses propres actions.
Ne pouvant rester propriétaire de ses propres actions si la fusion est réalisée, SELTEC, Société Absorbante, procédera,
immédiatement après l'augmentation de capital susvisée, à une réduction de capital d'un montant égal à la valeur nominale
des 2.200 actions, antérieurement détenues par ELTEC MANAGEMENT S.A., lesquelles seront annulées.
La valeur d'apport (valeur comptable) des 2.200 actions antérieurement propriété de ELTEC MANAGEMENT S.A.
(soit 22 000 euros) étant identique au montant de la réduction de capital nécessaire à l'annulation de ces 2.200 actions (soit
22 000 euros), la prime de fusion sera maintenue à 100 425,03 euros.
VII. Propriété - Jouissance. Conformément à l'article L.236-31 du Code de commerce français, la Fusion prendra effet
à la date de remise du certificat de légalité par le Greffier du Tribunal de commerce de Lyon.
SELTEC sera propriétaire et prendra possession des biens et droits mobiliers et immobiliers à elle apportés à titre de
fusion à compter de cette date.
Jusqu'audit jour, ELTEC MANAGEMENT S.A. continuera de gérer avec les mêmes principes, règles et conditions que
par le passé, l'ensemble de ses actifs sociaux.
Toutefois, elle ne prendra aucun engagement important sans l'accord préalable de la société.
De convention expresse, il est stipulé que, du point de vue comptable et fiscal, toutes les opérations faites depuis le 1
er
janvier 2015 par ELTEC MANAGEMENT S.A. seront considérées comme l'ayant été, tant activement que passivement,
pour le compte et aux profits et risques de la Société Absorbante.
Tous accroissements, tous droits et investissements nouveaux, tous risques et tous profits quelconques, et tous frais
généraux, toutes charges et dépenses quelconques afférents aux biens apportés incomberont à SELTEC, ladite société
acceptant dès maintenant de prendre, au jour où la remise des biens lui en sera faite, les actifs et passifs qui existeront alors
comme tenant lieu de ceux existant au 1
er
janvier 2015.
A cet égard, le représentant de ELTEC MANAGEMENT S.A. déclare qu'il n'a pas été fait depuis le 31 décembre 2014
(et il s'engage à ne faire entre la date de la signature des présentes et celle de la réalisation définitive des apports) aucune
opération autre que les opérations de gestion courante.
En particulier, le représentant de la Société Absorbée déclare qu'il n'a été pris, depuis la date du 31 décembre 2014 (et
qu'il ne sera pris jusqu'à la réalisation définitive de la fusion objet des présentes) aucune disposition de nature à entraîner
une réalisation d'actif et qu'il n'a été procédé depuis ladite date du 31 décembre 2014 (et qu'il ne sera procédé jusqu'à la
date de réalisation définitive de la fusion) à aucune création de passif en dehors du passif commercial courant.
VIII. Statuts de la société absorbante. Les statuts de la Société Absorbante, tels que joints en annexe II au présent projet
commun de fusion, ne seront pas modifiés suite à la Fusion, à l'exception des articles 6 et 7 qui prendront acte de l'aug-
mentation et de la réduction de capital visées ci-dessus au point IV.
IX. Effets probables de la fusion sur l'emploi. La Fusion n'aura pas d'effet négatif sur l'emploi d'aucun employé des
sociétés qui fusionnent. Aucun contrat de travail ne sera transféré et il n'y aura aucun changement d'employeur.
(a) Concernant les employés de la Société Absorbée:
- La Société Absorbée n'a aucun employé;
- Il n'existe donc pas d'organe de représentation des employés au sein de la Société Absorbée, et aucune consultation
des employés ne doit être organisée au sein de la Société Absorbée en vertu du droit luxembourgeois.
(b) Concernant les employés de la Société Absorbante:
- Le nombre de personnes employées par la Société Absorbante ne sera pas modifié du fait de la Fusion;
- Les droits et obligations des employés de la Société Absorbante ne seront pas modifiés du fait de la Fusion;
- La représentation des employés au sein de la Société Absorbante ne sera pas modifiée du fait de la Fusion. Aucun
changement structurel concernant les activités de la Société Absorbante n'aura lieu ou n'est actuellement envisagée du fait
de la fusion ou en relation avec celle-ci.
X. Droits accordés par la Société Absorbante aux actionnaires avant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des actions ou des parts représentatifs du capital ou les mesures proposées à leur égard. Il n'existe aucun droit spécial
accordé à l'un des actionnaires, ni de porteur de titres autres que des actions.
119694
L
U X E M B O U R G
XI. Avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet commun de fusion transfrontalière ainsi qu'aux
membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent. Confor-
mément aux dispositions applicables, il a été désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon, sur requête
conjointe des sociétés soussignées, un commissaire à la fusion choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 822-1 du Code de commerce français ou parmi les experts Inscrits sur une des listes établies par
les cours et tribunaux.
Ce commissaire vérifiera notamment que le montant de l'actif net apporté par la Société Absorbée est au moins égal au
montant de l'augmentation de capital de la Société Absorbante et ne bénéficiera, indépendamment de ses frais et honoraires,
d'aucun avantage particulier.
Aucun avantage particulier ne sera octroyé aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou
de contrôle des sociétés qui fusionnent du fait de la Fusion ou en lien avec celle-ci,
XII. Informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs
dans la définition de leurs droits de participation dans la Société Absorbante. Un tel système de participation n'existe ni au
sein de la Société Absorbée, qui ne compte aucun employé, ni au sein de la Société Absorbante. Aucune procédure pour
la fixation des modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation n'est
donc prévue par la Société Absorbante.
Deuxième partie. Déclarations
Le représentant de la Société Absorbée déclare;
(a) Sur la Société Absorbée elle-même
1) Qu'elle n'est pas actuellement et n'a jamais été en état de faillite, de liquidation judiciaire, de liquidation de biens ou
de règlement judiciaire, de redressement ou de liquidation judiciaires; qu'elle n'est pas actuellement, ni susceptible d'être
ultérieurement l'objet de poursuites pouvant entraver ou interdire l'exercice de son activité,
2) Qu'elle n'a contracté avec un tiers quelconque aucune interdiction de fabrication ou de commerce, sous quelque forme
que ce soit, ni aucune clause de non-concurrence.
3) Qu'il n'existe aucun engagement financier ou autre, de nature à modifier la parité retenue pour la présente fusion.
4) Qu'elle a son siège de direction effective au Luxembourg, ne dispose d'aucun établissement stable en France, et est
soumise à l'impôt sur les sociétés au Luxembourg sans en être exonérée.
(b) Sur les biens apportés
1) Que le patrimoine de la société n'est menacé d'aucune confiscation ou d'aucune mesure d'expropriation.
2) Que les éléments de l'actif apporté, au titre de la fusion, notamment les divers éléments incorporels compris dans les
apports, ne sont grevés d'aucune inscription de privilège de vendeur, hypothèque, nantissement, warrant, ou gage quel-
conque, et que lesdits éléments sont de libre disposition entre les mains de la Société Absorbée, sous réserve de
l'accomplissement des formalités nécessaires pour la régularité de leur mutation.
Troisième partie. Conditions suspensives
Les présents apports faits à titre de fusion sont soumis aux conditions suspensives suivantes:
1) Approbation de la Fusion par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ELTEC MANAGEMENT S.A.,
Société Absorbée;
2) Approbation de la Fusion, par voie d'absorption de ELTEC MANAGEMENT S.A. par une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de SELTEC, qui augmentera le capital de cette dernière, en conséquence de la Fusion.
3) Obtention des certificats de conformité et de légalité délivrés par le Tribunal de Commerce de Lyon.
Le tout dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La réalisation de ces conditions suspensives sera suffisamment établie, vis-à-vis de quiconque, par la remise d'une copie
ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de chacune des délibérations des assemblées générales de SELTEC et
de ELTEC MANAGEMENT S.A. et par la délivrance des certificats de conformité et de légalité par le Greffe du Tribunal
de Commerce de Lyon.
La constatation matérielle de la réalisation définitive de la Fusion pourra avoir lieu par tous autres moyens appropriés.
Quatrième partie. Régime fiscal
Déclarations générales
Madame Françoise AULAGNE, ès-qualité, déclare que la société SELTEC est une société soumise à l'impôt sur les
sociétés en France.
Madame Cornelia METTLEN, ès-qualité, déclare que la société ELTEC MANAGEMENT SA est une société soumise
à l'impôt sur les sociétés au Luxembourg.
Les Parties déclarent en tant que de besoin que conformément aux prescriptions des instructions administratives publiées
aux Bulletins Officiels 4-I.1-93 et 4-I.2-00 de la Direction Générale des Impôts française, la présente Fusion aura, sur le
plan fiscal, la même date d'effet que sur le plan comptable, soit le 1
er
janvier 2015.
119695
L
U X E M B O U R G
Enregistrement
En application des dispositions de l'article 816-I du Code général des impôts français, l'opération de fusion absorption
de la Société Absorbée par la Société Absorbante sera soumise au droit fixe d'enregistrement de 500 euros.
Au regard des impôts directs
Les Parties déclarent placer la Fusion sous le régime de l'article 210 A du Code général des impôts français. En consé-
quence, la Société Absorbante s'engage expressément, en tant que de besoin, à respecter les prescriptions légales et,
notamment:
- à calculer les plus-values réalisées ultérieurement, à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables
qui lui sont apportées, d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée à
la Date de Réalisation;
- à reprendre à son passif, le cas échéant, les provisions de fa Société Absorbée dont l'imposition aurait été différée;
- à réintégrer dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, dans les délais et conditions fixées par l'article
210 A du Code général des impôts français, les plus-values éventuellement dégagées par la Fusion sur les biens amortis-
sables qui lui sont apportés, étant ici précisé que la cession d'un bien amortissable entraînera l'imposition immédiate de la
fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'aura pas encore été réintégrée;
- à inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal
dans les écritures de la Société Absorbée. A défaut, la Société Absorbante comprendra dans ses résultats de l'exercice au
cours duquel intervient l'opération, le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la
valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la Société Absorbée;
- à se substituer à la Société Absorbée pour la réintégration des plus-values et des résultats dont la prise en compte a été
différée pour l'imposition de cette société.
La Société Absorbante s'engage à reprendre l'ensemble des engagements qui ont pu être souscrits par la Société Absorbée
à l'occasion d'opérations antérieures d'apport partiel d'actif, de fusion, de scission, de transmission universelle de patrimoine
sans liquidation ou d'opérations assimilées, le tout de manière à ce que les sursis d'imposition et autres régimes fiscaux de
faveur découlant des engagements antérieurement pris par la Société Absorbée ne puissent pas être remis en cause.
La Société Absorbante remplira les obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies I et II du Code général des
impôts français.
Cinquième partie. Dispositions diverses
1. Formalités.
a) La Société Absorbante remplira toutes formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la
Fusion.
b) La Société Absorbante fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes admi-
nistrations qu'il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens apportés.
c) La Société Absorbante devra, en ce qui concerne les mutations de valeurs mobilières et droits sociaux qui lui sont
apportés, se conformer aux dispositions statutaires des sociétés considérées relatives aux mutations desdites valeurs et
droits sociaux.
d) La Société Absorbante remplira, d'une manière générale, toutes formalités nécessaires en vue de rendre opposable
aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
2. Désistement. Le représentant de la Société Absorbée déclare désister purement et simplement celle-ci de tous droits
de privilège et d'action résolutoire pouvant profiter à ladite société sur les biens ci-dessus apportés, pour garantir l'exécution
des charges et conditions imposées à la Société Absorbante aux termes du présent acte.
En conséquence, il dispense expressément de prendre inscription au profit de la Société Absorbée pour quelque cause
que ce soit
3. Remise de titres. Il sera remis à SELTEC, lors de la réalisation définitive de la fusion, les originaux des actes constitutifs
et modificatifs de ELTEC MANAGEMENT S.A., ainsi que les livres de comptabilité, les titres de propriété, les valeurs
mobilières, la justification de la propriété des parts et autres droits sociaux et tous contrats, archives, pièces ou autres
documents relatifs aux biens et droits apportés par ELTEC MANAGEMENT S.A. à SELTEC.
4. Frais. Tous les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la fusion, ainsi que tous ceux qui en seront la
suite et la conséquence, seront supportés par la Société Absorbante, ainsi que son représentant l'y oblige.
5. Élection de domicile. Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et pour toutes significations et notifications,
les représentants des sociétés en cause, ès-qualité, élisent domicile aux sièges respectifs desdites sociétés.
6. Pouvoirs. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour remplir toutes for-
malités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, publications et autres.
En 6 exemplaires, dont:
UN pour chaque partie,
119696
L
U X E M B O U R G
QUATRE pour les dépôts au Greffe prévus par la loi
Fait à Strassen, le 22 juin 2015.
<i>Pour la société SELTEC / Pour la société ELTEC MANAGEMENT S.A.
i>Signature / C. METTLEN
FUSION SELTEC- ELTEC MANAGEMENT
<i>Annexe I - Méthodes d'évaluationi>
1. Évaluation de la société SELTEC. La démarche utilisée pour procéder à l'évaluation des titres de la société SELTEC
a été la suivante:
1- Prise en compte du montant des capitaux propres au 31 décembre 2014, soit 1 762 681 €
2- Valorisation d'un fonds de commerce:
Aucun fonds commercial n'est inscrit à l'actif de la société SELTEC, cette dernière ayant créé son activité.
Il a été décidé de valoriser le fonds de commerce de la société SELTEC de la façon suivante
10% de la moyenne du chiffre d'affaires des trois derniers exercices, diminué de la valeur nette comptable des actifs
immobilisés nécessaires à l'exploitation.
Chiffre d'affaires
Moyenne des
chiffres
d'affaires
10% de la
moyenne des
CA
VNC des
actifs
immobilisés
Valeur du
fonds
31.12.2014
4 518 295 €
3 579 561,30 €
357 956,13 €
5 851 €
352 105,13 €
31.12.2013
3 308 843 €
31.12.2012
2 911 546 €
Par application de cette méthode, l'intégralité de la société SELTEC est valorisée à la somme de 2 114 786,13 €.
2. Évaluation de la société ELTEC MANAGEMENT S.A. La société ELTEC MANAGEMENT S.A. n'a pas d'autre
activité que de gérer sa participation dans le capital de la société SELTEC et les actions de cette dernière constituent son
seul actif immobilisé.
Compte tenu de la valorisation de la société SELTEC ci-dessus, sa participation dans le capital de ladite société (55%
des titres) est évaluée à la somme de 1 163 132,37 euros.
Eltec Management SA / SELTEC
C. Mettlen / F. AULAGNE
<i>Statuts modifiés par A.G.E du 15 novembre 2010i>
Art. 2. Dénomination sociale. La dénomination sociale est:
SELTEC
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie Immédia-
tement des mots «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S» et de L'énonciation du capital social.
Art. 3. Siège social. Le siège social est fixé:
ZAC de SACUNY - PARK AVENIR II
313 Avenue Marcel MERIEUX - Lot A1
69530 BRIGNAIS
Art. 4. Objet. La société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger:
- L'importation, l'exportation, la distribution et la vente de tous produits, sous produits, marchandises et matériels tels
que décoration, matériel électrique et électronique, ameublement, outillages.
- La signature de contrats d'agent commercial pour la distribution de tous types de produits, et particulièrement ceux se
rapportant au paragraphe précédent
Toutes opérations Industrielle et commerciales se rapportant à:
- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'instal-
lation, l'exploitation de tous établissement, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus.
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle con-
cernant lesdites activités.
- La participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, Immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet,
119697
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Durée. La société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans qui commencera à courir à
compter du Jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des
associés.
<i>Statuts modifiés par A.G.E. du 31 octobre 2005i>
<i>Statuts modifiés par A.G.E. du 20 décembre 2006i>
LES SOUSSIGNES:
Monsieur Thierry BONY
né le 29 octobre 1958 à TOURNUS (71)
demeurant 69 rue de la Passementerie, 42390 VILLARS
de nationalité Française
La Société ELTEC MANAGEMENT S.A., ayant son siège social 23, Val Fleuri, 1526 LUXEMBOURG, représentée
par Messieurs Christophe BLONDEAU, et Romain THILLENS en qualité d'administrateurs, dûment habilités à l'effet des
présentes.
Ont préalablement exposé ce qui suit:
<i>Préambulei>
Les soussignés ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par actions simplifiée qu'ils sont convenus de constituer.
Titre I
er
. Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme. La Société est une Société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par
les présents statuts.
Elle fonctionne Indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.
Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.
Art. 2. Dénomination sociale. La dénomination sociale est:
SELTEC
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédia-
tement des mots «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S,» et de l'énonciation du capital social.
Art. 3. Siège social. Le siège social est fixé:
250 RUE DU GENERAL DE GAULLE
69530 BRIGNAIS
Art. 4. Objet. La société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger:
- L'importation, l'exportation, la distribution et la vente de tous produits, sous produits, marchandises et matériels tels
que décoration, matériel électrique et électronique, ameublement, outillages
- La signature de contrats d'agent commercial pour la distribution de tous types de produits, et particulièrement ceux se
rapportant au paragraphe précédent.
Toutes opérations industrielle et commerciales se rapportant à:
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités;
- la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Art. 5. Durée. La société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans qui commencera à courir à
compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des
associés,
Titre II. Apports - Capital social - Forme des actions - Droits et obligations attachés aux actions
Art. 6. Apports. Il a été apporté à la Société par;
- la société ELTEC MANAGEMENT S.A. la somme en numéraire dé 36 000 (trente six mille) euros
- Monsieur Thierry BONY la somme en numéraire de 4 P00 (quatre mille) euros
119698
L
U X E M B O U R G
Soit au total la somme de 40 000 (quarante mille) euros.
Ladite somme correspondant à 4000 actions de 10 euros, souscrites en totalité et libérées chacune de la totalité, ainsi
que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque:
Société Générale
61 rua du docteur Charcot
42000 Saint Etianne
Cette somme de 40 000 euros a été déposée le 24 février 2004 à ladite banque pour le compte de la Société en formation.
Art. 7. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de 40 000 euros, divisé en 4 000 actions de 10 euros entièrement
libérées et de même catégorie.
Art. 8. Modifications du capital social.
1. Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant, sur le rapport du
Président.
2. Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais
prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
3. En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un
droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois,
les associés peuvent renoncer à titre Individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du
capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
4. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du
nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, dé la totalité de la prime d'émission.
Art. 9. Forme des actions. Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont Inscrites en compte conformément
à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.
Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'Inscription en compte.
Art. 10. Droits et obligations attachés aux actions.
1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité dé capital
qu'elle représente.
Pour y parvenir, il est fait masse, te cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations,pouvant être
prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu,
2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
3. Les actions sont Indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de
la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.
4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives,
sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.
5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de
titres Isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire
personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.
Titre III. Transmission des actions exclusion d'associés
Art. 11. Dispositions communes applicables aux cessions d'actions.
Définitions
Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après:
- Cession: signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-
propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir: cession, transmission, échange, apport en
société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission
universelle de patrimoine.
- Action ou Valeur mobilière: signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate
ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi
que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.
Modalités de transmission des actions
La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre
de mouvement. Ce mouvement est Inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.
Art. 12. Agrément.
1 Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote; les actions du cédant n'étant pas prises en compte
pour le calcul de cette majorité,
119699
L
U X E M B O U R G
2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au
Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les noms,
prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination,
siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, Identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément
est transmise par le Président aux associés.
3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mots à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire
connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
6. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande
d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 60 Jours de la décision d'agrément: à défaut de
réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
6. En cas de refus d'agrément, la Société est ténue dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus
d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure
ci-dessus prévue.
Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mots; l'agrément du où des cessionnaires
est réputé acquis,
En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition
de les céder ou de les annuler.
Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut
d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Art. 13. Modifications dans le contrôle d'un associé.
1. En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une Société associée celle-
ci doit en Informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai
de 30 jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes infor-
mations sur le ou les nouveaux contrôlaires.
Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrôle est modifié pourra être exclue de la Société
dans les conditions prévues à l'article 14.
2. Dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre
en oeuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la Société associée dont le contrôle a été
modifié, telle que prévue à l'article 14. Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera
réputée avoir agréé le changement de contrôle.
3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la Société associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de
fusion, de scission ou de dissolution.
Art. 14. Exclusion d'un associé.
Exclusion de plein droit
L'exclusion de plein droit Intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.
Exclusion facultative
L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants;
- violation des dispositions des présents statuts;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social;
- condamnation pénale prononcée à rencontre d'un associé;
Modalités de la décision d'exclusion
1. L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant
du droit de vote; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
2. Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président; si le Président est lui-même susceptible d'être,
exclu, les associés seront consultés à l'Initiative de l'associé le plus diligent.
Formalités de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion ne peut Intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes:
1. notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 05 jours avant la
date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure
et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion; cette notification devant également être adressée à tous les autres
associés;
119700
L
U X E M B O U R G
2. convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 10 jours avant la date prévue
pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire
valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.
Prise d'effet de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet à compter
de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les
acquéreurs de ces actions. Il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses
d'agrément prévues aux présents statuts.
La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'ini-
tiative du Président,
Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative
L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non
pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.
La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 10 jours de la décision d'exclusion à toute personne
désignée comme Il est prévu ci-dessus.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les
conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Art. 15. Nullité des cessions d'actions. Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles
12 à 13 des présents statuts sont nulles.
Au surplus, une telle cession constitue un Juste motif d'exclusion.
Titre IV. Administration et direction de la société - Conventions entre la société et ses dirigeants - Commissaires
aux comptes
Art. 16. Président de la Société. La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique
ou morale, associé ou non, de la Société,
Désignation
Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par
décision collective des associés.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne
physique.
Durée des fonctions
Le Président est nommé sans limitation de durée,
Révocation pour motifs graves à l'unanimité des associés
La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime
des associés autres que le Président, Toute révocation Intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à une
indemnisation du Président
Révocation ad nutum
Le Président peut être révoqué à tout moment sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés
prise à l'Initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 51 % du capital et des droits de vote de la Société et
statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Cette révocation n'ouvre droit à aucune Indemnisation.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas
suivants:
- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale;
- exclusion du Président associé;
- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite
personnelle du Président personne physique.
Rémunération
La rémunération du Présidant est fixée chaque année par décision collective des associés.
Pouvoirs
Le Président dirige la Société et fa représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires
pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus
par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.
Toutefois à titre de règlement Intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes
qu'après autorisation préalable de la collectivité des associés:
- Investissements supérieurs à 15 000 euros;
- Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments du fonds de commerce;
119701
L
U X E M B O U R G
- Prise ou mise en location-gérance d'un fonds de commerce;
- Acquisition et cession de participations;
- Octroi de garanties sur l'actif social;
- Abandon de créances.
Le Président peut sous sa responsabilité, consentie toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets
déterminés.
Art. 17. Directeur Général.
Désignation
Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur
Général.
Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent
personne physique.
Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.
Durée des fonctions
La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder
celle des fonctions du Président
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire
des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président
Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président.
La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune Indemnité.
En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants:
- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne
morale;
- exclusion du Directeur Général associé;
- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, Incapacité ou faillite
personnelle du Directeur Général personne physique.
Rémunération
La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte
de son contrat de travail.
La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constituent une convention réglementée soumise
à la procédure prévue à l'article 18 des statuts.
Pouvoirs
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des
mêmes pouvoirs de direction que le Président.
Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, sauf en cas de délégation
spéciale et écrite du Président.
Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social,
sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.
Art. 18. Conventions entre la Société et ses dirigeants. Toute convention intervenant, directement ou par personne
interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code
de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.
Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au
cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet
exercice.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne Intéressée d'en supporter
les conséquences dommageables pour la Société.
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Com-
missaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
Art. 19. Commissaires aux comptes. La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la
mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux
comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.
119702
L
U X E M B O U R G
Titre V. Décisions collectives des associés
Art. 20. Décisions collectives obligatoires. La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions
suivantes:
- transformation de la Société;
- modification du capital social: augmentation, amortissement et réduction;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs;
- dissolution;
- nomination des Commissaires aux comptes;
- nomination, rémunération, révocation du Président;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés;
- modification des statuts et transfert du siège social;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation;
- agrément des cessions d'actions;
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.
- autorisation des décisions du Président visées à l'article 19 des présents statuts.
Art. 21. Règles de majorité. Les décisions collectives sont prises à l'unanimité des associés.
Art. 22. Modalités des décisions collectives. Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du
Président.
Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés.
Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du
Liquidateur.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit Justifier de son Identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Art. 23. Assemblées. Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout
autre lieu mentionné dans la convocation.
Selon l'article L. 432-6-1 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en Justice la désignation d'un man-
dataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.
La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze Jours au moins avant la date de la réunion.
Elle indique l'ordre du jour.
Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.
Les associés peuvent sa faire représenter, aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.
Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 23 ci-
après.
Art. 24. Procès-verbaux des décisions collectives. Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées
par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux
sont signés par le Président de l'assemblée et parles associés présents,
Les procès-verbaux doivent Indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de séance,
l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un
résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote dé chaque
associé.
En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit
mentionner les documents et Informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et
retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus
Art. 26. Information préalable des associés. Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir
fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et Informations permettant aux associés de se pro-
noncer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.
Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des
Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 10 jours avant la date d'établissement
du procès-verbal de la décision des associés.
119703
L
U X E M B O U R G
Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au
siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des
comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de
gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.
S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux
frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.
Titre VI. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des résultats
Art. 26. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, Le
premier exercice social sera clos le 31 décembre 2004.
Art. 27. Etablissement et approbation des comptes annuels. Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.
Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels,
au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.
Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des
Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.
Art. 28. Affectation et répartition des résultats.
1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne
droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans
l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque aption supporte les pertes sociales
dans les mêmes proportions.
2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa
distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et
l'emploi.
3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau
bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en Indiquant expressément les postes de réservés sur lesquels ces prélèvements
sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.
Titre VII. Dissolution - Liquidation de la société
Art. 29. Dissolution - Liquidation de la Société. La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de
dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.
La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.
Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les
associés.
Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour
les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et
non amorti des actions.
Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est
une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, con-
formément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
Titre VIII. Contestations
Art. 30. Contestations. Clause d'arbitrage
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation
entre tes associés où entre un associé et la Société, seront soumises à l'arbitrage.
A défaut d'accord sur la désignation d'un arbitre unique, chacune des parties devra nommer dans les quinze jours de la
constatation de leur désaccord sur ce choix, un arbitre et notifier cette désignation, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception aux autres parties.
Les arbitres ainsi désignés doivent choisir un tiers arbitre.
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du Tribunal de commerce
du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre.
Les arbitres ainsi désignés statuent comme amiables compositeurs et en dernier ressort
Clause de droit commun
119704
L
U X E M B O U R G
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation
entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.
Titre IX. Constitution de la société
Art. 31. Nomination des dirigeants. Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une
durée de cinq ans est Messieurs
La société ELTEC MANAGEMENT SA, représentée par Messieurs Christophe BLONDEAU, né le 28 février 1954,
de nationalité belge, demeurant 46 route de Luxembourg, 7240 BERELDANGE et Romain THILLENS, né le 30/10/52,
de nationalité luxembourgeoise, demeurant professionnellement au 23 Val fleuri à L-1526 Luxembourg.
Lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour
leur exercice.
Art. 32. Nomination des premiers Commissaires aux comptes. Sont désignés Commissaires aux comptes de la Société
pour une durée de six exercices:
- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire:
Cabinet BEAL Audit
8 rue Bourgneuf
42000 Saint Etienne
- En qualité de Commissaire aux comptes suppléant:
ABAC
12 rue des tulipes
42000 Saint Etienne
Lesquels interviennent aux présentes à l'effet d'accepter lesdites fonctions, chacun d'eux précisant que les dispositions
légales Instituant des incompatibilités ou des Interdictions de fonctions ne peuvent lui être appliquées.
Art. 33. Formalités de publicité - Immatriculation. Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à
l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés.
«Article à ajouter seulement en cas d'existence d'actes accomplis avant la signature des statuts»
Art. 34. État des actes accomplis pour le compte de la Société en formation. Un état des actes accomplis pour le compte
de la Société en formation, avec l'Indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société est annexé
aux présents statuts. Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l'adresse du siège social.
«Si les soussignés donnent mandat pour prendre des engagements pour le compte de la Société»
Art. 35. Mandat de prendre des engagements pour le compte de la Société. Les soussignés donnent mandat à Monsieur
Thierry BONY en sa qualité de directeur commercial salarié et l'effet de prendre les engagements suivants au nom et pour
le compte de la Société:
- Ouverture d'un compte bancaire au nom de la société SELTEC
- Enregistrement des statuts au Centre des impôts compétent
- Publications légales et formalités d'inscription auprès du Greffe du Tribunal de Saint Etienne (42)
- Signature d'un contrat de bail immobilier pour la location de bureau pour la société SELTEC
- Ouverture des lignes téléphoniques au nom de la société SELTEC et réalisation des différentes démarches pour l'ou-
verture d'un compteur d'eau, d'électricité et de la boîte postale.
- Et signature de tous contrats ou abonnements permettant le démarrage opérationnel de la société SELTEC.
Fait à Villars, l'an deux mille quatre, et le trois février, en six exemplaires originaux.
Signatures
Référence de publication: 2015152102/785.
(150166707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2015.
Igorance Les Créateurs S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7217 Bereldange, 71, rue de Bridel.
R.C.S. Luxembourg B 60.817.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PINHEIRO Samantha.
Référence de publication: 2015079536/10.
(150091428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
119705
L
U X E M B O U R G
Thunderbolt Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 154.025.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of July.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) "THUNDERBOLT
PARTNERS S.A.", with registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, registered with the Trade Register and
Companies of Luxembourg section B number 154.025 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-
Joseph WAGNER, then notary residing in Sanem, on June 28
th
, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1610 of August 9
th
, 2010, and whose articles have been amended December 10, 2012 by Maître
Jean-Joseph WAGNER, prenamed, published in the Memorial C, Associations, number 488 of 27 February 2013.
The meeting is chaired by Mrs. Anaïs DEYGLUN, notary clerk, residing professionally at 66, Grand-Rue, L-8510
Redange-sur-Attert.
The chairman appoints as secretary Mrs. Barbara SCHMITT, notary clerk, residing professionally at 66, Grand-Rue,
L-8510 Redange-sur-Attert.
The meeting elects as scrutineer Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at 66, Grand-Rue, L-8510
Redange-sur-Attert.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
A) That the shareholders present or represented, the proxy-holder of the represented shareholders and the number of
shares they hold are indicated on an attendance list. This attendance list, having been signed "ne varietur" by the share-
holders, the proxy-holder of the shareholders represented and by the members of the bureau and the notary, will remain
attached to these minutes to be filed with the formality recording.
Remain annexed to this deed, the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the persons appearing
and the undersigned notary.
B) As a result of the attendance list, the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted
and may validly deliberate, as constituted on the items on the agenda.
C) That this meeting is the following agenda:
1. Transfer of the current registered office of the Company at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, with immediate effect and subsequent modification of the first sentence of the first paragraph of Article
4 of Article of Association.
2. Acceptance of the resignation of the statutory auditor of the Company and discharge.
3. Appointment of "KRD-Services S.à r.l." abbreviated "KRD" having its registered office at 79, route d'Arlon, L-1140
Luxembourg (RCS Luxembourg B 88 617) as an auditor and determination of the duration its mandate to six (6) years.
The general meeting discusses the agenda and, after deliberation, unanimously takes the following resolution:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to transfer the current registered office of the Company at 10, rue Antoine Jans, L-1820
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.
Consequently, the first sentence of the first paragraph of Article 4 will now read as follows:
Art. 4. (first paragraph, first sentence). The registered office of the Company is established in the municipality of
Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.”
<i>Second resolutioni>
The general meeting acknowledges and accepts the resignation of the current statutory auditor of the Company and grant
him full discharge accounts for the execution of its mandate to date.
<i>Third resolutioni>
The general meeting appoints «KRD-Services S.à r.l.» in abbreviated «KRD» having its registered office at 79, route
d'Arlon, L-1140 Luxembourg (RCS Luxembourg B 88.617) as statutory auditor of the Company.
His mandate will end after the annual general meeting 2021.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand fifty Euro (EUR 1,050.-).
Nothing else being on the agenda, the meeting was adjourned.
119706
L
U X E M B O U R G
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing parties, who is/are known to the notary by his/
their surname(s), name(s), civil status and residence, the said proxyholder(s) of the appearing parties signed the present
deed together with the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «THUNDERBOLT PARTNERS S.A.» ayant
son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 154.025 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER,
alors notaire de résidence à Sanem, en date du 28 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1610 du 9 août 2010 et dont les statuts ont été modifiés le 10 décembre 2012 par Maître Jean-Joseph WAGNER,
prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 488 du 27 février 2013.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, avec adresse professionnelle
au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Barbara SCHMITT, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au
66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 66,
Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.
Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
A) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur"
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est réguliè-
rement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social actuel de la Société au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, avec effet immédiat et modification subséquente de la première phrase du premier alinéa de l'article 4 des statuts.
2. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes actuel de la Société et décharge.
3. Nomination de «KRD-Services S.à r.l.» abrégé «KRD» ayant son siège social au 79, route d'Arlon, L-1140 Luxem-
bourg (RCS Luxembourg B 88.617) en tant que commissaire aux comptes et fixation de la durée de son mandat à six (6)
ans.
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social actuel de la Société au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.
En conséquence, la première phrase du premier alinéa de l'article 4 aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. (premier alinéa, première phrase). Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale prend acte et accepte la démission du commissaire aux comptes actuel de la Société et lui accorde
décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale nomme «KRD-Services S.à r.l.» abrégé «KRD» ayant son siège social au 79, route d'Arlon, L-1140
Luxembourg (RCS Luxembourg B 88.617) en tant que commissaire aux comptes de la Société.
Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.
119707
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinquante euros (1.050,- EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes
ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la requête des mêmes parties
comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants, connus du notaire par leurs noms,
prénoms usuels, état et demeures, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. DEYGLUN, B. SCHMITT, V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 27 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12516. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 29 juillet 2015.
Référence de publication: 2015130027/126.
(150138889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.
Tyson Global Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 146.762.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of June.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
The company TYSON INTERNATIONAL HOLDINGS Sàrl, a private limited liability company (société à responsa-
bilité limitée) duly organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10,
avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
101.268,
duly represented by Mr. Pablo UMBON-MANZANO, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal on 30 June 2015.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party as represented as stated here above, declared and requested the notary to record that:
I. It is the sole member (the “Sole Member”) of Tyson Global Holding Sàrl, a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, avenue de la Gare,
L-1610 Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 146.762 (the
“Company”);
II. The Company was incorporated by a deed received by the undersigned notary on 20 May 2009, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1350 dated 14 July 2009, which deed has been amended several
times and most recently on 24 June 2015, by a deed received by the undersigned notary not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations;
III. As of the date of the present deed, the Company has a corporate capital amounting to EUR 186,618,900.- represented
by 1,866,189 corporate units, each having a par value of EUR 100;
IV. It has been invited to decide on the following items:
(i) Decision to decrease the corporate capital of the Company by an amount of one hundred eighty-six million one
hundred six thousand four hundred Euros (EUR 186,106,400.-) so as to bring it from its present amount of one hundred
eighty-six million six hundred eighteen thousand nine hundred Euros (EUR 186,618,900.-) represented by one million
eight hundred sixty-six thousand one hundred eighty-nine (1,866,189) corporate units, each having a par value of one
hundred Euros (EUR 100.-), to the amount of five hundred twelve thousand five hundred Euros (EUR 512,500.-) represented
by five thousand one hundred twenty-five (5,125) corporate units, each having a par value of one hundred Euros (EUR
100.-), through the cancellation of one million eight hundred sixty-one thousand sixty-four (1,861,064) corporate units
with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each (the “Units”), held by the Sole Member (the “Capital
Decrease”);
119708
L
U X E M B O U R G
(ii) Subsequently to the cancellation of the Units, decision to repay the Sole Member an amount in cash of two hundred
four million seven hundred seventeen thousand forty US dollars (USD 204,717,040.-), being the USD equivalent of one
hundred eighty-six million one hundred six thousand four hundred Euros (EUR 186,106,400.-) (which amount corresponds
to the aggregate nominal value of the Units to be cancelled), pursuant to an exchange rate of EUR 1 for USD 1.10, without
such repayment may impair the rights of possible creditors of the Company;
(iii) Decision to amend the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association (the “Articles of Asso-
ciation”) so as to reflect the above Capital Decrease as well as the related cancellation of the Units, which paragraph shall
henceforth have the following wording:
“ Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at five hundred twelve thousand five hundred Euros (EUR 512,500.-)
represented by five thousand one hundred twenty-five (5,125) corporate units having a par value of one hundred Euros
(EUR 100.-) each”;
(iv) Decision to grant authorization to any one manager of the Company or to any one employee of Centralis S.A.,
having its offices in Luxembourg (“Centralis”), (a) to proceed to any and all formalities which may be required to effect
the Capital Decrease (including, without limitation, to update the Company's member(s) register, to determine the repay-
ment arrangements with respect to the Capital Decrease and in particular to sign and execute, in the name and on behalf
of the Company, any banking instructions accordingly) and more generally (b) to carry out any necessary action in relation
to the resolutions to be adopted by the Sole Member in the context and for the purpose of the Capital Decrease;
(v) Miscellaneous.
The Sole Member then took the following resolutions which were deemed to be in the best interest of the Company:
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolved to approve and to proceed to the Capital Decrease, i.e. to decrease the corporate capital of
the Company by an amount of one hundred eighty-six million one hundred six thousand four hundred Euros (EUR
186,106,400.-) so as to bring it from its present amount of one hundred eighty-six million six hundred eighteen thousand
nine hundred Euros (EUR 186,618,900.-) represented by one million eight hundred sixty-six thousand one hundred eighty-
nine (1,866,189) corporate units, each having a par value of one hundred Euros (EUR 100.-), to the amount of five hundred
twelve thousand five hundred Euros (EUR 512,500.-) represented by five thousand one hundred twenty-five (5,125) cor-
porate units, each having a par value of one hundred Euros (EUR 100.-), through the cancellation of one million eight
hundred sixty-one thousand sixty-four (1,861,064) corporate units with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-)
each (i.e. the Units), it holds in the Company.
The Sole Member further resolved to proceed to the cancellation of the Units.
<i>Second resolutioni>
Subsequently to the cancellation of the Units, the Sole Member resolved to approve the repayment, in its favour, of a
cash amount of two hundred four million seven hundred seventeen thousand forty US dollars (USD 204,717,040.-), being
the USD equivalent of one hundred eighty-six million one hundred six thousand four hundred Euros (EUR 186,106,400.-)
(which amount corresponds to the aggregate nominal value of the cancelled Units), according to an exchange rate of EUR
1 for USD 1.10- under arrangements to be further determined between the Company and the Sole Member, while declaring
that such repayment will not impair the rights of possible creditors of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Member resolved to amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Association to reflect the above
Capital Decrease as well as the related cancellation of Units, which paragraph shall henceforth have the following wording:
“ Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at five hundred twelve thousand five hundred Euros (EUR 512,500.-)
represented by five thousand one hundred twenty-five (5,125) corporate units having a par value of one hundred Euros
(EUR 100.-) each”;
No further amendment is to be made to this article.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Member resolved to grant any one manager of the Company or to any lawyer or any one employee of Centralis,
(a) to proceed to any and all formalities which may be required to effect the Capital Decrease (including, without limitation,
to update the Company's member(s) register, to determine the repayment arrangements with respect to the Capital Decrease
and in particular to sign and execute, in the name and on behalf of the Company, any banking instructions accordingly)
and more generally (b) to carry out any necessary action in relation to the present resolutions.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated,
are evaluated at approximately two thousand Euros (EUR 2.000,-).
119709
L
U X E M B O U R G
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English stated herewith that on request of the above appearing
party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The said deed, having been read to proxy holder, acting as here above stated, he has been signed by the latter together
with us, the notary.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois de juin.
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU:
La société TYSON INTERNATIONAL HOLDINGS Sàrl, une société à responsabilité limitée régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.268,
dûment représentée par Monsieur Pablo UMBON-MANZANO, juriste, demeurant professionnellement au Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 30 juin 2015.
Ladite procuration, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiquée ci-avant, a déclaré et demandé au notaire instrumentant d'acter ce
qui suit:
I. Elle est l'associé unique (ci-après «Associé Unique») de la société Tyson Global Holding Sàrl, une société à respon-
sabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146.762 (la
«Société»);
II. La Société fut constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 20 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1350, en date du 17 juillet 2009 et dont les statuts ont été modifiés a plusieurs reprises
et pour la dernière fois en date du 24 juin 2015, suivant acte du notaire instrumentant non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations;
III. Le capital social de la Société s'élève au jour du présent acte à 186.618.900,- EUR, représenté par 1.866.189 parts
sociales d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune.
IV. Elle a été invitée à se prononcer sur les points suivants:
(i) Décision de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-six millions cent six mille quatre
cent euros (186.106.400,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-six millions six cent dix-huit
mille neuf cent euros (186.618.900,- EUR), représenté par un million huit cent soixante-six mille cent quatre-vingt-neuf
(1.866.189) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à un montant de cinq cent douze mille
cinq cent euros (512.500,- EUR) représenté par cinq mille cent vingt-cinq (5.125) parts sociales ayant une valeur nominale
de cent euros (100,- EUR) chacune, par la suppression d'un million huit cent soixante-et-un mille soixante-quatre
(1.861.064) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune (les «Parts Sociales»), détenues par
l'Associé Unique (la «Réduction de Capital»);
(ii) Subséquemment à la suppression des Parts Sociales, décision de procéder au remboursement de l'Associé Unique
d'un montant en numéraire de deux cent quatre millions sept cent dix-sept mille quarante dollars des Etats-Unis
(204,717,040 USD), représentant l'équivalent en dollars des Etats-Unis de cent quatre-vingt-six millions cent six mille
quatre cent euros (186,106,400,- EUR) (lequel montant correspond à la valeur nominale agrégée des Parts Sociales à
supprimer), selon un taux de change de 1 EUR pour 1,10 USD, lequel remboursement sera effectué sans préjudice des
intérêts des éventuels créanciers de la Société;
(iii) Décision de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société (les «Statuts») afin de refléter la
Réduction de Capital susmentionnée ainsi que l'annulation des Parts Sociales y relative, lequel paragraphe aura désormais
la teneur suivant:
« Art. 5. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à cinq cent douze mille cinq cent euros (512.500,- EUR) représenté
par cinq mille cent vingt-cinq (5.125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune»;
(iv) Décision de donner pouvoir à tout gérant de la Société ou tout employé de Centralis S.A., dont les bureaux sont
situés à Luxembourg («Centralis») (a) d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de la Réduction de
Capital (incluant en particulier la modification du registre d'associé(s) de la Société, l'élaboration des modalités du rem-
boursement résultant de la Réduction du Capital et notamment de signer et d'exécuter, au nom et pour le compte de la
Société, toutes instructions bancaires qui pourraient être requises à cet effet) et plus généralement (b) d'effectuer toutes
119710
L
U X E M B O U R G
actions nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des résolutions devant être adoptées dans le cadre et pour les besoins de
la Réduction de Capital;
(v) Divers.
L'Associé Unique a dès lors adopté les résolutions suivantes, dans le meilleur intérêt de la Société:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'approuver et de procéder à la Réduction de Capital, i.e. de réduire le capital social de la
Société d'un montant de cent quatre-vingt-six millions cent six mille quatre cents euros (186.106.400,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de cent quatre-vingt-six millions six cent dix-huit mille neuf cents euros (186.618.900,- EUR),
représenté par un million huit cent soixante-six mille cent quatre-vingt-neuf (1.866.189) parts sociales d'une valeur nominale
de cent euros (100,- EUR) chacune, à un montant de cinq cent douze mille cinq cents euros (512.500,- EUR) représenté
par cinq mille cent vingt-cinq (5.125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, par la
suppression d'un million huit cent soixante-et-un mille soixante-quatre (1.861.064) parts sociales d'une valeur nominale de
cent euros (100,- EUR) chacune (i.e. les Parts Sociales) détenues par celui-ci.
L'Associé Unique a, à cet effet, décidé de procéder à la suppression des Parts Sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
Subséquemment à la suppression des Parts Sociales, l'Associé Unique a décidé de procéder au remboursement, en sa
faveur, d'un montant en numéraire de deux cent quatre millions sept cent dix-sept mille quarante dollars des Etats-Unis
(204,717,040 USD), représentant l'équivalent en dollars des Etats-Unis de cent quatre-vingt six millions cent six mille
quatre cents euros (186,106,400,- EUR) (lequel montant correspond à la valeur nominale agrégée des Parts Sociales ainsi
supprimées), selon un taux de change de EUR 1 pour USD 1,10 - suivant des modalités à convenir ultérieurement entre la
Société et l'Associé Unique, tout en déclarant que ce remboursement n'affectera en aucun cas les intérêts des éventuels
créanciers de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts, aux fins de refléter la Réduction
de Capital ainsi que l'annulation des Parts Sociales y relative, lequel paragraphe aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à cinq cent douze mille cinq cent euros (512.500,- EUR) représenté
par cinq mille cent vingt-cinq (5.125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune».
Aucune autre modification n'est à apporter à cet article.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de donner pouvoir à tout gérant de la Société ou tout employé de Centralis (a) d'accomplir
toutes les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de la Réduction de Capital (incluant en particulier la modification du
registre d'associé(s) de la Société, l'élaboration des modalités du remboursement résultant de la Réduction du Capital et
notamment de signer et d'exécuter, au nom et pour le compte de la Société, toutes instructions bancaires qui pourraient être
requises à cet effet) et plus généralement (b) d'effectuer toutes actions nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des présentes
résolutions.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'Anglais, a déclaré que sur la demande de la personne comparante ci-dessus,
dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte est dressé à Luxembourg, à la date d'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ès-qualités qu'il agit, le présent acte fut signé par ce dernier,
ensemble avec le notaire instrumentant.
Signé: P. UMBON-MANZANO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 2 juillet 2015. 2LAC/2015/14753. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 28 juillet 2015.
Référence de publication: 2015130008/198.
(150139839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.
119711
L
U X E M B O U R G
Somaf Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 141.335.
J'ai le regret de vous informer que je renonce par la présente à mes fonctions de commissaire aux comptes au sein de
votre société, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 23 juillet 2015.
HAMERVATE LIMITED
GORDALE MARKETING LIMITED
Signatures
Référence de publication: 2015129961/13.
(150138918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.
Soins de Jardin Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9678 Nothum, 41C, rue de kaundorf.
R.C.S. Luxembourg B 99.959.
L'an deux mille quinze, le dix-sept juillet.
Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz
A comparu:
- Monsieur Albano DA MOTA DE MAGALHAES PORTILHO, maître-jardinier, demeurant à L-9676 Noertrange, 24,
Op der Louh
- Madame Albertina MOREIRA ESCUDEIRO, jardinière, demeurant à L-9676 Noertrange, 24, Op der Louh
Lesquels comparants, présents ou tel que représentés, ont exposé au notaire:
- que la société à responsabilité limitée Soins de Jardins Sàrl a été constituée suivant acte reçu par le notaire Anja HOLTZ,
alors de résidence à Wiltz, en date du 1
er
avril 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro
539 du 25 mai 2004, dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 99.959,
- qu'elle a un capital de quinze mille euros (15.000.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales de cent cinquante
euros (150.-EUR) chacune,
- que les comparants sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée
«Soins de Jardin Sàrl» avec siège social à L-9676 Noertrange, 24, Op der Louh.
Ensuite les comparants, agissant comme prédit, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Résolution Uniquei>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de Noertrange à L-9678 Nothum, 41 C, Rue de Kaundorf
et modifie par conséquence l'article 2 des statuts, qui aura la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Lac de la Haute Sure.
Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, et des succursales pourront être créées tant
au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger sur décision des associés.»
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent
approximativement à la somme de 670 EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Da Mota De Magalhaes A., Moreira Escudeiro A., Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Diekirch, le 22 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12214. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.
Wiltz, le 29 juillet 2015.
Référence de publication: 2015129955/40.
(150138917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
119712
Agence Générale Deckenbrunnen Sàrl
Aries Invest Holding S.A.
Aries Invest Holding S.A.
Aries Invest Holding S.A.
A.T.S. LU S.à r.l.
Benelux Mezzanine 5 S.à r.l.
Brif Management S.A.
Brif Management S.A.
Brif Management S.A.
Brif Management S.A.
Caulus Luxembourg S.à r.l.
Caulus Luxembourg S.à r.l.
Caulus Luxembourg S.à r.l.
Eltec Management S.A.
Goodhart Partners Longitude Fund Sicav-SIF
Halcor S.à r.l.
Hathor Participations SA
Health Management S.A.
Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l.
Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l.
Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l.
Highwind
Holgoun International S.à r.l.
Hubs S. à r.l.
Ifore SICAV-SIF S.C.A.
Igorance Les Créateurs S.à.r.l.
Igorance S.à r.l.
Immobilix S.A.
Implex S.à r.l.
Information Technology for Translational Medicine (ITTM) S.A.
International Strategic Advisory S. à r. l.
Invenergy Clean Power Mexico S.à r.l.
IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund SCA SICAV-SIF
Kléber Luxembourg Holding S.à r.l.
Mazarine 60 SARL
Panthera/Funding Lux 1 S. à r.l.
Phimac Finances S.A.
Platinium Advisory Services Luxembourg S.à r.l.
Real Estate Property Management
Sagoma Investments S.à r.l.
Soins de Jardin Sàrl
Somaf Corporation S.A.
Sycomore Fund Sicav
Sycomore Sicav
Thunderbolt Partners S.A.
Tyson Global Holding Sàrl
Ufilug S.A.
United Investors Synergy
United Investors Synergy