logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2389

4 septembre 2015

SOMMAIRE

CBC Keto Pumps S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114648

CQS Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114636

Eaglefin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114631

Entreprise Serge Bressaglia Sàrl  . . . . . . . . . . .

114626

Food Delivery Holding 23 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

114653

GRE Gin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114667

Hermes Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

114633

Il Sipario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114669

Indiana S.A., S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114672

Logistis Germany Luxembourg 3 S.à r.l.  . . . .

114639

Majorcan Hotels Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . .

114627

Marfi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114627

Max Mara International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

114627

MBERP (Luxembourg) 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

114628

MDC Consulting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114628

Mimas International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

114626

Minacom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114627

Mitra Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114629

Mitra Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114627

ML Immo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114631

Monita S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114628

Monteferro International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

114631

Monteferro International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

114628

Moury-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114630

MRL S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114632

MTL (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

114632

Mystral Coiffure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114630

Nabuko Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114633

Neovara European Mezzanine 2004 Lux S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114630

Newcombe House Investment S.à r.l.  . . . . . . .

114629

Newcontainer No.36 (Luxembourg) Shipping

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114631

NG Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114630

NIRAAMAYA Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

114629

N.M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114629

Orbital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114632

Réalisations Immobilières Strassen S.à r.l.  . . .

114647

SPH S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114626

Stral Stockage Transports Locations S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114626

STS Medical Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

114626

Summit Partners SFB S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

114664

SW Luxembourg Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . .

114633

T-C Luxembourg Neptune Holding S.à r.l.  . .

114664

Thirem S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114639

Tivolex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114672

Tower Properties (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . .

114634

Trilantic Capital Partners V (Europe) GP S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114633

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114636

Valore VI-A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114667

Van Laar S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114672

VA No1 (Alto) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114672

114625

L

U X E M B O U R G

Entreprise Serge Bressaglia Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4959 Bascharage, 2, Zone Artisanale Am Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 62.208.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015119122/9.
(150128972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Stral Stockage Transports Locations S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 63.278.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Référence de publication: 2015118568/10.
(150127019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

STS Medical Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.853.332,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 171.172.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Référence de publication: 2015118570/10.
(150127207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

SPH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.074.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015118561/11.
(150126929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Mimas International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 123.002.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2015.

<i>Pour: MIMAS INTERNATIONAL S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015119466/14.
(150128745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

114626

L

U X E M B O U R G

Majorcan Hotels Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 96.187.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015119453/9.
(150128411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Mitra Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 117.707.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015119469/10.
(150127882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Minacom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 162.924.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MINACOM S.A.

Référence de publication: 2015119467/10.
(150128983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Marfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 69.700.

Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MARFI S.À.R.L.
ANTANI S.A.R.L.
<i>Gérant De Société

Référence de publication: 2015119456/12.
(150129110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Max Mara International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 41.757.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 de la maison-mère «MAX MARA FINANCE S.R.L.», ayant son siège

social à I-10122 TORINO - Via del Carmine 10, immatriculée sous le n° 07661520010, n° REA 909847/TORINO ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015119459/13.
(150128929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

114627

L

U X E M B O U R G

Monita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3489 Dudelange, 15, rue Mme Mayrisch de St. Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 124.824.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015119473/10.
(150128375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Monteferro International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 70.107.

Le bilan, compte pertes et profits et annexes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015119475/12.
(150128004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

MDC Consulting, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 169.819.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2015

<i>Résolution:

L'assemblée générale décide renouveler, pour une durée de 3 ans, le mandat du Commissaire Comptes, Madame Anne-

Françoise MOUTSCHEN, employée, née le 19 juillet 1969 à Verviers (Belgique), demeurant à B-4141 Louveigné, 67, rue
des Fawes;

Pour extrait analytique certifié sincère et conforme à l'orignal
C Sangiovanni
<i>Administrateur Unique

Référence de publication: 2015119463/15.
(150128349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

MBERP (Luxembourg) 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 160.785.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la tenue de l'assemblée générale de l'associé unique, du 16 avril 2015, que:
- Monsieur Walter Tocco, né le 12 Octobre 1979 à San Gavino Monreale (VS), Italy, résidant professionnellement au

412F, route d'Esch L-1030 Luxembourg, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée en remplacement de
Donatien-Xavier Martin, gérant démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 Juillet 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015119461/17.
(150127875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

114628

L

U X E M B O U R G

N.M. S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-3489 Dudelange, 15, rue Madame Mayrisch de Saint-Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 44.018.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015119483/10.
(150127862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Newcombe House Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 155.367.

<i>Extrait des minutes du conseil d'administration du 19 juin 2015

En date du 19 juin 2015, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la Société de l'adresse actuelle du 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au

2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec date effective au 23 juin 2015.

Le 9 juillet 2015.

Pour extrait analytique conforme

Référence de publication: 2015119486/13.
(150128229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

NIRAAMAYA Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 138.474.

<i>Résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 19 mai 2015:

- L'Assemblée a nommé en qualité d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels arrêtés au 31 décembre 2016:

- Mr. Gilles Verduron, domicilié au 12 

th

 floor, Kwok Kai Mansion, 164 Tung Choi Street - KLN, Hong-Kong, admi-

nistrateur,

- Mr. Giancarlo Cioffi, domicilié au 12 

th

 floor, Kwok Kai Mansion, 164 Tung Choi Street - KLN, Hong-Kong, admi-

nistrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015119515/15.
(150128752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Mitra Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 117.707.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 juillet 2015 que:
- Gestman S.A. a démissionné de son poste de commissaire.
- A été nommée au poste de Commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire:
* Gestal Sàrl, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 184722 avec siège social au 23, rue Aldringen -

L-1118 Luxembourg.

- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2017.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015119468/16.
(150127881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

114629

L

U X E M B O U R G

Neovara European Mezzanine 2004 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 101.733.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015119485/9.
(150128325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Moury-Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 19.368.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015119476/9.
(150127849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Mystral Coiffure, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 60, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 139.959.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2015119451/13.
(150128954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

NG Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.665.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Associés tenue le 9 juillet 2015

- La démission de la société GALAXIS CAPITAL LLP, en tant que gérant de catégorie A, avec effet immédiat est

acceptée;

- La démission de Monsieur Marc Limpens, en tant que gérant de catégorie B avec effet immédiat est acceptée;
- Monsieur Alexis Philippe GURDJIAN, Investment Banker, né le 10 janvier 1977 à Paris (France), qui désormais

demeure professionnellement au 64, Knightsbridge, SW1X 7JF Londres (Royaume-Uni), est nommé gérant de catégorie
A avec effet immédiat, et ce pour une durée indéterminée en remplacement de la société GALAXIS CAPITAL LLP, gérant
de catégorie A, démissionnaire.

- Monsieur Grégory GUISSARD, conseil juridique, né le 1 

er

 Août 1980 à Braine l'Alleud en Belgique qui désormais

demeure professionnellement à cette nouvelle adresse, au 118, rue du Rhône à 1207 Genève (Confédération helvétique)
change de catégorie de gérant et est nommé gérant de catégorie B, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée,
en remplacement de Monsieur Marc Limpens gérant de catégorie B démissionnaire.

Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Certifié sincère et conforme
NG INVEST S.à r.l

Référence de publication: 2015119513/23.
(150127828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

114630

L

U X E M B O U R G

ML Immo 1, Société Anonyme.

Siège social: L-9970 Leithum, 3, Wirwelt.

R.C.S. Luxembourg B 167.204.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015119470/9.
(150128856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Eaglefin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 165.362.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015119106/9.
(150128142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Newcontainer No.36 (Luxembourg) Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 144.305.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Référence de publication: 2015119487/10.
(150128516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Monteferro International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 70.107.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique tenue le 29 juin 2015 à 18h00 au siège

<i>social de la société

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de renouveler le

mandat des administrateurs et du même commissaire aux comptes pour l'exercice 2015 et de les réélire pour une nouvelle
période expirant à l'assemblée générale à tenir en 2016 et appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice 2015,
comme suit:

<i>Administrateurs de catégorie A:

- M. Giancarlo BESANA, demeurant au 64, Via Cantore, I-21020 Varese (Italie)
- Mme Mariele BERTÈ, demeurant au 76, Corso Sempione, I-20121 Milan (Italie)

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Mme Vania BARAVINI, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg
- Mme Federico FRANZINA, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg

<i>Personne chargée du contrôle des comptes:

- AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.469, commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015119474/25.
(150128003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

114631

L

U X E M B O U R G

Orbital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7217 Bereldange, 66, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 87.374.

<i>Extrait de la convention de cession de parts sociales en date du 02 juillet 2015 à Luxembourg

Il résulte de la convention de cession de parts sociales que Monsieur Bahaeddin KHUB MOHADJER, gérant en retraite,

demeurant à L-7217 Bereldange, 66, rue de Bridel

Cède
62 (soixante-deux) parts sociales de la société Orbital Sàrl, RCS B87374, avec siège social à L-7217 Bereldange, 66,

rue de Bridel

à Madame Jina JOUBINE FATEMEH, sans état, demeurant à L-7217 Bereldange, 66, rue de Bridel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2015119526/17.
(150128733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

MRL S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 181.318.

Par décision du conseil d'administration du 24 mars 2015, Monsieur Alfred GUETTI, demeurant au 8A, rue de Messancy,

L-4962 Clemency, Monsieur Giacomo DI BARI, demeurant professionnellement au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxem-
bourg, et Monsieur Philippe CHAN, demeurant professionnellement au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, ont été cooptées
au conseil d'administration avec effet au 31 mars 2015 en remplacement de Monsieur Gavin RUTLEDGE, Monsieur Martin
RUTLEDGE et Madame Diana RUTLEDGE, qui ont démissionnés avec effet au 31 mars 2015.

Leurs mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018.

Luxembourg, le 5 juin 2015.

<i>Pour: MRL S.A. SPF
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015119480/18.
(150128744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

MTL (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 186.657.

Veuillez prendre note que Candy Investments S.à r.l, une société à responsabilité limitée, ayant eu son siège social au

5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 185.304, a été dissoute et liquidée en date du 29 juin
2015 de telle sorte que désormais (i) Monsieur Nicolas Anthony Christopher Candy, ayant son adresse à The Penthouse
One Hyde Park, 100, Knightsbridge, GB - SW1X 7LJ, Londres, détient 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales
dans la Société, d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, et (ii) Monsieur Christian Peter Candy, ayant son
adresse au 20, Cornwall Terrace, Lethbridge House, GB - NW1 4QP, Londres, détient 6.250 (six mille deux cent cinquante)
parts sociales dans la Société, d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, et sont désormais les associés de la
Société.

Luxembourg, le 16 juillet 2015.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015119482/19.
(150128289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

114632

L

U X E M B O U R G

Hermes Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 179.164.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015119275/9.
(150128144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Trilantic Capital Partners V (Europe) GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.504,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 185.398.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Hana Balajkova.

Référence de publication: 2015118603/10.
(150126876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Nabuko Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 189.618.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 16. Juli 2015.

<i>Für: NABUKO INVEST S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015119505/14.
(150128902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

SW Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Jean Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 198.392.

EXTRAIT

En date du 18 juin 2015, l’ensemble des 1.000 (mille) parts sociales de la Société ont été transférées par son associé

unique 504-514 West 34 

th

 Street Corp., une société régie par les lois de l'Etat du Maryland, Etats-Unis d'Amérique, ayant

son siège social sis au c/o The Corporation Trust Incorporated, 351 West Camden Street, Baltimore, Maryland 21201,
Etats-Unis d'Amérique à Coach International Holdings, une société à responsabilité limitée, établie et existante selon la loi
luxembourgeoise, ayant son siège social sis au 2, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange (Grand-Duché de Luxembourg),
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.469.

Il en résulte que l'actionnariat de la Société est désormais composé comme suit:
- Coach International Holdings: 1.000 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015118576/20.
(150126792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

114633

L

U X E M B O U R G

Tower Properties (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 191.636.

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of June.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting, of the shareholders of Tower Properties (Luxembourg) S.ŕ r.l., a société à responsa-

bilité limitée existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 35 Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 191.636, incorpo-
rated following a deed of the undersigned notary, dated 29 October 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on 29 November 2014, number 3629 (the Company”). The articles of incorporation of the Company have
not yet been amended.

The meeting was opened with Mr. Ailton BERNARDO, director, professionally residing in Luxembourg in the chair,

who appointed as secretary Mr. Mathieu BEAUMONT, director, professionally residing in Luxembourg. The meeting
elected as scrutineer Mr. Fernando BATISTA, director, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to

record that:

I The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list which, signed by the shareholders presents, the board of the meeting, the proxies of the
represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed to the present deed and be registered therewith.

The proxies of the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the appearing parties will remain

annexed to the present deed.

II It appears from the attendance list mentioned here above, that all the shares representing the entire share capital of

the Company are duly represented at the present meeting. The shareholders present or represented declare that they have
had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

III The present meeting, at which all the whole share capital is present or represented, is regularly constituted and validly

deliberates on all the items on the agenda.

IV The agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

1 Change of the financial year of the Company, which shall henceforth begin on 1 April of each year and shall end on

31 March of the following year and subsequent change of the ending of the current financial year;

2 Subsequent amendment to the transitional provisions of the Company’s deed of incorporation and to article 22 of the

Company’s articles of association.

The extraordinary general meeting of the Company then takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders resolves to amend the financial year of the Company, which shall henceforth

begin on 1 April of each year and shall end on 31 March of the following year.

Further to the foregoing, the general meeting of the shareholders resolves that the first financial year of the Company,

which has begun on the 29 October 2014, has ended on 31 March 2015.

The current financial year of the Company which has begun on the 1 

st

 of April 2015 will end on the 31 March 2016.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting of the shareholders resolves to amend the transitional

provisions of the deed of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

<i>“Transitional provisions

1) The Company’s first financial year shall begin on the date of the Company’s incorporation and shall end on 31 March

2015.”

Moreover, the general meeting resolves to amend article 22 of the articles of association of the Company, which shall

henceforth read as follows:

“ Art. 22. The Company’s financial year shall begin on first April of each year and shall terminate on thirty-first March

of the following year.”

There being no further business, the meeting is closed.

114634

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the

appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux-mille quinze, le seize juin.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de Tower Properties (Luxembourg) S.ŕ r.l., une société à responsa-

bilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 35 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191.636, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations le 29 novembre 2014 sous le numéro 3629 (la «Société»). Les statuts n’ont pas été modifiés.

L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Ailton BERNARDO, admi-

nistrateur, résidant professionnellement à Luxembourg qui a désigné comme secrétaire Monsieur Mathieu BEAUMONT,
administrateur, résidant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée générale a choisi comme scrutateur Monsieur Fernando BATISTA, administrateur, résidant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée générale extraordinaire ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d’acter

que:

I. Les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent

sont renseignés sur une liste de présence, signée par les associés présents, le bureau de l'assemblée, les mandataires des
associés représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également

annexées au présent acte.

II. Toutes les parts sociales représentant l’entièreté du capital social étant représentées à la présente assemblée, il a pu

être fait abstraction des convocations d’usage, les associés représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social de la Société est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:

<i>Ordre du jour

L’assemblée générale extraordinaire de la Société prend les résolutions suivantes:
1. Modification de l’exercice social de la Société, qui commencera désormais le 1 

er

 avril de chaque année et se terminera

le 31 mars de l’année suivante et modification subséquente de la date de fin de l’exercice social en cours;

2. Modification subséquente des dispositions transitoires de l’acte de constitution de la Société et de l’article 22 des

statuts de la Société. L’assemblée générale extraordinaire de la Société prend alors les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la Société décide de modifier l’exercice social de la Société, qui commencera

désormais le 1 

er

 avril de chaque année et se terminera le 31 mars de l’année suivante.

Suite à ce qui précède, l’assemblée générale extraordinaire de la Société décide que le premier exercice social de la

Société, qui a commencé le 29 octobre 2014, s’est terminé le 31 mars 2015, et que l’exercice social en cours qui a commencé
le 1 

er

 avril 2015 s’achèvera le 31 mars 2016.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale extraordinaire de la Société décide de modifier les

dispositions transitoires de l’acte de constitution de la Société qui seront désormais lues comme suit:

<i>«Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 mars 2015.»

114635

L

U X E M B O U R G

L’assemblée générale décide également de modifier l’article 22 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur

suivante:

« Art. 22. L’année sociale commence le premier avril de chaque année et se termine le trente-et-un mars de l’année

suivante.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille Euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandant des

comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu'à la demande du mandant des
mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. BERNARDO, M. BEAUMONT, F. BATISTA et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 18 juin 2015. 1LAC/2015/18994. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015118600/126.
(150127461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.210.

<i>Extrait de la résolution prise par le Conseil d'Administration de la Société en date du 12 mai 2015

Le Conseil d'Administration de la Société décide d'acter la démission de Monsieur Mario CUENI, en tant que membre

du Conseil d'Administration de la Société, à la date du 31 mai 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2015118652/13.
(150126374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

CQS Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 115.191.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of June.
Before Us Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of CQS Finance S.A. (the Company), a public limited liability

company (société anonyme), established and existing under Luxembourg law, with registered office at 9, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Re-
gister under number B 115191, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on March 2, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1105, of June 7, 2006, and whose articles of association have last been amended pursuant to a deed of Maître Francis
Kesseler, then notary then residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated September 19, 2014, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3211, dated November 3, 2014 (the Articles).

The meeting is chaired by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, with professional address at Pétange,

Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Laetitia ZUANEL, employee, with professional address at Pétange.
The meeting elected as scrutineer Mrs Laetitia ZUANEL, employee, with professional address at Pétange.

114636

L

U X E M B O U R G

The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented by virtue of two (2) proxies given under private seal on June 2015, and

the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the
undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Company, presently set at twenty-four million eight hundred twenty-seven thousand one hundred ten United States Dollars
(USD 24.827.110,00) are present or represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly
decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase the Company’s subscribed share capital by an amount of ten United States Dollars (USD 10,00) in order to

raise it from its present amount of twenty-four million eight hundred twenty-seven thousand one hundred ten United States
Dollars (USD 24.827.110,00) to twenty-four million eight hundred twenty-seven thousand one hundred twenty United
States Dollars (USD 24.827.120,00) by the creation and issuance of one (1) new ordinary share, with a nominal value of
ten United States Dollars (USD 10,00), vested with the same rights and obligations as the existing shares (the New Share);

2. Amendment of article 5 paragraph 1 of the Articles to give it henceforth the following wording:

“ Art. 5. The subscribed capital is set at twenty-four million eight hundred twenty-seven thousand one hundred twenty

United States Dollars (USD 24.827.120,00) represented by three thousand (3.000) ordinary shares (the Ordinary Shares),
twenty (20) category B shares (the Category B Shares), and two million four hundred seventy-nine thousand six hundred
ninety-two (2.479.692) category C shares (the Category C Shares), all of ten United States Dollars (USD 10,00) each,
carrying one voting right each in the general shareholders meetings.”

IV. The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the Company’s share capital by an amount of ten United States Dollars (USD 10,00)

in order to raise it from its present amount of twenty-four million eight hundred twenty-seven thousand one hundred ten
United States Dollars (USD 24.827.110,00) to twenty-four million eight hundred twenty-seven thousand one hundred
twenty United States Dollars (USD 24.827.120,00) by the creation and issuance of one (1) new ordinary share, with a
nominal value of ten United States Dollars (USD 10,00), vested with the same rights and obligations as the existing shares
(the New Share).

<i>Subscription - Payment

CQS Cayman Limited Partnership, resolves to subscribe the New Share, and to fully pay it up for an aggregate amount

of forty million United States Dollars (USD 40.000.000,00) corresponding to the nominal value of the New Share in the
amount of ten United States Dollars (USD 10,00) and the share premium related thereto in the amount of thirty-nine million
nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety United States Dollars (USD 39.999.990,00) by contribution in cash
in the same amount. The amount of forty million United States Dollars (USD 40.000.000,00) has been fully paid up in cash
and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend article 5 paragraph 1 of the Articles, to give it henceforth the following wording:

“ Art. 5. The subscribed capital is set at twenty-four million eight hundred twenty-seven thousand one hundred twenty

United States Dollars (USD 24.827.120,00) represented by three thousand (3.000) ordinary shares (the Ordinary Shares),
twenty (20) category B shares (the Category B Shares), and two million four hundred seventy-nine thousand six hundred
ninety-two (2.479.692) category C shares (the Category C Shares), all of ten United States Dollars (USD 10,00) each,
carrying one voting right each in the general shareholders meetings.”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified that the conditions provided for in article 26 of the Law, have

all been complied with.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the

above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.
The document having been read to the members of the bureau and to the proxy holder of the appearing persons, who

are known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present
deed.

114637

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L’an deux mille quinze, le vingt-neuf juin.
Par-devant nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

S’est tenue

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CQS Finance S.A. (ci-après la Société), société anonyme de

droit luxembourgeois dont le siège est sis au 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115191, constituée suivant
acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 2 mars 2006 et
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1105, du 7 juin 2006, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte de Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 19 septembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3211,
en date du 3 novembre 2014 (ci-après les Statuts).

L’assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, ayant son adresse profession-

nelle à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

La présidente a désigné Madame Laetitia ZUANEL, employée, ayant son adresse professionnelle à Pétange, Grand-

Duché de Luxembourg.

L’assemblée a désigné Madame Laetitia ZUANEL, employée, ayant son adresse professionnelle à Pétange, Grand-

Duché de Luxembourg.

La présidente a requis le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires sont présents ou représentés en vertu de deux (2) procurations remises sous seing privé en juin

2015, et que le nombre de leurs actions est indiqué sur une liste de présence, signée par la présidente, le secrétaire, le
scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que les procurations seront enregistrées dans le présent procès-verbal.

II. Comme l’indique ladite liste de présence, les détenteurs de toutes les actions en circulation représentant la totalité

du capital social de la Société, actuellement fixé à vingt-quatre millions huit cent vingt-sept mille cent dix Dollars Amé-
ricains (USD 24.827.110,00), sont présents ou représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut valablement se prononcer sur l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour.

V. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix Dollars Américains (USD 10,00) pour le faire passer

de son montant actuel de vingt-quatre millions huit cent vingt-sept mille cent dix Dollars Américains (USD 24.827.110,00)
à vingt-quatre millions huit cent vingt-sept mille cent vingt Dollars Américains (USD 24.827.120,00) par la création et
l’émission d’une nouvelle action ordinaire d’une valeur nominale de dix Dollars Américains (USD 10,00), investie des
mêmes droits et obligations que les actions existantes (la Nouvelle Action);

2. Modification de l’article 5, paragraphe 1, des Statuts, afin de lui conférer désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à vingt-quatre millions huit cent vingt-sept mille cent vingt Dollars Américains

(USD 24.827.120,00) représentés par trois mille (3.000) actions ordinaires (ci-après dénommées les Actions Ordinaires),
vingt (20) actions de catégorie B (ci-après dénommées les Actions de Catégorie B), et deux millions quatre cent soixante-
dix-neuf mille six cent quatre-vingt-douze (2.479.692) actions de catégorie C (ci-après dénommées les Actions de Catégorie
C), possédant chacune un montant unitaire de dix Dollars Américains (USD 10,00), et assorties chacune d’un droit de vote
lors des assemblées générales d’actionnaires.»

VI. L’assemblée, après délibération, adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix Dollars Américains (USD 10,00)

pour le faire passer de son montant actuel de vingt-quatre millions huit cent vingt-sept mille cent dix Dollars Américains
(USD 24.827.110,00) à vingt-quatre millions huit cent vingt-sept mille cent vingt Dollars Américains (USD 24.827.120,00)
par la création et l’émission d’une nouvelle action ordinaire d’une valeur nominale de dix Dollars Américains (USD 10,00),
investie des mêmes droits et obligations que les actions existantes (la Nouvelle Action).

<i>Souscription - Libération

CQS Cayman Limited Partnership, décide de souscrire à la Nouvelle Action d’une valeur totale de dix Dollars Améri-

cains (USD 10,00), et de la libérer intégralement pour un montant total de quarante millions de Dollars Américains (USD
40.000.000,00), correspondant à la valeur nominale de la Nouvelle Action d’un montant de dix Dollars Américains (USD
10,00) ensemble avec la prime d’émission liée à celle-ci d’un montant de trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix Dollars Américains (USD 39.999.990), par un apport en numéraire du même montant.

Le montant de quarante millions de Dollars Américains (USD 40.000.000,00) a été intégralement libéré et se trouve dès

à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

114638

L

U X E M B O U R G

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5, paragraphe 1, des Statuts, afin de lui conférer désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à vingt-quatre millions huit cent vingt-sept mille cent vingt Dollars Américains

(USD 24.827.120,00) représentés par trois mille (3.000) actions ordinaires (ci-après dénommées les Actions Ordinaires),
vingt (20) actions de catégorie B (ci-après dénommées les Actions de Catégorie B), et deux millions quatre cent soixante-
dix-neuf mille six cent quatre-vingt-douze (2.479.692) actions de catégorie C (ci-après dénommées les Actions de Catégorie
C), possédant chacune un montant unitaire de dix Dollars Américains (USD 10,00), et assorties chacune d’un droit de vote
lors des assemblées générales d’actionnaires.»

L'ordre du jour étant épuisé, l’assemblée a été ajournée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié que les conditions prévues par l’article 26 de la Loi ont été observées.
La partie soussignée, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu'à la requête du mandataire des com-

parants susvisés, le présent acte est libellé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes personnes
et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, a été fait et passé à Pétange, à la date figurant en tête des présentes.
Après lecture faite aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms,

état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Zuanel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 juillet 2015. Relation: EAC/2015/15608. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015120015/151.
(150129041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Logistis Germany Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Thirem S.à r.l.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 195.860.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of June.
Before the undersigned, Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED

LOGISTIS Germany Luxembourg S.à r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed

by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 185.747;

here represented by Isabelle MANGEL, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given privately on

24 June 2015.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Thirem S.à r.l. (the "Company"), a private

limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of com-
merce and companies under number B 195.860, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Henri HELLINCKX,
notary, residing in Luxembourg, dated 26 March 2015, the articles of association of which (the "Articles") have been
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1338, page 64210, dated 23 May 2015. The
Articles of the Company have not been amended since its incorporation.

The appearing party, representing the whole corporate capital, requires the notary to act the following resolution taken

in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915,
as amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the
general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn
up in writing:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to restate the Articles which shall henceforth read as follows:

114639

L

U X E M B O U R G

1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of "LOGISTIS

Germany Luxembourg 3 S.à r.l." (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial
companies as amended from time to time (the "1915 Law").

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution

of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including
Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which

would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such  time  as  the  situation  becomes  normalised;  such  temporary  measures  will  not  have  any  effect  on  the  Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Objects.
3.1 The Company's object is:
3.1.1 buying or holding shares, securities or units in one or more Real Estate Companies;
3.1.2 granting financing to Real Estate Companies provided they are, directly or indirectly via one or more Real Estate

Companies, controlled by the Company; and/or

3.1.3 buying Real Estate and developing, administering, operating, renting Real Estate held by it.
3.2 For the purpose of this clause, "Real Estate" shall comprise:
3.2.1 direct title to property (consisting of land and/or buildings);
3.2.2 any similar right in rem over property (consisting of land and/or buildings);
3.2.3 other assets that are necessary to operate the assets within the meaning of lit. 3.2.1 to 3.2.2.
3.3 For the purpose of this article, "Real Estate Company" means any company or partnership whose object (according

to its articles of incorporation or other constituent documents) in substance corresponds to the Company's object.

3.4 The Company can perform all operations and transactions which it deems necessary to fulfil its object as well as all

operations that facilitate the accomplishment of its object, including:

3.4.1 transactions to hedge interest and/ or currency exchange risks,
3.4.2 transactions to finance and/or refinance its own debts or Real Estates or Real Estates held by the Company, as the

case may be as joint and/or several co-debtor together with other companies controlling (or controlled by) the Company
or being with the Company under joint control, through any form of borrowing, including but not limited to, the obtaining
of credit facility and issue of debt instruments;

3.4.3 as well as granting security interest and/or guarantee to secure its own debts and/or debts of companies controlling

(or controlled by) the Company or being with the Company under joint control,

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law, without due authorisation under Luxembourg
Law.

4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand

five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Share-
holders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium

paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities

in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of

114640

L

U X E M B O U R G

any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of
doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.4 All Shares have equal rights.
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the

Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that repre-
sentative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other
payment rights.

7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders

holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding

at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by
article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'

Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil

de gérance (the "Board of Managers").

8.4 A Manager may be removed at any time for any legitimate reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance

with Luxembourg Law and these Articles.

9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the

Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to represent

and/or bind the Company:

10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, any two Managers.
10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.

11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers

may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent’s powers
and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of its agency.

12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers

shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or

any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's

Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or
participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of

conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons partici-
pating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way

114641

L

U X E M B O U R G

is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to
Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed
to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of managers (or
their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)

shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by any Manager present at the Meeting and extracts of the minutes

of a Board Meeting may be certified by any Manager present at the Meeting.

13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by

Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution
may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their

participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered

Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing
three quarters of the Shares.

13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint

the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.

13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying

with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.8
13.8.1 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed

by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the precise
wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.

13.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis

mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall be
no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall
be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission
or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8.1 and the above
provisions of Article 13.8.2, irrespective of whether all shareholders have voted or not.

14. Business year. The Company’s financial year starts on 1 

st

 January and ends on the 31 

st

 December of each year

provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and
ends on the following 31 

st

 December (all dates inclusive).

15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be

deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders

declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.

15.3 The Sole Manager or the Board of Managers, as appropriate, may decide to pay interim dividends to the Shareholder

(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles
and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant
Shareholder(s).

16. Dissolution and liquidation.  The  liquidation  of  the  Company  shall  be  decided  by  the  Shareholders'  meeting  in

accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder

114642

L

U X E M B O U R G

may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.

17. Interpretation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,

state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications)

thereof.

17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general

words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular
class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;

17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.»

<i>Declaration and costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU

LOGISTIS Germany Luxembourg S.à r.l (la "Société"), une société à responsabilité de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 185.747,

ici représentée par Isabelle MANGEL résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée

sous seing privé le 24 juin 2015.

Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

attachée au présent acte pour être soumise aux autorités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de Thirem S.à r.l. (la "Société"), une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, imma-
triculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.860, constituée par un acte
notarié de Maître Henri HELLINCKX, notaire résidant à Luxembourg, en date du 26 mars 2015, dont les statuts (les
"Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 23 mai 2015, numéro 1338, page 64210.
Les Statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, requiert le notaire d'acter la résolution suivante prise

conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915,
telle que modifiée, en vertu duquel un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs dévolus
à l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront actées dans des procès-verbaux
ou prises par écrit:

<i>Résolution unique

L'Associé Unique décide de refondre les Articles qui se liront dorénavant comme suit:

1. Forme sociale et nom. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de "LOGISTIS Germany Luxembourg

3 S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg,
y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").

114643

L

U X E M B O U R G

2. Siège social.
2.1 La siège social de la Société (le "Sičge Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) le Gérant Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si la Société est gérée à ce moment là par un Gérant Unique; ou
(b) le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si la Société est gérée à ce moment là par un Conseil de Gérance;

ou

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une

résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") passée conformément à ces Statuts - y compris l'Article
13.4 - et les lois du Grand-Duché de Luxembourg de temps à autre, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").

2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à

compromettre l'activité normale au Siège Social se produiraient ou seraient jugés imminents, le Siège Social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provi-
soires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège
Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l’étranger sera prise par le Gérant
Unique ou le Conseil de Gérance de la Société selon le cas.

2.4  La  Société  peut  avoir  des  bureaux  et  des  succursales  à  la  fois  au  Grand-Duché  de  Luxembourg  tout  comme  à

l’étranger.

3. Objets.
3.1 La Société a pour objet:
3.1.1 l'acquisition ou la détention de parts, actions ou autres titres de participation dans une ou plusieurs Sociétés Im-

mobilières;

3.1.2 la conclusion de financement au profit de Sociétés Immobilières contrôlées par la Société, que ces Sociétés Im-

mobilières soient détenues directement ou indirectement à travers une ou plusieurs Sociétés Immobilières; et/ou

3.1.3 l'acquisition d'Immeubles ainsi que le développement, l'administration, l'exploitation, la location d'Immeubles

qu'elle détient.

3.2 Pour les besoins de cet article, le terme "Immeuble" inclut:
3.2.1 des biens immobiliers (terrains et/ou immeubles) en pleine propriété;
3.2.2 tous droits réels similaires sur des biens immobiliers (terrains et/ou immeubles);
3.2.3 tous autres biens nécessaires à l'exploitation des biens visés aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.2 ci-dessus.
3.3 Pour les besoins de cet article, le terme "Sociétés Immobilières" signifie toute société ou groupement dont l'objet

(tel que défini par ses statuts ou ses autres documents constitutifs) correspond en substance à l'objet social de la Société.

3.4  La  Société  pourra  également  conclure  toutes  opérations  ou  transactions  qu'elle  considérera  nécessaires  pour  la

réalisation de son objet ainsi que toutes opérations qui faciliteraient l'accomplissement de son objet, y compris:

3.4.1 des transactions afin de procéder à la couverture de taux d'intérêts et/ou de risques liés au taux de change;
3.4.2 des transactions afin de financer et/ou refinancer ses propres dettes ou Immeubles ou les Immeubles détenus par

la Société, le cas échéant en qualité de co-débiteur conjoint et/ou solidaire avec d'autres sociétés contrôlant (ou contrôlées
par) la Société ou étant avec la Société sous contrôle commun, par voie de toute forme d'emprunt, y compris mais sans être
limité à, la prise d'une ligne de crédit et l'émission d'instruments de dette;

3.4.3 ainsi que la constitution de toutes sûretés et/ou garanties pour garantir ses propres dettes et/ou des dettes dues par

des sociétés contrôlant (ou contrôlées par) la Société ou étant avec la Société sous contrôle commun,

A CONDITION TOUJOURS que la Société n'entre pas dans une transaction qui pourrait constituer une activité régle-

mentée du secteur financier ou requérir une licence professionnelle en vertu de la Loi Luxembourgeoise, sans autorisation
de droit en vertu de la Loi Luxembourgeoise.

4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq

cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents
Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit être interprété confor-
mément.

5.2 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par le(s) Associé(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.

5.3 La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres apports sans émettre de Parts Sociales ou autres titres

en contrepartie de l'apport et peut affecter les apports à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de tels

114644

L

U X E M B O U R G

comptes doivent être prises par le(s) Associé(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Pour éviter tout
doute, toute décision peut, mais ne doit pas nécessairement, allouer tout montant apporté à l'apporteur.

5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.5 La Société peut racheter et/ou annuler ses propres Parts Sociales sous réserve des dispositions y afférentes de la Loi

de 1915.

6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Part

Sociale notifient par écrit à la Société celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société considérera
ce représentant comme s'il était le seul Associé pour la Part Sociale en question, y compris pour les besoins de vote,
dividende et autres droits de paiement.

7. Cession de parts sociales.
7.1 Au cours de la période durant laquelle la Société a un seul Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.
7.2 Au cours de la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés:
7.2.1 les Parts Sociales ne peuvent pas être cédées, sauf pour raison de décès, à d'autres personnes que des Associés à

moins que les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales n'aient accepté la cession en assemblée générale;

7.2.2 les Parts Sociales ne peuvent pas être transmises pour raison de décès à d'autres personnes que les Associés sauf

si les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales détenues par les survivants ont accepté la cession ou que
les conditions prévues par l'article 189 de la Loi de 1915 sont remplies;

7.2.3 la cession de Parts Sociales est sujette aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

8. Administration.
8.1 La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution des

Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

8.2 Si la Société est administrée à un moment par un seul Gérant, il sera désigné dans les présents Statuts comme le

"Gérant Unique".

8.3 Si la Société est administrée de temps à autre par plus d'un Gérant, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil

de Gérance").

8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment pour toute raison légitime par une Résolution des Associés prise

conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, quand la Société est administrée par un seul Gérant, ou en cas de pluralité

de Gérants, le Conseil de Gérance, aura tous pouvoirs pour prendre tout ou partie des actions qui sont nécessaires ou utiles
à la réalisation de l’objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise et
les présents Statuts comme devant être décidées par les Associés.

10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, les personnes

suivantes sont autorisées à représenter et/ou engager la Société:

10.1 si la Société est administrée par un Gérant Unique, le Gérant Unique;
10.2 si la Société est administrée par plus d'un Gérant, deux de ces Gérants;
10.3 toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué conformément à l'Article 11.

11. Mandataire des gérants. Le Gérant Unique ou, si la Société a plus d'un Gérant, le Conseil de Gérance pourra déléguer

n'importe lesquels de leurs pouvoirs pour accomplir des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et devront
déterminer les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires ainsi que leur rémunération (le cas échéant), la durée de la
période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de leur mandat.

12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le

Conseil de Gérance peut nommer un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans

respecter tout ou partie des exigences et formalités de convocation si tous les Gérants ont renoncé aux exigences et formalités
de convocation en question que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil concernée, en personne ou par l'inter-
médiaire d'un représentant autorisé.

12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un gérant) pour le représenter (le "Représentant du Gérant")

lors d'une Réunion du Conseil, participer, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonctions en son nom lors de la Réunion
du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance à la condition que (sans préjudice quant
à tout quorum requis) au moins deux Gérants soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne
ou participe en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'Article 12.5.

114645

L

U X E M B O U R G

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si la majorité des Gérants sont

présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à la majorité simple.

12.5 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peuvent valablement participer à une Réunion du Conseil par voie

d’utilisation de conférence téléphonique, vidéo conférence ou tous autres moyens de communication à condition que toutes
les personnes participant à une telle réunion soient en mesure de s'entendre et de parler tout au long de la réunion. Une
personne participant de cette manière est réputée être présente en personne à la réunion et devra être comptée dans le quorum
et sera autorisée à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toutes les affaires qui sont traitées de cette manière par
les Gérants seront réputées pour les besoins des présents Statuts, valables et effectivement conclues à une Réunion du
Conseil, nonobstant le fait qu'un nombre inférieur de Gérants (ou leurs représentants) tels que requis pour constituer un
quorum aient été physiquement présents au même endroit.

12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou s'agissant de tout Gérant, le Représentant du Gérant) est

valable et effective comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et pourra consister
en un ou plusieurs document(s) ayant le même contenu et signé(s) par ou au nom du ou des Gérant(s) concerné(s).

12.7 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil devront être signés par tout Gérant présent à la Réunion et les extraits

de ces procès-verbaux pourront être certifiés par tout Gérant présent à la Réunion.

13. Résolutions des associés.
13.1 Chaque Associé a droit à un vote pour chaque Part Sociale dont il est le détenteur.
13.2 Sous réserve des dispositions prévues aux Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valables

uniquement si elles sont adoptées par les Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si ce chiffre n'est
pas atteint lors de la première assemblée ou lors de la première consultation écrite, les Associés devront être convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la majorité des votes émis,
quel que soit le nombre de Parts Sociales représentées.

13.3 Les Associés ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa

participation dans la Société sans un vote unanime de tous les Associés.

13.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 13.3, toute résolution modificatrice des présents Statuts (y compris

le changement de Siège Social), sous réserve de toute disposition contraire, doit être adoptée à la majorité en nombre des
Associés représentant les trois quarts des Parts Sociales.

13.5 Une résolution pour dissoudre la Société, déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou nommer les

liquidateurs doit être adoptée conformément à la Loi Luxembourgeoise.

13.6 Une réunion des Associés (la "Assemblée Générale") peut valablement débattre et prendre des décisions sans

respecter  tout  ou  partie  des  exigences  et  formalités  de  convocation  si  tous  les  Associés  ont  renoncé  aux  exigences  et
formalités de convocation en question, que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale concernée, en personne ou
par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

13.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout autre

moyen similaire) un mandataire ou un représentant, lequel ne doit pas nécessairement être un Associé.

13.8
13.8.1 S’il y a moins de vingt-cinq Associés dans la Société, les Assemblées Générales pourront être adoptées par voie

de résolutions écrites des Associés plutôt que lors d'une Assemblée Générale à la condition que chaque Associé reçoive le
texte précis des résolutions ou décisions à adopter et donne son vote part écrit.

13.8.2 La majorité requise pour l'adoption de résolutions par une Assemblée Générale s'applique mutatis mutandis à

l'adoption de résolutions écrites des Associés. Sauf si requis par la Loi Luxembourgeoise, il n'y aura pas de quorum pour
l'adoption de résolutions écrites des Associés. Les résolutions écrites des Associés sont valablement prises immédiatement
après la réception par la Société des exemplaires originaux (ou des copies envoyées par télécopieur ou des pièces jointes
aux courriels) des votes des Associés sous réserve des exigences prévues à l'article 13.8.1 et les dispositions ci-dessus de
l'article 13.8.2, indépendamment du fait si tous les Associés ont voté ou pas.

14. Exercice comptable.
14.1 L'exercice comptable de la Société débute le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année à condition

que, comme mesure transitoire, le premier exercice comptable de la Société débute à la date de son incorporation et se
termine le 31 décembre suivant (toutes les dates incluses).

15. Distribution sur parts sociales.
15.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent (5%) seront

prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que le montant
de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital nominal de la Société.

15.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par résolutions des Associés

déclarer des dividendes en conformité avec les droits respectifs des Associés.

15.3 Le Gérant unique ou le Conseil de Gérance peut, le cas échéant, décider de payer des dividendes intérimaires à ou

aux Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants

114646

L

U X E M B O U R G

sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, le cas échéant, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie en vertu de la Loi de 1915 ou des présents
Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés puissent être
recouvrées auprès du ou des Associé(s).

16. Dissolution et liquidation. La liquidation de la Société sera décidée par une Assemblée Générale en conformité avec

la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13. Dans le cas où la Société n'aurait qu'un Associé, cet Associé pourra, à son gré,
décider de liquider la Société en reprenant à son compte l'ensemble des actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.

17. Interprétation et loi Luxembourgeoise.
17.1 Dans ces Statuts:
17.1.1 une référence à:
a) un genre doit inclure chaque genre;
b) (à moins qu'il n'en soit disposé autrement en raison du contexte) le singulier inclus le pluriel et vice versa;
c) une "personne" inclut une référence à une personne physique, une firme, une société, une personne morale ou toute

autre entité, gouvernement, état ou agence d'état ou toute joint-venture, association ou partnership, comité d'entreprise ou
un organe représentatif des salariés (ayant ou non un personnalité morale distincte);

d) une disposition légale ou une loi comprend toutes les modifications de celles-ci et tous ses reconstitutions (avec ou

sans modifications).

17.1.2 les mots "inclure" et "en ce compris" seront réputés être suivis mots "sans limitation" et il ne doit pas être donné

un sens restreint aux termes généraux parce qu'ils sont suivis ou précédés par des mots indiquant une catégorie particulière
de catégorie d'actes, d'objets ou de choses ou par des exemples entrant dans les termes généraux;

17.1.3 les majuscules dans ces Statuts n'affectent pas leur interprétation ou leur construction.
17.2 En complément de ces Statuts, la Société est également régie par toutes les dispositions applicables de la Loi

Luxembourgeoise.»

<i>Déclaration et frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ mille euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire,

le présent acte.

Signé: I. MANGEL et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 26 juin 2015. 1LAC/2015/19842. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015118593/457.
(150127457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Réalisations Immobilières Strassen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 28.322.

<i>Extrait des décisions collectives des associés prises en date du 08 juin 2015

Les associés ont décidé de renouveler le mandat de la société Fiduciaire Cabexco S.à r.l., ayant son siège social à L-8399

Windhof, 2, rue d'Arlon, enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 139890, en tant que commissaire aux comptes
pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire en relation avec les comptes de l'exercice 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015119593/13.
(150128323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

114647

L

U X E M B O U R G

CBC Keto Pumps S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 174.942.

In the year two thousand and fifteen, on the seven day of July.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the unitholders (the “Members”) of the company “CBC Keto Pumps

S.à r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office (siège social) at
8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 174.942 (the “Company”).

The Meeting was presided by Mr. Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster (the “Chairman”).
The Chairman appointed Mrs. Delia NITESCU, lawyer, residing professionally in Luxembourg, as Secretary.
The Meeting elected Mr. Davide GIACOMONI, lawyer, residing professionally in Luxembourg, as Scrutineer. The

bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Acknowledgment of the resignation of Mr. Andrew Philip John COLLINS from his mandate as manager of the

Company and granting to him full discharge (quitus) with respect to his mandate as manager of the Company with effect
from May 28, 2015 (the “Effective Date”);

2. Acknowledgment of the waiver of the rights set out in clauses 6.1 (c) (1) and (2) of shareholders’ agreement of the

Company originally dated 18 December 2012 (the “Shareholders’ Agreement”) and consideration and, if thought fit, de-
cision to not appoint a new manager of the Company in replacement of Mr. Andrew Philip John COLLINS;

3. Increase of the corporate capital of the Company by contribution in cash so as to bring it from its present amount of

GBP 44,876 (forty-four thousand eight hundred and seventy-six Pounds Sterling) represented by 44,876 (forty-four thou-
sand eight hundred and seventy-six) corporate units each having a nominal value of one GBP 1 (one Pound Sterling),
divided into 4,868 (four thousand eight hundred and sixty-eight) class A to H and 4,894 (four thousand eight hundred and
ninety-four) class I and 1,038 (one thousand and thirty-eight) class J corporate units, to an amount of GBP 132,524 (one
hundred and thirty two thousand five hundred and twenty four Pounds Sterling) represented by 132,524 (one hundred and
thirty two thousand five hundred and twenty four) corporate units each having a nominal value of one GBP 1 (one Pound
Sterling), by issuance of 9,738 (nine thousand seven hundred and thirty eight) class A to H corporate units and 9,744 (nine
thousand seven hundred and forty four) class I corporate units having a nominal value of GBP 1 (one Pound Sterling) each
and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company, such new corporate units to
be subscribed by Clyde Blowers Capital Fund III LP, a limited partnership, having its registered office at 1, Redwood
Crescent,  Peel  Park,  East  Kilbride,  United  Kingdom,  registered  with  Companies  House  under  the  company  number
SL008995 ("CBC") together with an aggregate share premium amounting to GBP 10,912,352 (ten million nine hundred
and twelve thousand three hundred and fifty two Pound Sterling);

4. Waiver of the preferential subscription right by each other unitholder of the Company, where appropriate and except

CBC with respect to the subscription of the new corporate units to be issued by the Company;

5. Subscription and payment by Clyde Blowers Capital Fund III LP of 9,738 (nine thousand seven hundred and thirty

eight) class A to H corporate units and 9,744 (nine thousand seven hundred and forty four) class I corporate units having
a nominal value of GBP 1 (one Pound Sterling) each, with such rights and obligations as set out in the articles of association
of the Company, in consideration for an aggregate contribution in cash amounting to GBP 11,000,000 and together with
an aggregate share premium of GBP 10,912,352 (ten million nine hundred and twelve thousand three hundred and fifty
two Pound Sterling);

6. Subsequent amendment of the Article 5.1. of the articles of association of the Company;
7. Amendment of Articles 5.8, 6.2 first paragraph, 6.2(ii), 6.3 first paragraph and 8.1 of the articles of association of the

Company;

8. Granting of authorization to any one manager of the Company or any lawyer of the law firm Wildgen, Partners in

Law, to carry out any necessary action in relation to the resolutions to be taken on the basis of the present agenda including
but not limited to the amendment of the unitholders’ register of the Company and to the publication of the resignation of
Mr. Andrew Philip John COLLINS; and

9. Any other business.
II.- The represented unitholders, the proxy of the represented unitholders and the number of their corporate units are

shown on an attendance list, which, signed “ne varietur” by the proxyholder, the members of the bureau of the Meeting
and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authority.

114648

L

U X E M B O U R G

Proxies given by the represented unitholders, after having been initialed "ne varietur" by the proxyholder, the members

of the bureau of the Meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the attendance list that the entire corporate capital of the Company is represented at the present

Meeting, the unitholders waive the convening formalities and declare having perfect knowledge of the agenda which has
been made available before the Meeting. Subsequently, the present Meeting is regularly constituted and may validly deli-
berate on all items of the agenda and it passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolved to acknowledge the resignation of Mr. Andrew Philip John COLLINS from his position of manager

of the Company with with effect from May 28, 2015 and to grant full discharge of liability (quitus) for the performance of
his mandate as from 8 

th

 January 2013 until the Effective Date.

The  Unitholders’  Meeting  also  resolved  to  reiterate  such  discharge  at  the  annual  general  meeting  of  the  Company

approving the annual accounts of the Company as of 30 

th

 June, 2015.

<i>Second resolution

The Meeting resolved to acknowledge the waiver of the rights set out in clauses 6.1 (c) (1) and (2) of Shareholders’

Agreement and to not appoint a new manager in replacement of Mr. Andrew Philip John COLLINS.

With effect at the date hereof, the composition of the Company’s board of managers is the following:
1. Mrs. Samia RABIA,
2. Mr. François BROUXEL,
3. Mr. Pierre METZLER,
4. Mr. Keith Lewis MITCHELL,
5. Mr. James Allan McCOLL,
6. Mr. Gary Arthur DOWN, and
7. Ms. Shauna POWELL.

<i>Third resolution

The Meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by contribution in cash so as to bring it from its

present amount of GBP 44,876 (forty-four thousand eight hundred and seventy-six Pounds Sterling) represented by 44,876
(forty-four thousand eight hundred and seventy-six) corporate units each having a nominal value of one GBP 1 (one Pound
Sterling), divided into 4,868 (four thousand eight hundred and sixty-eight) class A to H and 4,894 (four thousand eight
hundred and ninety-four) class I and 1,038 (one thousand and thirty-eight) class J corporate units, to an amount of GBP
132,524 (one hundred and thirty two thousand five hundred and twenty four Pounds Sterling) represented by 132,524 (one
hundred and thirty two thousand five hundred and twenty four) corporate units each having a nominal value of one GBP
1 (one Pound Sterling), by issuance of 9,738 (nine thousand seven hundred and thirty eight) class A to H corporate units
and 9,744 (nine thousand seven hundred and forty four) class I corporate units having a nominal value of GBP 1 (one Pound
Sterling) each and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company for an aggregate
contribution in cash amounting to GBP 11,000,000 and together with an aggregate share premium of GBP 10,912,352 (ten
million nine hundred and twelve thousand three hundred and fifty two Pound Sterling). The Members further resolved to
waive their preferential subscription right, where opportune and except for CBC in relation to the new corporate units to
be issued by the Company under this RESOLUTION THIRD.

<i>Subscription and payment

Then intervenes Maître Delia NITESCU, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney of Clyde Blowers

Capital Fund III LP, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on 23 June 2015, such proxy, after initialed
“ne varietur” by the appearing person and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, who declared
to subscribe and fully pay-up in the name and on behalf of Clyde Blowers Capital Fund III LP, prenamed 9,738 (nine
thousand seven hundred and thirty eight) class A to H corporate units and 9,744 (nine thousand seven hundred and forty
four) class I corporate units having a nominal value of GBP 1 (one Pound Sterling) each and with such rights and obligations
as set out in the articles of association of the Company for an aggregate contribution in cash amounting to GBP 11,000,000
and together with an aggregate share premium of GBP 10,912,352 (ten million nine hundred and twelve thousand three
hundred and fifty two Pound Sterling);

Thereupon, the Members decide to accept such subscription and the payment up and to issue and allocate the above

listed corporate units to Clyde Blowers Capital Fund III LP, prenamed.

<i>Fourth resolution

The Members resolved to amend article 5.1. of the articles of association of the Company to read, as follows:

“ 5.1. The subscribed Corporate Capital is set at one hundred and thirty two thousand five hundred and twenty four

Pounds Sterling (GBP 132,524) represented by fourteen thousand six hundred and six (14,606) class A to H corporate units,

114649

L

U X E M B O U R G

fourteen thousand six hundred and thirty eight (14,638) class I corporate units and one thousand thirty eight (1,038) class
J corporate units in registered form and fully paid up having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each (the
“Class A to J Corporate Units”) and with such rights and obligations as set out in the present articles of association.”

The Members resolve to amend article 5.8 of the articles of association of the Company to read, as follows:

“ 5.8 . The Total Cancellation Amount for each of the class J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount

of the relevant Class of Corporate Units at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by
the General Meeting of Unitholders in the manner provided for in article 11.3. and according to the priority order established
under article 6.2 and 6.3”.

The Members further resolved to amend articles 6.2, first paragraph and 6.2(ii) of the articles of association of the

Company to read, as follows:

“ 6.2. Where the Company makes a distribution of Available Cash the Class A to I Corporate Unitholders shall receive

the distribution as follows after the repayment of all sums owing or payable to the holder of any Qualifying Securities,
CECs and PECs in accordance with the terms of the same (whether through redemption, repayment, cancellation repurchase
or otherwise).

6.2. (ii). second, in respect of the Class A to I Corporate Units, an amount equal to a multiple of such Class A to I

Corporate Unitholders’ Equity Contributions to be allocated to the Class A to I Corporate Unitholders in proportion to their
participation in the Company; such multiple to be agreed by the Unitholders Meeting in the manner provided for under
article 11.3. (such amount being the "Hurdle");

The Members further resolve to amend articles 6.3, first paragraph of the articles of association of the Company to read,

as follows:

“ 6.3. Where the Company makes a distribution of Available Cash the Class J Corporate Unitholders shall receive the

distribution as follows:”.

The Members further resolve to amend article 8.1, first paragraph of the articles of association of the Company to read,

as follows:

“  8.1.  Subject  to  any  Corporate  Unitholders'  agreement  which  may  be  entered  into  between  the  Company  and  the

Corporate Unitholders as amended, supplemented, adhered to or restated from time to time, the Company may redeem its
own Corporate Units within the limits set forth by the Law and according to the priority order established under article 6.2
and 6.3”.

<i>Fifth resolution

The Members authorize any one manager of the Company or any lawyer of the law firm Wildgen, Partners in Law, to

carry out any necessary action in relation to the above taken resolutions including but not limited to the amendment of the
unitholders’ register of the Company and the publication of the resignation of Mr. Andrew Philip John COLLINS.

The Meeting was declared closed as there was no further business.

<i>Costs

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

deed is estimated at four thousand eight hundred Euros (EUR 4,800.-).

For registration purposes, the total amount of the capital increase is valued at EUR 9,960,000.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons and
in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day indicated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le sept juillet.
Par-devant nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») des associés (les «Associés») de la société «CBC Keto Pumps S.à

r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg et im-
matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.942 (la «Société»).

L’Assemblée fût présidée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster (le

«Président»).

114650

L

U X E M B O U R G

Le Président désigna comme Secrétaire Madame Delia NITESCU, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’Assemblée désigna comme Scrutateur Monsieur Davide GIACOMONI, Avocat à la Cour, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg. Le bureau de l’Assemblée ayant été ainsi constitué, le Président déclara et requît le notaire d'acter
que:

I.- L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Reconnaissance de la démission de M. Andrew Philip John COLLINS de son mandat de gérant de la Société et

décharge pleine et entière (quitus) accordée à ce dernier pour ce qui a trait à son mandat de gérant de la Société avec effet
au 28 mai 2015 (la «Date d’Effet»);

2. Reconnaissance de la renonciation des droits prévus dans les clauses 6.1 (c) (1) et (2) du pacte d’associés de la Société

initialement daté au 18 décembre 2012 (le «Pacte d’Associés») et examen de, et s’ils le jugent opportun, décision quant à
la question de l’absence de nomination d’un nouveau gérant de la Société en remplacement de M. Andrew Philip John
COLLINS;

3. Augmentation du capital social de la Société par apport en numéraire de façon à le faire passer de son montant actuel

de 44.876 GBP (quarante-quatre mille huit cents soixante-seize Livres Sterling) représenté par 44.876 (quarante-quatre
mille huit cents soixante-seize) parts sociales ayant chacune une valeur nominale d’1 GBP (une Livre Sterling) divisées en
4.868 (quatre mille huit cents soixante-huit) parts sociales de classes A à H et 4.894 (quatre mille huit cents quatre-vingts
quatorze) parts sociales de classe I et 1.038 (mille trente-huit) parts sociales de classe J, à un montant de 132.524 GBP
(cent trente-deux mille cinq cents vingt-quatre Livres Sterling) représenté par 132.524 (cent trente-deux mille cinq cents
vingt-quatre) parts sociales ayant chacune une valeur nominale d’1 GBP (une Livre Sterling), suite à l’émission de 9.738
(neuf mille sept cents trente-huit) parts sociales de classes A à H et de 9.744 (neuf mille sept cents quarante-quatre) parts
sociales de classe I ayant chacune une valeur nominale d’1 GBP (une Livre Sterling) avec les droits et les obligations tels
que prévus par les statuts de la Société, ces nouvelles parts sociales devant être souscrites par Clyde Blowers Capital Fund
III LP, une limited partnership, ayant son siège social au 1, Redwood Crescent, Peel Park, East Kilbride, United Kingdom,
immatriculée au Companies House sous le numéro de sociétés SL008995 («CBC») ensemble avec une prime d’émission
totale s’élevant à 10.912.352 GBP (dix millions neuf cents douze mille trois cents cinquante-deux Livres Sterling);

4. Renonciation, si opportun, par tous les associés de la Société autres que CBC au droit de préemption relatif à la

souscription des parts sociales, pour ce qui concerne les nouvelles parts sociales devant être émises par la Société;

5. Souscription et paiement par Clyde Blowers Capital Fund III LP de 9.738 (neuf mille sept cents trente-huit) parts

sociales de classes A à H et de 9.744 (neuf mille sept cents quarante-quatre) parts sociales de classe I ayant chacune une
valeur nominale d’1 GBP (une Livre Sterling) avec les droits et les obligations tels que prévus par les statuts de la Société,
en échange d’un apport en numéraire total de 11.000.000 GBP (onze millions de Livres Sterling) et ensemble avec une
prime totale d’émission de 10.912.352 GBP (dix millions neuf cents douze mille trois cents cinquante-deux Livres Sterling);

6. Modification subséquente de l’Article 5.1. des statuts de la Société;
7. Modification des Articles 5.8, 6.2 premier paragraphe, 6.2(ii), 6.3 premier paragraphe et 8.1 des statuts de la Société;
8. Autorisation donnée à tout gérant de la Société ou à tout avocat de l’étude d’avocats Wildgen Partners in Law, d

´effectuer toute action nécessaire en relation avec les résolutions devant être prises sur la base du présent ordre du jour
incluant mais non limitée à la modification du registre des associés de la Société et à la publication de la démission de M.
Andrew Philip John COLLINS; et

9. Tout autre point.
II.- Les associés représentés, le mandataire des associés représentés, ainsi que le nombre des parts sociales qu'elles

détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui, signée "ne varietur" par le mandataire des associés représentés ainsi
que par les membres du bureau de l’Assemblée et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui au même moment aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par le mandataire des associés repré-

sentés, par les membres du bureau de l’Assemblée et par le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent
acte.

III.- Il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social de la Société est représentée à la présente As-

semblée. L'intégralité du capital social est représentée, les associés renonçant au droit d’être dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui a été mis à leur disposition avant l’Assemblée. Subséquemment, la
présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour
et l’Assemblée prît les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée a décidé de reconnaître la démission de M. Andrew Philip John COLLINS de son mandat de gérant de la

Société avec effet au 28 mai 2015 et de lui accorder décharge pleine et entière (quitus) pour l’exécution de son mandat à
partir du 8 janvier 2013 jusqu’à la Date d’Effet.

114651

L

U X E M B O U R G

L’Assemblée des Associés décide également de redonner une telle décharge à l’assemblée générale annuelle de la Société

approuvant les comptes annuels de la Société au 30 Juin 2015.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée  a  décidé  de  reconnaître  la  renonciation  des  droits  prévus  dans  les  clauses  6.1  (c)  (1)  et  (2)  du  Pacte

d’Associés et de ne pas nommer un nouveau gérant en remplacement de M. Andrew Philip John COLLINS.

Avec effet à la date des présentes, la composition du conseil de gérance de la Société est la suivante:
1. Mme. Samia RABIA,
2. M. François BROUXEL
3. M. Pierre METZLER,
4. M. Keith Lewis MITCHELL,
5. M. James Allan McCOLL,
6. M. Gary Arthur DOWN, et
7. Mme. Shauna POWELL.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée a décidé d’augmenter le capital social de la Société au moyen d’un apport en numéraire de telle manière

à le faire passer de son montant actuel de 44.876 GBP (quarante-quatre mille huit cents soixante-seize Livres Sterling)
représenté par 44.876 (quarante-quatre mille huit cents soixante-seize) parts sociales ayant chacune une valeur nominale
d’1 GBP (une Livre Sterling) divisées en 4.868 (quatre mille huit cents soixante-huit) parts sociales de classes A à H et
4.894 (quatre mille huit cents quatre-vingts quatorze) parts sociales de classe I et 1.038 (mille trente-huit) parts sociales de
classe J, à un montant de 132.524 GBP (cent trente-deux mille cinq cents vingt-quatre Livres Sterling) représenté par
132.524 (cent trente-deux mille cinq cents vingt-quatre) parts sociales ayant chacune une valeur nominale d’1 GBP (une
Livre Sterling), suite à l’émission de 9.738 (neuf mille sept cents trente-huit) parts sociales de classes A à H et de 9.744
(neuf mille sept cents quarante-quatre) parts sociales de classe I ayant chacune une valeur nominale d’1 GBP (une Livre
Sterling) avec les droits et les obligations tels que prévus par les statuts de la Société, en échange d’un apport total en
numéraire s’élevant à 11.000.000 GBP et ensemble avec une prime d’émission de 10.912.352 GBP (dix millions neuf cents
douze mille trois cents cinquante-deux Livres Sterling). Les Associés autres que CBC décident aussi si opportun de renoncer
à leur droit de préemption relatif à la souscription des parts sociales, pour ce qui concerne les nouvelles parts sociales devant
être émises par la Société sous CETTE Troisième résolution.

<i>Souscription et paiement

Intervient ensuite Maître Delia NITESCU, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment désignée de Clyde

Blowers Capital Fund III LP, prénommée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 23 juin 2015, après avoir
été paraphée «ne varietur» par la personne comparaissant et par le notaire instrumentant, qui restera attachée au présent
acte, qui déclara souscrire et payer dans son intégralité au nom et pour le compte de Clyde Blowers Capital Fund III LP,
prénommée, 9.738 (neuf mille sept cents trente-huit) parts sociales de classes A à H et de 9.744 (neuf mille sept cents
quarante-quatre) parts sociales de classe I ayant chacune une valeur nominale d’1 GBP (une Livre Sterling) avec les droits
et les obligations tels que prévus par les statuts de la Société en contrepartie d’un apport total en numéraire de 11.000.000
GBP et ensemble avec une prime d’émission totale de 10.912.352 GBP (dix millions neuf cents douze mille trois cents
cinquante-deux Livres Sterling);

Sur ce, les Associés décident d´accepter ladite souscription et le paiement ainsi que d’émettre et d’attribuer les parts

sociales ci-dessus mentionnées à Clyde Blowers Capital Fund III LP, prénommée.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée a décidé de modifier l’article 5.1. des statuts de la Société qui doit désormais être lu comme suit:

« 5.1. Le Capital Social souscrit est fixé à cent trente-deux mille cinq cents vingt-quatre Livres Sterling (132.524 GBP)

représenté par quatorze mille six cents six (14.606) parts sociales des classes A à H, quatorze mille six cents trente-huit
(14.638) parts sociales de classe I et mille trente-huit (1.038) parts sociales de classe J sous forme de parts sociales nomi-
natives et entièrement payées ayant chacune une valeur nominale d’une Livre Sterling (1 GBP) (les «Parts Sociales des
Classes A à J») avec les droits et obligations tels que prévus dans les présents statuts.»

L’Assemblée a décidé de modifier l’article 5.8. des statuts de la Société qui doit désormais être lu comme suit:

« 5.8. Le Montant Total d’Annulation pour chacune des classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible

de Classe de Parts Sociales en question au moment de l’annulation de la classe en question à moins qu’il en soit autrement
décidé par l’Assemblée Générale des Associés de la façon prévue à l’article 11.3 et conformément à l’ordre de priorité
établi sous les articles 6.2 et 6.3»

L’Assemblée a décidé de modifier les articles 6.2, premier paragraphe et 6.2(ii) des statuts de la Société qui doivent

désormais être lus comme suit:

114652

L

U X E M B O U R G

« 6.2. Si la Société fait une distribution des Fonds Disponibles (Available Cash) les Associés des Classes A à I recevront

la distribution comme suit après que le re-paiement de toutes les sommes dues ou payables au détenteur de Qualifying
Securities, de CECs et de PECs conformément aux termes de ceux-ci (le cas échéant au travers d’un rachat, d’un re-
paiement, d’une annulation, d’un rachat ou d’une autre façon).

6.2. (ii). deuxièmement, pour ce qui est des Parts Sociales de Classes A à I, un montant égal à un multiple de Contributions

en Capital (Equity Contributions) de tels Associés de Classes A à I devant être attribué aux Associés des Classes A à I en
proportion de leur participation dans la Société, un tel multiple devant être convenu par l’Assemblée des Associés de la
manière prévue à l’article 11.3 (un tel montant étant la «Barrière»);

Les Associés décident aussi de modifier l’article 6.3., premier paragraphe des statuts de la Société qui doit désormais

être lu comme suit:

« 6.3. Si la Société fait une distribution de Fonds Disponibles (Available Cash) les Associés de Classe J recevront la

distribution comme suit:».

Les Associés décident aussi de modifier l’article 8.1, premier paragraphe des statuts de la Société qui doit désormais

être lu comme suit:

« 8.1. Soumis à d’autre pacte d’Associés qui peut être conclu entre la Société et les Associés tel que modifié, complété,

refondu ou auquel il peut être adhéré, à tout moment, la Société peut racheter ses propres Parts Sociales dans les limites
définies par la Loi et conformément à l’ordre de priorité établi sous les articles 6.2 et 6.3».

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée autorise tout gérant de la Société et tout avocat de l’étude d’avocats Wildgen Partners in Law, d´effectuer

toute action nécessaire en rapport avec les résolutions précédemment prises incluant mais non limitée à la modification du
registre des associés de la Société et à la publication de la démission de M. Andrew Philip John COLLINS.

Plus rien ne figurait à l’ordre du jour, l’Assemblée fût clôturée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunération et charges incombant à la Société en raison de cet acte sont estimés à quatre mille huit

cents euros (EUR 4.800,-).

Pour les besoins de l’Enregistrement, le montant total de l’augmentation de capital est évalué à EUR 9.960.000,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclara qu’à la requête des personnes susmentionnées compa-

raissant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre ces deux
versions, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Delia NITESCU, Davide GIACOMONI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 10 juillet 2015. Relation GAC/2015/5869. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015119987/313.
(150129282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Food Delivery Holding 23 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 198.492.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of July,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., a limited liability corporation (société à responsabilité limitée)

existing  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  with  its  statutory  seat  in  Luxembourg,  Grand  Duchy  of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 175738, having its business address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;

here represented by Mrs Magdalena Staniczek, private employee, professionally residing in Senningerberg, by virtue

of a proxy.

114653

L

U X E M B O U R G

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as above stated, has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation

of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of
association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Food Delivery Holding 23 S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

114654

L

U X E M B O U R G

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the

transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse
or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.

114655

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers

114656

L

U X E M B O U R G

(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and
class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5.  An  independent  auditor  may  only  be  removed  by  the  general  meeting  of  shareholders  with  cause  or  with  its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators  shall  have  the  most  extensive  powers  for  the  realisation  of  the  assets  and  payment  of  the  liabilities  of  the
Company.

114657

L

U X E M B O U R G

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Emerging Markets Online Food

Delivery Holding S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1.550,-

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
- Mr Ralf Wenzel, born in Berlin, Germany, on 8 August 1979, professionally residing at Johannisstrasse 20, D-10117

Berlin;

- Mr Philipp Lederer, born in Frankfurt, Germany, on 5 April 1971, residing professionally at Johannisstraße 20, D-10117

Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, and Magdalena Staniczek is authorized to sign solely,

on behalf of the sole shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the
Company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunten Juli.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter

dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre
de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 175738, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großher-
zogtum Luxemburg.

hier vertreten durch Frau Magdalena Staniczek, Angestellte, geschäftsansässig in Senningerberg, gemäß einer Voll-

macht.

114658

L

U X E M B O U R G

Besagte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne

varietur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit

dem Namen Food Delivery Holding 23 S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1  Zweck  der  Gesellschaft  ist  das  Halten  von  Beteiligungen  jeglicher  Art  an  luxemburgischen  und  ausländischen

Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch  Aufnahme  von  Darlehen  in  jeglicher  Form  oder  mittels  Ausgabe  aller  Arten  von  Anleihen,  Wertpapieren  und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  durch  Beschluss  des  Rates  der  Geschäftsführer  im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten

darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

114659

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustim-
mung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen
werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-

lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit
statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in
einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die
Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schrift-
lichen  Konsultation  der  Gesellschafter  nicht  erreicht  wird,  können  die  Anteilseigner  ein  weiteres  Mal  mit  derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1  Die  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer  geleitet.  Falls  die  Gesellschaft  mehrere  Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

114660

L

U X E M B O U R G

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1  Der  bzw.  die  Geschäftsführer  werden  durch  die  Gesellschafterversammlung  ernannt,  welche  ihre  Bezüge  und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem  Amt  ausscheidet,  muss  die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-

punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-

ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-

führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2  Sitzungen  des  Rates  der  Geschäftsführer  werden,  falls  vorhanden,  durch  den  Vorsitzenden  des  Rates  der  Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore
ernennen.

17.3  Jeder  Geschäftsführer  kann  an  einer  Sitzung  des  Rates  der  Geschäftsführer  teilnehmen,  indem  er  ein  anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit

114661

L

U X E M B O U R G

der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie
B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B),
werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens
eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii)
durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschrifts-
befugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-

sellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-

klang  mit  den  gesetzlichen  Anforderungen  ein  Inventar  der  Aktiva  und  Passiva,  eine  Bilanz  und  eine  Gewinn-  und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-

falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

114662

L

U X E M B O U R G

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von
1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an

die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Emerging Markets Online Food Delivery

Holding S.à r.l., vorbenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die  gesamte  Einlage  von  in  Höhe  von  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500)  wird  vollständig  dem  Gesell-

schaftskapital zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.550,- geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
-  Herr  Ralf  Wenzel,  geboren  am  8.  August  1979  in  Berlin,  Deutschland,  geschäftsansässig  in  Johannisstrasse  20,

D-10117 Berlin.

- Herr Philipp Lederer, geboren am 5. April 1971, in Frankfurt, Deutschland geschäftsansässig in Johannisstraße 20,

D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:

114663

L

U X E M B O U R G

- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, und Magdalena Staniczek ist er-

mächtigt, das Anteilinhaberregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für
Rechnung des alleinigen Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei,

dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. STANICZEK, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/21710. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 17. Juli 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015120136/583.
(150129096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

T-C Luxembourg Neptune Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Gasperich, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 192.182.

Les statuts coordonnés au 16 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015118582/11.
(150127172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Summit Partners SFB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 111.798.

In the year two thousand fifteen, on the ninth day of the month of July;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “SUMMIT PARTNERS SFB S.à r.l.”, a private

limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
established and having its registered office in L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite, registered with the Trade and
Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 111798, (the”Company”), originally incorporated under the
denomination of “SUMMIT PARTNERS III S.à r.l.”, pursuant to a deed of Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN,
notary then residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on October 18, 2005, published in the Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 387 of February 22, 2006,

and whose articles of association (the “Articles”) have been amended several times and for the last time pursuant to a

deed of Me Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on March 13, 2009, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 892 of April 28, 2009, containing the adoption by the
Company of its current denomination.

The Meeting is presided by Mr. Frédéric GARDEUR, employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412

F, route d'Esch.

114664

L

U X E M B O U R G

The Chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mrs. Elisabeth VAN DER WILT, employee,

residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412 F, route d'Esch.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary

to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Dissolution of the company and decision to put it into liquidation;
2. Appointment of a liquidator;
3. Determination specification of the powers conferred to the liquidator;
4. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an

attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting

and  the  officiating  notary,  will  remain  annexed  to  the  present  deed  to  be  filed  at  the  same  time  with  the  registration
authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,

present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (liquidation

volontaire).

<i>Second resolution

The Meeting decides to appoint the private limited liability company “Merlis S.à r.l.”, established and having its regis-

tered office in L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscribed in the Trade and Companies Registry of Luxembourg,
section B, under the number 111320, as liquidator (the “Liquidator”) of the Company.

<i>Third resolution

The Meeting decides to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the

coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the “Law”).

The Meeting also decides to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to

realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the

name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general
meeting of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or
several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to

execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of
the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments

in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in accordance with
article 148 of the Law.

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,

the Chairman then adjourned the Meeting.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at nine hundred and twenty
Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

114665

L

U X E M B O U R G

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and

residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de juillet;
Par-devant  Nous  Maître  Carlo  WERSANDT,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des associés de “SUMMIT PARTNERS SFB S.à r.l.”, une société

à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2341
Luxembourg, 5, rue du Plébiscite, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 111798, (la “Société”), constituée originairement sous la dénomination de “SUMMIT PARTNERS III S.à r.l.”,
suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), le 18 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
387 du 22 février 2006,

et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître

Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 mars 2009, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 892 du 28 avril 2009, contenant l'adoption par la Société de sa dénomination
sociale.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric GARDEUR, employé, demeurant professionnellement à L-2086 Lu-

xembourg, 412 F, route d'Esch.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Elisabeth VAN DER WILT,

employée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412 F, route d'Esch.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution de la société et décision de la mettre en liquidation;
2. Désignation d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur;
4. Divers.
B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux repré-
sentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée et le

notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés, déclarent

avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux
formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée “Merlis S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à

L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 111320, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de

la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

114666

L

U X E M B O U R G

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation,

afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de
la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous verse-

ments d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article
148 de la Loi.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne

demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent vingt euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. GARDEUR, E. VAN DER WILT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 14 juillet 2015. 2LAC/2015/15748. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Référence de publication: 2015120680/156.
(150129817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

GRE Gin S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Valore VI-A S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 177.847.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of June.
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARS:

Wert Investment Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, with share capital of EUR 75,125, with registered office located at 6C, rue Gabriel Lipp-
mann, L-5365 Munsbach and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B132726 (the
Sole Shareholder),

represented by Audrey Cubizolles, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given under private seal.

The power of attorney of the Sole Shareholder, after having been initialled ne varietur by the attorney-in-fact and by

the  undersigned  notary,  shall  remain  attached  to  the  present  deed  and  be  submitted  with  this  deed  to  the  registration
authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all of the shares representing the entire share capital of Valore VI-A S.à r.l., a Luxembourg

private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 177.847 (the Company). The Company was incorporated on 4 June 2013 pursuant to a deed by Maître
Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des

114667

L

U X E M B O U R G

Sociétés et Associations, dated 20 July 2013 number 1747. The articles of association of the Company have not been
amended.

II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance

with article 200-2 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(i) Change of the Company's name from "Valore VI-A S.à r.l." to "GRE Gin S.à r.l.";
(ii) amendment of article 1 of the articles of association of the Company (the Articles); and
(iii) miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the Company's name from "Valore VI-A S.à r.l." to "GRE Gin S.à r.l.".

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles in order to reflect the above change so that it shall now

read as follows:

“ Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name “GRE

Gin S.à r.l.” (the Company), which is governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 

th

 August,

1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).”

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version, and that in case of discrepancies between the English and the French texts, the English
version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The deed having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, who is known to the notary by his surname,

first name, civil status and residence, the attorney-in-fact of the Sole Shareholder signs together with us, the notary, the
present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand Duché de Luxembourg,

COMPARAIT:

Wert Investment Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Luxembourg, ayant

un capital social de EUR 75,125, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132726 (l'Associé Unique),

représenté par Audrey Cubizolles, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration don-

née sous seing privé.

La procuration de l'Associé Unique, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, ainsi représenté, a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique est le détenteur de toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social de Valore VI-

A S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 177.847 (la Société). La Société a été constituée le 4 juin 2013 par un acte du notaire
Maître Francis Kesseler, résidant à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, daté du
20 juillet 2013 sous le numéro 1747. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés.

II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés conformément à l'article 200-2 de la loi

luxembourgeoise datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

III. L'Associé Unique souhaite adopter les résolutions suivantes:
(i) changement de la dénomination de la Société de "Valore VI-A S.à r.l." en "GRE Gin S.à r.l.";
(ii) modification de l'article 1 des statuts de la Société (les Statuts); et
(iii) divers.
III. L'Associé Unique adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de "Valore VI-A S.à r.l." en "GRE Gin S.à r.l.".

114668

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 1 des Statuts afin de refléter le changement intervenu ci-dessus, de telle

sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «GRE Gin S.à r.l.» (la

Société),  qui  sera  régie  par  les  lois  du  Luxembourg,  en  particulier  par  la  loi  du  10  août  1915  concernant  les  sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).»

Le notaire instrumentant, ayant personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare documenter le présent acte

en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé Unique, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Cubizolles, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 juillet 2015. Relation: EAC/2015/15416. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015120724/95.
(150129123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Il Sipario, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg F 10.453.

STATUTS

Entre les soussignés:

Alborino

Alfredo

219, rue Albert Unden

L-2652 Luxembourg

Employé privé

italien

Alborino

Massimo

31, Val Fleuri

L-1526 Luxembourg

Employé privé

italien

Belardi

Elisabetta

226, rue de Luxemourg

L-8077 Bertrange

Employée privée

italienne

Burman

Ewa

67, route d'Arlon

L-1140 Luxembourg

Liberale

anglaise

Cairo

Paola

95, rue de Luxembourg

L-8077 Bertrange

Journaliste

italienne

Carpentieri

Marco

90, rue de Mühlenbach

L-2168 Luxembourg

Employé privé

italien

Casaburi

Carla

11, rue du Canal

L-4050 Esch-sur-Alzette Architect

italienne

Casale

Gennaro

6, allé des Charmes

L-1372 Luxembourg

Employé privé

italien

Cirillo

Luca

198/A, route d'Arlon

L-8010 Strassen

Employé privé

italien

Conte

Amelia

120, Avenue X Septembre

L-2550 Luxembourg

Employée privée

italienne

Di Pietro

Francesca

6, rue Marguerite De Brabant L-1254 Luxembourg

Employée privée

italienne

D'Ippoliti

Alessia

44,rue de Bourgogne

L-1272 Luxembourg

Employée privée

italienne

Falcone

Maria Rosaria 10, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg

Insegnante

italienne

Gentile

Raffaele

6, rue Marguerite De Brabant L-1254 Luxembourg

Retraité

italien

Liberati

Francesca

1-3, rue d'Eich

L-1461 Luxembourg

Agent U.E.

italienne

Manca

Silvia

49, Avenue Pasteur

L-2311 Luxembourg

Agent U.E.

italienne

Malgarini

Cristiana

51, rue Paul Henkes

L-1710 Luxembourg

Employée privée

italienne

Margarita

Vincenza

14, rue de Strasbourg

L-2560 Luxembourg

Educatrice

italienne

Matalone

Federica

14, rue Henri VII

L-1725 Luxembourg

Employée privée

italienne

Michelino

Antonella

5, Boulevard Pershing

L-2323 Luxembourg

Dirigeant

italienne

Monateri

Anna Myrtha 1b, Bouldvard Prince Felix

L-1513 Luxembourg

Employée privée

italienne

Natini

Chiara

16, rue Dicks

L-9161 Ingeldorf

Employée privée

italienne

Notarantonio Giovanni

114, Avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg

Employé privé

italien

Sardiñas Diaz Gretel

88, rue de Luxembourg

L-8140 Bridel

Femme au foyer

cubaine

Scannapieco Giuseppe

11, rue du Canal

L-4050 Esch-sur-Alzette Agent de commerce italien

Trabucchi

Elena

5a, Sentier de l'Esperance

L-1474 Luxembourg

Fonctionnaire U.E. italienne

Zottola

Gianfranco

20, rue Michel Rodange

L-2430 Luxembourg

Fonctionnaire U.E. Italien

et toutes celles ou ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par

la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

114669

L

U X E M B O U R G

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination «Il Sipario» association sans but lucratif.

Art. 2. L'association a pour objet:
De regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer de manière générale à des activités culturelles

et artistiques aussi bien dans l’état du Grand- Duché du Luxembourg qu'à l’étranger et de promouvoir des activités favorisant
la connaissance du Grand- Duché de Luxembourg et des cultures des pays d'origine des associés en général.

Elle peut s’affilier à toutes organisations nationales ou internationales compatibles avec son objet. Toute affiliation doit

être soumise à l’accord préalable du conseil d’administration.

Art. 3. L'association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. L'association a son siège social à Luxembourg. Le siège social peut être transféré par simple décision du conseil

d'administration à tout autre endroit du Grand- Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de l'association est illimitée.

II. Exercice social

Art. 6. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

III. Membres

Art. 7. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d'administration

à la suite d’une demande formulée de manière écrite ou verbale.

Art. 8. Les membres s’engagent à respecter le principe et l’objet de l’association, ainsi que les décisions de l’assemblée

générale et du conseil d’administration.

Art. 9. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite au

conseil d'administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 3 mois à compter du jour de l'échéance tout membre
refusant de payer la cotisation lui incombant.

Art. 10. Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte

aux intérêts de l'association ou ne respectent pas les conditions émises à l’article 8 des présents statuts. À partir de la
proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la décision définitive de l'assemblée générale
statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses
fonctions sociales.

Art. 11. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont produites et ce

au 31 décembre.

IV. Cotisations

Art. 12.  Les  membres  fondateurs,  de  même  que  tout  nouveau  membre  de  l'Association,  seront  tenus  de  payer  une

cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Le montant de cette cotisation annuelle ne peut être
supérieur à 500 euro.

Art. 13. L’associé démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des

cotisations versées.

V. Assemblée générale

Art. 14.  L'assemblée  générale,  qui  se  compose  de  tous  les  membres,  est  convoquée  par  le  conseil  d'administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un cin-
quième des membres le demande par écrit en proposant un ordre du jour au conseil d'administration.

Art. 15. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, moyennant courrier

postale ou électronique devant mentionner l'ordre du jour proposé.

Art. 16. Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit

être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

Art. 17. L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- la modification des statuts et règlement interne;
- la nomination et révocation des administrateurs et des éventuels réviseurs de caisse;
- l’approbation des budgets et comptes;
- la dissolution de l'association;
- l’exclusion d’un membre.

114670

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à majorité

absolue des voix des membres présents ou validement représentés sous réserve des dispositions de l’article 26. Un membre
ne peut représenter qu'un seul autre membre empêché.

Art. 19. Les résolutions de l’assemblée générale, signées par deux membres du conseil d’administration, sont portées à

la connaissance des membres et tiers éventuels par voie postale ou électronique. Elles sont conservées dans un registre au
siège de l’association pouvant être notamment consulté sur demande préalable par les associés et tiers éventuels.

VI. Administration

Art. 20. L'association est gérée par un conseil d'administration composé entre 3 et 10 membres, élus à la majorité simple

des voix. La durée de leur mandat est de 3 ans.

Les décisions du conseil d’administration sont prises de manière collégiale. Il désigne notamment parmi ses membres

un président, un secrétaire et un trésorier.

Art. 21. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président chaque fois que les intérêts de l’association

l’exigent ou à la demande de deux tiers de ses membres. Il ne peut valablement délibérer que si 2/3 de ses membres au
moins sont présents ou représentés. Toute décision est prise à la majorité absolue des voix.

Art. 22. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et

extrajudiciaires. Pour que l'association soit valablement engagée à l'égard de ceux- ci, 2 signatures de membres en fonction
sont nécessaires.

Toutefois, la gestion journalière des affaires de l’association peut être déléguée par le conseil d’administration, à l’ex-

clusion de tous autres pouvoirs, soit à un associé, soit à un tiers.

Art. 23. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d’activités,

les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Art. 24. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives de

toute rémunération.

Art. 25. Les ressources de l'association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- l’autofinancement
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur autorisés dans les conditions de l’article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif.

VII. Modification des statuts, dissolution et liquidation

Art. 26. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts ou la dissolution de l’as-

sociation que si l'objet de celles- ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des
membres. Aucune modification aux statuts ou dissolution ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être

convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas, la décision sera soumise
à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification aux statuts porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, ces règles

sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou

représentés;

b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix;

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être

homologuée par le tribunal civil.

Art. 27. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté, après liquidation du passif, à une association

ayant des buts similaires.

VIII. Dispositions finales

Art. 28. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux

dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée, ainsi qu'à l’éventuel règlement interne en vigueur.

114671

L

U X E M B O U R G

Ainsi fait à Luxembourg, le 25 mars 2015.

Alborino Alfredo / Alborino Massimo / Belardi Elisabetta / Burman Ewa / Cairo Paola / Carpentieri Marco / Casaburi
Carla / Casale Gennaro / Cirillo Luca / Conte Amelia / Sardiñas Diaz Gretel / Scannapieco Giuseppe / Trabucchi
Elena / Zottola Gianfranco / Di Pietro Francesca / D'Ippoliti Alessia / Falcone Maria Rosaria / Gentile Raffaele /
Liberati Francesca / Manca Silvia / Malgarini Cristiana / Margarita Vincenza / Matalone Federica / Michelino An-
tonella / Monateri Anna Myrtha / Natini Chiara / Notarantonio Giovanni
<i>Les membres fondateurs

Référence de publication: 2015120265/143.
(150129412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Tivolex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.421.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015118622/10.
(150127706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

VA No1 (Alto) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.346.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Référence de publication: 2015118670/10.
(150126599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Van Laar S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9774 Urspelt, 64, Beim Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 107.104.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015118676/10.
(150127092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Indiana S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 98.839.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2015119328/13.
(150128781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

114672


Document Outline

CBC Keto Pumps S.à r.l.

CQS Finance S.A.

Eaglefin S.A.

Entreprise Serge Bressaglia Sàrl

Food Delivery Holding 23 S.à r.l.

GRE Gin S.à r.l.

Hermes Development S.A.

Il Sipario

Indiana S.A., S.P.F.

Logistis Germany Luxembourg 3 S.à r.l.

Majorcan Hotels Luxembourg S.à r.l.

Marfi S.à r.l.

Max Mara International S.A.

MBERP (Luxembourg) 5 S.à r.l.

MDC Consulting

Mimas International S.A.

Minacom S.A.

Mitra Holding S.A.

Mitra Holding S.A.

ML Immo 1

Monita S.A.

Monteferro International S.A.

Monteferro International S.A.

Moury-Finance

MRL S.A. SPF

MTL (Luxembourg) S.à r.l.

Mystral Coiffure

Nabuko Invest S.A.

Neovara European Mezzanine 2004 Lux S.à r.l.

Newcombe House Investment S.à r.l.

Newcontainer No.36 (Luxembourg) Shipping S.à r.l.

NG Invest S.à r.l.

NIRAAMAYA Holdings S.A.

N.M. S.A.

Orbital S.à r.l.

Réalisations Immobilières Strassen S.à r.l.

SPH S.à r.l.

Stral Stockage Transports Locations S.àr.l.

STS Medical Group S.à r.l.

Summit Partners SFB S.à r.l.

SW Luxembourg Holdings

T-C Luxembourg Neptune Holding S.à r.l.

Thirem S.à r.l.

Tivolex S.A.

Tower Properties (Luxembourg) S.à r.l.

Trilantic Capital Partners V (Europe) GP S.à r.l.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Valore VI-A S.à r.l.

Van Laar S. à r.l.

VA No1 (Alto) S.à r.l.