logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2347

2 septembre 2015

SOMMAIRE

ADMC-Audit, Diagnostic, Mise en Conformité

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112615

Ady's Hygiène S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112656

AIM SOFTWARE Luxembourg S.A.  . . . . . . .

112637

AIM Software Luxembour S.à r.l.  . . . . . . . . . .

112637

Alison Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112610

ANS Europe Holdings (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . .

112610

Antinous S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112611

Argenta Life Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

112611

Artotal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112610

Assumption Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

112620

Azurestia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112611

Azzurinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112610

Café Restaurant Chinois Shen-Zhen  . . . . . . . .

112613

California Hill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112614

Callista Real Estate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112612

Calonge Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112621

Camarimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112614

Cana S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112613

Carbone S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112613

Car-Renting & Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112613

Cars Benelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112614

CCP III Shopping Eastleigh S.à r.l.  . . . . . . . . .

112615

Co-IV Capitole S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112612

ColBaroco Funding S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

112612

ColTour S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112611

Communication - System & Business Consult-

ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112611

Complexys S.à r.l. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112614

Convento III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112612

Crescent S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112613

Delos LuxCo 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112626

Dogs4Life  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112618

Gamma Trading Gestion S.A., S.P.F.  . . . . . . .

112615

IB Management Services S.A.  . . . . . . . . . . . . .

112615

ICAMAP Advisory S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

112616

IFI Estates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112616

IML Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112616

Infeurope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112616

Julius Baer SICAV II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112634

Mercado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112653

Mercado S.à r.l. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112653

PCV Investment S.àr.l., SICAR  . . . . . . . . . . . .

112650

REVAL Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112636

RMF Promotions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112617

Tooway4you Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

112610

112609

L

U X E M B O U R G

Alison Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 76.756.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015116528/9.
(150125627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Artotal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 45.463.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015116544/10.
(150125406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

ANS Europe Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 170.294.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Référence de publication: 2015116538/10.
(150125356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Tooway4you Europe S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 161.733.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2014 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2015118625/11.
(150126566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Azzurinvest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 133.352.

Orangefield (Luxembourg) S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, a dénoncé, en date

du 10 juillet 2015, tout office de domiciliation fourni à la société:

AZZURINVEST S.A.
enregistrée au RCS de Luxembourg sous le numéro B133 352
et ce avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2015.

Orangefield (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015116557/14.
(150126207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

112610

L

U X E M B O U R G

Azurestia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8151 Bridel, 51A, rue de Schoenfels.

R.C.S. Luxembourg B 157.054.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015116499/9.
(150125736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

ColTour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 125.850.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015116659/10.
(150125742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Communication - System &amp; Business Consulting, Société Anonyme.

Capital social: EUR 53.550,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 69.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015116660/10.
(150125714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Antinous S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 153.521.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CERTIFIE CONFORME
Michel Jadot / Freddy Bracke
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015116539/12.
(150126175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Argenta Life Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 36.509.

Les comptes intermédiaires au 23 juillet 2014, correspondant aux comptes de clôture de la société en continuation

d’activités et aux comptes d’ouverture de la procédure de liquidation, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Laurence FRISING
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015116542/13.
(150126068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

112611

L

U X E M B O U R G

Callista Real Estate, Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 106.387.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015116670/9.
(150125582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Co-IV Capitole S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 185.732.

Les comptes annuels pour la période du 21 mars 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2014 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Référence de publication: 2015116654/11.
(150126018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Convento III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.895.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14.07.2015.

<i>Pour CONVENTO III S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015116664/13.
(150125383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

ColBaroco Funding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 195.749.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession sous seing privé intervenu en date du 10 Juillet 2015, que:
Colony Luxembourg S.à r.l., une Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B 88.540, dont le siège social est situé au 121 avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg,

a cédé à:
CDCF III Baroc Funding, LLC, «a Limited liability company», immatriculée au registre de commerce et des sociétés

du Delaware Division of Corporations sous le numéro 5773113, dont le siège social est situé au 2711 Centerville Road,
Suite 400, DE-19808 Wilmington (USA), l'entièreté des parts sociales de la Société ColBaroco Funding S.à r.l. à savoir,
douze mille six cents (12.600) parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Najat Mokhnache
<i>Mandataire habilité

Référence de publication: 2015116656/21.
(150125972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

112612

L

U X E M B O U R G

Car-Renting &amp; Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 98.171.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015116674/10.
(150125566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Café Restaurant Chinois Shen-Zhen, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7374 Helmdange, 147, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 59.235.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13.07.15.

Signature.

Référence de publication: 2015116668/10.
(150124892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Crescent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 134.638.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Référence de publication: 2015116665/11.
(150125937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Carbone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 106.211.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CARBONE S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015116675/11.
(150125985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Cana S.C.I., Société Civile.

Siège social: L-1927 Luxembourg, 2, rue Lemire.

R.C.S. Luxembourg E 680.

Monsieur Guy LANNERS associé et gérant de la société CANA SCI, a actuellement son adresse privée au 2, rue Lemire

L - 1927 Luxembourg.

Madame Nathalie SCHILTZ associé de la société CANA SCI, a actuellement son adresse privée au 2, rue Lemire L -

1927 Luxembourg.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2015116672/12.
(150125521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

112613

L

U X E M B O U R G

Cars Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 60, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 44.626.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015116676/9.
(150125166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Camarimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.450.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-1470 Luxembourg, le 14 juillet 2015.

<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015116671/11.
(150125699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

California Hill, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1927 Luxembourg, 2, rue Lemire.

R.C.S. Luxembourg E 5.574.

Monsieur Guy LANNERS associé et gérant de la société CALIFORNIAN HILL SC, a actuellement son adresse privée

au 2, rue Lemire L - 1927 Luxembourg.

Madame Nathalie SCHILTZ associé et gérante de la société CALIFORNIAN HILL SC, a actuellement son adresse

privée au 2, rue Lemire L - 1927 Luxembourg.

Monsieur Ben LANNERS associé de la société CALIFORNIAN HILL SC, a actuellement son adresse privée au 2, rue

Lemire L - 1927 Luxembourg.

Monsieur Jo LANNERS associé de la société CALIFORNIAN HILL SC, a actuellement son adresse privée au 2, rue

Lemire L - 1927 Luxembourg.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2015116669/16.
(150125504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Complexys S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

R.C.S. Luxembourg B 148.786.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation conformément à l'article 203 de la loi sur les sociétés
commerciales, de la société «COMPLEXYS S.à.r.l. SPF.», dont le siège social sis à L-1650 Luxembourg, 6 avenue Guil-
laume a été dénoncé le 13 septembre 2010;

Ce jugement a déclaré applicable les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite et ont nommé juge-

commissaire  Monsieur  Julien  LUCAS,  juge  au  Tribunal  d'Arrondissement  de  et  à  Luxembourg,  et  liquidateur  Maître
Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créance sont à faire au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6 

ème

 chambre.

Pour extrait conforme
Maître Karima HAMMOUCHE
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015116662/18.
(150125930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

112614

L

U X E M B O U R G

ADMC-Audit, Diagnostic, Mise en Conformité S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 90-94, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 140.375.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015116511/9.
(150125585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

CCP III Shopping Eastleigh S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 174.516.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2015.

Langham Hall Luxembourg
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015116693/13.
(150125293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

IB Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 47.699.

<i>Extrait des résolutions adoptées par les administrateurs de la Société en date du 12 Juin 2015:

- Mathieu Gangloff, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a démissionné de sa fonction d'administrateur de la

société avec effet au 12 juin 2015.

- Eduardo Goulart, 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, est nommé administrateur de la société avec effet 12

juin 2015 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015117016/15.
(150125909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Gamma Trading Gestion S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 147.067.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 9 juillet 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme GAMMA TRADING
GESTION SA, SPF (RCS B147067) avec siège social à L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
de fait inconnue à cette adresse.

Les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Stéphanie STAROWICZ
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015116944/16.
(150125632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

112615

L

U X E M B O U R G

Infeurope, Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 20.174.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015117027/10.
(150125222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

IML Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 178.700.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2014 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2015117022/11.
(150126256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

ICAMAP Advisory S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 180.566.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en date du 16 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 2878 du 15 novembre 2013.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ICAMAP Advisory S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015117017/15.
(150124867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

IFI Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 84.151.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 3 juillet 2015 que

la démission de Monsieur Frédéric Gardeur, de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat a été acceptée.

Le conseil d'administration est désormais composé de:
- Alexander Studhalter, administrateur et Président du conseil d'administration
- Luca Gallinelli, administrateur
- Sabrina Colantonio, administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2015.

<i>Pour IFI Estates S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2015117019/18.
(150125716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

112616

L

U X E M B O U R G

RMF Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 149.620.

L’an deux mil quinze, le dix-neuf juin.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RMF PROMOTIONS S.A., avec siège

social à L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
la section B et le numéro 149620, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 novembre 2009,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2529 du 29 décembre 2009 (la "Société").

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1 

er

 avril 2011, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C numéro 752 du 19 avril 2011.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Caroline Weber, juriste, demeurant professionnellement à Sen-

ningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Senninger-

berg,

L’assemblée  choisit  comme  scrutateur  Madame  Sylvie  Ramos,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à

Senningerberg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la Société à L-2146 Luxembourg, 76, Rue de Merl;
2. Modification subséquente de l'article 2 §1 des statuts de la Société;
3. Modification de l’adresse professionnelle de Monsieur Frédéric Reichling en tant qu'administrateur, administrateur-

délégué  et  représentant  permanent  de  Espace  Invest  Sarl  et  de  Monsieur  Michael  Reichling  en  tant  que  président  et
administrateur de la Société qui se lira dorénavant comme suit: L-2146 Luxembourg, 76, Rue de Merl.

4. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions  qu'ils  détiennent  sont  indiqués  sur  une  liste  de  présence;  cette  liste  de  présence,  après  avoir  été  signée  par  les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur“ par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale des actionnaires décide de transférer le siège social de la Société de L-8008 Strassen, 130, route

d’Arlon vers L-2146 Luxembourg, 76, Rue de Merl.

<i>Deuxième résolution:

A la suite de la résolution qui précède, l'article 2 premier paragraphe des statuts de la Société est modifié et aura la teneur

suivante:

Art. 2. §1. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg."

<i>Troisième résolution:

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’adresse professionnelle de Monsieur Frédéric Reichling en

tant qu'administrateur, administrateur-délégué et représentant permanent de l’administrateur Espace Invest Sarl et de Mon-
sieur Michael Reichling en tant que président et administrateur de la Société qui se lira dorénavant comme suit: L-2146
Luxembourg, 76, Rue de Merl.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

112617

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100).

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et/ou employés de l'Étude du notaire

soussigné, chacun pouvant agir individuellement, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous connus

du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent
acte.

Signé: Caroline Weber, Sylvie Ramos, Sophie Mathot, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C1., le 1 

er

 juillet 2015. 1LAC / 2015 / 20402. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 7 juillet 2015.

Référence de publication: 2015117404/70.
(150125829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Dogs4Life, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6560 Hinkel, 1, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg F 10.450.

STATUTEN

Kapitel I. Benennung - Sitz - Dauer - Zweck und Ziel:

Art. 1. Der Verein führt den Namen "Dogs4Life ", und ist dem "Club Luxembourgeois pour Agility ", kurz benannt

"C.L.A.", angeschlossen.

Der Sitz ist in Hinkel und seine Dauer unbegrenzt.
Gründung des Vereins: 01.06.2015

Art. 2. Der Verein hat zum Zweck und zum Ziel, unter Ausschluss jeder politischen und konfessionellen Tätigkeit:
a) eine enge kameradschaftliche Verbindung der Hundesportler zu gewährleisten, respektiv zu fördern,
b) die Interessen seiner Mitglieder zu wahren und zu fördern,
c) die Förderung der Hunde-Ausbildung

Kapitel II. Zusammensetzung und Aufnahme

Art. 3. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt., darf jedoch nicht unter 3 fallen
Der Verein besteht aus aktiven, und inaktiven Mitgliedern.

Art. 4. Jede unbescholtene Person kann in den Verein aufgenommen werden.
Wer dem Verein beizutreten wünscht, hat ein schriftliches Aufnahmegesuch an den Vorstand einzureichen.
Der Vorstand entscheidet über die An- oder Nichtannahme.
a) Aktive Mitglieder sind alle Vorstandsmitglieder und alle Hundesportler, sowie Mitglieder, die im Verein eine Funktion

irgendwelcher Art ausüben, und sich verpflichteten, gegenwärtige Statuten, Reglemente und Beschlüsse anzuerkennen,

Kapitel III. Austritt und Ausschluss:

Art. 5. Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch schriftliche Erklärung an die Adresse des Präsidenten oder des Sekretärs
b) durch Weigerung zur Zahlung der Beiträge.

Art. 6. Der Ausschluss kann vom Vorstand ausgesprochen werden:
a) bei Nichtbezahlen von Schulden gegenüber dem Verein, nach zweimaliger schriftlicher Aufforderung; die zweite
schriftliche Aufforderung erfolgt spätestens 30 Tage nach der ersten;
b) durch einwandfrei nachgewiesenen Handlungen oder Unterlassungen, welche die Interessen des Vereins schädigen;
c) bei groben Verstößen gegen die Statuten, der Interessen oder des Ansehendes Vereins
Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat kein Anspruch auf irgendeinen Vermögensanteil des Vereins.

112618

L

U X E M B O U R G

Kapitel IV. Verwaltung:

Art. 7. Der Verein wird durch einen Vorstand verwaltet, welcher von der Generalversammlung gewählt wird, und sich

aus 3-8

Mitgliedern zusammensetzt.

Art. 8.
a) Um Vorstandsmitglied zu werden, muss der Kandidat mindestens 3 Jahre Mitglied des Vereins sein, und
mindestens 18 Jahre alt sein;
b) der Vorstand besteht aus: Präsident, Vize-Präsident, Sekretär, Kassierer und 1-3 Beisitzenden;
c) die Vorstandsmitglieder werden von der Generalversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt:
d) der Präsident, Sekretär und Kassierer werden von der Generalversammlung in getrennten Wahlgängen gewählt.
Die höchste Stimmenzahl bestimmt den zu besetzenden Posten;
e) die Kandidaturen für den Vorstand müssen schriftlich 8 Tage vor Beginn der Generalversammlung beim Präsident
oder dem Sekretär eingereicht werden; Der Poststempel bzw. die Empfangsbestätigung sind ausschlaggebend
f) die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus;
g) scheidet im Laufe des Jahres ein Vorstandsmitglied aus, so kann es durch den nächsten Ersatzkandidaten für die
Dauer des übernommenen Mandats ersetzt werden.
h) der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins.
Die Sitzungen werden durch einfaches Schreiben oder elektronische Post einberufen, sofern es die Interessen des
Vereins Verlangen, jedoch mindestens 3 mal Jährlich
i) die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet den Vorstandssitzungen beizuwohnen.
Wenn ein Mitglied mehr als 3x unentschuldigt fehlt, kann der Vorstand dasselbe seines Amtes entheben;
j) in Erfüllung seiner Mission hat der Vorstand die weitgehendsten Machtbefugnisse.
Alles was nicht ausdrücklich der Generalversammlung durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Statuten
vorbehalten ist, fällt unter seine Zuständigkeit;
k) bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten oder dessen Stellvertreter, im falle der Abwesenheit

des Presidenten

I) von jeder Sitzung wird ein Protokoll angefertigt. Erfolgt in der darauf folgenden Sitzung keine Beanstandung, so
wird dieses Protokoll vom Präsidenten oder dessen Stellvertreter und vom Sekretär unterschrieben.
m) jede ordnungsgemäß einberufene Vorstandssitzung, in der die Merheit der gewählten Vorstandsmitglider anwesend

ist, ist beschlussfähig.

Sie beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit;
n) das Kassenbuch, worin alle Finanzoperationen eingetragen werden, wird einmal jährlich von den Kassenrevisoren
geprüft.
Zur Kontrolle der Abrechnungen werden in der Generalversammlung jährlich 2 Kassenrevisoren gewählt.
Dieselben dürfen dem Vorstand des Vereins nicht angehören.

Kapitel V. Generalversammlung:

Art. 9.
a) Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im ersten Trimester statt.
Der Vorstand muss eine Generalversammlung einberufen, wenn 1/5der Vereinsmitglieder dies fordert
Die Mitglieder werden schriftlich eingeladen, und zwar 14 Tage im Voraus.
Die Einladungen enthalten die Tagesordnung, sowie eventuelle Vorschläge der Mitglieder bzw. des Vorstandes
b) Der Präsident oder dessen Stellvertreter übernimmt den Vorsitz der Generalversammlung;
c) die Generalversammlung ist immer beschlussfähig und kann gültig tagen, gleichviel wie viel Mitglieder auch immer
anwesend sind.
Sie fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder, in Übereinstimmung mit den Artikeln 7 und

8 des Gesetzes vom 21.04.1928.

Die Veröffentlichungen müssen in Übereinstimmung mit Artikel 9 desselben Gesetzes erfolgen.
Alle Mitglieder sind stimmberechtigt.

Art. 10.  Die  Tagesordnung  muss  in  der  Einladung  zur  Generalversammlungaufgelistet  sein  Beschlüsse  zu  Punkten

ausserhalb der Tagesordnung können mit Einverständniss der Generalversammlung veranlasst werden.

Anträge welche von mindestens 1/20 der eingetragenen Mitglieder durch Unterschrift eingebracht werden, müssen in

die Tagesordnung augenommen werden

112619

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Über die Sitzung der Generalversammlung wird ein Protokoll angefertigt.
Die Beschlüsse der Generalversammlung sind den Mitgliedernsowie ggf. Dritten schriftlich oder elektronisch mittzu-

teilen

Art. 12. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
der Jahresbeitrag darf die Summe von 250 euro Index 100 nicht überschreiten.

Kapitel VI. Statutenänderung:

Art. 13. Eine Statutenänderungen, kann von einer Gv. vorgenommen werden sofern 2/3 der eingetragenen Mitglieder

anwesend bez. vertreten ist und der Antrag

zur Statutenänderung 2/3 der Stimmen erhält.

Kapitel VII. Auflösung:

Art. 14. Die Auflösung des Vereins erfolgt automatisch wenn die Zahl der Mitglieder weniger als 3 (drei) beträgt oder

eine GV. gemäss Art.4 bzw.art.8

einen entspreschenden Beschluss fasst.

Kapitel VIII. Vermögen des Vereins:

Art. 15.
a) Das Vermögen des Vereins besteht aus den jährlichen Beiträgen den aktiven und inaktiven Mitgliedern (max.250

€.-), welche jeweils in der Generalversammlung festgesetzt werden, sowie aus

Einnahmen von Veranstaltungen, Spenden, Subsidien, usw.
b) die Gelder dürfen nur zum Ausbau des Vereins und zur Förderung des Hundesports verwendet werden.
c) das Gesamtvermögen ist Eigentum des Vereins.
d) lm falle der Auflösung des Vereins wird das Vermögen des Vereins dem Tierheim, Sozialbüro, oder anderen Wohl-

tätigen Verienen übertragen.

Kapitel IX. Verschiedene Bestimmungen:

Art. 16.
a) Jedes Mitglied, welches mit einem Hund dem Verein beitritt, muss im Besitze einer gültigen Haftpflichtversicherung

sein

und der Hund muss veterinärmedizinisch bez. die gesetzlichen vorgegebenen Impungen aufweisen. Der oder die HUN-

DE müssen

einen Mikrochip haben.
Die Mitglieder verpflichten sich die durch den Vorstand erlassenen internen Bestimmungen zu befolgen.
b) Der Verein ist nicht für Schäden haftbar die im Rahmen seiner Veranstaltungen entstehen, und nicht durch Versi-

cherungen abschliegedeckt werden.

Der verein schliesst die notwendigen Versicherungen ab.
c) Die vorliegenden Statuten gelten insoweit als sie sich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben befinden.
d) Der Verein verpflichtet sich die vorgaben zur geschlechtlichen Gleichstellung sowie zum datenschutz zu beachten

Kapitel X. Allgemeine Verfügung:

Dieses Statut tritt mit dem Tag der Genehmigung in Kraft.

Hinkel, den 01.06.2015.

Référence de publication: 2015116768/125.
(150125860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Assumption Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 124.439.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'Administrateur suivant
- Madame Sophie LERAY, née le 25 octobre 1970 à Nice, France, demeurant au Villa 109, Palmera 2, Dubai, Emirats

Arabes Unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ASSUMPTION FINANCES S.A.

Référence de publication: 2015116549/12.
(150125749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

112620

L

U X E M B O U R G

Calonge Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 198.420.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of July.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing at Redange-sur-Attert (Grand-Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

«Kale Services S.à r.l.» having its registered office at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with

the Luxembourg Trade and Companies register under the number B-178.301,

here represented by Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-

sur-Attert by virtue of one proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of

incorporation of a company:

Name - Registered office - Duration - Corporate object - Capital

Art. 1. A public limited company (SA) named “Calonge Invest S.A.” is hereby established.

Art. 2. The registered office is established in the Municipality of Luxembourg.
It may be moved within the boundaries of this municipality by decision of the Board of Directors.
If any extraordinary political, economic or social events compromising normal business at the registered office or easy

communication with this office from abroad should arise or be imminent, the registered office may be declared to be
temporarily moved abroad, without such a measure having any effect on the nationality of the company, which shall remain
Luxembourgish despite this temporary transfer of the registered office.

Art. 3. The duration of the company is unlimited.

Art. 4. The company's purpose for the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign

companies and any other forms of investment, the acquisition by purchase, subscription or any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or any other manner of securities of any kind, administration, supervision and development of
these interests. The company may participate in the establishment and development of any industrial or trading company
and may grant its assistance to such company in the form of loans, guarantees or otherwise. It may lend or borrow with or
without interest, issue bonds and other acknowledgments of debt.

The company also provides acquisition, management, development and leasing by any other means and, where appro-

priate, the sale of buildings of any kind, whether in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad. It may carry out all
industrial, commercial, financial, securities or property in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad which are directly
or indirectly, in whole or in part, to its object.

It may achieve its object directly or indirectly for itself or for third parties, alone or in combination and carry out any

operation to promote said purpose or that of the companies in which it holds interests.

In general, the company may take any measures of inspection or supervision and perform any operation which is regarded

useful in the accomplishment of its object and purpose.

Art. 5. The share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by one hundred (100) shares each

having a nominal value of three hundred and ten Euro (EUR 310.-).

The shares may be in a bearer or registered form, at the discretion of the shareholder, with the exception of those shares

required by law to be registered.

The holder may choose to have the shares in the company created in single units or certificates representing several

shares.

Management - Monitoring

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company is managed by a Board of Directors composed of at least three

(3) members who need not to be shareholder(s) of the Company.

If the Company is held by a sole Shareholder, or if, during a general meeting of shareholders, it is found that it has only

one shareholder, the composition of the Board of Directors may be limited to one (1) director until the annual general
meeting acknowledging more than one shareholder.

The Director(s) shall be elected by the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the general meeting

of shareholders, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any

112621

L

U X E M B O U R G

director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall be
reeligible and removed at any time.

If the position of a board member appointed by the general assembly becomes vacant, the remaining board members

appointed by the general assembly shall be entitled to fill the position temporarily. In this case, the general assembly shall
make a definitive choice at the next meeting.

Art. 7. The board of directors is authorised to undertake all essential or useful actions to achieve the corporate objective,

and it shall be competent to handle any matters not reserved for the general assembly by law or these articles of association.

Art. 8. The board of directors shall have full powers to undertake all actions essential for or leading to fulfilment of the

corporate object. The board of directors may exercise any powers not expressly reserved by law or these articles of incor-
poration for the shareholders' assembly.

The board of directors shall elect a chairman from amongst its members. In the absence of the chairman, meetings may

be chaired by another board member. The sole board member shall act as de facto chairman.

The board of directors may only validly deliberate and pass resolutions if the majority of its members are present or

represented. Any board member may be represented by appointing, in writing or by telegram, fax or e-mail, any other board
member as their representative. Board members may not represent more than one of their colleagues.

Absent board members may also vote by letter, telegram, fax or e-mail. In both cases, the absent board member shall

be deemed to be present at the meeting.

In exceptional circumstances and following an express decision by the Chairman, board members may participate in a

board meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling everybody
taking part in the meeting to hear and talk to one another. In this case, the board member using this type of technology shall
be deemed to be present at the meeting and may take part in the vote.

The board of directors may pass resolutions validly using circular letters if they are signed and approved in writing by

all the board members. This approval may result from one or more separate documents sent in writing or by telegram, fax
or e-mail. Resolutions passed under these conditions shall have the same effect as resolutions passed during board meetings.
Documents, telegrams, faxes and e-mails expressing board members' votes shall be attached to the minutes of the meeting.

Decisions of the board of directors shall be taken by a majority of votes. In the event of a tie, the Chairman shall have

the casting vote.

Art. 9. The board of directors may delegate some or all of its powers concerning the daily management and representation

of the company regarding such management to one or more board members, directors, managers or other agents, who need
not be shareholders.

Art. 10. The company will be bound vis-à-vis third parties, in case of sole director, by signing this director and in case

of plurality of managers by the joint signatures of two (2) directors or by the individual signature of the person to whom
the daily management of the company has been delegated, within such daily management, or by the signatures of any
persons to whom such authority has been delegated by the Board, but only in limits of that power.

Art. 11. The company shall be monitored by one or more statutory auditors (“commissaires aux comptes”), who need

not be shareholders, appointed for a term that shall not exceed six years. They may be re-elected and removed from office
at any time.

Business year - General meeting

Art. 12. The business year shall run from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 13. General assemblies shall be convened in accordance with the related legal provisions. Notice need not be served

if all shareholders are present or represented, and they acknowledge prior knowledge of the agenda.

The board of directors may decide that, to attend the general assembly, holders of shares must deposit them at least five

clear days before the date set for the meeting. All shareholders shall have the right to vote in person or by means of a
representative, who need not be a shareholder.

Each share shall entitle the holder to one vote.

Art. 14. A properly constituted meeting of shareholders of the company shall represent all of the company shareholders.
The assembly shall have absolute power to undertake and/or ratify any deed in the interest of the company.

Art. 15. The general assembly shall decide on the allocation and distribution of net profits. The board of directors shall

be authorized to pay interim dividends in accordance with the related legal provisions.

Art. 16. The annual general meeting shall be held on the first Tuesday of May at 02:00 p.m. at the registered office or

in any other place named in the notice.

Art. 17. The Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, shall apply throughout, unless overridden

by these articles of association.

112622

L

U X E M B O U R G

<i>Transitional provisions:

1. The first financial year shall begin on the date these articles of association are signed, and shall end on December 31

st

 , 2015.

2. The first annual ordinary general meeting shall be held in 2016.

<i>Subscription - Payment of capital:

The articles of incorporation of the company having been agreed, the one hundred (100) shares have been subscribed

by the appearing party “Kale Services S.à r.l.”, prenamed and represented as aforesaid, and fully paid-up by contribution
in cash at the rate of twenty-five percent (25%), such the amount of seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR
7,750.-) is freely available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary who states it.

<i>Resolutions of the sole shareholder:

The appearing party, represented as aforesaid and representing the entire subscribed capital, has immediately taken the

following resolutions:

1) The registered office is fixed at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2) The following person has been elected as sole director fo the Company:
Mr. Yannick KANTOR, director of companies, residing at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
The term of his mandate shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in 2021.
3) The following person is appointed statutory auditor (“commissaire aux comptes”) of the Company:
Mrs. Ana DE OLIVIERA, accountant, residing professionally at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
The term of his mandate shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in 2021.

<i>Costs

All of the costs, expenses, remunerations and charges incurred by the company, including as a result of its establishment,

come to approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.
The notary drawing up this deed hereby acknowledges the existence of the conditions listed in Article 26 of the law on

commercial companies, expressly confirming the fulfilment thereof. These articles of incorporation are written in English
and followed by a French translation. In case of any discrepancy between these two versions of these articles of incorpo-
ration, the english version shall prevail.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mil quinze, le six juillet.
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

«Kale Services S.à r.l.» ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 178.301,

ici représentée par Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-Rue, L-8510

Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant

restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va

constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "Calonge Invest S.A.».

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans les limites de cette municipalité par décision du conseil d'administration.
Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises

ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que

112623

L

U X E M B O U R G

l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la
supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de
toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de
garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-
sances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le

cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra géné-
ralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de
Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association

en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération

qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent actions (100) d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit

la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Administration - Surveillance.

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique, ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires de la

société, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) seul administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique sont élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne

peut dépasser six (6) ans jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-

més ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à
l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles à

l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée des actionnaires
relèvent de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. En l'absence du président un autre administrateur peut

présider la réunion. L'administrateur unique remplira de fait les fonctions de président.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée. Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier élec-
tronique un autre administrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d'un de ses collègues.

L'administrateur empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Dans l'un

comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.

En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision expresse du Président, tout administrateur peut participer à une

réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéo conférence, ou par tout autre moyen de com-
munication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette réunion puissent s'entendre et se parler
mutuellement. Dans ce cas, l'administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent à la réunion et sera habilité
à prendre part au vote.

Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et

approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces conditions auront
les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Les écrits, télégrammes, télé-
copies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président est

prépondérante.

112624

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi

que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société sera engagée vis-à-vis des tiers, en cas d'administrateur unique, par la signature de cet administrateur

et en cas de pluralité d'administrateurs par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs, ou par la signature indi-
viduelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière,
ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit

en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites

par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le premier mardi du mois de mai à 14 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires:

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

<i>Souscription et libération:

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante «Kale Services S.à r.l.», prénommée et représentée comme

ci-avant, déclare souscrire les cent (100) actions et les libérer par apport en numéraire à hauteur de vingt-cinq pour cent
(25%) de sorte que le montant de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre
disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant qui le constate.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de mille cinq cent euros (1.500,-
EUR).

<i>Résolutions de l'actionnaire unique:

Et immédiatement après la constitution de la société, l'actionnaire unique, représenté comme ci-avant et détenant l'in-

tégralité du capital social, a pris les décisions suivantes:

1) Le siège social de la société est fixé à L-1528 Luxembourg, 8A, Boulevard de la Foire.
2) Est appelé aux fonctions d'administrateur unique de la société:
Monsieur Yannick KANTOR, administrateur de sociétés, demeurant au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

112625

L

U X E M B O U R G

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:
Mme Ana DE OLIVEIRA, comptable, demeurant professionnellement au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-

bourg.

Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2021.

DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue par le notaire instrumentant par

son nom prénom, état et demeure celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 9 juillet 2015. Relation: DAC/2015/11532. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

<i>Le Receveur (signé): J. THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 14 juillet 2015.

Référence de publication: 2015116638/278.
(150126457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Delos LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 197.991.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of June,
Before Us, Me Jacques KESSELER, notary residing in Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED

MPE (G.P. IV) LP, with business office at 50, Lothian Road, Edinburgh, EH3 9WJ, United Kingdom, registered in the

commercial register (Registrar of Companies) of Scotland under No. SL008391, acting by its manager Montagu Private
Equity LLP, with business office at 2, More London Riverside SE1 2AP, United Kingdom, registered in the commercial
register (Registrar of Companies) of England and Wales under No. OC319972,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address in Pétange, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, is the sole shareholders (the "Sole Shareholder") of Delos LuxCo

1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg register of commerce and companies
and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 12 June 2015, whose articles of association (the
"Articles") have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and have not yet been
amended since then.

The Sole Shareholder, representing the whole corporate capital of the Company and represented as indicated above,

requires the notary to act the following resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à
responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions
of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the nominal value of the existing shares of the Company from EUR 1.- to EUR

0.01 per share, so that the Sole Shareholder now holds 1,250,000 shares in the Company.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to create 10 new classes of preferred shares having the rights set out below and each

share having a nominal value of EUR 0.01, hereinafter referred to as:

- class A shares (the "Class A Preferred Shares");
- class B shares (the "Class B Preferred Shares");
- class C shares (the "Class C Preferred Shares");
- class D shares (the "Class D Preferred Shares");
- class E shares (the "Class E Preferred Shares");
- class F shares (the "Class F Preferred Shares");
- class G shares (the "Class G Preferred Shares");

112626

L

U X E M B O U R G

- class H shares (the "Class H Preferred Shares");
- class I shares (the "Class I Preferred Shares"); and
- class J shares (the "Class J Preferred Shares").

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves that pursuant to the first and second resolutions, the existing 1,250,000 shares in the

Company shall be referred to as the "Initial Ordinary Shares".

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,000,000.-, in order

to raise it from its current amount of EUR 12,500.-to EUR 1,012,500.-, through the creation and issuance of 10,000,000
Class A Preferred Shares, 10,000,000 Class B Preferred Shares, 10,000,000 Class C Preferred Shares, 10,000,000 Class D
Preferred Shares, 10,000,000 Class E Preferred Shares, 10,000,000 Class F Preferred Shares, 10,000,000 Class G Preferred
Shares, 10,000,000 Class H Preferred Shares, 10,000,000 Class I Preferred Shares and 10,000,000 Class J Preferred Shares,
with a nominal value of EUR 0.01 each (together, the "New Shares"), having the rights set out below.

<i>Subscription and payment

The Sole Shareholder, represented as indicated above, declares to subscribe for the ownership of the New Shares, fully

paid up by a contribution in cash in a total amount of EUR 8,262,323.-, which shall be allocated as follows: an amount of
EUR 1,000,000.- is allocated to the share capital of the Company and an amount of EUR 7,262,323.- is allocated to the
share premium account of the Company.

Proof that the amount of EUR 8,262,323.- is at the disposition of the Company.

<i>Fifth resolution

Further to the resolutions above, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles which shall now read

as follows:

5.1. The Company's share capital is set at one million twelve thousand five hundred euros (EUR 1,012,500.-) divided

into:

- one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) initial ordinary shares (the "Initial Ordinary Shares"),
- ten million (10,000,000) class A preferred shares (the "Class A Preferred Shares"),
- ten million (10,000,000) class B preferred shares (the "Class B Preferred Shares"),
- ten million (10,000,000) class C preferred shares (the "Class C Preferred Shares"),
- ten million (10,000,000) class D preferred shares (the "Class D Preferred Shares"),
- ten million (10,000,000) class E preferred shares (the "Class E Preferred Shares"),
- ten million (10,000,000) class F preferred shares (the "Class F Preferred Shares"),
- ten million (10,000,000) class G preferred shares (the "Class G Preferred Shares"),
- ten million (10,000,000) class H preferred shares (the "Class H Preferred Shares"),
- ten million (10,000,000) class I preferred shares (the "Class I Preferred Shares"), and
- ten million (10,000,000) class J preferred shares (the "Class J Preferred Shares"),
each a "Share" and together referred to as the "Shares", having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each and

the rights and obligations set out in these Articles. The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders"
and individually a "Shareholder".

Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.5 of the Articles which shall now read as follows:

5.5. The share capital of the Company may be reduced exclusively through the repurchase and subsequent cancellation

of all the issued shares of one or more Classes (a "Share Redemption") in respect of the following periods, provided however
that the Company may not at any time purchase and cancel the Initial Ordinary Shares. A reduction of share capital through
the repurchase of a class of Preferred Shares may only be made within the respective Class Periods:

- The period for the Class A Preferred Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 25 June 2015 and

ending no later than on 31 December 2016 (the "Class A Period").

- The period for the Class B Preferred Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending no

later than on 31 December 2017 (the "Class B Period").

- The period for the Class C Preferred Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no

later than on 31 December 2018 (the "Class C Period").

- The period for the Class D Preferred Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending on

no later than on 31 December 2019 (the "Class D Period").

112627

L

U X E M B O U R G

- The period for the Class E Preferred Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no

later than on 31 December 2020 (the "Class E Period").

- The period for the Class F Preferred Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no

later than on 31 December 2021 (the "Class F Period").

- The period for the Class G Preferred Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending no

later than on 31 December 2022 (the "Class G Period").

- The period for the Class H Preferred Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no

later than on 31 December 2023 (the "Class H Period").

- The period for the Class I Preferred Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no

later than on 31 December 2024 (the "Class I Period").

- The period for the Class J Preferred Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later

than on 31 December 2025 (the "Class J Period").

Where a Class has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and cancellation

of that Class may be made within a new period (the "New Period"), which shall start on the date after the last Class Period
(or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another class) and end no later
than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class J Period.

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a Class shall take place prior to the last

day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case may be,
New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such Class and shall continue to end on the day
initially defined in the Articles above.

Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant Class(es), the Cancellation Amount will become due and

payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such Class(es). For the avoidance of doubt the
Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the Sole Manager or,

in case of plurality of managers the Board of Managers (as both terms defined below) in its reasonable discretion and within
the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the Sole Manager or, in case of plurality the Board
of Managers can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount
the freely distributable reserves either in part or in totality.

For the purposes of these Articles, the following words shall have the following definitions:
-"Available Amount" shall mean for each Class Period the total amount of net profits of the Company (including carried

forward profits), increased by (i) any freely distributable reserves and share premium attributable to the Preferred Shares
(ii) as the case may be, by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of
Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums
to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each time as set out in the relevant
Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, and double counting), (iii) any dividend to which the holder(s) of
the Initial Ordinary Shares are entitled pursuant to the Articles and (iv) any Profit Entitlement so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + OD + PE)
Whereby:
AA = Available Amount;
NP = net profits (including carried forward profits);
P = any freely distributable reserves;
CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preferred Shares to be

cancelled;

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive;
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the 1915 Law or of the Articles;
OD = any dividend to which the holder(s) of the Initial Ordinary Shares are entitled pursuant to the Articles;
PR = Profit Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by

the Sole Manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers of the Company in good faith with the view
to the Company's ability to continue as a going concern.

-"Available Liquidities" shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a

remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds, and notes
and any receivable which in the opinion of the Sole Manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers
will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six
(6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the
case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company.

112628

L

U X E M B O U R G

-"Cancellation Amount" shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period

(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities
relating to the relevant Class Period (or New Period).

-"Class" refers to a particular class or classes of Preferred Shares.
-"Class Period" shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the

Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

-"Interim Accounts" shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
-"Interim Account Date" shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the

date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preferred Shares.

-"Preferred Shares" means the Class A Preferred Shares, Class B Preferred Shares, Class C Preferred Shares, Class D

Preferred Shares, Class E Preferred Shares, Class F Preferred Shares, Class G Preferred Shares, Class H Preferred Shares,
Class I Preferred Shares and Class J Preferred Shares.

-"Profit Entitlement" shall mean the dividends allocated to the Preferred Shares."

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 15.2 of the Articles of the Company, which shall now read as follows:

15.2. Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholder

declare dividends. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken
by the Shareholders and such dividend shall be allocated and paid in the following sequential order:

- first to the holder(s) of the Initial Ordinary Shares who shall be entitled to a dividend equal to 0.60% of the nominal

value of the Initial Ordinary Share held by them, then,

- to the holder(s) of the Class A Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 0.10% of the nominal value

of the Class A Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class B Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 0.15% of the nominal value

of the Class B Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class C Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 0.20% of the nominal value

of the Class C Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class D Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 0.25% of the nominal value

of the Class D Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class E Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 0.30% of the nominal value

of the Class E Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class F Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 0.35% of the nominal value

of the Class F Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class G Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 0.40% of the nominal value

of the Class G Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class H Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 0.45% of the nominal value

of the Class H Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class I Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 0.50% of the nominal value

of the Class I Preferred Shares held by them, then,

- to the holder(s) of the Class J Preferred Shares who shall be entitled to a dividend equal to 0.55% of the nominal value

of the Class J Preferred Shares held by them,

the balance shall be allocated to the holder(s) of the Preferred Shares pursuant to a decision taken by the general meeting

of Shareholders."

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 15.3 of the Articles of the Company, which shall now read as follows:

15.3. The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder

(s) before the end of the financial year in accordance with the distribution provisions described in the preceding Article
15.2 of these Articles on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of
the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward
losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any
such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder
(s)."

112629

L

U X E M B O U R G

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq juin,
Par-devant le soussigné, Maître Jacques KESSELER, notaire résidant à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU

MPE (G.P. IV) LP, ayant son siège social au 50, Lothian Road, Edinburgh, EH3 9WJ, Royaume-Uni, immatriculé auprès

du registre des sociétés (Registrar of Companies) de l'Ecosse sous le numéro SL008391, agissant par sont administrateur
Montagu Private Equity LLP, ayant son siège social au 2, More London Riverside SE1 2AP, Royaume-Uni, immatriculé
auprès du registre des sociétés (Registrar of Companies) d'Angleterre et du Pays des Galles sous le numéro OC319972,

ici représentées par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc du notaire, résidant professionnellement à

Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera attachée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, est l'associé unique (l'"Associé Unique") de Delos

LuxCo 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  en  cours  d'immatriculation  auprès  du  registre  du  commerce  et  des  sociétés  de
Luxembourg (la "Société") et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juin 2015, dont les statuts
(les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et n'ont pas encore été
modifiés depuis lors.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société et représenté comme indiqué ci-dessus, requiert

le notaire d'acter les résolutions suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, en vertu duquel un associé unique d'une société à
responsabilité limitée exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de
l'associé unique seront actées dans des procès-verbaux ou prises par écrit:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de changer la valeur nominale des parts sociales existantes de la Société de EUR 1.- à EUR

0,01 par part sociale, de sorte que l'Associé Unique détient maintenant 1.250.000 parts sociales dans la Société.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de créer 10 nouvelles catégories de parts sociales préférentielles ayant les droits décrits ci-

dessous et chaque part sociale ayant une valeur nominale de EUR 0,01, ci-après dénommées:

- parts sociales préférentielles de catégorie A (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A");
- parts sociales préférentielles de catégorie B (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B");
- parts sociales préférentielles de catégorie C (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C");
- parts sociales préférentielles de catégorie D (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D");
- parts sociales préférentielles de catégorie E (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E");
- parts sociales préférentielles de catégorie F (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F");
- parts sociales préférentielles de catégorie G (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G");
- parts sociales préférentielles de catégorie H (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H");
- parts sociales préférentielles de catégorie I (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I"); et
- parts sociales préférentielles de catégorie J (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J").

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide que suivant les première et deuxième résolutions, les 1.250.000 parts sociales existantes dans

la Société seront dénommées comme les "Parts Sociales Ordinaires Initiales".

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 1.000.000,- afin de le porter

de son montant actuel de EUR 12.500,- à EUR 1.012.500,-, par la création et l'émission de 10.000.000 Parts Sociales
Préférentielles de Catégorie A, 10.000.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B, 10.000.000 Parts Sociales Pré-

112630

L

U X E M B O U R G

férentielles de Catégorie C, 10.000.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, 10.000.000 Parts Sociales Préféren-
tielles de Catégorie E, 10.000.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F, 10.000.000 Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie G, 10.000.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H, 10.000.000 Parts Sociales Préférentielles de
Catégorie I et 10.000.000 Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J, avec une valeur nominale de EUR 0,01 chacune
(ensemble, les "Nouvelles Parts Sociales"), ayant les droits décrits ci-dessous.

<i>Souscription et paiement

L'Associé Unique, représenté tel qu'indiqué ci-dessus, déclare souscrire à la propriété des Nouvelles Parts Sociales

payées intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de EUR 8.262.323,-, qui sera attribué comme suit:
EUR 1.000.000,-sont alloués au capital social de la Société et EUR 7.262.323,- sont alloués au compte de prime d'émission
de la Société.

La preuve que la somme de EUR 8.262.323,- est à la disposition de la Société.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier de l'article 5.1 des Statuts de la Société, qui se lira

désormais comme suit:

5.1. Le capital souscrit est fixé à un million douze mille cinq cents euros (1.012.500,- EUR) représenté par:
- un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires initiales (les "Parts Sociales Ordinaires

Initiales"),

- dix millions (10.000.000) parts sociales préférentielles de catégorie A (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

A"),

- dix millions (10.000.000) parts sociales préférentielles de catégorie B (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

B"),

- dix millions (10.000.000) parts sociales préférentielles de catégorie C (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

C"),

- dix millions (10.000.000) parts sociales préférentielles de catégorie D (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

D"),

- dix millions (10.000.000) parts sociales préférentielles de catégorie E (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

E"),

- dix millions (10.000.000) parts sociales préférentielles de catégorie F (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

F"),

- dix millions (10.000.000) parts sociales préférentielles de catégorie G (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

G"),

- dix millions (10.000.000) parts sociales préférentielles de catégorie H (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

H"),

- dix millions (10.000.000) parts sociales préférentielles de catégorie I (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

I"), et

- dix millions (10.000.000) parts sociales préférentielles de catégorie J (les "Parts Sociales Préférentielles de Catégorie

J"),

chaque  "Part  Sociale"  et  ensemble  ci-après  désignées  comme  les  "Parts  Sociales",  ayant  une  valeur  nominale  d'un

centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et ayant les droits et obligations décrits dans les présents Statuts. Les détenteurs de
Parts Sociales sont désignés tous ensemble comme les "Associés", et individuellement comme "Associé".

Chaque Part Sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier de l'article 5.5 des Statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:

5.5. Le capital social de la Société peut être réduit exclusivement par le rachat et l'annulation subséquente des Parts

Sociales émises d'une ou plusieurs Catégorie(s) (un "Remboursement de Part Sociale") à l'égard des périodes suivantes,
sous réserve cependant, que la Société ne rachète et n'annule à tout moment les Parts Sociales Ordinaires Initiales. Une
réduction du capital social par le biais d'un rachat d'une catégorie de Parts Sociales Préférentielles peut se faire seulement
endéans les Périodes de Catégorie respectives:

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A est la période qui commence à la date de l'acte notarié

du 25 juin 2015 et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2016 (la "Période de Catégorie A").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie A et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2017 (la "Période de Catégorie B").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie B et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2018 (la "Période de Catégorie C").

112631

L

U X E M B O U R G

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie C et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2019 (la "Période de Catégorie D").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie D et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2020 (la "Période de Catégorie E").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie E et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2021 (la "Période de Catégorie F").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie F et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2022 (la "Période de Catégorie G").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie G et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2023 (la "Période de Catégorie H").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie H et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2024 (la "Période de Catégorie I").

- La période pour les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J est la période qui commence le jour après la Période

de Catégorie I et qui se terminera au plus tard au 31 décembre 2025 (la "Période de Catégorie J").

Lorsqu'une Catégorie n'aura pas été rachetée et annulée endéans la Période de Catégorie concernée, le remboursement

et l'annulation de cette Catégorie peut se faire endéans une nouvelle période (la "Nouvelle Période"), laquelle devra com-
mencer à la date après la dernière Période de Catégorie (ou selon le cas, la date après la fin immédiate de la Nouvelle
Période précédente d'une autre catégorie) et se terminer pas plus tard qu'un an après la date de début de cette Nouvelle
Période. La première Nouvelle Période devra commencer le jour après la Période de Catégorie J.

Afin d'éviter tout doute, dans le cas où un rachat et une annulation d'une Catégorie aurait lieu avant le dernier jour de

sa Période de Catégorie respective (ou selon le cas, Nouvelle Période), la Période de Catégorie suivante (ou selon le cas,
Nouvelle Période) devra commencer la jour après la rachat et l'annulation de cette Catégorie et devra continuer pour se
terminer le jour comme initialement défini dans les Statuts ci-dessus.

Sur le rachat et l'annulation de la(des) Catégorie(s) entière(s) concernée(s), le Montant d'Annulation deviendra dû et

exigible par la Société à l'(aux) Associé(s) au pro rata de leur détention dans cette(ces) Catégorie(s). Afin d'éviter tout doute
la Société peut s'acquitter de ses obligations de paiement en numéraire, en nature ou par voie de compensation.

Le Montant d'Annulation mentionné dans le paragraphe ci-dessus devant être retenu devra être déterminé par le Gérant

Unique ou, en cas de pluralité de gérants le Conseil de Gérance (les deux termes définis ci-dessous) à sa discrétion rai-
sonnable et dans le meilleur intérêt de la Société. Afin d'éviter tout doute, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité le Conseil
de Gérance peut choisir à sa seule discrétion d'inclure ou d'exclure dans sa détermination du Montant d'Annulation les
réserves librement distribuables soit en partie soit en totalité.

Pour les besoins de cet Article, les mots suivants auront les définitions suivantes:
"Catégorie" désigne une ou plusieurs catégories spécifiques de Parts Sociales.
"Comptes Intérimaires" signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés.
"Date des Comptes Intérimaires" signifie la date pas plus tôt que trente (30) jours mais pas plus de dix (10) jours avant

la date de rachat et d'annulation de la catégorie de Parts Sociales Préférentielles concernée.

"Droit au bénéfice" signifie les dividendes préférentiels des Parts Sociales Préférentielles.
"Liquidités Disponibles" signifie (i) tout l'argent détenu par la Société (sauf l'argent sur des dépôts à terme avec une

maturité restante excédant six (6) mois, (ii) tous instruments financiers facilement négociables, obligations et notes et toutes
créances qui selon l'opinion du Conseil de Gérance sera payées à la Société à court terme moins tout endettement ou autre
dette de la Société payable dans les six (6) mois déterminé sur la base des Comptes Intérimaires relatifs à la Période de
Catégorie concernée (ou Nouvelle Période, selon le cas) et (iii) tous actifs tels que des parts sociales, actions ou titres
d'autres sortes détenus par la Société.

"Montant d'Annulation" signifie un montant n'excédant pas le Montant Disponible relatif à la Période de Catégorie

concernée (ou Nouvelle Période, selon le cas) à condition que le Montant d'Annulation ne peut être plus élevé que les
Liquidités Disponibles relatives à la Période de Catégorie concernée (ou Nouvelle Période).

"Montant Disponible" signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant les bénéfices reportés) augmenté

par (i) toutes réserves librement distribuables et (ii) selon le cas, par le montant de la réduction de capital et la réduction
de la réserve légale relative à la catégorie de Parts Sociales Préférentielles devant annulée mais réduite par (i) toutes pertes
(incluant les pertes reportées) exprimées comme positive, (ii) toutes sommes devant être placées dans la(les) réserve(s) en
application aux exigences de la Loi de 1915 ou des Statuts, chaque fois comme établi dans les Comptes Intérimaires
concernés (sans, afin d'éviter tout doute, tout double comptage), (iii) tous dividendes auxquels le(s) détenteur(s) de Parts
Sociales Ordinaires Initiales a(ont) droit en vertu des Statuts et (iv) tout Droit au Bénéfice de manière que:

AA = (NP + P+ CR) - (L+LR+OD+PE)
Dont:
AA = Montant Disponible;
NP = bénéfices nets (incluant les bénéfices reportés);
P = toutes réserves librement distribuables;

112632

L

U X E M B O U R G

CR = le montant de la réduction de capital et la réduction de la réserve légale relative à la catégorie de Parts Sociales

Préférentielles devant être annulée;

L= pertes (incluant les pertes reportées) exprimées comme positive;
LR = toutes sommes devant être placées dans la(les) réserve(s) en vertu des dispositions de la Loi de 1915 ou des Statuts;
OD = tous dividendes auxquels le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires a droit en vertu des Statuts
PE = Bénéfice Autorisé.
Le Montant Disponible doit être établi dans les Comptes Intérimaires de la Période de Catégorie respective et devra être

évalué par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants le Conseil de Gérance de la Société de bonne foi et avec la
vue des capacités de la Société pour qu'elle puisse continuer.

"Parts Sociales Préférentielles" signifie les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A, Parts Sociales Préférentielles

de Catégorie B Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, Parts Sociales
Préférentielles de Catégorie E, Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F, Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G,
Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H, Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I et Parts Sociales Préférentielles
de Catégorie J.

"Période de Catégorie" signifie chacune de la Période de Catégorie A, la Période de Catégorie B, la Période de Catégorie

C, la Période de Catégorie D, la Période de Catégorie E, la Période de Catégorie F, la Période de Catégorie G, la Période
de Catégorie H, la Période de Catégorie I et la Période de Catégorie J."

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide de modifier de l'article 15.2 des Statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:

15.2. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par résolutions des

Associés déclarer des dividendes. La décision de distribuer des fonds et la détermination du montant d'une telle distribution
seront prises par les Associés et ledit dividende sera alloué et payé dans l'ordre suivant:

- d'abord, le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires Initiales a(ont) droit à un dividende égal à 0,60 % de la valeur

nominale des Parts Sociales Ordinaires Initiales détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A a(ont) droit à un dividende égal à 0,10% de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B a(ont) droit à un dividende égal à 0,15% de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C a(ont) droit à un dividende égal à 0,20% de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D a(ont) droit à un dividende égal à 0,25% de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E a(ont) droit à un dividende égal à 0,30% de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F a(ont) droit à un dividende égal à 0,35% de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G a(ont) droit à un dividende égal à 0,40% de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H a(ont) droit à un dividende égal à 0,45% de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie H, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I a(ont) droit à un dividende égal à 0,50% de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie I, détenues par lui/eux, puis,

- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J a(ont) droit à un dividende égal à 0,55% de la valeur

nominale des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie J, détenues par lui/eux, puis,

la différence sera allouée au(x) détenteur(s) de Parts Sociales Préférentielles conformément à une décision prise par

l'assemblée générale des Associés."

<i>Huitième résolution

L'Associé Unique décide de modifier de l'article 15.3 des Statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:

15.3. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut, le cas échéant, décider de payer des acomptes sur dividendes

au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social conformément aux dispositions relatives à la distribution décrites dans
l'Article 15.2 précédent sur base d'une situation comptable montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la
distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis
la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes
reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi de 1915 ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes
distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés peuvent devoir être remboursés par le(s) Associé
(s)."

112633

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Pétange, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 juin 2015. Relation: EAC/2015/14770. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015116756/436.
(150125181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Julius Baer SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 121.992.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand fifteen, on the thirtieth day of June.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

GAM Advisory (Luxembourg) S.A., a Luxembourg public limited company (société anonyme), having its registered

office at 25, Grand Rue, L-1661 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under the number B 85427 (the ”Shareholder”),

hereby represented by Mr Nils KRUSE, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given

by the Shareholder on 9 June 2015.

The said proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The Shareholder requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of JULIUS

BAER SICAV II (the “Company”), in liquidation, a société d'investissement à capital variable registered at the Trade and
Companies Register of Luxembourg under number B121992 and having its registered office at 25, Grand Rue, L-1661
Luxembourg, incorporated by notarial deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, on 24 November
2006, its articles of incorporation having been modified for the last time by notarial deed of Maître Henri Hellinckx on 14
May 2012, as published in the Mémorial C number 2347 of 15 December 2006 and C number 1498 of 15 June 2012,
respectively.

The Company has been put into liquidation by notarié deed of the undersigned notary on 30 June 2015, not yet published

in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholder, represented as above mentioned, declares having recognized to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

1. To acknowledge the report of the Auditor for the period from 1 July 2014 to 30 June 2015 (date on which the Company

has been put into liquidation);

2. To approve the audited financial statements for the period from 1 July 2014 to 30 June 2015;
3. To grant discharge to the directors of the board of directors of the Company for the period of time comprised between

1 July 2014 to 30 June 2015;

4. To hear and approve the report of the liquidator on the liquidation of the Company;
5. To receive and approve the report of the Company's Auditor on the liquidation of the Company;
6. To grant discharge to the liquidator;
7. To decide on the close of the liquidation.
The Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution:

The Shareholder acknowledged the report of the auditor for the period from 1 July 2014 to 30 June 2015; (date on which

the Company has been put into liquidation);

112634

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to approve the audited financial statements for the period from 1 July 2014 to 30 June 2015;

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to grant discharge to the directors of the board of directors of the Company for the performance

of their duties for the interim period of time comprised between 1 July 2014 to 30 June 2015;

<i>Fourth resolution

The Shareholder having received and heard the report of the liquidator on the liquidation resolved to approve the said

report.

<i>Fifth resolution.

The Shareholder having received the report of the auditor on the liquidation of the Company, resolved to approve same

report.

<i>Sixth resolution

The Shareholder having heard and approved the report of the auditor resolved to give discharge to the liquidator for the

carrying out of their duties until the date of this resolution.

<i>Seventh resolution

The Shareholder decided to close the liquidation and decides that the books and documents of the Company are deposited

for a period of five years at the former registered office of the dissolved Company at L-1661 Luxembourg, 25, Grand Rue.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first

name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois de juin,
Par-devant nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

GAM Advisory (Luxembourg) S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au

25, Grand Rue, L-1661 Luxembourg et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
85427 (l'”Associé”),

représenté par Monsieur Nils KRUSE, employé, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par l'Associé

le 9 juin 2015.

La dite procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, sera annexée au présent acte à des fins d'enregis-

trement.

L'Associé a demandé au notaire instrumentant d'acter que l'Associé est l'associé unique de JULIUS BAER SICAV II

une société d'investissement à capital variable régie par le droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-121992 et ayant son siège social à 25, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, Grand-
duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte notarié de Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 24 novembre 2006, les statuts ayant été modifies pour la dernière fois par acte notarié de Maître
Henri Hellinckx en date du 14 mai 2012, les dit actes ayant été publiés au Mémorial C, sous le numéro 2347 du 15 décembre
2006 et C numéro 1498 du 15 juin 2012 respectivement.

La Société a été mise en liquidation suivant acte notarié en date du 30 juin 2015, non encore publié au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

L'Associé, représenté tel que précédemment mentionné, reconnaît être parfaitement au courant des décisions à intervenir

sur base de l'ordre du jour suivant:

1. Prendre connaissance le rapport du réviseur d'entreprises pour la période du 1 

er

 juillet 2014 au 30 juin 2015 (date de

la mise en liquidation de la Société);

2. Approuver les rapports financiers révisés pour la période du 1 

er

 juillet 2014 au 30 juin 2015;

3. Donner décharge aux administrateurs du conseil d'administration de la Société pour la période du 1 

er

 juillet 2014 au

30 juin 2015;

112635

L

U X E M B O U R G

4. Entendre et approuver le rapport du liquidateur sur la liquidation de la Société;
5. Recevoir et approuver le rapport du réviseur d'entreprises sur la liquidation de la Société;
6. Donner décharge au liquidateur;
7. Décider de la clôture de la liquidation de la Société.
L'Associé a demandé au notaire instrumentant soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a pris connaissance du rapport du réviseur d'entreprises pour la période du 1 

er

 juillet 2014 au 30 juin 2015

(date de la mise en liquidation de la Société).

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé d'approuver les rapports financiers révisés pour la période du 1 

er

 juillet 2014 au 30 juin 2015.

<i>Troisième résolution

L'Associé a décidé de donner décharge aux administrateurs du conseil d'administration de la Société pour l'exécution

de leur mandat pour la période du 1 

er

 juillet 2014 au 30 juin 2015;

<i>Quatrième résolution

L'Associé ayant entendu et reçu le rapport du liquidateur sur la liquidation, a décidé d'approuver ce dernier.

<i>Cinquième résolution

L'Associé ayant reçu le rapport du réviseur d'entreprises sur la liquidation a décidé d'approuver ce dernier.

<i>Sixième résolution

Après avoir entendu et approuvé le rapport du réviseur d'entreprises, l'Associé a décidé de donner décharge au liquidateur

pour l'exécution de son mandat.

<i>Septième résolution

L'Associé a décidé de clôturer la liquidation de la Société et a décidé que les livres et documents sociaux de la Société

seront déposés pendant la durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à L-1661 Luxembourg, 25, Grand
Rue.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: N. KRUSE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/20932. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Référence de publication: 2015117053/129.
(150125418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

REVAL Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 54.136.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15/07/2015.

G.T. Fiduciaires S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2015117402/12.
(150126330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

112636

L

U X E M B O U R G

AIM Software Luxembour S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AIM SOFTWARE Luxembourg S.A.).

Siège social: L-8070 Bertrange, 10A-10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 146.512.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of June.
Before the undersigned, Maître Jacques Kesseler, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

AIM Holding S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 193.755, having its
registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

here represented by Philipp Metzschke, Avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of AIM Software Luxembourg S.A. (the “Com-

pany”),  a  société  anonyme  incorporated  and  existing  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  having  its
registered office at 10A-10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pur-
suant to a deed of the notary, Me. Henri Beck, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on 4 June 2009,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Memorial C”) number 1263 on 1 July 2009. The
articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the notary, Me. Karine
Reuter, residing in Redange/Atert, Grand Duchy of Luxembourg, on 28 July 2010, published in the Memorial C number
2028 on 29 September 2010.

The appearing party, representing the whole share capital of the Company, requires the notary to enact the following

resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company in order to transform it from its current form

of a société anonyme into a société à responsabilité limitée and to fully restate the articles of association in order to adapt
them to the new legal form of the Company.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the purpose of the Company so that it ready henceforth as follows:
“The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a

direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing

any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

The purpose of the Company is also the trade and sale of office supply -, software - and hardware products as well as

consulting in the IT sector.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes.”.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to reappoint as managers for an unlimited period:
- Mr. Sandeep Sahai, born on 18 April 1963 in India, with professional address at 320, Park Avenue, Suite 2500, New

York, NY 10022, United States of America, as A manager;

-  Mr.  Martin  Buchberger,  born  on  15  June  1973  in  Linz  (Austria),  residing  at  Obholzstrasse  5b,  8500  Frauenfeld,

Switzerland, as B manager;

- Mr. Josef Sommeregger, born on 21 January 1981 in Klagenfurt (Austria), residing at Meynertgasse 9/7, 1090 Vienna

Austria, as B manager; and

- Mr. David Voogd, born on 9 July 1979 in Mons (Belgium), with address at 10, rue du Bois, B-6700 Toernich, as B

manager.

112637

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution

The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the signature of the sole manager, or, if the

Company has several managers, (i) by the joint signature of one (1) class A Manager and one (1) class B Manager, (ii) by
the joint signature of two (2) class B Managers (excluding, however, for the operations covered by article 13.4 of the articles
of association of the Company), or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory
power may have been delegated by the Company within the limits of such delegation.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to restate the Company’s articles of association in their entirety as follows:

A.“Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

AIM Software Luxembourg S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also the trade and sale of office supply -, software -and hardware products as well

as consulting in the IT sector.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty six thousand euro (EUR 36,000), represented by seven hundred twenty

(720) shares with a nominal value of fifty euro (EUR 50) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

112638

L

U X E M B O U R G

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the

transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at

the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of
such meeting, on the first Monday in June at 5 pm local time. If such day is a legal holiday, the annual general meeting
shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening

notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

10.3 The following collective decisions of the Company’s shareholders shall be adopted by the approval of shareholders

representing three quarters of the share capital at least:

- Any amendment of the corporate purpose of the Company, in particular any business with software products which

do not belong to or are not marketed by AIM, as well as any broadening of the corporate purpose to the distribution of
hardware or services not covered by the corporate purpose;

- Any appointment of any managers of the Company as well as of the chairman of the board of managers of the Company

to the extent provided in these articles of association;

- Any discharge to the board of managers of the Company;
- Any decision regarding potential profit distributions, in particular of any dividend payments;
- Any termination or amendment of the reseller contract with AIM;
- Any conclusion of contracts which could cause a conflict with the provisions contained in the reseller contract entered

into with AIM Advanced Information Management Software GmbH;

- Any decision which could cause a conflict of interests with AIM Advanced Information Management Software GmbH;

112639

L

U X E M B O U R G

- Any investments which exceed a price of thirty thousand euro (EUR 30,000) and an aggregate price of hundred thousand

euro (EUR 100,000) in one financial year;

- Any decision to borrow by the means of bonds, loans and/or credits exceeding thirty thousand euro (EUR 30,000) and

an aggregate amount of one hundred thousand euros (EUR 100,000) in one financial year;

- Any decision to grant loans or credits;
- Any decision to enter into business deals exceeding costs of fifty thousand euro (EUR 50,000) in one financial year;
- Any decision to enter into services agreements with shareholders;
- Any decision to grant an entitlement to maintenance;
- Any decision regarding incentives, under whatever form, to the shareholders or any service providers to the Company

as long as they do not exceed twenty percent (20%) of their gross annual salary;

- Any form of capital increase of the Company;
- Any restriction or any revocation of preemptive rights;
- Dissolution of the Company without prior liquidation; and
- Approval of the annual report and the annual financial statement.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers. In the case of several managers, the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders,
may decide that they shall be named “A Manager” or “B Manager”.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.

13.4 Except for any items of the list below which have already been explicitly included in a budget formally approved

by the sole manager of AIM Holding S.C.A., the following decisions (or any actions resulting from such decisions) shall
be subject to the prior approval of the board of managers of the Company:

- any decision relating to financing or refinancing (in any form) that results, individually or in aggregate, in a liability

in excess of fifty thousand euro (EUR 50,000);

- any corporate restructuring, such as merger, spin-off, partial contribution in kind or lease of business, between the

Company or any of its subsidiary(-ies) and a third party;

- any change of control in the Company or its subsidiary(-ies);
- any acquisitions of businesses between the Company or any of its subsidiary(-ies) and a third party;
- the sale by the Company or any of its subsidiary(-ies) of any assets or group of related assets in one or a series of

related transactions or purchase or lease having a value in excess of fifty thousand euro (EUR 50,000);

- authorise any dividend or distribution with respect to the share capital of the Company;
- effects any redemption or repurchase of any shares of the Company;
- incurrence of indebtedness of any type in excess of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) in any one case or fifty

thousand euro (EUR 50,000) in the aggregate, other than accounts payable in the ordinary course of business;

- entering into a new line of business, or substantially changing the type of business currently conducted by the Company

or any of its subsidiary(-ies);

- materially amending the articles of association (other than with a view to ensuring compliance with laws, dealing with

minor technical points or implementing the transactions contemplated herein) of the Company or any of its subsidiary(-
ies);

- any transaction between the Company or any of its subsidiary(-ies) and a shareholder or an affiliate of a shareholder

of any company belonging to the Company or any of its subsidiary(-ies), to the extent outside the ordinary course of business
or not on arm’slength terms;

- any material capital increase or capital decrease of the Company or any of its subsidiary(-ies), any issuance of shares

or other securities, including any right to acquire shares, giving access to the capital of any company belonging to the group
as well as any material modification to the rights attached to the shares in any company belonging to the Company or any
of its subsidiary(-ies);

112640

L

U X E M B O U R G

- any transfer of shares as other securities in the Company or any of its subsidiary(-ies);
- any material surety or security interest (regardless its form) over one of its assets granted by the Company or any of

its subsidiary(-ies), other than in the ordinary course of business or if in the ordinary course of business exceeding twenty-
five thousand euro (EUR 25,000);

- any change to the statutory auditors of the Company or any of its subsidiary(-ies);
- any material change in the accounting methods and practices of the Company or any of its subsidiary(-ies), other than

changes required by laws or regulations;

- the initiation or amicable settlement of any dispute, judicial proceedings, arbitration or other proceedings for an amount

in excess of twenty-five thousand euro (EUR 25,000);

- the appointment, recruitment, revocation or dismissal by the Company or any of its subsidiary(-ies) of any person

whose  gross  annual  compensation  (including  benefits  in  kind)  is  in  excess  of  one  hundred  fifty  thousand  euro  (EUR
150,000), and any decision to modify the remuneration of the employees, other than in the ordinary course of business;

- the appointment or dismissal of the president, chief executive officer or managing director (or other executive officers,

as applicable, depending on the management bodies and form of the company in question) of the Company or any of its
subsidiary(-ies);

- any material change in the remuneration policy for managers, including their annual variable remuneration or the

allocation of warrants, stock options or other methods of performance-related pay or any broad based employee benefit or
incentive compensation plan or program;

- the launch of a public sale;
- the liquidation or opening of insolvency proceedings for the Company or any of its subsidiary(-ies);
- the entering into, termination or modification of any contract providing for commitments representing an amount in

excess of fifty thousand euro (EUR 50,000) or of a duration of over three (3) years, other than contracts entered into in the
course of business under usual conditions;

- entering any client contract which allows for termination upon a change in control of the Company;
- any capital expenditure in excess of fifty thousand euro (EUR 50,000) (i) in the single case (ii) in the aggregate of

similar cases

- any material reduction of workforce or establishing any lay-off, redundancy, or early retirement program or taking any

other action that would reasonably be expected to constitute collective dismissals according to applicable law; and

- any binding undertaking to accomplish any of the actions mentioned above.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The A Manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders from a list of nominees submitted by

WCAS XI AIM, L.P. which shall determine their remuneration and term of office.

14.2 The B Manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.3 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

Art. 15. Convening meetings of the board of managers.
15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers may elect among it’s A Manager(s) a chairman. It may also choose a secretary, who does

not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

112641

L

U X E M B O U R G

16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if a majority of managers is present or represent, out

whom are at least one A Manager and one B Manager, at a meeting of the board of managers.

16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting and by at least

one A Manager and one B Manager. The chairman, if any, shall have a casting vote.

16.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.

Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), by any A Manager together with any B Manager. Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, by
any A Manager together with any B Manager.

17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 18. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, (i) by the joint signature of one (1) class A Manager
and one (1) class B Manager, (ii) by the joint signature of two (2) class B Managers (excluding, however, for the operations
covered by article 13.4 of the articles of association of the Company), or (iii) by the joint signatures or the sole signature
of  any  person(s)  to  whom  such  signatory  power  may  have  been  delegated  by  the  Company  within  the  limits  of  such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 19. Auditor(s).
19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

19.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

19.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

19.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 20. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

21.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

21.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

21.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

112642

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.

22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 23. Liquidation.
23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators  shall  have  the  most  extensive  powers  for  the  realisation  of  the  assets  and  payment  of  the  liabilities  of  the
Company.

23.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 24. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.”.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünfundzwanzigsten Juni,
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Jacques Kesseler, mit Amtssitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

AIM  Holding  S.C.A.,  eine  Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  (société  en  commandite  par  actions),  gegründet  und

bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxem-
burg unter der Nummer B 193.755, mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg,

hier vertreten durch Philipp Metzschke, Avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlich ausge-

stellten Vollmacht.

Besagte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar ne varietur paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei ist die alleinige Aktionärin (die „Alleinige Aktionärin“) der AIM Software Luxembourg S.A.

(die „Gesellschaft”), einer Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großher-
zogtums  Luxemburg,  mit  Sitz  in  10A-10B,  rue  des  Mérovingiens,  L-8070  Bertrange,  Großherzogtum  Luxemburg,
gegründet am 4. Juni 2009 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Henri Beck, mit Amtssitz in Echternach, Großherzogtum
Luxemburg, welche am 1. Juli 2009 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial C“), Nummer
1263 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 28. Juli 2010 gemäß einer Urkunde der Notarin
Maître Karine Reuter, mit Amtssitz in Redingen/Attert, Großherzogtum Luxemburg, geändert, welche am 29. September
2010 im Mémorial C, Nummer 2028 veröffentlicht wurde.

Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertritt, ersucht den Notar, die folgenden

Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Alleinige Aktionärin beschließt die Änderung der Rechtsform der Gesellschaft, um sie von ihrer derzeitigen Form

einer Aktiengesellschaft (société anonyme) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
umzuwandeln, und die vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um diese an die neue Rechtsform der Ge-
sellschaft anzupassen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Alleinige Aktionärin beschließt die Änderung des Zwecks der Gesellschaft, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

112643

L

U X E M B O U R G

„Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesell-

schaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch  Aufnahme  von  Darlehen  in  jeglicher  Form  oder  mittels  Ausgabe  aller  Arten  von  Anleihen,  Wertpapieren  oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.

Zweck der Gesellschaft ist zudem der Handel mit und der Verkauf von Büromaterial, Softwareund Hardwareprodukten

sowie Beratung im IT-Bereich.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie solche,

welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich
erscheinen.“

<i>Dritter Beschluss

Die  Alleinige  Aktionärin  beschließt  die  Wiederernennung  folgender  Personen  als  Geschäftsführer  für  unbegrenzte

Dauer:

- Herr Sandeep Sahai, geboren am 18. April 1963 in Indien, mit Geschäftsadresse in 320, Park Avenue, Suite 2500, New

York, NY 10022, Vereinigte Staaten von Amerika, als A-Geschäftsführer;

- Herr Martin Buchberger, geboren am 15. Juni 1973 in Linz (Österreich), ansässig in Obholzstrasse 5b, 8500 Frauenfeld,

Schweiz, als B-Geschäftsführer;

- Herr Josef Sommeregger, geboren am 21. Januar 1981 in Klagenfurt (Österreich), ansässig in Meynertgasse 9/7, 1090

Wien, Österreich, als B-Geschäftsführer; und

- Herr David Voogd, geboren am 9. Juli 1979 in Mons (Belgien), ansässig in 10, rue du Bois, B-6700 Toernich, als B-

Geschäftsführer.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die Unterschrift des Einzelgeschäftsführers oder,

für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, (i) durch die gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäfts-
führers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B, (ii) durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
(2) Geschäftsführern der Kategorie B (außer in den in Artikel 13.4 der Satzung vorgesehenen Fällen), oder (iii) durch die
gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch
die Gesellschaft übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.

<i>Fünfter Beschluss

Die Alleinige Aktionärin beschließt die Neufassung der gesamten Satzung der Gesellschaft wie folgt:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit

dem Namen AIM Software Luxembourg S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1  Zweck  der  Gesellschaft  ist  das  Halten  von  Beteiligungen  jeglicher  Art  an  luxemburgischen  und  ausländischen

Gesellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch  Aufnahme  von  Darlehen  in  jeglicher  Form  oder  mittels  Ausgabe  aller  Arten  von  Anleihen,  Wertpapieren  oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.

2.4 Zweck der Gesellschaft ist zudem der Handel mit und der Verkauf von Büromaterial, Software- und Hardwarepro-

dukten sowie Beratung im IT-Bereich.

112644

L

U X E M B O U R G

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Bertrange, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt

werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-

herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt sechsunddreißigtausend Euro (EUR 36.000), bestehend aus sie-

benhundertzwanzig (720) Anteilen mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (EUR 50) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für

eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten

darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung der

überlebenden Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln der von Ihnen gehaltenen Rechte übertragen werden.
Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehe-
partner/in übertragen werden.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und

diese Satzung übertragen wurden.

112645

L

U X E M B O U R G

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich ge-
fasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt
sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Die Jahreshauptversammlung der Gesellschafter muss in Lu-

xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg abgehalten werden, wie in der Einberufung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt, und dies am ersten Montag des Monats Juni um 17 Uhr Ortszeit. Ist dieser Tag
ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Jahreshauptversammlung am nächsten Werktag statt.

Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einbe-

rufung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf
sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankün-
digung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben.

10.3 Die folgenden gemeinsamen Entscheidungen der Gesellschafter bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern,

die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten:

- Änderungen des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft, insbesondere Geschäfte mit Softwareprodukten, die nicht der

AIM gehören oder von ihr vermarktet werden, sowie eine Erweiterung des Gesellschaftszwecks auf den Vertrieb von
Hardware oder Dienstleistungen, die nicht vom Gesellschaftszweck abgedeckt werden;

- Ernennung von Geschäftsführern der Gesellschaft sowie des Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft

in dem in dieser Satzung festgelegten Ausmaß;

- Entlastung des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft;
- Entscheidungen im Hinblick auf mögliche Gewinnausschüttungen, insbesondere Dividendenzahlungen;
- Kündigung oder Änderung des Reseller-Vertrags (reseller contract) mit AIM;
- Abschluss von Verträgen, welche einen Konflikt mit den Bestimmungen des mit der AIM Advanced Information

Management Software GmbH eingegangenen Reseller-Vertrags verursachen könnten;

- Entscheidungen, die zu Interessenkonflikten mit der AIM Advanced Information Management Software GmbH führen

könnten;

- Investitionen, die eine Höhe von dreißigtausend Euro (EUR 30.000) und eine Gesamthöhe von einhunderttausend Euro

(EUR 100.000) pro Geschäftsjahr übersteigen;

- Entscheidungen über die Kreditaufnahme durch Anleihen, Darlehen und/oder Kredite, die eine Höhe von dreißigtau-

send Euro (EUR 30.000) und eine Gesamthöhe von einhunderttausend Euro (EUR 100.000) pro Geschäftsjahr übersteigen;

- Entscheidungen in Bezug auf die Gewährung von Darlehen oder Krediten;
- Entscheidungen in Bezug auf Geschäftsabschlüsse, die Kosten von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) pro Geschäfts-

jahr übersteigen;

- Entscheidungen in Bezug auf den Abschluss von Dienstleistungsverträgen (service agreements) mit Gesellschaftern;
- Entscheidungen in Bezug auf die Gewährung von Versorgungsansprüchen (entitlement to maintenance);
- Entscheidungen in Bezug auf Prämien jeglicher Art an die Gesellschafter oder an Dienstleister der Gesellschaft, solange

diese nicht mehr als zwanzig Prozent (20%) ihres Bruttojahresgehalts betragen;

- Jede Form von Kapitalerhöhungen der Gesellschaft;
- Beschränkungen oder Entzug von Bezugsrechten;
- Auflösung der Gesellschaft ohne vorherige Liquidation; und
- Genehmigung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die (ii) mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

112646

L

U X E M B O U R G

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1  Die  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer  geleitet.  Falls  die  Gesellschaft  mehrere  Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat. Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, so können der
Alleingesellschafter beziehungsweise die Gesellschafter beschließen, „A-Geschäftsführer“ oder „BGeschäftsführer“ ge-
nannt zu werden.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-

führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

13.4 Mit Ausnahme der Punkte auf der unten aufgeführten Liste, die bereits explizit in einem vom Geschäftsführungsrat

genehmigten Haushaltsplan eingeschlossen wurden, erfordern die folgenden Beschlüsse (oder alle Maßnahmen, die aus
solchen Beschlüssen hervorgehen) die vorherige Zustimmung des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft:

- Beschlüsse bezüglich der Finanzierung oder Refinanzierung (in jeglicher Form) die, einzeln oder in ihrer Gesamtheit,

zu einer Verbindlichkeit in Höhe von über fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) führen;

- Unternehmensrestrukturierungen, wie Verschmelzungen, Abspaltungen, partielle Sacheinlagen oder Verpachtungen

von Geschäftsbetrieben (lease of business) zwischen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften und einem
Dritten;

- Kontrollwechsel innerhalb der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaft(en);
- Unternehmenserwerbe zwischen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften und einem Dritten;
- der Verkauf seitens der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften von Vermögenswerten oder einer Gruppe

von verbundenen Vermögenswerten in einer oder mehreren verbundenen Transaktionen oder ein Kauf oder Leasingkauf
in einem Wert von über fünfzigtausend Euro (EUR 50.000);

- Genehmigung einer Dividende oder Ausschüttung in Bezug auf das Gesellschaftskapital der Gesellschaft;
- Durchführung von Rücknahmen oder Rückkäufen von Anteilen der Gesellschaft;
- Eingehen von Verschuldungen jeder Art, die fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) im Einzelfall oder fünfzig-

tausend Euro (EUR 50.000) im Ganzen übersteigen, mit Ausnahme von Verbindlichkeiten im gewöhnlichen Geschäfts-
gang;

- Aufnahme neuer Geschäftszweige, oder die wesentliche Änderung der aktuellen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft

oder einer ihrer Tochtergesellschaften;

- wesentliche Änderungen der Satzung (andere als im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, auf

unbedeutende technische Punkte oder auf die Umsetzung der hierin vorgesehenen Transkationen) der Gesellschaft oder
einer ihrer Tochtergesellschaften;

- Transaktionen zwischen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften und einem Gesellschafter oder einem

verbundenen Unternehmen eines Gesellschafters einer zur Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften gehörenden
Gesellschaft, sofern diese außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs liegen oder nicht zu marktüblichen Bedingungen
erfolgen;

- eine wesentliche Kapitalerhöhung oder Kapitalherabsetzung der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften,

eine Ausgabe von Anteilen oder anderen Wertpapieren, einschließlich eines Rechts zum Anteilserwerb, welches Zutritt
zum Gesellschaftskapital einer zur Gruppe gehörenden Gesellschaft verleiht, sowie eine wesentliche Änderung der mit den
Anteilen einer zur Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften gehörenden Gesellschaft verbundenen Rechte;

- eine Übertragung von Anteilen als andere Wertpapiere der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften;
- eine wesentliche Sicherheit oder ein Sicherungsrecht (gleich welcher Art) über eines ihrer Vermögenswerte von der

Gesellschaft  oder  einer  ihrer  Tochtergesellschaften,  welche/s  sich  nicht  im  gewöhnlichen  Geschäftsgang  befindet  und
fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) überschreitet;

- Änderungen in Bezug auf die Abschlussprüfer der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften;
- wesentliche Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze und -verfahren der Gesellschaft oder einer ihrer Tochter-

gesellschaften, mit Ausnahme gesetzlich vorgeschriebener Änderungen;

- Einleitung oder gütliche Beilegung von Streitfällen, Gerichtsverfahren, Schiedsverfahren oder anderen Verfahren mit

einem Streitwert von über fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000);

- Ernennung, Einstellung, Abberufung oder Kündigung seitens der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften

einer Person, deren jährliche Bruttovergütung (einschließlich Sachleistungen) einen Betrag von einhundertfünfzigtausend
Euro (EUR 150.000) übersteigt, und jeder Beschluss bezüglich der Änderung der Mitarbeitervergütung, die nicht im ge-
wöhnlichen Geschäftsgang liegt;

112647

L

U X E M B O U R G

- Ernennung oder Absetzung des Direktors (president), Vorstandsvorsitzenden (chief executive officer) oder Geschäfts-

führers (managing director) (oder gegebenenfalls anderer leitender Angestellter, je nach Verwaltungsorgan und Form der
betroffenen Gesellschaft) der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften;

- wesentliche Änderungen in der Vergütungspolitik der Geschäftsführer, einschließlich ihrer jährlichen variablen Ver-

gütung oder der Zuteilung von Optionsscheinen, Aktienoptionen oder anderen Methoden der leistungsbezogenen Vergü-
tung oder breit angelegter Altersversorgungspläne oder Mitarbeiterbeteiligungspläne oder -programme;

- Start eines öffentlichen Verkaufs;
- Liquidation oder Eröffnung von Insolvenzverfahren für die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften;
- Abschluss, Kündigung oder Änderung von Verträgen mit Verpflichtungszusagen in Höhe eines Betrags von über

fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) oder mit einer Dauer von über drei (3) Jahren, mit Ausnahme von Verträgen, die im
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft zu üblichen Konditionen geschlossen werden;

- Abschluss von Verträgen mit Kunden, welche bei einem Kontrollwechsel der Gesellschaft kündbar sind;
- Investitionen, die eine Höhe von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) (i) im Einzelfall (ii) im Ganzen in ähnlichen Fällen

übersteigen;

- wesentliche Reduzierungen der Belegschaft oder die Einführung von Entlassungs-, Freisetzungs- oder Altersteilzeit-

programmen oder jede andere Maßnahme, von der berechtigterweise angenommen werden kann, dass sie Massenentlas-
sungen im Einklang mit dem anwendbaren Recht darstellt; und

- verbindliche Verpflichtungen zur Erfüllung einer der obengenannten Maßnahmen.

Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die A-Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Bezüge und Amtszeit

festlegt, aus einer von der WCAS XI AIM, L.P. vorgelegten Liste von Kandidaten gewählt.

14.2 Der bzw. die B-Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.3 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

Art. 15. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
15.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung [eines] Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen

finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

15.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum

zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dring-
lichkeit  in  der  Einladung  zu  bezeichnen  sind.  Eine  solche  Einladung  kann  unterbleiben,  wenn  alle  Geschäftsführer
schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben,
wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen
des Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäfts-
führungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

15.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-

ladungsvoraussetzungen  abbedingen  oder  im  Fall  von  schriftlichen  Umlaufbeschlüssen,  wenn  alle  Mitglieder  des  Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

Art. 16. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
16.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen A-Geschäftsführern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäfts-

führungsrat kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein
muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

16.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats

geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

16.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es

ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

16.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-

deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.

16.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn eine Mehrheit der Geschäftsführer

in der Sitzung anwesend oder vertreten ist, von denen mindestens einer A-Geschäftsführer und einer B-Geschäftsführer
sein muss.

112648

L

U X E M B O U R G

16.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer und von mindestens einem A-Geschäftsführer und einem B-Geschäfts-
führer  gefasst.  Der  Vorsitzende  des  Geschäftsführungsrats,  falls  vorhanden,  hat  im  Falle  von  Stimmgleichheit  die
entscheidende Stimme.

16.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per

Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt  erteilen,  wobei  die  Gesamtheit  aller  schriftlichen  Zustimmungen  die  Annahme  des  betreffenden  Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 17. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
17.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls

vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokoll-
führer, von einem AGeschäftsführer gemeinsam mit einem B-Geschäftsführer unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher
Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden
des  Geschäftsführungsrates  (falls  vorhanden),  von  einem  A-Geschäftsführer  gemeinsam  mit  einem  B-Geschäftsführer
unterzeichnet.

17.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-

schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige
Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

Art. 18. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die Unterschrift

des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, (i) durch die gemeinsame
Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B, (ii) durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Geschäftsführern der Kategorie B (außer in den in Artikel 13.4 der Satzung vorge-
sehenen Fällen), oder (iii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch die Gesellschaft übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam ver-
pflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 19. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
19.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

19.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
19.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

19.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend

das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen in seiner ge-
änderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.

19.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-

sellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Jahresabschluss und Gewinne.
21.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang

mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.

21.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

21.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-

falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

21.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

21.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz

von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.

112649

L

U X E M B O U R G

21.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 22. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
22.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom

Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung  stehen.  Der  ausschüttbare  Betrag  darf  nicht  die  Summe  der  seit  dem  Ende  des  vergangenen  Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer Rücklage
zugeführt werden müssen, übersteigen.

22.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation.

Art. 23. Liquidation.
23.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

23.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an

die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 24. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.“

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der  unterzeichnende  Notar,  der  die  englische  Sprache  beherrscht  und  spricht,  erklärt  hiermit,  dass  die  vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom besagten Bevollmächtigten der erschienenen Parteien gemeinsam mit
dem Notar unterzeichnet worden.

Signé: Metzschke, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 juillet 2015. Relation: EAC/2015/15356. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015116523/750.
(150126227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

PCV Investment S.àr.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en

Capital à Risque.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 147.666.

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of June
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg

APPEARED:

PCV Lux S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered

office at 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under registered number B 141175 (the Sole Shareholder) represented by its general
partner, PCV Lux GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg and an
issued and paid-up share capital amounting to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 141035,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address at 13, route

de Luxembourg, L-4701 Pétange, by virtue of a power of attorney given under private seal.

112650

L

U X E M B O U R G

The said proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
A That the appearing party is the sole shareholder of PCV Investment S.à r.l., SICAR, a private limited liability company

(société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Re-
gistre de Commerce et des Sociétés) under number B 147666 (the Company). The Company has been incorporated pursuant
to a deed drawn up by Maître Francis Kesseler on 18 June 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations dated 31 August 2009, number 1670, page 80116.

B The Company's articles of association (the Articles) have been lastly amended pursuant to a deed drawn-up by Maître

Francis Kesseler on 7 August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 31 August
2009, number 1670, page 80131.

C The Sole Shareholder, duly represented as stated here above, having recognised to be duly informed of the resolutions

to be taken, has decided to vote in favour of all of the items for the following agenda:

<i>Agenda

1)  Granting  of  full  and  complete  discharge  to  the  directors  (gérants)  of  the  Company  for  the  performance  of  their

respective mandates as from 1 January 2015 until the date hereof;

2) Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
3) Approval of the appointment of Facts Services S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at

1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 98790, as liquidator of the Company for the liquidation period and determination of the powers of the liquidator;
and

4) Miscellaneous.
Consequently, on the basis of the aforementioned agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>Resolutions

<i>First Resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to grant full and complete discharge to the directors (gérants) of the Company for

the performance of their respective mandates as from 1 January 2015 until the date of the present resolutions.

<i>Second Resolution

The Sole Shareholder RESOLVED, in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amen-

ded (the Law), the law of 15 June 2004 concerning the societés d'investissement en capital à risque, as amended, and article
27 of the Articles to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire).

<i>Third Resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to appoint Facts Services S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered

office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 98790 as liquidator of the Company (the Liquidator).

The Sole Shareholder further RESOLVED to grant the Liquidator the broadest powers in respect of the liquidation of

the Company and notably the powers as provided for by articles 144 and following of the Law.

It is further RESOLVED by the Sole Shareholder that the Liquidator is notably instructed and empowered to:
- represent the Company during the liquidation proceedings and do everything which is required for the liquidation of

the Company, to realise and/or dispose of all assets on the best possible terms and for the best possible consideration, to
discharge all the liabilities and to pay advances on the liquidation surplus (boni de liquidation) after having paid the debts
or made the necessary provisions for the payment of the debts;

- carry out all operations, execute all deeds and accomplish any acts in the name of the Company, including those referred

to in article 145 of the Law without having the prior approval of the Sole Shareholder and notably contribute the assets of
the Company to other companies;

- deal, with or without payment, with all intangible, privileged, secured or mortgaged rights, actions in termination,

transcription, seizure, oppositions or other impediments;

- without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all movable properties and rights of

the Company as the case may be; and

- under its sole responsibility, delegate some of its powers for specific operations or tasks to one or several persons or

entities.

THERE BEING NO FURTHER BUSINESS THE MEETING IS CLOSED.

112651

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this deed.
The document having been read to the attorney of the appearing party, who is known to the notary by surname, first

name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de juin.
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg)

A COMPARU:

PCV Lux S.C.A., une société en commandite par actions luxembourgeoise, dont le siège social est situé 1-3 Boulevard

de la Foire, L-1528, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141175 (l'Associé Unique) représenté par son associé commandité, PCV Lux
GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141035,

ici représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, ayant son adresse professionnelle au

13, route de Luxembourg, L-4701 Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte comme suit:
A Le comparant est l'associé unique de la société PCV Investment S.à r.l., SICAR, une société à responsabilité limitée

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147666 (la Société). La
Société a été constituée par un acte du notaire Maître Francis Kesseler en date du 18 juin 2009, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations daté du 31 août 2009, numéro 1670 page 80116.

B Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois par un acte dressé par Maître Francis

Kesseler le 7 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations daté du 31 août 2009, numéro 1670,
page 80131.

C L'Associé Unique, dûment représenté, ayant reconnu avoir été dûment informé des résolutions à prendre, a décidé de

voter en faveur de tous les points de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs depuis le 1

er

 janvier 2015 jusqu'à la présente date;

2 Dissolution de la Société et décision de placer volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
3 Approbation de la nomination de Facts Services S.A., une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social

sis au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 98790, en tant que liquidateur de la Société pour la période de liquidation et détermination des pouvoirs
du liquidateur; et

4 Divers.
En conséquence, sur base de l'ordre du jour mentionné ci-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

<i>Première résolution

L'Associé Unique a DECIDE de donner décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'accomplissement de

leurs mandats respectifs à compter du 1 

er

 janvier 2015 jusqu'à la date des présentes résolutions.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a DECIDE en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée

(la Loi), la loi du 15 juin 2004 sur les sociétés d'investissement en capital à risque, telle que modifiée et l'article 27 des
Statuts d'approuver la dissolution immédiate de la Société et de placer volontairement la Société en liquidation (liquidation
volontaire).

112652

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique a DECIDE de nommer Facts Services S.A., une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège

social sis au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 98790 en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur).

L'Associé Unique a DECIDE également de donner au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour la liquidation de la

Société et plus particulièrement les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi.

L'Associé Unique a aussi DECIDE de notamment conférer les pouvoirs suivants au Liquidateur:
- représenter la Société pendant la procédure de liquidation et accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la

Société, de réaliser dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles l'entièreté de ses actifs, de payer la
totalité de ses dettes et de payer des avances sur boni de liquidation après avoir payé les dettes ou réalisé les provisions
nécessaires au paiement des dettes;

- accomplir toutes les opérations et passer tous les actes au nom de la Société, y compris ceux prévu à l'article 145 de

la Loi sans requérir le consentement préalable de l'Associé Unique et notamment apporter les actifs de la Société à d'autres
sociétés;

- de traiter, avec ou sans paiement, tous les droits incorporels, privilèges, gages ou hypothèques, actions résolutoires,

transcriptions, saisies, oppositions ou tout autre empêchement;

- sans que l'énumération suivante ne soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens mobiliers et/ou droits de la

Société, le cas échéant; et

- sous sa seule responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs pour des opérations ou tâches spécifiques à une ou

plusieurs personnes ou entités.

L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA REUNION EST CLOTUREE.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante a requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date figurant en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 juin 2015. Relation: EAC/2015/14278. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015117354/157.
(150125419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Mercado S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial,

(anc. Mercado).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.589.

L'an deux mille quinze, le six juillet.
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

1. Monsieur Ludovicus Angela Jozef Maria VERHEYEN, demeurant au 129, Port Saeed, Dubaï (Emirats Arabes Unis),

et

2. Monsieur Bernard ZIMMER, demeurant professionnellement au 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ici représenté par Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-Rue, L-8510

Redange-sur-Attert, en vetru de deux (2) procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par la mandataire des comparants et par le notaire

instrumentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparants, représentés comme ci-avant, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “MERCADO”, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A,

Boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 86.589, (la

112653

L

U X E M B O U R G

“Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich le 05
mai 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 946 du 21 juin 2002,

et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph

ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 2 août 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2464 du 13 octobre 2011.

- Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de trois cent cinquante euros (310,-EUR), chacune.

- Que les cent (100) parts sociales sont détenues comme suit:

1. M. Ludovicus Angela Jozef Maria VERHEYEN, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. M. Bernard ZIMMER, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Les comparants, représentés comme ci-avant, sont les seuls associés actuels (les “Associés”) de la Société et qu'ils ont

pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident:
- de transformer la Société en société de gestion de patrimoine familial (“SPF”);
- de changer la dénomination de la Société en “MERCADO S.à r.l. SPF”; et
- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme suivante:
“L'objet de la Société est exclusivement l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

définis à l'article 2 de la Loi SPF relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (“SPF”), à l'exclusion
de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion

de ces sociétés.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.”

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de refondre complètement les statuts afin de refléter les décisions prises ci-dessus et de mettre

les Statuts en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi qu'avec
les dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (“SPF”).

Les STATUTS auront dorénavant la teneur suivante:

«Titre I 

er

 . Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée dénommée “MERCADO S.à r.l. SPF”, (la “Société”), qualifiée

comme société de gestion de patrimoine familial au sens des dispositions de la loi modifiée du 11 mai 2007 concernant la
création d'une société de gestion de patrimoine familial (la “Loi SPF”), régie par les présents statuts (les “Statuts”) ainsi
que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la
“Loi”).

Art. 2. L'objet de la Société est exclusivement l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers

tels que définis à l'article 2 de la Loi SPF relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (“SPF”), à
l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion

de ces sociétés.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège

social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

112654

L

U X E M B O U R G

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant

comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs

aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de

trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Les parts sociales sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la

SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeur.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Sous réserve que le cessionnaire remplisse les conditions de l'article 3 de la Loi SPF définissant l'investisseur éligible,

les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique.
Sous réserve que le cessionnaire remplisse les conditions de l'article 3 de la Loi SPF définissant l'investisseur éligible, les
parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés repré-

sentant les trois quarts du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi et sous réserve que le cessionnaire
remplisse les conditions de l'article 3 de la Loi SPF définissant l'investisseur éligible.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi Sociétés où il

pourra être consulté par chaque associé.

Art. 7. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter
aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

112655

L

U X E M B O U R G

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds
de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'/aux associé(s) en proportion avec sa/leur participation dans le capital

de la Société.

La gérance est autorisée à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. la gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution

des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai

2007 concernant la création d'une société de gestion de patrimoine familial (“SPF”), telle qu'amendée, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.»

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire des comparants, connus du notaire par nom, prénom, état civil et domicile,

elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 09 juillet 2015. Relation: DAC/2015/11531. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 14 juillet 2015.

Référence de publication: 2015117222/168.
(150125827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Ady's Hygiène S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3583 Dudelange, 14, rue des Poseurs.

R.C.S. Luxembourg B 31.854.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015116515/9.
(150125772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

112656


Document Outline

ADMC-Audit, Diagnostic, Mise en Conformité S.à r.l.

Ady's Hygiène S.à r.l.

AIM SOFTWARE Luxembourg S.A.

AIM Software Luxembour S.à r.l.

Alison Investments S.A.

ANS Europe Holdings (Lux) S.à r.l.

Antinous S.A.

Argenta Life Luxembourg S.A.

Artotal S.A.

Assumption Finances S.A.

Azurestia S.à r.l.

Azzurinvest S.A.

Café Restaurant Chinois Shen-Zhen

California Hill

Callista Real Estate

Calonge Invest S.A.

Camarimmo S.A.

Cana S.C.I.

Carbone S.à r.l.

Car-Renting &amp; Services

Cars Benelux S.A.

CCP III Shopping Eastleigh S.à r.l.

Co-IV Capitole S.A.

ColBaroco Funding S.à.r.l.

ColTour S.à r.l.

Communication - System &amp; Business Consulting

Complexys S.à r.l. SPF

Convento III S.à r.l.

Crescent S.à r.l.

Delos LuxCo 1 S.à r.l.

Dogs4Life

Gamma Trading Gestion S.A., S.P.F.

IB Management Services S.A.

ICAMAP Advisory S.à r.l.

IFI Estates S.A.

IML Holding S.A.

Infeurope

Julius Baer SICAV II

Mercado

Mercado S.à r.l. SPF

PCV Investment S.àr.l., SICAR

REVAL Consulting S.A.

RMF Promotions S.A.

Tooway4you Europe S.A.