logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2329

1

er

 septembre 2015

SOMMAIRE

Advent Software Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

111772

Atid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111792

Bache Global Series  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111755

BPI 17 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111756

Brunswick Real Estate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

111746

Camelia Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

111781

Candara Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111770

CDW S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111782

Centaurae Assets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111784

Centrale Convergence Finances Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111784

CF Corporate Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111785

CHC Helicopter (1) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111788

CHC Helicopter (2) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111788

CHC Helicopter (4) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111789

CHC Helicopter (5) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111789

CHC Helicopter Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

111791

Cie d'Investissement et de Participations du

Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111770

Claematis Assets S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111789

Clymene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111790

CMS Management Services S.A.  . . . . . . . . . . .

111790

Coachbuilder Intellectual Property Manage-

ment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111771

Cobalt Waterline S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111771

Cobolt Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111772

Colombe Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111791

Compagnie de Financements et d'Investisse-

ments Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111792

Compagnie Financière des Bruyères S.A.  . . . .

111780

Compass Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

111790

Componentia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111780

Culture Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111781

Dover Luxembourg Finance Sàrl . . . . . . . . . . .

111780

Dynamics Films Library (DFL) S.A.  . . . . . . . .

111790

Farringdon I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111791

Goodman Enargite Logistics (Lux) S.à r.l.  . . .

111746

Interactive Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

111770

JC Aviation (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . .

111771

Logicor (Shine) Winsen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

111746

Lux Nature et Jardins S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

111782

Madev Holding Corporation S.A., SPF . . . . . .

111784

SML Alpha S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111781

Sonnenberg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111768

Vermillion Aviation Finance S.à r.l.  . . . . . . . .

111785

111745

L

U X E M B O U R G

Brunswick Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 189.529.

Je vous présente ma démission comme gérant de classe B de votre société avec effet au 30 juin 2015.

Le 13 Juillet 2015.

Gulcin Tekes.

I hereby tender my resignation as Manager B of your company with effect as from June 30, 2015.

On 13 July 2015.

Gulcin Tekes.

Référence de publication: 2015115245/11.
(150124540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Logicor (Shine) Winsen S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Goodman Enargite Logistics (Lux) S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.867.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN,
ON THE THIRTIETH DAY OF THE MONTH OF JUNE.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) Shine Investment Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and being registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 196.932; and

(2) Logistics Holdings Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and being registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 196.959

(the “Shareholders”),
each represented by Maître Patrick Santer, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to two

proxies dated 29 June 2015 which proxies shall be registered together with the present deed,

being the Shareholders of Goodman Enargite Logistics (Lux) S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited

liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B163.867 (the "Company"),
incorporated on 19 September 2011 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of 24 No-
vember 2011, number 2873.

The articles of association of the Company have never been amended since the incorporation of the Company.
The appearing parties, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
1. The Shareholders hold all the 12,500 shares in issue in the Company so that the total share capital is represented and

resolutions can be validly taken by the Shareholders.

2. The items on which resolutions are to be taken are as follows:
1. Change of the corporate denomination of the Company to Logicor (Shine) Winsen S.à r.l. and amendment of article

1 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

“ Art. 1. Form - Corporate Name. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Logicor

(Shine)  Winsen  S.à  r.l.”  (the  “Company”)  is  hereby  formed  by  the  appearing  party  and  all  persons  who  will  become
shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.”

2. Amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety so that they shall read as

set forth in the second resolution and in particular the object of the Company (article 2) which shall be amended as follows:

“ Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.

111746

L

U X E M B O U R G

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in

which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance

money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.”

Thereafter the following resolutions were passed by the Shareholders of the Company:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to amend Article 1 of the articles of association of the Company so that Article 1 of the

articles of association of the Company reads as set out in item 1. of the above agenda.

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to fully amend and re-state the Company’s articles of association and in particular the cor-

porate object of the Company so that such articles of association shall read as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Logicor (Shine)

Winsen S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in

which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance

money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

111747

L

U X E M B O U R G

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case

may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)

represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its own shares
upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business

of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to

act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,

by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.

111748

L

U X E M B O U R G

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the

board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal

to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in

the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in  the  register  of  shareholders  held  by  the  Company  at  least  eight  (8)  days  before  the  proposed  effective  date  of  the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions  (or  subject  to  the  satisfaction  of  the  majority  requirements,  on  the  date  set  out  therein).  Unanimous  written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

111749

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies;

in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,300.-.

The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above

appearing party the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
party and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by its name, first name,

civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

IM JAHRE ZWEITAUSENDFÜNFZEHN,
AM DREISSIGSTEN TAG DES MONATS JUNI.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

sind erschienen:

(1) Shine Investment Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) lu-

xemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftau-
sendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg
unter der Nummer B196.932; und

(2) Logistics Holdings Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftau-
sendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg
unter der Nummer B196.959

(die „Gesellschafter“),
jeder hier vertreten durch Maître Patrick Santer, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund zweier

privatschriftlicher Vollmachten, ausgestellt am 29. Juni 2015, welche vorliegender Urkunde beigefügt sind um mit dieser
bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden,

als Gesellschafter der Goodman Enargite Logistics (Lux) S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit

beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesell-
schaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des
Sociétés in Luxemburg, unter der Nummer B163.867 (die «Gesellschaft»), gegründet am 19 September 2011 gemäß Ur-

111750

L

U X E M B O U R G

kunde aufgenommen durch Maître Jean-Joseph Wagner, Notar wohnhaft in Sanem, Großherzogtum Luxemburg, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») am 24 November 2011, Nummer 2873.

Die Satzung der Gesellschaft wurde nie abgeändert seit der Gründung der Gesellschaft.
Die Erschienenen geben, in Ausübung ihres obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersuchen den amtie-

renden Notar folgendes zu beurkunden:

1. Die Gesellschaften halten alle 12.500 von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftsanteile, so dass das gesamte

Gesellschaftskapital vertreten ist und die Gesellschafter wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entscheiden können.

2. Die Punkte über die ein Beschluss getroffen werden soll sind die folgenden:
1. Änderung des Gesellschaftsnamen der Gesellschaft in „Logicor (Shine) Winsen S.à r.l.“ und Abänderung von Artikel

1 der Satzung der Gesellschaft, sodass dieser wie folgt lautet:

„ Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem

Namen " Logicor (Shine) Winsen S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen,
die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.“

2. Änderung und Neuformulierung der kompletten Satzung der Gesellschaft, sodass diese wie im zweiten Beschluss

beschrieben lautet und besonders des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft (Artikel 2) der wier folgt lautet:

„ Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,

Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen

die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Ge-
sellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-

geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-

denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.“

Danach wurden folgende Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter haben beschlossen Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 1 der Satzung

der Gesellschaft den Wortlaut hat wie im ersten Punkt der Tagesordnung beschrieben.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter haben beschlossen die komplette Satzung der Gesellschaft zu ändern und umzuformulieren und

besonders der Gesellschaftszweck der Gesellschaft, sodass die Satzung der Gesellschaft wie folgt lautet:

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

"Logicor (Shine) Winsen S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die

111751

L

U X E M B O U R G

gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,

Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen

die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Ge-
sellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-

geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-

denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,

durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-

hundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von
je 1 Euro (EUR 1).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung

vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine eigenen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht

anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

111752

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die

keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-

gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse

um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und

abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der

Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,

von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen

Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder

leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;

111753

L

U X E M B O U R G

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-

schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die  Rechte  zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage

vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens  acht  (8)  Tage  bevor  der  Beschluss  wirksam  werden  soll,  an  alle  Gesellschafter  an  ihre  im  Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember

eines jeden Jahres.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die  Gesellschafter  können  auf  der  Grundlage  eines  von  dem  alleinigen  Geschäftsführer,  beziehungsweise  der  Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

111754

L

U X E M B O U R G

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet

werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179

(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich

nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Akte

entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 1.300,-.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen und deutschen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage

der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung
maßgebend ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Parteien der dem

amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe zusammen mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. SANTER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/20617. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. Juli 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015116936/529.
(150126199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Bache Global Series, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 129.297.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 6 juillet 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 7 juillet 2015, 2LAC/2015/15194, aux droits de soixante-
quinze euros (75.- EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "BACHE GLOBAL
SERIES (en liquidation)", inscrite auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 129.297, ayant son siège social au 4,
rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, constituée par acte de Maître Henri HELLINKX, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 26 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1591 du 30 juillet
2007.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentaire en date du 20 janvier 2015, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 623 du 3 juin 2015.

Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la

liquidation auprès de son siège social au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Référence de publication: 2015115247/23.
(150124185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

111755

L

U X E M B O U R G

BPI 17 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 198.389.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth of June.
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

1. Baupost Limited Partnership 1983 A-1, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered

office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583745, (“Baupost LP A-1”);

here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

2. Baupost Limited Partnership 1983 B-1, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered

office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583749, (“Baupost LP B-1”);

here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private

seal.

3. Baupost Limited Partnership 1983 C-1, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered

office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583752, (“Baupost LP C-1”);

here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private

seal.

4. Baupost Value Partners, L.P. - I, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered office

at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of Ame-
rica, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3186829, (“BVP-I”);

here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private

seal.

5. Baupost Value Partners, L.P. - II, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered

office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3191682, (“BVP-II”);

here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private

seal.

6. Baupost Value Partners, L.P. - III, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered

office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3289794, (“BVP-III”);

here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private

seal.

7. Baupost Value Partners, L.P. - IV, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered

office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4520054, (“BVP-IV”);

here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private

seal.

8. HB Institutional Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered

office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583754, (“HBILP”);

here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private

seal.

9. PB Institutional Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered

office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583757, (“PBILP”);

here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private

seal.

10. YB Institutional Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of Delaware, having its registered

office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3583760, (“YBILP”);

111756

L

U X E M B O U R G

here represented by Mr Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, aforementioned, by virtue of a proxy, given under private

seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated above, have requested the officiating notary to enact the deed of incorpo-

ration of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they wish to incorporate with the following
articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

BPI 17 S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind, or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by one million

two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

111757

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the

transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers which shall be composed of one or more class A managers (the “Class A Manager(s)”) and one
or more class B managers (the “Class B Manager(s)”).

13.2 Any reference made hereinafter to the “managers” shall in such case be construed as a reference to the Class A

Manager(s) and/or the Class B Manager(s), depending on the context and as applicable. If the Company is managed by
one manager, a reference to the “board of managers” used in these articles of association is to be construed as a reference
to the sole manager.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.

111758

L

U X E M B O U R G

13.4 The board of managers shall respect any requirements for approval by the majority shareholders of matters set forth

in any agreement among the shareholders, as may be amended or replaced from time to time.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The managers shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital and in accordance with the provisions of
any agreement between the shareholders, as such agreement may from time to time be amended or replaced.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager. In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal

incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time
not exceeding the initial mandate of the replaced manager in accordance with the provisions of any agreement between the
shareholders, as such agreement may from time to time be amended or replaced, by the remaining managers until the next
meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal pro-
visions.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B

Manager are present or represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by the vote of a majority of managers present or represented at such meeting, including

at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager present or represented subject to any agreement between
the shareholders, as may be amended or replaced from time to time.

17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of managers shall

be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any) or by one (1)
Class A Manager together with one (1) Class B Manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in
judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by one (1) Class A Manager together with
one (1) Class B Manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

joint signatures of one (1) Class A Manager together with one (1) Class B Manager, or (ii) by the joint signatures of any
person to whom such power to sign may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

111759

L

U X E M B O U R G

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators  shall  have  the  most  extensive  powers  for  the  realisation  of  the  assets  and  payment  of  the  liabilities  of  the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares issued have been subscribed as follows

111760

L

U X E M B O U R G

1. One hundred eleven thousand two hundred and fifty (111,250) shares have been subscribed by Baupost LP A-1

aforementioned, for the price of one thousand one hundred twelve euro and fifty cents (EUR 1,112.50), wholly allocated
to the share capital of the Company.

2. Forty-three thousand eight hundred seventy-five (43,875) shares have been subscribed by Baupost LP B-1 afore-

mentioned, for the price of four hundred thirty-eight euro and seventy-five cents (EUR 438.75), wholly allocated to the
share capital of the Company.

3. Two hundred forty-five thousand two hundred fifty (245,250) shares have been subscribed by Baupost LP C-1 afo-

rementioned, for the price of two thousand four hundred fifty-two euro and fifty cents (EUR 2,452.50), wholly allocated
to the share capital of the Company.

4. Seventy thousand (70,000) shares have been subscribed by BVP-I aforementioned, for the price of seven hundred

euro (EUR 700), wholly allocated to the share capital of the Company.

5. Ninety thousand seven hundred fifty (90,750) shares have been subscribed by BVP-II aforementioned, for the price

of nine hundred seven euro and fifty cents (EUR 907.50), wholly allocated to the share capital of the Company.

6. Thirty-five thousand (35,000) shares have been subscribed by BVP-III aforementioned, for the price of three hundred

fifty euro (EUR 350), wholly allocated to the share capital of the Company.

7. Five hundred fourteen thousand one hundred twenty-five (514,125) shares have been subscribed by BVP- IV afore-

mentioned,  for  the  price  of  five  thousand  one  hundred  forty-one  euro  and  twenty-five  cents  (EUR  5,141.25),  wholly
allocated to the share capital of the Company.

8. Seventy-three thousand six hundred twenty-five (73,625) shares have been subscribed by HBILP aforementioned,

for the price of seven hundred thirty-six euro and twenty-five cents (EUR 736.25), wholly allocated to the share capital of
the Company.

9. Thirty-nine thousand one hundred twenty-five (39,125) shares have been subscribed by PBILP aforementioned, for

the price of three hundred ninety-one euro and twenty-five cents (EUR 391.25), wholly allocated to the share capital of the
Company.

10.  Twenty-seven  thousand  (27,000)  shares  have  been  subscribed  by  YBILP  aforementioned,  for  the  price  of  two

hundred seventy euro (EUR 270), wholly allocated to the share capital of the Company.

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five

hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been evidenced to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

<i>Resolutions of the shareholders

The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, have passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:

<i>Class A Manager:

(i) Mr. Collin J. Beecroft, born in San Diego, California, United States of America, on 22 August 1961, having his

professional address at The Baupost Group, L.L.C., 10 Saint James Avenue, Suite 1700, Boston, Massachusetts 02116,
United States of America; and

<i>Class B Managers:

(i) Ms. Sonia Baldan, born in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 27 January 1960, having her professional

address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg; and

(ii) Ms. Antonella Graziano, born in Orvieto (Italy) on 20 January 1966, having her professional address at 19, rue de

Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

111761

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le trente juin.
Pardevant le soussigné notaire Carlo WERSANDT, de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1. Baupost Limited Partnership 1983 A-1, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son

siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3583745, («Baupost
LP A-1»);

dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, demeurant professionnellement

à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

2. Baupost Limited Partnership 1983 B-1, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son

siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3583749, («Baupost
LP B-1»);

dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

3. Baupost Limited Partnership 1983 C-1, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son

siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3583752, («Baupost
LP C-1»);

dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

4. Baupost Value Partners, L.P. - I, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège

social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3186829, («BVP-I»);

dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

5. Baupost Value Partners, L.P. - II, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège

social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3191682, («BVP-II»);

dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

6. Baupost Value Partners, L.P. - III, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège

social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3289794, («BVP-III»);

dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

7. Baupost Value Partners, L.P. - IV, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège

social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 4520054, («BVP-IV»);

dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

8. HB Institutional Limited Partnership, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège

social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3583754, («HBILP»);

dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

9. PB Institutional Limited Partnership, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son siège

social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3583757, («PBILP»);

dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

10. YB Institutional Limited Partnership, une limited liability company existant sous les lois du Delaware, ayant son

siège social auprès de Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3583760, («YBILP»);

dûment représentée par Monsieur Luis A. AGUERRE ENRÍQUEZ, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

111762

L

U X E M B O U R G

Les procurations signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire instrumentant resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution

d'une société à responsabilité limitée qu'elles souhaitent constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «BPI 17 S.à r.l.» (ci-après

la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des

sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit, ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute

forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties,
et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée

selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique

ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par un million deux

cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre

événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour

consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

111763

L

U X E M B O U R G

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession

ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous

réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des survivants.
Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants,
descendants ou au conjoint survivant.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les

présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il

détient.

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une

assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.

Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement

unanime des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil

de gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A (le(s) «Gérant(s) de Catégorie A») et d'un ou plusieurs
gérant(s) de catégorie B (le(s) «Gérant(s) de Catégorie B»).

13.2 Toute référence faite aux «gérants» ci-après devra être entendue comme une référence au(x) Gérant(s) de Catégorie

A et/ou au(x) Gérant(s) de Catégorie B, selon le contexte et le cas échéant. Lorsque la Société est gérée par un gérant
unique, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme une référence au gérant unique.

13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute

mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

13.4 Le conseil de gérance doit respecter toutes conditions posées pour l'approbation par les associés majoritaires de

tous points prévus dans toute convention entre les associés, telle que modifiée ou remplacée de temps à autre.

111764

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leur rémunération et la durée de leur

mandat.

14.2 Les gérants sont nommés et peuvent être librement révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision

des  associés  représentant  plus  de  la  moitié  du  capital  social  de  la  Société  et  conformément  aux  dispositions  de  toute
convention entre les associés telle que modifiée ou remplacée de temps à autre.

Art. 15. Vacance d'un poste de gérant. Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à

l'incapacité juridique, la faillite, la démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire
et pour une période ne pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé, conformément aux disposition de toute
convention entre les associés, modifiées ou remplacées de temps à autre, par les gérants restants jusqu'à la prochaine
assemblée des associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au

siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures à

l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle
urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.

16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés

à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites, approuvées
et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.

17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,

le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres
du conseil de gérance.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue
au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un

(1) Gérant de Catégorie B sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance.

17.6 Les décisions sont prises par un vote à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion comprenant au

moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B présents ou représentés sous réserve de toute convention
entre les associés, telle que modifiée ou remplacée de temps à autre.

17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.

Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de

gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en son absence, par le président temporaire et le secrétaire (le cas
échéant), ou par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés

par le président, ou par un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B.

Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par

la signature conjointe d'un (1) Gérant de Classe A et d'un (1) Gérant de Classe B, ou (ii) par la signature conjointe de toutes

111765

L

U X E M B O U R G

personnes  auxquelles  pareil  pouvoir  de  signature  aura  été  délégué  par  le  conseil  de  gérance,  dans  les  limites  de  cette
délégation.

E. Audit et surveillance

Art. 20. Commissaire(s).
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront

surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.

20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif

ou avec son accord.

F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le

trente-et-un décembre de la même année.

Art. 22. Comptes annuels et distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif

et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-

néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la

Société.

Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-

formément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre

de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2015.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

111766

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et paiement

Les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales émises ont été souscrites comme suit:
1. cent onze mille deux cent cinquante (111.250) parts sociales ont été souscrites par Baupost LP A-1, susmentionnée,

pour un prix de mille cent douze euro et cinquante centimes (EUR 1.112,50), entièrement affecté au capital social.

2. quarante-trois mille huit cent soixante-quinze (43.875) parts sociales ont été souscrites par Baupost LP B-1, susmen-

tionnée, pour un prix de quatre cent trente-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 438,75), entièrement affecté au
capital social.

3. deux cent quarante-cinq mille deux cent cinquante (245.250) parts sociales ont été souscrites par Baupost LP C-1,

susmentionnée, pour un prix de deux mille quatre cent cinquante-deux euros et cinquante centimes (EUR 2.452,50), en-
tièrement affecté au capital social.

4. soixante-dix mille (70.000) parts sociales ont été souscrites par BVP-I, susmentionnée, pour un prix de sept cents

euros (EUR 700), entièrement affecté au capital social.

5. quatre-vingt-dix mille sept cent cinquante (90.750) parts sociales ont été souscrites par BVP-II, susmentionnée, pour

un prix de neuf cent sept euros et cinquante centimes (EUR 907,50), entièrement affecté au capital social.

6. trente-cinq mille (35.000) parts sociales ont été souscrites par BVP-III, susmentionnée, pour un prix de trois cent

cinquante euros (EUR 350), entièrement affecté au capital social.

7. cinq cent quatorze mille cent vingt-cinq (514.125) parts sociales ont été souscrites par BVP-IV, susmentionnée, pour

un prix de cinq mille cent quarante et un euros et vingt-cinq centimes (EUR 5.141,25), entièrement affecté au capital social.

8. soixante-treize mille six cent vingt-cinq (73.625) parts sociales ont été souscrites par HBILP, susmentionnée, pour

un prix de sept cent trente-six euros et vingt-cinq centimes (EUR 736,25), entièrement affecté au capital social.

9. trente-neuf mille cent vingt-cinq (39.125) parts sociales ont été souscrites par PBILP, susmentionnée, pour un prix

de trois cent quatre-vingt-onze euros et vingt-cinq centimes (EUR 391,25), entièrement affecté au capital social.

10. vingt-sept mille (27.000) parts sociales ont été souscrites par YBILP, susmentionnée, pour un prix de deux cent

soixante-dix euros (EUR 270), entièrement affecté au capital social.

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le

montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Résolutions des associés

Les associés fondateurs, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de

convocation, ont adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

<i>Gérant de Catégorie A:

(i) Monsieur Collin J. Beecroft, né à San Diego, California, Etats-Unis d'Amérique, le 22 août 1961, résidant profes-

sionnellement auprès de The Baupost Group, LLC, 10 Saint James Avenue, Suite 1700, Boston, Massachusetts 02116,
Etats-Unis d'Amérique; et

<i>Gérants de Catégorie B:

(i) Madame Sonia Baldan, née à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 janvier 1960, résidant profession-

nellement au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, et

(ii) Madame Antonella Graziano, née à Orvieto (Italie), le 20 janvier à 1966, résidant professionnellement au 19, rue de

Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande des comparantes que le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. A. AGUERRE ENRIQUEZ, C. WERSANDT.

111767

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 2 juillet 2015. 2LAC/2015/14748. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Référence de publication: 2015115265/659.
(150125049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Sonnenberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 188.917.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of June.

Before Us M 

e

 Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED

ERGAN INTERNATIONAL SARL, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 188.882 and having its registered office at L-2529 Howald, 45 rue des Scillas,

here represented by Mr. Shmuel PLUCZENIK, manager, residing in B-2018 Antwerpen (Belgium), 25 Korte Leemstraat,

by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to state that:
- That the private limited liability company (société à responsabilité limitée) "Sonnenberg S.à r.l.", with registered office

in L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 188.917, has been incorporated by deed of Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, on the 15

th

 of July 2014, published in the Memorial C Number 2680 of the 2 

nd

 of October 2014.

- That the corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), divided into one hundred and

twenty-five (125) sharequotas with a par value of one hundred euro (EUR 100) each.

- That the appearing party, represented as said before, declares that it is the sole actual partner of the said company and

that she requires the officiating notary to state the following resolutions taken in the present extraordinary general meeting:

<i>First resolution

The general meeting resolved to transfer the address of the registered office to L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, and

subsequently to amend the article 2.1. of the articles of incorporation in order to give it the following wording:

« 2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Hesperange. It may be transferred

within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of
managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of
Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.»

<i>Second resolution

The general meeting acknowledges that the sole shareholder changed its name from P-WORLD S.à r.l. into ERGAN

INTERNATIONAL SARL and transferred the address of its registered office to L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are

estimated at one thousand Euro (EUR 1’000.-)

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the mandatory, the present

deed is worded in English followed by a German version; on request of the same mandatory and in case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Howald, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, acting as said before, known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, the mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.

111768

L

U X E M B O U R G

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, den dreissigsten Juni
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

ERGAN INTERNATIONAL SARL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter der Gesetzgebung des Grossherzogtums Luxemburg, eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsre-
gister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) Sektion B, unter der Nummer 188.882
mit Sitz in L-2529 Howald, 45 rue des Scillas,

hier vertreten durch Herr Shmuel PLUCZENIK, Geschäftsführer, wohnhaft in Korte Leemstraat 25, B-2018 Antwerpen

(Belgien), auf Grund einer erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht, vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Sonnenberg S.à r.l.",, mit Sitz in

L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) Sektion B, unter der Nummer 188.917, gegründet wurde gemäss Urkunde
aufgenommen durch Maître Roger Arrensdorff, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 15. Juli 2014, veröffentlicht im
Memorial C Nummer 2680 vom 2. Oktober 2014.

- Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) beträgt, eingeteilt in einhundertfün-

fundzwanzig (125) Anteile von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

- Dass die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt die alleinige Gesellschafterin der vorgenannten Gesell-

schaft zu sein und dass sie den amtierenden Notar ersucht die von ihr in der gegenwärtigen ausserordentlichen Gesell-
schafterversammlung, gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, zu verlegen

und dementsprechend Artikel 2.1. der Satzung folgenden Wortlaut zu erteilen:

„ 2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Hespersange. Er kann durch einfachen Beschluss des Geschäfts-

führers, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, des Verwaltungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der
Gemeinde verlegt werden. Des weiteren kann der Sitz durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Haupt-
versammlung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, an einen anderen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.“

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest dass die alleinige Gesellschafterin ihren Named von P-World S.à r.l. in ERGAN

INTERNATIONAL SARL abgeändert hat und ihren Sitz nach L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, verlegt hat.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausend Euro (EUR 1‘000.-) veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische und die deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag des Be-

vollmächtigten, dass diese Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag desselben
Bevollmächtigten und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes, ist die englische Fassung
massgebend.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Howald, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige
Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Shmuel PLUCZENIK, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 02 juillet 2015. Relation GAC/2015/5585. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Nathalie DIEDERICH.

Référence de publication: 2015117440/97.
(150125610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

111769

L

U X E M B O U R G

Candara Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.320.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 8 juillet 2015

1. Le Conseil d Administration acte la démission avec effet au 22 juin 2015, de Monsieur Guillaume Scroccaro de son

mandat d'Administrateur de la société.

2. Le Conseil d'Administration décide de coopter, avec effet au 22 juin 2015, au poste d'Administrateur Monsieur Marc

Besch, employé privé, né le 21 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015115278/16.
(150124956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

C.I.P.A.L., Cie d'Investissement et de Participations du Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 165.185.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 8 juillet 2015

1. Le Conseil d Administration acte la démission avec effet au 22 juin 2015, de Monsieur Guillaume Scroccaro de son

mandat d'Administrateur de la société.

2. Le Conseil d'Administration décide de coopter, avec effet au 22 juin 2015, au poste d'Administrateur Monsieur Marc

Besch, employé privé, né le 21 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015115286/16.
(150125014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Interactive Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 54.023.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 17 juin 2015 à 9.30 heures à Luxembourg

<i>Résolutions:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de ratifier la nomination de Monsieur Jean-Charles THOUAND

au poste d'administrateur.

Nommer Monsieur Jean-Charles THOUAND, Monsieur David GILLARD et la société JALYNE S.A., 44, avenue J-F

Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par Monsieur Jacques BONNIER, 44, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg au poste d'administrateur.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de la société EURAUDIT SARL au

poste de Commissaire aux Comptes.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les Comptes Annuels arrêtés au 31.12.2015.

Certifiée Conforme
- / JALYNE S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015115624/22.
(150124443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

111770

L

U X E M B O U R G

Coachbuilder Intellectual Property Management, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 154.939.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 8 juillet 2015

1. Le Conseil d Administration acte la démission avec effet au 22 juin 2015, de Monsieur Guillaume Scroccaro de son

mandat d'Administrateur de la société.

2. Le Conseil d'Administration décide de coopter, avec effet au 22 juin 2015, au poste d'Administrateur Monsieur Marc

Besch, employé privé, né le 21 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015115288/16.
(150124953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Cobalt Waterline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 390.400,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 123.830.

EXTRAIT

En date du 9 juillet 2015, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
- La démission de Alan Botfield comme gérant de la société est acceptée avec effet au 15 octobre 2014;
- La nomination de Eric-Jan Van de Laar comme gérant de la société, né à Utrecht (Pays-Bas) le 27 mars 1969 et avec

adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est acceptée avec effet au 15 décembre 2014 et
pour une durée indéterminée;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Référence de publication: 2015115289/16.
(150124929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

JC Aviation (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 161.517.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 6 juillet 2015 lors de la réunion du Conseil d’Administration de la Société

- La démission de M. Fabrice HUBERTY de sa fonction d’administrateur de la Société a été acceptée avec effet au 12

juin 2015.

- La démission de M. Nicolas MILLE de sa fonction d’administrateur de la Société a été acceptée avec effet au 1 

er

juillet 2015.

- La cooptation de Melle Alexandra DALLÜGE, employée privée, née le 21 juin 1989 à Siegburg (Allemagne), résidant

professionnellement au 127, me de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 juillet 2015 et ce jusqu’au 9 juin

2017, a été décidée.

- La cooptation de M. Vishal SOOKLOLL, employé privé, né le 14 juin 1975 à Goodlands (République de Maurice),

résidant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, avec effet au 12 juin 2015 et ce jusqu’au
9 juin 2017, a été décidée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JC aviation (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015115634/22.
(150124396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

111771

L

U X E M B O U R G

Cobolt Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 512.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 177.003.

Il est à noter que l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter le lettre de démission de Monsieur Martin Eckel en date du 18 juin 2015 de son mandat de gérant de la

Société avec effet au 3 juillet 2015;

- de nommer Julie Pierre, demeurant professionnellement au 41, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en tant que nouvelle gérante de la Société avec effet au 3 juillet 2015 et pour une durée indéterminée;

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de
Madame Julie Pierre, gérante,
Madame Ghizlane Gryp, gérante,
Monsieur Jean-Paul Vignac, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Cobolt Investments S.à r.l.
Julie Pierre
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015115290/21.
(150124760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Advent Software Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 198.391.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the first day of July.
before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Advent  Software  Inc.,  a  corporation  duly  incorporated  and  validly  existing  under  the  laws  of  the  United  States  of

America, having its head office at 600 Townsend Street, 5 

th

 Floor, San Francisco, CA, 94103, United States of America,

and registered with the California Secretary of State under number C1952855,

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg,Grand-

Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated.

Title I. - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by

Luxembourg law as well as by the present Articles (the “Company”).

Art. 2. Name. The Company's name is "Advent Software Luxembourg".

Art. 3. Purpose. The Company's primary purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form

whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents, trademarks and licenses or other property
as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or
in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity

that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan,
advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow
and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

111772

L

U X E M B O U R G

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose

in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality by means of a resolution of the sole
manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or
to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of
plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

Title II. - Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at USD 15,000.- (fifteen thousand US Dollars) divided into 15,000

(fifteen thousand) shares with a nominal value of USD 1,- (one US Dollar) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of

plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share whatever its class has identical voting rights and each shareholder has total voting

rights commensurate with such shareholder's total ownership of shares.

Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only

one owner per share.

Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company

has a sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-

five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning com-

mercial companies, as amended from time to time (the "Law").

Art. 10. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient

distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.

Title III. - Management

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where

more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different
types of managers, namely type A managers and type B managers.

No  manager  needs  be  a  shareholder  of  the  Company.  The  manager(s)  shall  be  appointed  by  resolution  of  the  sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent
(50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in

case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share
capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole share-

holder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole
manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint

signature of at least one type A manager and one type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or

several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of
managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well
as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its

members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who
shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the

time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when
waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

111773

L

U X E M B O U R G

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another

manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, video-conference, or any suitable telecommunication

means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear each
other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in

person or by alternate at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers

of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies

or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly

made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the
Company.

Title IV. - Shareholder meetings

Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in

accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole share-

holder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of

managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24

hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed on

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as

such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a
first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the

shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-

five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast
as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote and in writing
by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-

Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice,
on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

Title V. - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1 

st

 of each year and ends on December 31

st

 of the same year.

Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as

the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder,
or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

111774

L

U X E M B O U R G

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of

the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it
proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case

may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the
end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be

entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory
auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.
Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of

the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders
following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register as

well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The
general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Title VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality

of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the

sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the
shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets
of  the  Company  will  be  allocated  to  the  sole  shareholder,  or  in  case  of  plurality  of  shareholders,  to  the  shareholders
proportionally to the shares they hold.

<i>Temporary provision

Notwithstanding the provisions of article 17, the first financial year of the Company starts today and will end on De-

cember 31 

st

 , 2015.

<i>Subscription - Payment

All the 15,000 (fifteen thousand) shares representing the entire share capital of the Company, have been entirely sub-

scribed by the Sole Shareholder, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 15,000.- (fifteen thousand US
Dollars) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked
funds certificate.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,300.-.

The corporate capital is valued at EUR 13,413.80-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, representing the entirety of the Share Capital,

passed the following resolutions:

1) - Mr. James S. COX Jr., born on November 13, 1971, in Athens, Ohio, USA, residing at 296 Greene Street, Mill

Valley, California (CA 94941), USA; and

- Mr. Mark Edward HOBSON, born on December 16, 1968, in Taplow, England, residing at 5 Rectory Close, High

Wycombe, Buckinghamshire, HP13 6HF, England;

are appointed as Type A managers for a term commencing on today's date and for an undetermined duration; and

111775

L

U X E M B O U R G

- Mrs. Marjorie ALLO, born on 19 November 1967, in Paris, France, residing professionally at 2-4, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

is appointed as Type B manager for a term commencing on today's date and for an undetermined duration.
2) The registered office of the Company shall be established at 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Junglinster, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, known to the undersigned notary, by name,

surname, civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le premier jour du mois de juillet.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Advent Software Inc., une société dûment constituée et existant valablement en vertu des lois des Etats-Unis d’Amérique,

ayant son adresse au 600 Townsend Street, 5 

th

 Floor, San Francisco, USA et immatriculée auprès du California Secretary

of State, sous le numéro C1952855, (l'«Associé Unique»), ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant
professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée paraphée signée
ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant qui restera annexée au présent acte aux fins d'enregis-
trement.

La dite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d'une

société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I 

er

 . - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois

ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est «Advent Software Luxembourg»

Art. 3. Objet. L'objet premier de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous

quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des
participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets, marques
et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer,
grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute

société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société,
incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre forme d'intérêt,
tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir les obligations des
sociétés précitées, ainsi qu'emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir par tous moyens le
remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son

objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par
décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par réso-
lution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus
de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. - Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 15’000.- USD (quinze mille Dollars US), divisé en 15’000 (quinze mille)

parts sociales d’une valeur nominale de 1.- USD (un Dollar US) chacune et sont chacune entièrement libérées.

111776

L

U X E M B O U R G

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.

Art. 7. Droits de vote.  Chaque  part  confère  un  droit  de  vote  identique  et  chaque  associé  dispose  de  droits  de  vote

proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire

par part sociale.

Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés de la Société ou lorsque la Société a un

associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-

quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

Art. 10. Rachat des parts. La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves

distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

Titre III. - Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où

plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories
différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas

de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de
la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé

unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique,

ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil
de gérance, le cas échéant. La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à

un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de
gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres
modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses

membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure

et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par
chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de

communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication approprié, s'ils sont initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à
l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation
est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type A et

au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par

un vote de la majorité des gérants présents ou représentés.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.

Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.

111777

L

U X E M B O U R G

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés con-

formément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la

Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,

le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut, elles
sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins

24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre

du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un

tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus

de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée,
les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout
moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son
vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au

Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant
si ce jour est férié.

Titre V. - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31

décembre de la même année.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas

échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble
de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblé
générale des associés.

Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges

et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés,
représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être

obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à
entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés repré-

sentant  plus  de  cinquante  pour  cent  (50%)  du  capital  social  de  la  Société,  décidant  de  sa  distribution  aux  associés
proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,

peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un

commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.

111778

L

U X E M B O U R G

Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du

capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination.

Cependant leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.
Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes
à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée
générale des associés peut cependant nommé un réviseur d'entreprise à tout moment.

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par

l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension
des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé

unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des
associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui déterminera
leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'associé
unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

<i>Disposition temporaire

Nonobstant les dispositions de l'article 17, le premier exercice de la société débute ce jour et s'achèvera le 31 décembre

2015.

<i>Souscription - Paiement

L'intégralité des 15.000 (quinze mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société, ainsi que

a été entièrement souscrite par l'Associé Unique, et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de 15,000.-USD
(quinze mille Dollars) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la
production d'un certificat de blocage de fonds.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 1.300,- EUR.

Le capital social a été évalué à 13.413,80.- EUR.

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit, a

pris les résolutions suivantes:

1) - M. James S. COX Jr, né le 13 Novembre 1971, à Athens, Ohio, USA, résidant professionnellement à 296 Greene

Street, Mill Valley, California (CA 94941) USA; et

- M. Mark Edward HOBSON, né le 16 Décembre 1968 à Taplow, England, résidant professionnellement à 5 Rectory

Close, High Wycombe, Buckinghamshire HP13 6HF, England;

sont nommées en tant que gérants de type A à compter de ce jour et pour une durée indéterminée
- Mme Marjorie ALLO, née le 19 novembre 1967, à Paris, France, résidant professionnellement à 2-4, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

est nommée en tant que gérant de type B à compter de ce jour et pour une durée indéterminée:
2) Le siège social de la Société est établi au 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état et demeure, il a signé

avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

111779

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 06 juillet 2015. Relation GAC/2015/5648. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015116456/411.
(150125205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

COFIBRU S.A., Compagnie Financière des Bruyères S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 103.489.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 8 juillet 2015

1. Le Conseil d'Administration acte la démission avec effet au 22 juin 2015, de Monsieur Guillaume Scroccaro de son

mandat d Administrateur de la société.

2. Le Conseil d'Administration décide de coopter, avec effet au 22 juin 2015, au poste d'Administrateur Monsieur Marc

Besch, employé privé, né le 21 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015115295/16.
(150125012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Componentia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 233, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 170.930.

Bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung vom 2. Juni 2014, wird G.T. Fiduciaires S.A., mit Sitz in L-1273

Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, zum neuen Rechnungskommissar ernannt. Sie ersetzt die ausscheidende G.T. Experts
Comptables S.àr.l. bis zur Generalversammlung im Jahre 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Juli 2015.

G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2015115296/14.
(150124238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Dover Luxembourg Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.053.303.800,00.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 89.430.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 11.06.2015

Le mandat des Cinq gérants:
- Monsieur Philippe SANTIN, demeurant 28, Rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
- Monsieur Richard CAMPION, demeurant 135 Manor Road, Albany Building, Bournemouth, BH1 3EL England.
- Madame Florence JONCKERS, demeurant 11, Rue des Quatre Vents, bâtiment bât "Picardie ", 92380 Garches, France.
- Monsieur Dennis BOSJE, demeurant 3, Rue Boxepull, L-8447 Steinfort, Luxembourg.
- Monsieur Stefan FRANKEN, demeurant 1123, Route de Meribel, F-01170 Echenevex, France.
est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle en relation avec les comptes au 31 décembre 2015.

Veuillez prendre note du changement de l'adresse de la société avec effet au 1 

er

 Août 2015:

Dover Luxembourg Finance S.à r.l.
10-12, Boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

111780

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 08 Juillet 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Dover Luxembourg Finance S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2015115366/24.
(150124055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Culture Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 120.904.

EXTRAIT

Par résolution écrite de l'associé unique en date du 29 juin 2015, l'associé unique a décidé d'adopter la résolution suivante:
Le siège social de la société a été transféré du 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg à 7, rue Robert Stümper,

L-2557 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 juillet 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2015115301/16.
(150124340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Camelia Participations S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 90.750.

La Convention de Domiciliation, conclue en date du 07 octobre 2003 avec la société CAMELIA PARTICIPATIONS

S.A., ayant précédemment son siège social à L-2420 Luxembourg, 15, Avenue Emile Reuter et inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 90.750, a été résiliée avec effet au 10/07/2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST

Référence de publication: 2015115303/11.
(150124548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

SML Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 198.310.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 1 

<i>er

<i> juillet 2015

En date du 1 

er

 juillet 2015, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de nommer Monsieur Cédric FRISCH, né le 5 janvier 1982, à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle

au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée;

- de nommer Monsieur Jérôme LETSCHER, né le 21 mai 1973, à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, ayant

son adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Robin NG CHENG JIET, né le 16 septembre 1974, à Singapour, Singapour, ayant son adresse

professionnelle au #06-00 Golden Agri Plaza, 108 Pasir Panjang Road, Singapour 118535, Singapour, en tant que gérant
de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Ferdinand SADELI, né le 8 octobre 1973, à Jakarta, Indonésie, ayant son adresse professionnelle

au #06-00 Golden Agri Plaza, 108 Pasir Panjang Road, Singapour 118535, Singapour, en tant que gérant de la Société avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée;

111781

L

U X E M B O U R G

- de nommer Madame Margaretha Natalia WIDJAJA, née le 20 décembre 1981, à Jakarta, Indonésie, ayant son adresse

professionnelle au #06-00 Golden Agri Plaza, 108 Pasir Panjang Road, Singapour 118535, Singapour, en tant que gérant
de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le 13 juillet 2015.

Pour extrait analytique conforme

Référence de publication: 2015115994/27.
(150125017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

CDW S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 196.144.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu en date du 03 juillet 2015

<i>Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de nommer Mr. Raymond Hilbert, homme d'affaires, né le 17 Février 1947 à Lu-

xembourg, Luxembourg, et dont l'adresse professionnelle est au 22 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg en tant que
gérant technique avec date effective au 11 juin 2015 et pour une période illimitée.

Référence de publication: 2015115308/12.
(150124990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Lux Nature et Jardins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 198.402.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le six juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Daniel DALLE MESE, entrepreneur d'espaces verts, né à Algrange (France) le 13 novembre 1968, demeurant

à 3A, Chemin du Colombier à F-57100 Thionville,

ici représenté par Monsieur Norbert MEISCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-

Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par
le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Lequel comparant a, par son mandataire, requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une

société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente.

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les dispo-

sitions légales en vigueur et notamment celles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet tous travaux de jardinage, plantations, élagage, abattage, débroussaillage, taille gazon

haies, protection des cultures, piégeage et paysagisme ainsi que l'achat et la vente de tous articles de la branche.

La Société a encore pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de
négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la Société
pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques,

sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières,

susceptibles de favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

Art. 3. La société prend la dénomination de «LUX NATURE ET JARDINS S.à r.l.».

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Esch-sur-Alzette.

111782

L

U X E M B O U R G

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Titre II. Administration - Assemblée Générale

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par

l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par les associés.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son
objet social.

Art. 8. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1 

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies

par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit. Cette disposition n'est applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui au nom de la société.

Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes

sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 12. L'associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 13. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 14. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 15. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition Générale

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

<i>Disposition Transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Daniel DALLE

MESE, prénommé, et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou

qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent soixante-dix euros (EUR 970,-).

<i>Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. - Le siège social est établi à L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, Route de Belval.

111783

L

U X E M B O U R G

2. - Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Daniel DALLE MESE, entrepreneur d'espaces verts, né à Algrange (France) le 13 novembre 1968, demeurant

à 3A, Chemin du Colombier à F-57100 Thionville.

3. - La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Norbert MEISCH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 08 juillet 2015. Relation GAC/2015/5776. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015117166/96.
(150125519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Centaurae Assets, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 192.291.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 8 juillet 2015

1. Le Conseil d Administration acte la démission avec effet au 22 juin 2015, de Monsieur Guillaume Scroccaro de son

mandat d'Administrateur de la société.

2. Le Conseil d'Administration décide de coopter, avec effet au 22 juin 2015, au poste d'Administrateur Monsieur Marc

Besch, employé privé, né le 21 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015115313/16.
(150124955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Centrale Convergence Finances Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 191.666.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 10 juillet 2015, avec effet à ce jour, que la société

Laurad Holding S.A. une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1511 Luxembourg; 121, Avenue de
la Faïencerie, a cédé 2 500 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à la société Laurad Groupe Holding S.à r.l., ayant
son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B137024.

Pour extrait
La Société

Référence de publication: 2015115314/16.
(150123960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Madev Holding Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 16.532.

<i>Circular resolutions of the board of directors

The directors resolve unanimously to move the registered office of the Company to 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg with effect as of March 20, 2015.

111784

L

U X E M B O U R G

On May 18, 2015.

K. SHOVAL / P. KURZ
<i>Director and Chairman / Director

On 13/05/2015.

D. BOURGER
<i>Director

<i>Résolution circulaire du conseil d'administration

Le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité de transférer le siège social de la société, avec effet au 20 mars 2015,

au:

44, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg

<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015115755/22.
(150124442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

CF Corporate Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 165.872.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 mai 2015

La démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat d'administrateur est acceptée avec effet au 31 décembre 2014.
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 30 septembre 2015:

- Monsieur Erwan LOQUET, conseiller fiscal, Président,
- Monsieur Daniel CROISE, réviseur d'entreprises, expert-comptable,
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, conseiller fiscal,
- Monsieur Pierre LENTZ, réviseur d'entreprises, expert-comptable,
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial
- Monsieur Marc THILL, réviseur d'entreprises, expert-comptable
tous demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.
Est renommé réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 30 septembre 2015:

- H.R.T. Révision S.A., société anonyme, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L - 8030 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015115318/23.
(150124189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Vermillion Aviation Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 191.853.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of June,
Before  the  undersigned,  Maître  Jean  SECKLER,  notary  residing  in  Junglinster,  Grand  Duchy  of  Luxembourg  (the

"Notary"),

THERE APPEARED

I. Vermillion Aviation Holdings Limited, a private company limited by shares, governed by the laws of Hong Kong,

whose registered office is at 30 

th

 Floor, Jardine House, one Connaught Place, Central, Hong Kong and registered with the

Companies Registry of Hong Kong under the number 2162059 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given

under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

111785

L

U X E M B O U R G

II. The appearing party, represented as stated above, is currently the sole shareholder of Vermillion Aviation Finance

S.à r.l. (formerly JV Finance (Luxembourg) S.à r.l.) a Luxembourg private limited liability company (société à responsa-
bilité limité) whose registered office is at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 191853 (the "Company") incor-
porated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, dated 4 November 2014, whose articles
of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial")
on 4 December 2014, number 3710, page 178059 and have been amended for the last time on 18 March 2015 pursuant to
a deed of Maître Jean Secker, notary residing in Junglinster, published in the Mémorialon 8 May 2015, number 1209, page
57987.

III. Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (the "1915 Law")

("Article 200-2") provides that the sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the
general meeting of shareholders of the company, and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn
up in writing.

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

(a) To increase the share capital of the Company by an amount of forty five thousand seven hundred twenty five US

Dollars (USD 45,725.-) so as to bring it from its current amount of two million four hundred seventy-nine thousand eight
hundred fifty-eight United States Dollars (USD 2,479,858.-) to two million five hundred twenty five thousand five hundred
eighty three US Dollars (USD 2,525,583.-) by creating and issuing forty five thousand seven hundred twenty five (45,725)
new shares to be fully subscribed and paid up by its Sole Shareholder through a contribution in cash for an aggregate amount
of forty five thousand seven hundred twenty five US Dollars (USD 45,725.-);

(b) To amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above resolution;
(c) Miscellaneous.
V. The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole existing shareholder of the Company, hereby passes the following

written resolutions in accordance with Article 200-2 before the Notary:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of forty five thousand

seven hundred twenty five US Dollars (USD 45,725.-) so as to bring it from its current amount of two million four hundred
seventy-nine thousand eight hundred fifty-eight United States Dollars (USD 2,479,858.-) to two million five hundred twenty
five thousand five hundred eighty three US Dollars (USD 2,525,583.-) by creating and issuing forty five thousand seven
hundred twenty five (45,725) new shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, having the same
rights and features as those attached to the existing shares (the "New Shares").

<i>Subscription and payment

The Sole Shareholder declares to subscribe and fully pay in for the New Shares a total amount of forty five thousand

seven hundred twenty five US Dollars (USD 45,725.-) by a contribution in cash of an aggregate amount of forty five
thousand seven hundred twenty five US Dollars (USD 45,725.-) (the "Contribution").

The proof of the existence and of the value of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, which shall now read

as follows:

5.1. The share capital of the Company is two million five hundred twenty five thousand five hundred eighty three US

Dollars (USD 2,525,583.-) divided into two million five hundred twenty five thousand five hundred eighty three (2,525,583)
shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the
holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by

reason of the present deed are assessed to one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

The Notary who speaks and understands English and French, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.

The present deed is drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the Notary by name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the Notary the present deed.

111786

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-neuf juin,
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

Vermillion Aviation Holdings Limited, une société à responsabilité limitée, soumise aux lois de Hong Kong, ayant son

siège social au 30 

th

 Floor, Jardine House, one Connaught Place, Central, Hong Kong et immatriculée auprès du registre

des sociétés de Hong Kong sous le numéro 2162059 (l'«Associé Unique»),

Ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une

procuration délivrée sous seing privée.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, est l'associé unique de Vermillion Aviation Finance

S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191853, constituée par un acte notarié du notaire soussigné, en date du
4 novembre 2014 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
"Mémorial") le 4 décembre 2014, numéro 3710, page 178059, et ont été modifiés pour la dernière fois le 18 mars 2015 par
un acte du notaire Maître Jean Seckler, notaire résidant à Junglinster, publié au Mémorial le 8 mai 2015, numéro 1209,
page 57987.

L'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la "Loi de

1915") ("Article 200-2") prévoit que l'associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'as-
semblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal
ou rédigées par écrit.

L'agenda de l'assemblée est le suivant:

<i>Agenda

(a) Augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de quarante-cinq mille sept cents vingt-cinq

Dollars des Etats-Unis (USD 45,725,-) pour le porter de son montant actuel de deux million quatre cent soixante-dix-neuf
mille huit cent cinquante-huit Dollars des Etats-Unis (USD 2,479,858,-) à deux millions cinq cent vingt-cinq mille cinq
cent quatre-vingt-trois Dollars des Etats-Unis (USD 2,525,583,-) par l'émission de quarante-cinq mille sept cents vingt-
cinq (45,725) nouvelles parts sociales émises et entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de
quarante-cinq mille sept cents vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 45,725,-),

(b) Modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la résolution précédente,
(c) Divers.
L'Associé Unique, agissant en sa capacité d'associé unique de la Société, requiert le Notaire d'acter les résolutions

suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2.

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de quarante-cinq mille

sept cents vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 45,725,-) pour le porter de son montant actuel de deux million quatre
cent soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante-huit Dollars des Etats-Unis (USD 2,479,858,-) à un montant de deux
millions cinq cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois Dollars des Etats-Unis (USD 2,525,583,-) par l'émission de
quarante-cinq mille sept cents vingt-cinq (45,725) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar
des Etats Unis (USD 1,-) et ayant les mêmes caractéristiques et droits tels que définis dans les Statuts (les "Nouvelles Parts
Sociales").

<i>Souscription et libération

L'Associé Unique déclare souscrire et entièrement libérer les Nouvelles Parts Sociales pour un montant total de quarante-

cinq mille sept cents vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 45,725,-) par un apport en numéraire d'un montant total de
quarante-cinq mille sept cents vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 45,725,-) (l"'Apport")

La preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport a été apportée au notaire soussigné.

<i>Seconde résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, lequel sera désormais rédigé

comme suit:

Le capital social est fixé à deux millions cinq cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois Dollars des Etats-Unis

(USD 2,525,583,-) représenté par deux millions cinq cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois (2,525,583) parts
sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar US (USD 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts,
"Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit être interprété conformément".

111787

L

U X E M B O U R G

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise,

suivi d'une version française, à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Junglinster, à la date figurant en tête des présents.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence,

le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 1 

er

 juillet 2015. Relation GAC/2015/5517. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015116052/139.
(150124634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

CHC Helicopter (1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.502,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 190.559.

<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 6 juillet 2015

L'associé unique de la Société, a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Aidan Joyce et Gordon Blake Fizzard en tant que gérants A, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Geoff Kellogg, né le 26 octobre 1968 à Vancouver au Canada, résidant professionnellement au 4740 Agar

Drive, Richmond, British Columbia, V7B 1A3 au Canada et Hooman Yazhari, né le 16 juillet 1972 à Téhéran en République
Islamique d'Iran, résidant professionnellement au DFW Operations Center, 6555 N State Highway 161, Irving, Texas,
75039, Etats-Unis d'Amérique en tant que gérants A, et ce avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Caroline De Grox
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015115322/19.
(150125064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

CHC Helicopter (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.502,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 190.564.

<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 6 juillet 2015

L'associé unique de la Société, a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Aidan Joyce et Gordon Blake Fizzard en tant que gérants A, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Geoff Kellogg, né le 26 octobre 1968 à Vancouver au Canada, résidant professionnellement au 4740 Agar

Drive, Richmond, British Columbia, V7B 1A3 au Canada et Hooman Yazhari, né le 16 juillet 1972 à Téhéran en République
Islamique d'Iran, résidant professionnellement au DFW Operations Center, 6555 N State Highway 161, Irving, Texas,
75039, Etats-Unis d'Amérique en tant que gérants A, et ce avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Caroline De Grox
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015115323/19.
(150125063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

111788

L

U X E M B O U R G

Claematis Assets S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 190.781.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 8 juillet 2015

1. Le Conseil d Administration acte la démission avec effet au 22 juin 2015, de Monsieur Guillaume Scroccaro de son

mandat d'Administrateur de la société.

2. Le Conseil d'Administration décide de coopter, avec effet au 22 juin 2015, au poste d'Administrateur Monsieur Marc

Besch, employé privé, né le 21 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015115330/16.
(150124954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

CHC Helicopter (4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.502,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 190.572.

<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 6 juillet 2015

L'associé unique de la Société, a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Aidan Joyce et Gordon Blake Fizzard en tant que gérants A, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Geoff Kellogg, né le 26 octobre 1968 à Vancouver au Canada, résidant professionnellement au 4740 Agar

Drive, Richmond, British Columbia, V7B 1A3 au Canada et Hooman Yazhari, né le 16 juillet 1972 à Téhéran en République
Islamique d'Iran, résidant professionnellement au DFW Operations Center, 6555 N State Highway 161, Irving, Texas,
75039, Etats-Unis d'Amérique en tant que gérants A, et ce avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Caroline De Grox
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015115324/19.
(150125062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

CHC Helicopter (5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 190.587.

<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 6 juillet 2015

L'associé unique de la Société, a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Aidan Joyce et Gordon Blake Fizzard en tant que gérants A, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Geoff Kellogg, né le 26 octobre 1968 à Vancouver au Canada, résidant professionnellement au 4740 Agar

Drive, Richmond, British Columbia, V7B 1A3 au Canada et Hooman Yazhari, né le 16 juillet 1972 à Téhéran en République
Islamique d'Iran, résidant professionnellement au DFW Operations Center, 6555 N State Highway 161, Irving, Texas,
75039, Etats-Unis d'Amérique en tant que gérants A, et ce avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Caroline De Grox
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015115325/19.
(150125061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

111789

L

U X E M B O U R G

Clymene, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 145.471.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 8 juillet 2015

1. Le Conseil d Administration acte la démission avec effet au 22 juin 2015, de Monsieur Guillaume Scroccaro de son

mandat d'Administrateur de la société.

2. Le Conseil d'Administration décide de coopter, avec effet au 22 juin 2015, au poste d'Administrateur Monsieur Marc

Besch, employé privé, né le 21 novembre 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015115331/16.
(150125013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Dynamics Films Library (DFL) S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 1, rue de Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 87.017.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2015 que:
1. le siège social a été transféré à L-1946 Luxembourg, 1, rue de Louvigny
2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Dominique Vignet, administrateur de société, avec adresse pro-

fessionnelle à L-1946 Luxembourg, 1, rue de Louvigny, administrateur unique en remplacement de Mesdames Juliette
Pham et Gabriele Schneider et de Monsieur Michel Schaeffer.

Le mandat de l'administrateur unique nouvellement élu expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an

2020.

Luxembourg, le 7 juillet 2015.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2015115368/19.
(150124299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Compass Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8261 Mamer, 63, rue Dangé Saint-Romain.

R.C.S. Luxembourg B 79.735.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2015

Démission de Fiduciaire &amp; Expertises (Luxembourg) S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes.
Nomination de FGA (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 61 096, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer en tant que

commissaire aux comptes pour une durée de 6ans.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015115344/12.
(150123909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

CMS Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 81.525.

Une liste des fondés de pouvoirs de la Société CMS Management Services S.A. en fonction au 1 

er

 Juillet 2015 a été

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

111790

L

U X E M B O U R G

CMS Management Services S.A.

Référence de publication: 2015115332/11.
(150123912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

CHC Helicopter Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.511,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 155.574.

<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 7 juillet 2015

L'associé unique de la Société, a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Joan Schweikart Hooper en tant que gérant de classe A, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Geoff Kellogg, né le 26 octobre 1968 à Vancouver au Canada, résidant professionnellement au 4740 Agar

Drive, Richmond, British Columbia, V7B 1A3 au Canada en tant que gérant de classe A, et ce avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Caroline De Grox
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015115326/17.
(150125078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Farringdon I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 121.761.

Il résulte d'une décision de la Société en date du 19 juin 2015, de:
- Rayer Monsieur Jean-Marc DELMOTTE, Mr Bruno FREREJEAN, Monsieur Danilo LINOSA et Monsieur Stephan

KARLSTEDT en tant qu'administrateurs de la Société avec effet immédiat.

- Nommer Monsieur Luc COURTOIS, né le 21 août 1970 à Bastogne, Belgique, résidant professionnellement au 2, rue

Peternelchen, L-2370 à Howald, Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en 2016;

- Nommer Monsieur Denis VAN WEES, né le 24 septembre 1976 à Amsterdam, Pays-Bas, résidant professionnellement

au 5, place de la gare, L-1616 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en 2016;

- Nommer Monsieur Vincent GRUSELLE né le 7 novembre 1969 à Neuilly-Sur-Seine, France, résidant professionnel-

lement au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec
effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016;

- Rayer la société DELOITTE AUDIT, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat; et
- nommer la société PRICEWATERHOUSECOOPER, une société coopérative de droit luxembourgeois, enregistré au

Registre de Commerce et des Société de et à Luxembourg sous le numéro B65477 ayant son siège social au 2, Rue Gerhard
Mercator, L-2182 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Référence de publication: 2015115486/26.
(150124542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Colombe Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 190.558.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 7 juillet 2015 lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société

- La démission de M. Fabrice Huberty de sa fonction d'administrateur de catégorie B de la Société a été acceptée avec

effet au 12 juin 2015,

111791

L

U X E M B O U R G

- La cooptation de M. Alexandre Taskiran, expert-comptable, né Le 24 avril 1968 à Karaman (Turquie), résidant pro-

fessionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société
avec effet au 12 juin 2015 et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2020, a été décidée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colombe Investments S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015115337/17.

(150124232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Compagnie de Financements et d'Investissements Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 78.521.

EXTRAIT

L'administrateur Monsieur Paolo Brichetti a déménagé au 34, Berenstraat à 1016 GH Amsterdam.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015115342/10.

(150125154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Atid, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 66.397.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2015 que:

Le mandat d'administrateur de:

- Madame Anne-Marie GILER, demeurant B-1040 Bruxelles, 83, rue du commerce

- Madame Renée GILER, demeurant L-6488 Echternach, 8, rue des vergers

- Monsieur Patrick GILER demeurant B-1040 Bruxelles, 83, rue du commerce

est renouvelé pour une période de une année, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur

les comptes clôturés le 31 décembre 2014 qui se tiendra en 2016.

Monsieur Patrick GILER, précité, est nommé en tant que Président du conseil d'administration pour la durée de son

mandat d'administrateur, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés le
31 décembre 2014 qui se tiendra en 2016.

Monsieur Patrick GILER, précité, est reconduit dans sa fonction d'administrateur-délégué pour une période de une année,

à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés le 31 décembre 2014 qui se
tiendra en 2016.

Monsieur Daniel MAGITTERI est appelé aux fonctions de commissaire pour l'exercice 2014 soit jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés le 31 décembre 2014 qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015116552/27.

(150125849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

111792


Document Outline

Advent Software Luxembourg

Atid

Bache Global Series

BPI 17 S.à.r.l.

Brunswick Real Estate S.à r.l.

Camelia Participations S.A.

Candara Invest S.A.

CDW S.à r.l.

Centaurae Assets

Centrale Convergence Finances Luxembourg S.à r.l.

CF Corporate Services

CHC Helicopter (1) S.à r.l.

CHC Helicopter (2) S.à r.l.

CHC Helicopter (4) S.à r.l.

CHC Helicopter (5) S.à r.l.

CHC Helicopter Holding S.à r.l.

Cie d'Investissement et de Participations du Luxembourg S.A.

Claematis Assets S.A.

Clymene

CMS Management Services S.A.

Coachbuilder Intellectual Property Management

Cobalt Waterline S.à r.l.

Cobolt Investments S.à r.l.

Colombe Investments S.A.

Compagnie de Financements et d'Investissements Holding S.A.

Compagnie Financière des Bruyères S.A.

Compass Consulting S.A.

Componentia S.A.

Culture Holding S.à r.l.

Dover Luxembourg Finance Sàrl

Dynamics Films Library (DFL) S.A.

Farringdon I

Goodman Enargite Logistics (Lux) S.à r.l.

Interactive Development S.A.

JC Aviation (Luxembourg) S.A.

Logicor (Shine) Winsen S.à r.l.

Lux Nature et Jardins S.à r.l.

Madev Holding Corporation S.A., SPF

SML Alpha S.à r.l.

Sonnenberg S.à r.l.

Vermillion Aviation Finance S.à r.l.