This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2279
27 août 2015
SOMMAIRE
1640 Investment 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
109352
Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg IIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109376
AIV SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109353
Baracoa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109351
BDP International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
109349
Becky S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109349
Belcada (Luxembourg) Spf S. à r.l. . . . . . . . . .
109351
BP C Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109350
Bulb S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109350
Centrum Poznan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109347
Centrum Warta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109353
CEP III Chase S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109346
CETP II Imola Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
109362
EF Investments (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
109348
Elzara S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109348
eOffice Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109352
Filauro Giuseppe Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109348
Fondation Crèche de Luxembourg . . . . . . . . .
109354
Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109385
GT Multi Alternative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109347
"Icasa S.à r.l." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109353
Irocy Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109384
Jezara Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109346
Kensington Italy Retail Holdco S.à r.l. . . . . . .
109356
Miremar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109392
Opalys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109351
OXEA FINANCE & Cy S.C.A. . . . . . . . . . . . .
109351
Oxea S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109352
Pamiga Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109353
Pathway Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109385
PIT D Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109373
P.L.T. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109352
Premier Cru Multi Investments . . . . . . . . . . . .
109392
ProLogis European Holdings XVII S.à r.l. . . .
109346
ProLogis UK CC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109347
Reynolds Group Issuer (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109349
Servimat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109346
Servimat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109346
Silver Corporate Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109347
Silver II GP Holdings S.C.A. . . . . . . . . . . . . . .
109358
Skipper Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109384
Société de Financement des Risques Industriels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109350
Sophielux 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109350
Swiss Life (LUX) German Core Real Estate
Management S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109363
Synapse Logistique Luxembourg . . . . . . . . . . .
109385
Tampico S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109348
Tasty Strategies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109348
Triumvirate III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109347
Zantek Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109384
109345
L
U X E M B O U R G
ProLogis European Holdings XVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 137.200.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015109639/9.
(150118889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Servimat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 36.812.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 juillet 2015.
Référence de publication: 2015109739/10.
(150118944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Servimat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 36.812.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 juillet 2015.
Référence de publication: 2015109740/10.
(150119057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
CEP III Chase S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 179.090.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 juillet 2015.
CEP III Chase S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015112967/12.
(150121141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Jezara Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 158.441.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
44, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2015113276/13.
(150121786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
109346
L
U X E M B O U R G
ProLogis UK CC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 102.108.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015109640/9.
(150118898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Silver Corporate Capital, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5376 Üebersyren, 25, rue de Beyren.
R.C.S. Luxembourg B 178.888.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2015.
Référence de publication: 2015109744/10.
(150119594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Triumvirate III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 179.673.
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions de gérant de votre
société et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
Nicolas MILLE.
Référence de publication: 2015109787/10.
(150119026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Centrum Poznan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 123.442.
Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Centrum Poznan S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2015112931/12.
(150121085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
GT Multi Alternative, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 141.909.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2015.
<i>Pour GT MULTI ALTERNATIVE
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2015113185/13.
(150121654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
109347
L
U X E M B O U R G
Tasty Strategies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 131.985.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015112683/9.
(150120447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
EF Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 148.103.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015113062/10.
(150121059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Filauro Giuseppe Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 36.607.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PINHEIRO Samantha.
Référence de publication: 2015112165/10.
(150120573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Tampico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 168.871.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2015112681/11.
(150119939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Elzara S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 189.642.
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales du 30 juin 2015 que la société BOSFIN Luxembourg S.à r.l. avec
siège social à 2, avenue Charles de Gaulle, L-2535 Luxembourg, immatriculée auprès du RCSL sous le numéro B 183.636,
a cédé 125 parts sociales de la société ELZARA S.à r.l. à la société BOSFIN S.A. avec siège social à 19 square Vergote,
B-1200 Bruxelles, immatriculée auprès du RCB sous le numéro 602.549.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fons MANGEN
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015113069/14.
(150120999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
109348
L
U X E M B O U R G
Becky S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 141.215.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 juin 2015 a renouvelé les mandats des administrateurs et du
commissaire aux comptes pour un an.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Mark HOLDEN
- Monsieur Jean HOFFMANN
- Monsieur Marc KOEUNE
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015112108/17.
(150120443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Reynolds Group Issuer (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 148.957.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’actionnaire unique de la Société en date du 12 juin 2015 que:
- Messieurs Olivier Dorier, Hermann-Günter Schommarz et Carl John Getz ont été reconduits dans leurs mandats de
membres du Conseil d’Administration de la Société jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2021.
- PricewaterhouseCoopers S.à r.l. dont le siège social est sis au 400, Route d’Esch, L-1014 Luxembourg, a été reconduit
dans son mandat de réviseur d’entreprises agréé des comptes annuels de la Société pour l’exercice social qui se terminera
le 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 6 juillet 2015.
<i>Pour la Société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015113559/18.
(150122332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
BDP International S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 182.819.
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 juin 2015 que:
- Monsieur Robert W. Adriaansen a démissionné de son poste de membre de classe A de la Société et ce avec effet
immédiat.
- Madame Corinne Sophie Shim Muller, née à Seoul, Corée du Sud, le 15 octobre 1976, ayant son adresse professionnelle
au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, a été nommée en tant que gérant de classe A de la Société et ce
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
- Monsieur Johannes Andries van den Berg, né à Pijnacker, Pays-Bas, le 28 décembre 1979, ayant son adresse profes-
sionnelle au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, a été nommé en tant que gérant de classe A de la Société
et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Référence de publication: 2015112106/19.
(150120412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
109349
L
U X E M B O U R G
Sophielux 2, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 173.828.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015113667/9.
(150120962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
BP C Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 179.219.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015112123/10.
(150120414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Bulb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6235 Beidweiler, 26, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 78.394.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015112915/12.
(150121725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
SOFIRI, Société de Financement des Risques Industriels, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 26.550.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 19 juin 2015i>
L'Assemblée décide de reconduire le mandat des Administrateurs suivants:
M. Markus HOFER,
M. Robert TUTCHENER,
M. Vic PANNUZZO,
Mrs Sophie VANDEVEN.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2015.
L'assemblée décide de nommer Réviseur Indépendant de la société
Grant Thornton Lux Audit S.A.
89A Pafebruch
L-8308 CAPELLEN
Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social au 31 décembre 2015.
<i>Pour la société SOFIRI
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2015113659/23.
(150122003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
109350
L
U X E M B O U R G
Baracoa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 171.383.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08. Juillet 2015.
Référence de publication: 2015112856/10.
(150121036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
OXEA FINANCE & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 153.693.
AUSZUG
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 08.07.2015.
<i>Für die Gesellschaft
Der Beauftragtei>
Référence de publication: 2015113495/13.
(150121908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Belcada (Luxembourg) Spf S. à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 100.233.
EXTRAIT
En date du 22 juin 2015, les associés de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Gulcin Tekes comme gérant de la société avec effet au 30 juin 2015;
- Nomination de Shira Becker-Alon, née le 30 septembre 1977 à Tel Aviv, en Israël, avec adresse professionnelle au
15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouveau gérant de la société avec effet au 30 juin 2015 et ce pour
une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Référence de publication: 2015112858/15.
(150122422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Opalys S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 115.133.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 19 mars 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère
Public en leurs conclusions, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société anonyme
OPALYS SA, dont le siège social à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy a été dénoncé en date du 22 janvier
2010.
Ce même jugement a dit que les frais sont à charge des actionnaires.
Pour extrait conforme
Maître Carmen RIMONDINI
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015113487/16.
(150121102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
109351
L
U X E M B O U R G
eOffice Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 90.728.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
eOFFICE INVEST S.A.
Référence de publication: 2015111971/10.
(150120128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
1640 Investment 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 185.584.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015111966/10.
(150119821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Oxea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 872.664,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 122.023.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 08.07.2015.
<i>Für die Gesellschaft
Der Beauftragtei>
Référence de publication: 2015113498/12.
(150121912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
P.L.T. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5532 Remich, 17, rue Enz.
R.C.S. Luxembourg B 196.192.
En date du 15 juin 2015, a eu lieu la cession de parts sociales suivante:
Monsieur DA SILVA NEVES CARLOS, comptable, né à Esch-sur-Alzette le 19 novembre 1985, demeurant à L-4222
Esch-sur-Alzette, 274 rue de Luxembourg, a cédé ses cinq (5) parts sociales lui appartenant à Madame Tania HUTSCH,
vendeuse, née à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 1989, demeurant à L-5687 Dalheim, 15A, Hossegaass.
Monsieur Carlos DA SILVA NEVES démissionne de son poste de gérant technique et n’est plus associé dans la société.
Madame Tania HUTSCH a été nommé au poste de gérante technique.
Madame Marie-Louise WIRTZ , née le 24/04/1962 à Esch-sur-Alzette, demeurant à D-66706 Perl, Allemagne, a été
nommé au poste de gérante administrative.
La société est valablement engagée par la signature individuelle d’une des deux gérantes.
Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit:
- Madame Marie-Louise WIRTZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 parts sociales
- Madame Tania HUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 parts sociales
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015113502/22.
(150122305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
109352
L
U X E M B O U R G
Pamiga Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 169.627.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015109651/9.
(150118951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.
"Icasa S.à r.l.", Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 189.068.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>La gérancei>
Référence de publication: 2015111972/10.
(150120904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Centrum Warta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 188.766.
Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Centrum Warta S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015112932/12.
(150121205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
AIV SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 127.762.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ajournée des actionnaires tenue au siège social de la société eni>
<i>date du 30 juin 2015i>
<i>(l'“Assemblée”)i>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de catégorie A de la
Société avec effet au 25 mars 2015 pour une période de 6 ans. Le mandat des administrateurs sera renouvelé lors de
l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2021:
- Hinnerk Koch, administrateur de sociétés, né le 15 mars 1963 à Brême, Allemagne, avec adresse professionnelle au
9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Alain Koch, administrateur de sociétés, né le 13 août 1965 à Esch-sur-Alzette, Luxembourg, avec adresse profession-
nelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Danielle Delnoije, administrateur de sociétés, né le 14 Février 1974 à Sittard, Pays-Bas, avec adresse professionnelle
au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
A Luxembourg, le 30 juin 2015.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2015112044/23.
(150120902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
109353
L
U X E M B O U R G
Fondation Crèche de Luxembourg, Fondation.
Siège social: L-1123 Luxembourg, 12, Plateau Altmünster.
R.C.S. Luxembourg G 144.
<i>Comptes 2013i>
<i>Budget 2014i>
<i>Bilan au 31 décembre 2013i>
<i>Pertes et profits au 31 décembre 2013i>
G144
<i>Budget 2014i>
Recettes
Dépenses
Cotisations parentales: . . . . . . . . . . . . .
380.000€
Dépenses salariales: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.200 000€
Dépenses de fonctionnement courant . . . . .
130.000€
Participation de l'Etat . . . . . . . . . . . . . .
950.000€
Total des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.330 000€ Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1 330 000,00
<i>Bilan au 31 décembre 2013i>
ACTIF
31.12.13
31.12.12
EUR
EUR
Actif Immobilisé
Immobilisations Corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,324
1,328
Actif Circulant
1. Créances
Créances Clients / Usagers Foyer Jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53,329
56,355
Créances envers des établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,425
Autres créances à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,252
0
Subvention Ministère de la Famille à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Etat et autre Collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318
2. Valeurs Mobilières
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
909,780
880,803
Valeurs Mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135,956
196,675
3. Avoirs en Banque
C.C.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101,073
118,510
Banque de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
780,211
574,918
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
11
Comptes de Régularisation
Charges à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,011
584
1,986,158 1,830,928
PASSIF
Capitaux propres
Fonds Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
949,533
949,533
Réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,176
711
Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
787,078
752,541
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-28,561
34,537
Dettes
Dettes sur achats et prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,257
8,818
Subvention Ministère de la Famille à rembourser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
226,302
37,175
Etat et autres Collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,752
0
Dettes au titre de la Sécurité Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,460
38,406
Salaires à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,160
7,286
Comptes de Régularisation
Produits à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,920
1,986,158 1,830,928
109354
L
U X E M B O U R G
<i>Pertes et profits au 31 décembre 2013i>
112147
CHARGES
31.12.13
31.12.12
EUR
EUR
Achats
Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,675
17,674
Alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,600
34,662
Frais d'hygiène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,294
4,346
Pédagogie / animation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,866
6,495
Langes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,132
4,858
Électroménager et petit équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,573
7,038
Frais médicaux et hygiène enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,207
7,340
Informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
754
2,695
Services extérieurs
Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,428
2,389
Formation et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,315
1,968
Contrats de maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,391
6,094
Autres services extérieurs
Honoraires consultants externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,831
2,660
Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
732
784
Frais de communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,769
6,256
Impôts, taxes et versements
Frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
165
Charges de personnel
Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,043,468
996,633
Cotisations sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152,668
147,144
Autres charges d'exploitation
Pertes sur créances irrécouvrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
832
Charges financières
Autres charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
397
456
Variation moins value non réalisée sur Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,719
Dotations aux corrections de valeur
Correction de valeur mobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
221
Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
1,330
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-28,561
34,537
1,344,608 1,285,746
PRODUITS
Subventions d'exploitation
Ministère de la Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
839,327
844,799
Dons Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
1,000
Autres produits d'exploitation
Remboursements sur salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63,075
55,536
Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,290
1,091
Contributions parentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400,714
344,566
Produits financiers
Intérêts comptes courants et dépôt à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,531
11,872
Variation plus-value non réalisée sur Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,013
Assurance La Luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,339
19,593
Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,682
277
1,334,959 1,285,746
Notes aux comptes
Principe de valorisation
Les valeurs mobilières (point 2 de l'actif circulant) sont évaluées à leur valeur liquidative.
Immobilisations corporelles et incorporelles
109355
L
U X E M B O U R G
Les immobilisations sont inscrites au coût d'acquisition qui comprend les frais accessoires.
Les immobilisations corporelles sont amorties sur une base linéaire selon leur durée de vie approximative.
Autres installations, outillage et mobilier 4-10 ans
A l'attention du Conseil d'Administration Crèche de Luxembourg
Plateau Altmunster, 11
L-1123 Luxembourg
<i>Rapport du commissaire aux comptesi>
Conformément aux dispositions légales et statutaires, j'ai l'honneur de vous rendre compte de l'exécution, pour l'exercice
2013, du mandat de commissaire aux comptes que vous avez bien voulu me confier.
Par analogie avec le régime des sociétés anonymes holding, j'ai effectué ma mission sur base de l'article 62 de la loi
modifiée du 10 août 1915.
J'ai constaté que les comptes annuels de la Crèche de Luxembourg («la Crèche»), dont la somme bilantaire au 31
décembre 2013 s'élève à EUR 1,986,158 et le résultat de l'exercice du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 à EUR -28,561
(perte), sont en concordance avec la comptabilité et les pièces comptables qui m'ont été soumises. Nous avons, cependant,
des remarques à formuler sur les comptes annuels.
A l'issue de notre contrôle, nous avons constaté un problème de séparation des exercices. En effet, le décompte du Centre
Commun de la Sécurité Sociale de décembre 2013 (reçu en février 2014) mentionne un remboursement de la mutualité.
Ce remboursement s'élevant à EUR 10,444 a été comptabilisé sur l'exercice 2014 bien qu'il se rapporte à l'exercice 2013.
Par ailleurs, concernant le contrat d'assurance vie «La Luxembourgeoise» enregistré comme participation à l'actif du
bilan, nous avons noté que l'évaluation a été faite sur base d'un relevé au 8 juillet 2014 et non au 31 décembre 2013.
De fait l'actif est surévalué au 31.12.2013 de EUR 9,074.
Nous estimons que l'effet net sur les comptes annuels de ces deux éléments non corrigés ne sont pas significatifs, au
regard des comptes annuels pris dans leur ensemble.
Je souhaite enfin attirer votre attention sur la variation du cours de l'or en 2013.
En effet, celui-ci ayant chuté de plus de 30% pendant l'année, a entraîné une perte de EUR 60,719 pour la Crèche.
Le 13 mai 2015.
Vinciane Istace.
Référence de publication: 2015112146/136.
(150119960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Kensington Italy Retail Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.601.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of June.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Kensington Italy Retail Pledgeco S.à.r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 197.452 (the “Sole Shareholder”),
represented by Me Ségolène Le Marec, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy
dated 26 June 2015 which shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder
and the undersigned notary,
being the Sole Shareholder of Kensington Italy Retail Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited
liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 197.601 (the "Company"),
incorporated on 5
th
June 2015, pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the “Mémorial”).
The articles of association of the Company have not yet been amended.
The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all the five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital
is represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.
2. The item on which a resolution is to be taken is as follows:
109356
L
U X E M B O U R G
“Amendment of the current accounting year which has started on 5
th
June 2015 and shall terminate on 30
th
June 2015.
The following accounting year shall begin on 1
st
July 2015 and end on 31
st
December 2015. Consequential amendment
of Article 11 of the articles of association of the Company follows: The accounting year begins on 1
st
January of each year
and ends on 31
st
December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of
incorporation and end on 30
th
June 2015 and the following accounting year shall begin on 1
st
July 2015 and end on 31
st
December 2015.”
Thereafter the following resolution was passed by the Sole Shareholder of the Company:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the current accounting year of the Company which has started on 5
th
June
2015 and shall terminate on 30
th
June 2015. The following accounting year shall begin on 1
st
July 2015 and end on 31
st
December 2015.
Consequently, the Sole Shareholder resolved to amend Article 11 of the articles of association of the Company as set
forth in the above agenda.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at EUR 1,500.-
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, this
deed is drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of diver-
gences between the English and German version, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Englischen Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten Juni.
Vor Uns, Maître Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Kensington Italy Retail Pledgeco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftau-
sendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxemburg
unter der Nummer B 197.452 , (der «Alleinige Gesellschafter»),
hier vertreten durch Maître Ségolène Le Marec, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Voll-
macht welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt wird nachdem sie ne varietur durch den Vollmachtnehmer und den
unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde am 26. Juni 2015,
als Alleiniger Gesellschafter der Kensington Italy Retail Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren
Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxemburg, unter der Nummer B 197.601 (die «Gesellschaft»), gegründet am 5. Juni 2015 gemäß
Urkunde aufgenommen durch Maître Cosita Delvaux, Notar mit Amtsitz in Luxemburg, noch nicht veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial»).
Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.
Die Erschienene gibt, in Ausübung ihres obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden
Notar folgendes zu beurkunden:
1. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hält alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesell-
schaftsanteile, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und wirksam über alle Punkte der Tagesordnung
entschieden werden kann.
2. Der Punkt über den ein Beschluss getroffen werden soll ist der folgende:
„Änderung des aktuellen Geschäftsjahres, welcher am 5. Juni begonnen hat und am 30. Juni 2015 endet. Das folgende
Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli 2015 und endet am 31. Dezember 2015. Abänderung von Artikel 11 der Satzung der
Gesellschaft so dass Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft folgenden Wortlaut hat: Das Geschäftsjahr beginnt am ersten
(1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres,
welcher am Tag der Gründung beginnen soll und am 30. Juni 2015 enden soll und das folgende Geschäftsjahr soll am 1.
Juli 2015 beginnen und am 31. Dezember 2015 enden.“
Danach wurde der folgende Beschluss vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:
109357
L
U X E M B O U R G
<i>Alleiniger Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat entschlossen das aktuelle Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ändern,
welches am 5. Juni begonnen hat und am 30. Juni 2015 endet. Das folgende Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli 2015 und
endet am 31. Dezember 2015.
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 11 der
Satzung der Gesellschaft den Wortlaut hat wie in der Tagesordnung beschrieben.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass
dieser Akte entstehen werden, werden geschätzt auf ungefähr EUR 1.500,-
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene Partei hat dieselbe mit dem amtierenden Notar
diese Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: S. LE MAREC, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/20208. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 07. Juli 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015112309/103.
(150120185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Silver II GP Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 173.238.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of the month of June.
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders of Silver II GP Holdings S.C.A. (the “Company”), a société en com-
mandite par actions having its registered office at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, incorporated by
deed of the undersigned notary on 30
th
November, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
(the “Mémorial”) Nr. C-139 of 19
th
January 2013. The articles of association of the Company have been amended several
times and for the last time on 23
rd
May 2014 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial, Nr. C-2027,
of 1
st
August 2014.
The meeting was presided by Me Maryline Esteves, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Me Clémence PERSONNE, maître en droit,
residing professionally in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I) The shareholders represented and the number of shares held are shown on the attendance list, signed by the chairman,
the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
II) It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that the
shareholders declare having been duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and may
validly deliberate on the agenda set out below:
A. Reduction of the issued share capital of the Company from one hundred two thousand nine hundred twenty-nine US
dollars and fifty-four cents (USD 102,929.54) by an amount of two US dollars and twenty-four cents (USD 2.24) to one
hundred and two thousand nine hundred and twenty-seven US dollars and thirty cents (USD 102,927.30) by means of the
repurchase of twenty- eight (28) shares of each classes A-3 to H-3, each having a nominal value of USD 0.01. from Mr.
James MacLean, shareholder of the Company, and the subsequent cancellation of twenty-eight (28) shares of each classes
A-3 to H-3, each having a nominal value of USD 0.01. at an aggregate repurchase price of twenty-nine thousand one
hundred and twenty US dollars (USD 29,120) and payment of such repurchase price to Mr. James MacLean.
B. Amendment of Article 5 of the articles of association of the Company which shall read as follows:
109358
L
U X E M B O U R G
“The issued share capital of the Company is set at one hundred and two thousand nine hundred and twenty-seven US
dollars and thirty cents (USD 102,927.30) represented by ten million two hundred ninety-two thousand seven hundred and
thirty (10,292,730) shares, divided into:
(i) one million two hundred fifty-three thousand six hundred twenty (1,253,620) class A limited shares (the “Class A
Shares”), themselves divided into six hundred twenty-four thousand nine hundred ninety-nine (624,999) class A-1 limited
shares, six hundred twenty-four thousand nine hundred ninety-nine (624,999) class A-2 limited shares and three thousand
six hundred twenty-two (3,622) class A-3 limited shares,
(ii) one million two hundred fifty-three thousand six hundred twenty-two (1,253,622) class B limited shares (the “Class
B Shares”), themselves divided into six hundred twenty-five thousand (625,000) class B-1 limited shares, six hundred
twenty-five thousand (625,000) class B-2 limited shares and three thousand six hundred twenty-two (3,622) class B-3
limited shares,
(iii) one million two hundred fifty-three thousand six hundred twenty-two (1,253,622) class C limited shares (the “Class
C Shares”), themselves divided into six hundred twenty-five thousand (625,000) class C-1 limited shares, six hundred
twenty-five thousand (625,000) class C-2 limited shares and three thousand six hundred twenty-two (3,622) class C-3
limited shares,
(iv) one million two hundred fifty-three thousand six hundred twenty-two (1,253,622) class D limited shares (the “Class
D Shares”), themselves divided into six hundred twenty-five thousand (625,000) class D-1 limited shares, six hundred
twenty-five thousand (625,000) class D-2 limited shares and three thousand six hundred twenty-two (3,622) class D-3
limited shares,
(v) one million two hundred fifty-three thousand six hundred twenty-two (1,253,622) class E limited shares (the “Class
E Shares”), themselves divided into six hundred twenty-five thousand (625,000) class E-1 limited shares, six hundred
twenty-five thousand (625,000) class E-2 limited shares and three thousand six hundred twenty-two (3,622) class E-3
limited shares,
(vi) one million two hundred fifty-three thousand six hundred twenty-two (1,253,622) class F limited shares (the “Class
F Shares”), themselves divided into six hundred twenty-five thousand (625,000) class F-1 limited shares, six hundred
twenty-five thousand (625,000) class F-2 limited shares and three thousand six hundred twenty-two (3,622) class F-3 limited
shares,
(vii) one million two hundred fifty-three thousand six hundred twenty-two (1,253,622) class G limited shares (the “Class
G Shares”), themselves divided into six hundred twenty-five thousand (625,000) class G-1 limited shares, six hundred
twenty-five thousand (625,000) class G-2 limited shares and three thousand six hundred twenty-two (3,622) class G-3
limited shares,
(viii) one million two hundred fifty-three thousand six hundred twenty-two (1,253,622) class H limited shares (the “Class
H Shares”), themselves divided into six hundred twenty-five thousand (625,000) class H-1 limited shares, six hundred
twenty-five thousand (625,000) class H-2 limited shares and three thousand six hundred twenty-two (3,622) class H-3
limited shares,
(ix) one hundred thirty-one thousand eight hundred seventy-seven (131,877) class I limited shares (the “Class I Shares”),
themselves divided into twenty-six thousand three hundred seventy-seven (26,377) class I-1 limited shares, fifty-two thou-
sand seven hundred fifty (52,750) class I-2 limited shares and fifty-two thousand seven hundred fifty (52,750) class I-3
limited shares,
(x) one hundred thirty-one thousand eight hundred seventy-seven (131,877) class J limited shares (the “Class J Shares”),
themselves divided into twenty-six thousand three hundred seventy-seven (26,377) class J-1 limited shares, fifty-two thou-
sand seven hundred fifty (52,750) class J-2 limited shares and fifty-two thousand seven hundred fifty (52,750) class J-3
limited shares, and
(xi) two (2) management shares (the “Management Shares”),
each with a nominal value of one US cent (USD 0.01) (the limited shares being collectively referred to as the “Limited
Shares” and together with the Management Shares as the “shares”) and with such rights and obligations as set out in the
present Articles of Incorporation. For the avoidance of doubt, any numbered series or subdivision of a class of Limited
Shares shall not be considered as a class of Limited Shares of its own for any purpose.
The authorized un-issued share capital of the Company is set at an additional seven hundred US dollars and sixteen
cents (USD 700.16) represented by additional seventy thousand sixteen (70,016) limited shares, divided into:
thirty-five thousand eight (35,008) Class I Shares (the “Unallocated Class I Shares”), and thirty-five thousand eight
(35,008) Class J Shares (the “Unallocated Class J Shares”, and, together with the Unallocated Class I Shares, the “Unal-
located Class I/J Shares”),
each with a nominal value of one US cent (USD 0.01) and any of which may be divided into additional series or
subgroups.
The authorization of the Unallocated Class I/J Shares (and any authorization granted to the Manager in relation thereto)
shall be valid until the fifth anniversary of the date of publication of the deed of the extraordinary general meeting of
shareholders of the Company held on 22 November 2013 in the Mémorial.
109359
L
U X E M B O U R G
The Manager, or any delegate(s) duly appointed by the Manager, may from time to time issue Unallocated Class I/J
Shares within the limits of the authorized un-issued share capital against contributions in cash, contributions in kind or by
way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the
Manager or its delegate(s) may in its or their discretion resolve without reserving any preferential subscription rights to
existing shareholders. The shareholders authorize the Manager to waive, suppress or limit any preferential subscription
rights of shareholders provided for by law to the extent it deems such waiver, suppression or limitation advisable for any
issue or issues of Unallocated Class I/J Shares within the authorized un-issued share capital.
Any available share premium shall be freely distributable and shall not be attached to a particular class or category of
shares.
The Management Shares shall be held by Silver II GP S.à r.l. being the unlimited liability shareholder (“Unlimited
Liability Shareholder”) and Manager of the Company.”
Consequently the shareholders have passed the following resolutions unanimously:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to approve the reduction of the issued share capital of the Company from one hundred two thousand
nine hundred twenty-nine US dollars and fifty-four cents (USD 102,929.54) by an amount of two US dollars and twenty-
four cents (USD 2.24) to one hundred and two thousand nine hundred and twenty-seven US dollars and thirty cents (USD
102,927.30) by means of the repurchase of twenty- eight (28) shares of each classes A-3 to H-3, each having a nominal
value of USD 0.01. from Mr. James MacLean, shareholder of the Company, and the subsequent cancellation of twenty-
eight (28) shares of each classes A-3 to H-3, each having a nominal value of USD 0.01. at an aggregate repurchase price
of twenty-nine thousand one hundred and twenty US dollars (USD 29,120) and payment in cash of such repurchase price
to Mr. James MacLean.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company as stated under item B of the
agenda.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its reduction of share capital are estimated at one thousand one hundred euro (EUR 1,100,.).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois de juin.
Par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Silver II GP Holdings S.C.A. (la «Société»), une société en
commandite par actions ayant son siège social au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, constituée suivant
acte du notaire soussigné le 30 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»)
numéro C-139 du 19 janvier 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 23 mai 2014 par acte
notarié du notaire soussigné, publié au Mémorial, numéro C-2027 du 1
er
août 2014.
L'assemblée a été présidée par Me Maryline Esteves, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire et l'assemblée a élu comme scrutateur Me Clémence PERSONNE, maître en
droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I) Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur la liste de présence signée par
le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.
II) Il appert de la liste de présence que la totalité du capital social est représentée à la présente assemblée et que les
actionnaires déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour, permettant ainsi à la présente assemblée d'être régu-
lièrement constituée et de statuer valablement sur tous les points inscrits à l'ordre du jour énoncé ci-dessous:
A. Réduction du capital social émis de la Société de cent deux mille neuf cent vingt-neuf US dollars et cinquante-quatre
cents (USD 102.929,54) pour un montant de deux US dollars et vingt-quatre cents (USD 2,24) pour le porter à cent deux
mille neuf cent vingt-sept US dollars et trente cents (USD 102.927,30) par le rachat de vingt-huit (28) actions de chaque
classe de A-3 à H-3, toutes ayant une valeur nominale de USD 0,01. de M. James MacLean, actionnaire de la Société, et
l'annulation subséquente de vingt-huit actions de chaque classe de A-3 à H-3, chacune ayant une valeur nominale de USD
109360
L
U X E M B O U R G
0,01. à un prix total de vingt-neuf mille cent vingt US dollars (USD 29.120) et payement d'un tel prix de rachat à M. James
MacLean.
B. Modification de l'article 5 des statuts de la Société qui se lira comme suit:
«Le capital social émis de la Société est fixé à cent deux mille neuf cent vingt-sept US dollars et trente cents (USD
102.927,30) représenté par dix millions deux cent quatre-vingt-douze mille sept cent trente (10.292.730) actions divisées
en:
(i) un million deux cent cinquante-trois mille six cents vingt (1.253.620) actions de commanditaire de classe A (les
«Actions de Classe A»), elles-mêmes divisées en six cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (624.999)
actions de commanditaire de classe A-1, six cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (624.999) actions de
commanditaire de classe A-2 et trois mille six cent vingt-deux (3.622) actions de commanditaire de classe A-3,
(ii) un million deux cent cinquante-trois mille six cents vingt-deux (1.253.622) actions de commanditaire de classe B
(les «Actions de Classe B»), elles-mêmes divisées en six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de
classe B-1, six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de classe B-2 et trois mille six cent vingt-deux
(3.622) actions de commanditaire de classe B-3,
(iii) un million deux cent cinquante-trois mille six cents vingt-deux (1.253.622) actions de commanditaire de classe C
(les «Actions de Classe C»), elles-mêmes divisées en six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de
classe C-1, six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de classe C-2 et trois mille six cent vingt-deux
(3.622) actions de commanditaire de classe C-3,
(iv) un million deux cent cinquante-trois mille six cents vingt-deux (1.253.622) actions de commanditaire de classe D
(les «Actions de Classe D»), elles-mêmes divisées en six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de
classe D-1, six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de classe D-2 et trois mille six cent vingt-deux
(3.622) actions de commanditaire de classe D-3,
(v) un million deux cent cinquante-trois mille six cents vingt-deux (1.253.622) actions de commanditaire de classe E
(les «Actions de Classe E»), elles-mêmes divisées en six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de classe
E-1, six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de classe E-2 et trois mille six cent vingt-deux (3.622)
actions de commanditaire de classe E-3,
(vi) un million deux cent cinquante-trois mille six cents vingt-deux (1.253.622) actions de commanditaire de classe F
(les «Actions de Classe F»), elles-mêmes divisées en six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de classe
F-1, six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de classe F-2 et trois mille six cent vingt-deux (3.622)
actions de commanditaire de classe F-3,
(vii) un million deux cent cinquante-trois mille six cents vingt-deux (1.253.622) actions de commanditaire classe G (les
«Actions de Classe G»), elles-mêmes divisées en six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de classe
G-1, six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de classe G-2 et trois mille six cent vingt-deux (3.622)
actions de commanditaire de classe G-3,
(viii) un million deux cent cinquante-trois mille six cents vingt-deux (1.253.622) actions de commanditaire classe H
(les «Actions de Classe H»), elles-mêmes divisées en six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de
classe H-1, six cent vingt-cinq mille (625.000) actions de commanditaire de classe H-2 et trois mille six cent vingt-deux
(3.622) actions de commanditaire de classe H-3,
(ix) cent trente et un mille huit cent soixante-dix-sept (131.877) actions de commanditaire classe I (les «Actions de
Classe I»), elles-mêmes divisées en vingt-six mille trois cent soixante-dix-sept (26.377) actions de commanditaire de classe
I-1, cinquante-deux mille sept cent cinquante (52.750) actions de commanditaire de classe I-2 et cinquante-deux mille sept
cent cinquante (52.750) actions de commanditaire de classe I-3,
(x) cent trente et un mille huit cent soixante-dix-sept (131.877) actions de commanditaire classe J (les «Actions de Classe
J»), elles-mêmes divisées en vingt-six mille trois cent soixante-dix-sept (26.377) actions de commanditaire de classe J-1,
cinquante-deux mille sept cent cinquante (52.750) actions de commanditaire de classe J-2 et cinquante-deux mille sept cent
cinquante (52.750) actions de commanditaire de classe J-3,
(xi) deux (2) actions de commandité (les «Actions de Commandité»), d'une valeur nominale d'un centime de US dollar
(0,01 USD) chacune (les actions de commanditaire étant ensemble désignées comme les «Actions de Commanditaire», et
avec les Actions de Commandité, comme les «actions») et assorties des droits et obligations tels qu'énoncés dans les présents
statuts. Afin d'éviter toute ambiguïté, aucune série ou sous-division énumérée d'une classe d'Actions de Commanditaire ne
sera considérée comme une classe d'Actions de Commanditaire en soi pour quelque usage que ce soit.
Le capital social autorisé mais non émis de la société est fixé à un montant supplémentaire de sept cent US dollars et
seize cents (USD 700,16) représenté par soixante-dix mille seize (70.016) actions de commanditaire supplémentaires,
divisées en: trente-cinq mille huit (35.008) Action de Classe I (les «Actions de Classe I Non Allouées»), et trente-cinq mille
huit (35.008) Action de Classe J (les «Actions de Classe J Non Allouées» et, avec les Actions de Classe I Non Allouées,
les «Actions de Classe I/J Non Allouées»), chacune avec une valeur nominale d'un centime de US dollar (USD 0,01)
chacune pouvant être divisée en séries ou sous-groupes supplémentaires.
109361
L
U X E M B O U R G
L'autorisation des Actions de Classe I/J Non Allouées (et toute autorisation donnée au Gérant y relative) sera valable
jusqu'au jour du cinquième anniversaire de la date de la publication au Mémorial de l'acte de l'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires de la Société tenue le 22 novembre 2013.
Le Gérant, ou tout(s) délégué(s) dûment nommé par le Gérant, pourra de temps à autre émettre des Actions de Classe
I/J Non Allouées dans les limites du capital social autorisé mais non émis en contrepartie d'apports en numéraire, d'apports
en nature ou par voie d'incorporation de réserves disponibles, aux moments et selon les termes et les conditions, y compris
le prix d'émission, que le Gérant ou son/ses délégué(s) pourra(ont) décider de manière discrétionnaire et ce sans réserver
de droits préférentiels de souscription aux actionnaires existants. Les actionnaires autorisent le Gérant à renoncer à, sup-
primer ou limiter tout droit préférentiel de souscription des actionnaires prévu par la loi dans la mesure où il juge cette
renonciation, suppression ou limitation utile pour toute(s) émission(s) d'Actions de Classe I/J Non Allouées dans les limites
du capital social autorisé mais non émis.
Toute prime d'émission disponible sera librement distribuable et ne pourra être attachée à une classe ou catégorie d'ac-
tions en particulier.
Les Actions de Commandité seront détenues par Silver II GP S.à r.l. étant l'actionnaire commandité («Actionnaire
Commandité») et le Gérant de la Société.»
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver la réduction du capital social émis de la Société de cent deux mille neuf cent vingt-neuf
US dollars cinquante-quatre cents (USD 102.929,54) pour un montant de deux US dollars vingt-quatre cents (USD 2,24)
pour le porter à cent deux mille neuf cent vingt-sept US dollars trente cents (USD 102.927,30) par le rachat de vingt-huit
(28) actions de chaque classe d'action de A-3 à H-3, chacune ayant une valeur nominale de USD 0.01 de M. James MacLean,
étant un actionnaire de la Société, et d'approuver l'annulation subséquente de vingt-huit (28) actions ayant une valeur
nominale de USD 0,01 chacune pour un prix total de rachat de vingt-neuf mille cent vingt US dollars (USD 29.120) et
payement en espèces d'un tel prix de rachat à M. James MacLean.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société tel qu'indiqué sous le point B de l'ordre du jour.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société émis à sa charge en
raison de la réduction du capital sont estimés à mille cent euro (EUR 1.100,-).
Le notaire instrumentant, comprenant et parlant l'anglais, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la demande de mêmes parties comparantes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Fait à Luxembourg, à la date précisée ci-avant.
Après lecture du présent acte, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. ESTEVES, C. PERSONNE, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 juillet 2015. Relation: DAC/2015/11247. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 08 juillet 2015.
Référence de publication: 2015112580/241.
(150120745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
CETP II Imola Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 163.486.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 juillet 2015.
CETP II Imola Finance S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015112979/12.
(150121207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
109362
L
U X E M B O U R G
Swiss Life (LUX) German Core Real Estate Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxemburg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 198.257.
STATUTEN
In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Swiss Life Investment Management Holding AG, an Aktiengesellschaft incorporated and existing under the laws of
Switzerland, registered with the Handelsregister des Kantons Zürích under number CHE-112.304.772, having its registered
office at c/o Swiss Life AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, Switzerland,
here represented by Mrs. Simone Baier, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Zurich,
on 3 July 2015.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Swiss Life (LUX) German Core Real Estate Management S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by
the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles
of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in Swiss Life (LUX) German Core Real Estate SCS,
which shall be organised as a société en commandite simple (S.C.S.) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and which shall further to its establishment be re-qualified as a specialised investment fund (fonds d'investissement spé-
cialisée) to be governed by the Luxembourg law of 13 February 2007 on specialised investment funds, and to act as its
general partner and statutory manager with unlimited liability, in order to control and manage the investment program(s)
of Swiss Life (LUX) German Core Real Estate SCS, including through the holding of participations in, and the acting as
general partner and statutory manager with unlimited liability of (i) Swiss Life German CRE Office and Retail SCS, which
shall be organised as a société en commandite simple (S.C.S.) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and (ii)
Swiss Life German CRE Residential SCS, which shall be organised as a société en commandite simple (S.C.S.) under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, it being understood that the entities mentioned in items (i) and (ii) shall be
established as indirect subsidiaries of Swiss Life (LUX) German Core Real Estate SCS. The Company may further hold
participations in, and act as general partner with unlimited liability of, any Related Fund (as such term is defined from time
to time in the limited partnership agreement of Swiss Life (LUX) German Core Real Estate SCS) of Swiss Life (LUX)
German Core Real Estate SCS established under the laws of Luxembourg from time to time for the purpose of investing
alongside Swiss Life (LUX) German Core Real Estate SCS.
2.2 In connection thereto, the Company may also hold interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, acquire by purchase, subscription or in any other manner as well as transfer
by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and manage, control and develop its portfolio.
2.3 The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, in the
context and for the purpose of organising, supporting and/or furthering the activities of the entities listed under article 2.1.
above
2.4 The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes, in the context and for the purpose
organising, supporting and/or furthering the activities of the entities listed under article 2.1. above
2.5 The Company may in addition generally carry out any commercial or financial activities which it may deem useful
in the accomplishment of its purposes in connection with the investment activities of the entities listed under article 2.1.
above
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
109363
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
109364
L
U X E M B O U R G
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the "sole manager".
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
109365
L
U X E M B O U R G
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall have a casting vote.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers, or
(ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of October of each year and shall end
on the thirtieth of September of the next year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
109366
L
U X E M B O U R G
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 30 September 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Swiss Life Investment Management
Holding AG, aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>Resolutions of the incorporating shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company, has passed the following resolu-
tions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Stephan Thaler, born on 10 August 1962 in Basel, Schwitzerland, with professional address at 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(ii) Vincent Charuel, born on 28 January 1978 in Saint-Quentin, France, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; und
(iii) Uwe Druckenmüller, born on 21 June 1961 in Albstadt-Ebingen, Germany, with professional address at 4a, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausendundfünfzehn, am sechsten Juli.
Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
109367
L
U X E M B O U R G
Swiss Life Investment Management Holding AG, eine nach schweizerischem Recht gegründete und bestehende Akti-
engesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Nummer CHE-112.304.772, mit eingetrage-
nem Sitz in c/o Swiss Life AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, Schweiz,
hier vertreten durch Frau Simone Baier, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 3. Juli 2015,
ausgestellt in Zürich.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde,
wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche folgende Satzung haben soll:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
dem Namen Swiss Life (LUX) German Core Real Estate Management S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestim-
mungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von
1915") und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in Swiss Life (LUX) German Core Real Estate SCS, welche
als dem luxemburgischen Recht unterliegende Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) gegründet, und
nachfolgend in einen dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Februar 2007 betreffend spezialisierte Investmentfonds un-
terliegenden spezialisierten Investmentfonds umgewandelt werden soll. Die Gesellschaft soll insbesondere als Komple-
mentärin und Geschäftsführerin mit unbeschränkter Haftung die Investitionsprogramme der Swiss Life (LUX) German
Core Real Estate SCS kontrollieren und verwalten, unter anderem durch das Halten von Beteiligungen an, und die Handlung
als Komplementärin und Geschäftsführerin mit unbeschränkter Haftung von, (i) Swiss Life German CRE Office and Retail
SCS, welche als dem luxemburgischen Recht unterliegende Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) ge-
gründet werden soll, und (ii) Swiss Life German CRE Residential SCS, welche als dem luxemburgischen Recht
unterliegende Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) gegründet werden soll, vorausgesetzt und verstan-
den, dass die unter (i) und (ii) genannten Gesellschaften als indirekte Tochtergesellschaften der Swiss Life (LUX) German
Core Real Estate SCS gegründet werden. Die Gesellschaft kann weiterhin Beteiligungen an jedem von Zeit zu Zeit zum
Zweck der Durchführung von Parallelinvestitionen unter dem Recht Luxemburgs gegründeten Verbundenen Fonds der
Swiss Life (LUX) German Core Real Estate SCS (im Sinne der diesem Begriff im Gesellschaftsvertrag der Swiss Life
(LUX) German Core Real Estate SCS zugeschriebenen Bedeutung) halten und als Komplementärin und Geschäftsführerin
mit unbeschränkter Haftung eines solchen Verbundenen Fonds handeln.
2.2 In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft weiterhin Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und
ausländischen Gesellschaften, sowie jede andere Form von Investition halten, Wertpapiere jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise erwerben, sowie für deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die
Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen, agieren.
2.3 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält
oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite
gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit und zum Zweck
der Organisation, Unterstützung und Förderung der Aktivitäten der unter Artikel 2.1. genannten Gesellschaften.
2.4 Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit und zum Zweck der Organisation, Unterstützung und Förderung der
Aktivitäten der unter Artikel 2.1. genannten Gesellschaften in jeder Form Gelder aufbringen, inklusive mittels Ausgabe
aller Arten von Anleihen und Schuldscheinen.
2.5 Die Gesellschaft kann weiterhin alle Tätigkeiten kaufmännischer und finanzieller Natur vornehmen, die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke und im Zusammenhang mit den Investitionstätigkeiten der unter Artikel 2.1. genannten Gesell-
schaften förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
109368
L
U X E M B O U R G
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus
zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung der
überlebenden Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln der von Ihnen gehaltenen Rechte übertragen werden.
Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehe-
partner/in übertragen werden oder einem sonstigen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich ge-
fasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt
sein Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesell-
schafter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesell-
schafterversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten
werden, wie in der Einberufung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden
an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesell-
109369
L
U X E M B O U R G
schafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben,
kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer" nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche
Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Ein-
klang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen
finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum
zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dring-
lichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Geschäftsführer
schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben,
wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen
des Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäfts-
führungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
109370
L
U X E M B O U R G
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.
17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden, hat
im Falle von Stimmgleichheit die entscheidende Stimme.
17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls
vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokoll-
führer oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem
Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungs-
rates (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-
schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige
Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift
des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder durch (ii) die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige
Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden
ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend
das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen in seiner ge-
änderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschlussgewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober eines jeden Jahres und endet am
dreißigsten September des nächsten Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
109371
L
U X E M B O U R G
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz
von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer Rücklage
zugeführt werden müssen, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September
2016.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden von Swiss Life Investment Management Holding
AG, vorbenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.
Der Preis für die so gezeichneten Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) Euro wird vollständig dem Gesell-
schaftskapital zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.800.-geschätzt.
<i>Beschlüsse der Gründungsgesellschafterini>
Die Gründungsgesellschafterin, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert, hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
(i) Stephan Thaler, geboren am 10. August 1962 in Basel, Schweiz, geschäftsansässig in 4a, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
(ii) Vincent Charuel, geboren am 28. Januar 1978 in Saint-Quentin, Frankreich, geschäftsansässig in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
(iii) Uwe Druckenmüller, geboren am 21. Juni 1961 in Albstadt-Ebingen, Deutschland, 4a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
109372
L
U X E M B O U R G
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei,
dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit
Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: S. BAIER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 7 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/21064. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 8. Juli 2015.
Référence de publication: 2015112599/559.
(150121188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
PIT D Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.561.144,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.006.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of June,
Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
INVESCO PIT (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, with a share capital of five hundred sixty-six thousand five hundred fifty-four euro seventyeight cent (EUR
566,554.78), having its registered office at 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 121720 (the “Shareholder”),
hereby represented by Me Anne Mauske, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on 29 June 2015.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of PIT D
Lux S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital
of one million two hundred sixty-seven thousand five hundred euro (EUR 1,267,500), having its registered office at 37A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Register of Commerce
and Companies under number B 130006 (the “Company”), incorporated following a deed of Maître Gérard Lecuit, notary,
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 4 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1868 of 3 September 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 130006. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last
time on 31 March 2009 pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Associations number 882 of 24 April 2009.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To change the nominal value of the shares from twenty-five euro (EUR 25) to one euro (EUR 1).
2 To increase the Company's share capital by an amount of one million two hundred ninety-three thousand six hundred
forty-four euro (EUR 1,293,644) so as to raise it from its present amount of one million two hundred sixty-seven thousand
five hundred euro (EUR 1,267,500) to two million five hundred sixty-one thousand one hundred forty-four euro (EUR
2,561,144).
3 To issue one million two hundred ninety-three thousand six hundred forty-four (1,293,644) new shares with a nominal
value of one euro (EUR 1) each, having such rights and privileges as set out in the articles of association of the Company.
4 To accept subscription for these new shares and to accept payment in full for such new shares by a contribution in
cash.
5 To amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation, in order to reflect the above resolutions.
6 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
109373
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to change the nominal value of the shares from twenty-five euro (EUR 25) to one euro (EUR
1).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of one million two hundred ninety-
three thousand six hundred forty-four euro (EUR 1,293,644) so as to raise it from its present amount of one million two
hundred sixty-seven thousand five hundred euro (EUR 1,267,500) to two million five hundred sixty-one thousand one
hundred forty-four euro (EUR 2,561,144).
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to issue one million two hundred ninety-three thousand six hundred forty-four (1,293,644)
new shares with a nominal value of one euro (EUR 1), having such rights and privileges as set out in the articles of association
of the Company.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon has appeared the Shareholder, represented as mentioned above.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Shareholder for the number of shares
mentioned hereafter and to make payment in full for each such new shares thus subscribed by contribution in cash (the
“Contribution”), for the amount mentioned hereafter:
Subscriber
Number
of shares
Nominal
value
Amount paid in
Shareholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,293,644
EUR 1
EUR 1,293,644
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,293,644
EUR 1
EUR 1,293,644
The Contribution thus represents a contribution in aggregate amount of one million two hundred ninety-three thousand
six hundred forty-four euro (EUR 1,293,644).
Proof of such payment has been given to the undersigned notary and the amount of one million two hundred ninety-
three thousand six hundred forty-four euro (EUR 1,293,644) is now at the disposal of the Company.
Thereupon, the Shareholder resolves (i) to accept the said subscription and payment, (ii) to allot the one million two
hundred ninety-three thousand six hundred forty-four (1,293,644) new shares as stated above, and (iii) to acknowledge the
effectiveness of the capital increase.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 6 of the articles of
incorporation, which will from now on read as follows:
“ Art. 6. The Company's share capital is set at two million five hundred sixty-one thousand one hundred forty-four euro
(EUR 2,561,144) represented by two million five hundred sixty-one thousand one hundred forty-four (2,561,144) shares
with a par value of one euro (EUR 1) each."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase
are estimated at two thousand four hundred euro (EUR 2,400).
The undersigned notary knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of discrepancies
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known by the notary by his surname, first
name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with Us, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf juin,
Par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
INVESCO PIT (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie les lois du Luxembourg, dont le capital
social est fixé à cinq cent soixante-six mille cinq cent cinquante-quatre euros soixante-dix-huit centimes (EUR 566.554,78),
ayant son siège social au 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée
auprès Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121720 (l'«Associé»),
représentée aux fins des présentes par Maître Anne Mauske, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,
109374
L
U X E M B O U R G
aux termes d'une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 29 juin 2015.
Ladite procuration restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.
L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter qu'il est associé unique associé de PIT D Lux S.à r.l., une société à
responsabilité limitée régie par les du Luxembourg, dont le capital social est fixé à un million deux cent soixante-sept mille
cinq cents euros (EUR 1.267.500), ayant son siège social au 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130006 (la
«Société»), constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en date du 4 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1868 du 3 septembre 2007
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130006. Les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois le 31 mars 2009 en vertu d'un acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 882 du 24 avril 2009.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, ayant reconnu avoir été dûment et complètement informé des résolutions
à adopter sur la base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Modification de la valeur nominale des parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25) à un euro (EUR 1).
2 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un million deux cent quatre-vingt-treize mille six cent
quarante-quatre euros (EUR 1.293.644) pour le porter de son montant actuel d'un million deux-cent soixante-sept mille
cinq cents euros (EUR 1.267.500) à deux millions cinq cent soixante-et-un mille cent quarante-quatre euros (EUR
2.561.144).
3 Émission d'un million deux-cent soixante-sept mille cinq cents (1.267.500) nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune ayant les droits et privilèges tels que prévus dans les statuts de la Société.
4 Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles et acceptation de la libération intégrale de ces parts
sociales nouvelles par apport en numéraire.
5 Modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus.
6 Divers.
a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé unique a décidé de convertir la valeur nominale des parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25) à un euro
(EUR 1).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un million deux cent quatre-vingt-treize
mille six cent quarante-quatre euros (EUR 1.293.644) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent soixante-
sept mille cinq cents euros (EUR 1.267.500) à deux millions cinq cent soixante et un mille cent quarante-quatre euros (EUR
2.561.144).
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé a décidé d'émettre un million deux cent quatre-vingt-treize mille six cent quarante-quatre (1.293.644) nou-
velles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune ayant les droits et privilèges tels que prévus dans
les statuts de la Société.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu l'Associé, représenté comme ci-dessus mentionné.
Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de l'Associé pour le nombre de parts sociales mentionné ci-
après et libérer intégralement ces parts sociales nouvelles par un apport en espèces (l'«Apport»), pour le montant mentionné
ci-après:
Souscripteur
Nombres de
parts sociales
Valeur
nominale
Montant libéré
Associé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.293.644
EUR 1
EUR 1.293.644
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.293.644
EUR 1
EUR 1.293.644
L'Apport représente ainsi un apport d'un montant total d'un million deux cent quatre-vingt-treize mille six cent quarante-
quatre euros (EUR 1.293.644).
La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant et le montant d'un million deux cent quatre-vingt-
treize mille six cent quarante-quatre euros (EUR 1.293.644) est désormais à la disposition de la Société.
L'Associé a alors décidé (i) d'accepter ladite souscription et le paiement, (ii) d'attribuer les un million deux cent quatre-
vingt-treize mille six cent quarante-quatre (1.293.644) nouvelles parts sociales comme indiqué ci-avant, et (iii) constater
la réalisation de l'augmentation de capital.
109375
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé a décidé de modifier premier paragraphe de l'article 6 des
statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social est fixé à deux millions cinq cent soixante et un mille cent quarante-quatre euros (EUR 2.561.144),
représenté par deux millions cinq cent soixante et un mille cent quarante-quatre (2.561.144) parts sociales, d'une valeur
d'un euro (EUR 1) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société en raison de cette augmentation
de capital sont estimés à deux mille quatre cents euros (EUR 2.400).
Le notaire soussigné qui connaît l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: A. Mauske, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 3 juillet 2015. GAC/2015/5630. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 8 juillet 2015.
Référence de publication: 2015112532/169.
(150120867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg IIA, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 198.278.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth, day of June at 2.30 p.m. in the Grand-Duchy of Luxembourg
time (CET);
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared,
Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg II, a société à responsabilité limitée (Private limited liability company) duly
formed and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 200,000
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 172.888,
here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by
virtue of a power of attorney.
The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed for the purpose of registration.
Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association (the “Articles”) of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated.
Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by
Luxembourg law as well as by the present Articles (the “Company”).
Art. 2. Name. The Company’s name is “Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg IIA”.
Art. 3. Purpose. The Company’s purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form what-
soever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents, trademarks and licenses or other property
or rights as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in
whole or in part, for such consideration as the Company may think fit. The Company may also enter into any financial,
commercial or other transactions and grant to any company or entity that forms part of the same group of companies as the
Company or is affiliated in any way with the Company, including companies or entities in which the Company has a direct
109376
L
U X E M B O U R G
or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan, advance or grant in favor of third parties any security or
guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow and raise money in any manner and secure by any means
the repayment of any money borrowed.
Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose
in order to facilitate the accomplishment of such purpose.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Schuttrange, Grand-Duchy
of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality by means of a resolution of the sole
manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or
to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of
plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital.
The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.
Title II - Capital - Shares
Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand US Dollars) divided into 2,000 (two
thousand) Shares with a nominal value of USD 10 (ten US Dollars) each, fully paid-up,
herein collectively as the “Shares” and individually as the “Share”.
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of
plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital.
Art. 7. Voting Rights. Each Share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-
mensurate to such shareholder’s ownership of Shares.
Art. 8. Indivisibility of Shares. Towards the Company, the Shares are indivisible and the Company will recognize only
one owner per Share.
Art. 9. Transfer of Shares. The Shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company
has a sole shareholder.
Transfers of Shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.
Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning com-
mercial companies, as amended from time to time (the “Law”).
Art. 10. Redemption of Shares. The Company may redeem its own Shares provided that the Company has sufficient
distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company’s share capital.
Title III - Management
Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where
more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different
types of managers, namely type A managers and type B managers.
No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole
shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent
(50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.
A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in
case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share
capital of the Company, as the case may be.
Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole share-
holder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole
manager or the board of managers, as the case may be.
The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint
signature of at least one type A manager and one type B manager.
The sole or any manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to
one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well
as any other relevant condition.
109377
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its
members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who
shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.
The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the
time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when
waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.
Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another
manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication
means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear each
other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.
A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in
person or represented by proxyholder at least one type A manager and at least one type B manager.
Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers
of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented by proxyholder including
the affirmative vote of at least one type A manager and at least one type B manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting
of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken
together, shall constitute the same instrument.
Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies
or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.
Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly
made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the
Company.
Title IV - Shareholder meetings
Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in
accordance with the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole share-
holder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.
Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of
managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24
hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed on
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as
such shareholder’s proxy, which person needs not be shareholder of the Company.
Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-
holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a
first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.
Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share
capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the
shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.
The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-
five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast
as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote and in writing
by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.
When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-
Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice,
on the third Thursday of February or on the following business day if such day is a public holiday.
Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit
Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on September 1
st
each year and ends on August 31
th
of the following year.
109378
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as
the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder,
or in case of plurality of shareholders, (i) to the general shareholders meeting, when the holding of such shareholders
meetings is compulsory pursuant to article 16 above, or (ii) in writing to all the shareholders when the holding of such
shareholders meetings is not compulsory.
Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.
Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This
allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.
The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of
the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it
proportionally to the Shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.
Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case
may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the
end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.
Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be
entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory
auditors.
No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.
Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of
the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders
following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.
Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register as
well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The
general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.
Title VI - Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality
of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.
Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the
sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the
shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital, which shall determine his/their powers and remuneration.
After payment of all the debts of the Company, including the expenses of liquidation and the repayment of the share
capital to each of the shareholders, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) proportionally to
the Shares they hold.
<i>Temporary provisioni>
Notwithstanding the provisions of article 17 above, the first financial year of the Company starts today and will end on
August 31
st
, 2015.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 2,000 (two thousand) Shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed
by Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg II, named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 20,000
(twenty thousand US Dollars) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary
by producing a blocked funds certificate.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,300.-
109379
L
U X E M B O U R G
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg II, acting as sole share-
holder representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:
1) Mr. Monsieur Christian JOLIVET, born on June 24,1962 in Montréal, Canada and residing professionally at 5, Place
Ville-Marie, Suite 1700, Montréal, QC H3B OB3, Canada is appointed as type A manager of the Company for an unde-
termined duration;
- Mr. Olivier DORIER, born on September 25
th
,1968 in Saint-Remy, France, residing professionally at 6C, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Stewart KAM-CHEONG, born on July 22
nd
,1962 in Port Louis, Mauritius, residing professionally at 6C, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand- Duchy of Luxembourg are appointed as type B managers of the Company
for an undetermined duration.
2) The registered office of the Company shall be established at 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Junglinster, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the present
original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour de juin à 14.00 heures au Grand-Duché de Luxembourg (CET);
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu,
Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg II, une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant valable-
ment selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 200.000 USD, ayant son siège social au 6C,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.888,
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte aux fins d’enregistrement.
Ladite partie comparante, agissant en qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d’une
société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
Titre I
er
- Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois
ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est «Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg IIA».
Art. 3. Objet. L’objet de la Société est d’investir, d’acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir par des partici-
pations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets, marques et
licences ou tout autre titre de propriété ou droits que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer,
développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.
La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, d’accorder à toute
société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d’une façon quelconque avec la Société,
incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre forme d’intérêt,
tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir les obligations
des sociétés précitées, ainsi que d’emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir par tous
moyens le remboursement de toute somme empruntée.
Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son
objet afin d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
109380
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il
peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Munsbach par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de
gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg
par résolution de l’associé unique, ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution de la majorité des associés repré-
sentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Titre II - Capital - Parts sociales
Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille Dollars américains), divisé en 2.000 (deux mille)
Parts Sociales d’une valeur nominale de 10 USD (dix Dollars américains) chacune et sont chacune entièrement libérées,
ici collectivement les «Parts Sociales» et individuellement la «Part Sociale».
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par
résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.
Art. 7. Droits de vote. Chaque Part Sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote
proportionnels au nombre de Parts Sociales qu'il détient.
Art. 8. Indivisibilité des Parts Sociales. Les Parts Sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu'un
seul propriétaire par Part Sociale.
Art. 9. Transfert des Parts Sociales. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés de la Société ou lorsque
la Société a un associé unique.
Les cessions de Parts Sociales aux tiers sont soumises à l’agrément préalable des associés représentant au moins soixante-
quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.
Les cessions de Parts Sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle que modifiée (la «Loi»).
Art. 10. Rachat des Parts Sociales. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales pour autant que la Société ait des
réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.
Titre III - Gérance
Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où
plus d’un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories
différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.
Aucun gérant n’a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l’associé unique ou, en cas
de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de
la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.
Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l’associé
unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.
Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’associé unique,
ou en cas de pluralité d’associés, à l’assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil
de gérance, le cas échéant.
La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe
d’au moins un gérant de type A et un gérant de type B.
Le gérant unique ou chaque gérant ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des
tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant
unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat
ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.
Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses
membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation d’un gérant. La convocation détaillant les points à l’ordre du jour, l’heure
et le lieu de la réunion, est donnée à l’ensemble des gérants au moins 24 heures à l’avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par
chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de
communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication approprié, s’ils sont initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à
109381
L
U X E M B O U R G
l’ensemble des gérants participant à la réunion de s’entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation
est réputée équivalente à une participation physique.
Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type A et
au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.
Lors d’une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par
un vote de la majorité des gérants présents ou représentés incluant le vote favorable d’au moins un gérant de type A et d’au
moins un gérant de type B.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d’une
réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d’eux constituant
un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.
Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.
Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n’engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-
lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.
Titre IV - Assemblée générale des associés
Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés con-
formément à la Loi.
Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé unique et la
Société doit faire l’objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.
Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d’associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,
le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s’il existe. A défaut, elles
sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.
Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins
24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l’ordre
du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un
tiers qui n’a pas à être associé de la Société.
Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus
de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée,
les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des
associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
La tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-
cinq (25). En l’absence d’assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout
moyen de communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à
son vote écrit.
Lorsque la tenue d’une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au
Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou tout autre lieu indiqué dans la convocation, le troisième jeudi
de février ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.
Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit
Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
septembre de chaque année et se termine le
31 août de l’année suivante.
Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas
échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l’ensemble
de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés (i) à
l’assemblé générale des associés, lorsque la tenue d’une telle assemblée est obligatoire en vertu de l’article 16 ci-dessus,
ou (ii) par écrit à tous des associés lorsque la tenue d’une telle assemblée n’est pas obligatoire.
Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges
et provisions, tel qu'approuvé par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés,
représente le bénéfice net de la Société.
109382
L
U X E M B O U R G
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d’être
obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à
entière reconstitution.
Le bénéfice restant est alloué par l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par résolution des associés repré-
sentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de le distribuer proportionnellement aux
Parts Sociales qu'ils détiennent, de le reporter ou de le transférer dans une réserve distribuable.
Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,
peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l’exercice social sur base d’un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.
Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un
commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.
Aucun commissaire n’a à être associé de la Société.
Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du
capital social de la Société jusqu'à l’assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination.
Cependant leur mandat peut être renouvelé par l’assemblée générale des associés.
Lorsque les conditions de l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes
à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés. L’assemblée
générale des associés peut cependant nommé un réviseur d’entreprise à tout moment.
Titre VI - Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par
l’assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n’est pas dissoute par la mort, la sus-
pension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un associé.
Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’associé
unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des
associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui déterminera
leurs pouvoirs et rémunérations. Après paiement de toutes dettes, y compris les dépenses relatives à la liquidation et le
remboursement du capital social aux associés, le boni de liquidation sera distribué aux associés proportionnellement aux
Parts Sociales qu'ils détiennent.
<i>Disposition temporairei>
Nonobstant les dispositions de l’article 17 mentionné au-dessus, le premier exercice de la société débute ce jour et
s’achèvera le 31 août 2015.
<i>Souscription - Paiementi>
L’intégralité des 2.000 (deux mille) Parts Sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société a été entiè-
rement souscrite par Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg II, prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire.
Le montant de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant par la production d’un certificat de blocage de fonds.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 1.300,- EUR.
<i>Résolutions de l’associéi>
Immédiatement après la constitution de la Société, Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg II, agissant en sa qualité
d’associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1) M. Christian JOLIVET, né le 24 juin 1962 à Montréal, Canada et résidant professionnellement au 5, Place Ville-
Marie, Suite 1700, Montréal, QC H3B OB3, Canada
est nommé gérant de type A de la Société pour une période indéterminé.
- M. Olivier DORIER, né le 25 septembre 1968 à Saint-Remy, France, résidant professionnellement au 6C, rue Gabriel
Lippmann L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg; et
- M. Stewart KAM-CHEONG, né le 22 juillet 1962 à Port-Louis, Ile Maurice, résidant professionnellement au 6C, rue
Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg
109383
L
U X E M B O U R G
sont nommés gérants de type B de la Société pour une période indéterminée.
2) Le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 juin 2015. Relation GAC/2015/5473. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la société.
Junglinster, le 08 juillet 2015.
Référence de publication: 2015112775/428.
(150121962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Zantek Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 168.400.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015113778/9.
(150121562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Skipper Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 215.821,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 138.229.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2015.
Référence de publication: 2015113656/10.
(150121750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Irocy Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 5.050.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.324.
En date du 8 Juin 2015, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Démision de Martin Paul Galliver, du poste de gérant de classe B avec effet au 22 mai 2015;
- Nomination de Angeliki Alafi, née le 1
er
septembre 1979 à Athènes, Grèce et ayant pour adresse professionnelle le
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au poste de gérant de classe B avec effet au 23 mai 2015 et pour une
durée déterminée de 6 ans et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au
31 décembre 2020, qui se tiendra en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Irocy Finance S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015112266/18.
(150120335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
109384
L
U X E M B O U R G
Pathway Finance, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.709.
Il est porté à la connaissance de tous que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015113508/11.
(150121805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Synapse Logistique Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 512.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 156.503.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg.
Le siège social de CDS International Limited, gérant de la Société a été transféré à l'adresse suivante: Hambro House,
St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 3ED. La société est enregistrée à présent au Guernsey Registered Company
sous le numéro 58044.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2015.
Synapse Logistique Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015113624/17.
(150120943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung, Fondation.
Siège social: L-7540 Berschbach, 47, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg G 149.
<i>Comptes annuels 31 décembre 2014i>
<i>Table des matièresi>
Page
- Rapport du Réviseur d'entreprises agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
- Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
- Compte de profits et pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
- Annexe aux comptes annuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
<i>Rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014 de la Fondation Lëtze-i>
<i>buerger Blannevereenegungi>
Nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de la Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung, comprenant
le bilan au 31 décembre 2014 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, et un résumé des
principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.
Responsabilité du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un contrôle interne qu'il juge nécessaire pour permettre l'établissement de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Responsabilité du réviseur d'entreprises agréé
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué
notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier
109385
L
U X E M B O U R G
et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entreprises
agréé, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation, le réviseur d'entreprises agréé prend en
compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et à la présentation sincère des comptes annuels
afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur le
fonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Admi-
nistration, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de la Fondation
Lëtzebuerger Blannevereenegung au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, confor-
mément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en
vigueur au Luxembourg.
Le 17 avril 2015.
Luxembourgeoise d'Audit et de Révision S.à r.l.
<i>Réviseur d'entreprises agréé
i>Marc Meyers
<i>Partneri>
<i>Bilan au 31/12i>
ACTIF
2014
2013
EUR
EUR
C. Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)
I. Immobilisations incorporelles
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et val. similaires:
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 028,50
0,00
11 028,50
0,00
II. Immobilisations corporelles
1. Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 484 241,70 17 552 134,91
3. Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
891 115,63
811 832,75
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours . . . . . . . . . . . . . . .
3 487 055,75 1 039 320,50
20 862 413,08 19 403 288,16
III. Immobilisations financières
1. Parts dans des entreprises liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 000,00
25 000,00
5. Titres et autres instruments financiers ayant
le caractère d'immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 369 372,40 6 894 372,40
14 394 372,40 6 894 372,40
D. Actif circulant
II. Créances
1. Créances résultant de ventes et prestations de services
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205 926,83
209 706,42
2. Créances sur des entreprises liées
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 861,34
62 043,74
4. Autres créances
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 133 654,40
795 423,91
1 401 442,57 1 067 174,07
III. Valeurs mobilières et autres instruments financiers
3. Autres valeurs mobilières et autres instruments financiers . . . . . . . . . . . . . . .
108 263,56
0,00
108 263,56
0,00
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux,
chèques et en caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 955 645,44 10 925 240,25
109386
L
U X E M B O U R G
2 955 645,44 10 925 240,25
E. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
36 549,13
89 937,73
39 769 714,68 38 380 012,61
PASSIF
2014
2013
EUR
EUR
A. Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 455 193,02 21 455 193,02
4. Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 597,88
1 544,01
V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 134 237,87 4 984 369,90
VI. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
933 085,90 2 149 867,97
VIII Subventions d'investissement en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 740 746,10 7 815 530,13
37 264 860,77 36 406 505,03
C. Provisions
3. Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
D. Dettes non subordonnées
4. Dettes sur achats et prestations de services
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . .
384 435,70
246 204,60
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
a) Dettes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
395 942,50
349 521,93
b) Dettes au titre de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
865 691,72
510 818,30
9. Autres dettes
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . .
854 448,58
831 612,75
2 500 518,50 1 938 157,58
E. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6)
4 335,41
350,00
39 769 714,68 38 380 012,61
<i>Compte de profits et pertes au 31/12i>
CHARGES
2014
2013
EUR
EUR
1. Consommation de marchandises et
de matières premières et consommables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 419 289,83 1 477 024,43
2. Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7) 1 005 942,21
953 884,65
3. Frais de personnel
a) Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(8) 13 049 629,12 12 007 493,94
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 970 440,97 1 825 242,06
4. Corrections de valeur
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et
incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 580 092,71 1 567 540,26
b) sur éléments de l'actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
858,60
5. Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215 186,37
208 175,85
10. Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 691,56
11 782,75
13. Profit de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
933 085,90 2 149 867,97
20 184 358,67 20 201 870,51
PRODUITS
2014
2013
EUR
EUR
1. Montant net du chiffre d'affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 409 974,40 17 506 021,02
4. Reprises de corrections de valeur
b) sur éléments de l'actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 621,30
0,00
5. Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(9) 2 624 197,58 2 406 420,07
8. Autres intérêts et autres produits financiers
b) autres intérêts et produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132 023,69
163 716,27
10. Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 541,70
125 713,15
20 184 358,67 20 201 870,51
109387
L
U X E M B O U R G
Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2014
1. Généralités. La Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung (ci-après la «Fondation») résulte du changement de la
dénomination de la Fondation de l'Association des Aveugles et des statuts suivant acte notarié du 5 novembre 2007.
La Fondation a pour principal objet l'amélioration du sort des déficients visuels et la défense de leurs intérêts.
En vue de réaliser son objet, la Fondation peut exercer à l'égard des déficients visuels le rôle de conseiller; elle peut
prodiguer aide et assistance morales et matérielles, à l'exclusion de tout soutien financier. Elle veille à leur orientation
professionnelle, à leur éducation, ainsi qu'à leur insertion dans la vie active.
La Fondation peut créer, reprendre et gérer toutes oeuvres et structures, prendre toutes initiatives et participations,
acquérir tous les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de son objet.
La Fondation peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, faire tous actes et transactions en
relation et dans les limites de son objet et de ses missions, telles que définies par les présents statuts.
La Fondation peut accepter des libéralités entre vifs ou testamentaires dans les conditions prévues par l'article 36 de la
loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Elle peut accepter des subsides privés
et publics.
L'adresse de la Fondation a changé en raison du redressement de certaines sections cadastrales de la commune de Mersch.
Le siège social de la Fondation est établi au 47, rue de Luxembourg, L-7540 Rollingen/Mersch. L'exercice social com-
mence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
La durée de la Fondation est illimitée.
La présentation des comptes annuels comparés des exercices 2014 et 2013 est celle de la Fondation Lëtzebuerger
Blannevereenegung.
Ces comptes comprennent:
- le bilan qui résume la situation patrimoniale de l'ensemble des éléments gérés par la Fondation;
- le compte de profits et pertes respectivement le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'année
selon leur destination;
- l'annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de profits et pertes.
2. Principes, règles et méthodes d'évaluation.
2.1. Principes généraux
Suite à l'introduction du plan comptable uniformisé du secteur social, certains reclassements ont été effectués sur les
comptes annuels au 31 décembre 2013 afin de permettre une comparabilité des exercices.
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux
principes comptables généralement admis au Grand-Duché de Luxembourg.
Les comptes annuels de la Fondation ont été préparés conformément aux principes comptables et règles d'évaluation
décrites ci-après.
2.2. Principales règles d'évaluation
2.2.1. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées au prix d'acquisition historique qui comprend les frais accessoires ou au
prix de revient, pouvant comporter une partie des coûts indirects, déduction faîte des corrections de valeur. A l'exception
des terrains et des autres immobilisations corporelles, les corrections de valeur sont calculées de façon linéaire en fonction
de la durée d'utilisation estimée. Les taux linéaires appliqués sont compris entre 3% et 25%
Lorsque la Fondation considère qu'un actif immobilisé a subi une diminution de valeur de nature durable, une réduction
de valeur complémentaire est effectuée de manière à refléter cette perte. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues
lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.
2.2.2. Immobilisation financières
Les immobilisations financières sont principalement composées de valeurs mobilières à revenu fixe qui ont été acquises
avec l'intention de les garder jusqu'à leur échéance.
Les valeurs mobilières à revenu fixe ayant le caractère d'immobilisations financières sont enregistrées à leur prix d'ac-
quisition dans leur devise d'origine. Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat. Elles
font l'objet de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qui leur est attribuée à la date de clôture du
bilan, si le Conseil d'Administration estime que la dépréciation sera durable.
2.2.3. Créances
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de corrections de valeur lorsque leur recouvrement
est compromis. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé
d'exister.
2.2.4. Valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont évaluées au plus bas de leur prix d'acquisition, incluant les frais accessoires et déterminé
selon leur valeur de marché. Les valeurs mobilières sont enregistrées dans la devise de préparation des comptes annuels.
109388
L
U X E M B O U R G
Une correction de valeur est enregistrée lorsque le prix du marché est inférieur au prix d'acquisition. Ces corrections de
valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d'exister.
La valeur de marché correspond:
- au dernier cours disponible le jour de l'évaluation pour les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse
de valeurs ou sur un autre marché réglementé.
2.2.5. Avoirs en banques, avoir en compte de chèque postaux, chèque et encaisse
Les avoirs en banques sont inscrits à leur valeur nominale à la date de clôture des comptes annuels.
2.2.6. Comptes de régularisation actif
Ce poste comprend les charges enregistrées avant la date de clôture et imputables à un exercice ultérieur. Les charges
sont indiquées à leur valeur nominale. Cette rubrique comprend également les intérêts courus non échus.
2.2.7. Capitaux propres
Sous les capitaux propres on retrouve les rubriques suivantes:
- fonds associatifs;
- fonds dédiés sur subventions;
- résultats reportés;
- le résultat de l'exercice;
- subventions d'investissement et d'équipement.
Les fonds dédiés sont constitués des ressources affectées par les donateurs ou testateurs à des programmes d'intervention
de la Fondation, qui n'ont pas encore été utilisées conformément à l'engagement pris à leur égard.
2.2.8. Dettes
Les dettes sont indiquées à leur valeur de remboursement.
2.2.9. Comptes de régularisation passif
Ce poste comprend les produits perçus durant l'exercice et qui sont imputables à un exercice ultérieur.
2.2.10 Conversion des postes en devises
La Fondation tient ses livres comptables en euros («EUR») et les comptes annuels sont établis dans la même devise.
Les immobilisations corporelles et incorporelles exprimées dans une devise autre que l'euro sont converties en euros au
cours de change historique en vigueur au moment de la transaction. À la date de clôture, ces immobilisations restent
converties au cours de change historique.
Les avoirs en banques sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de clôture des comptes annuels. Les pertes
et les profits de change en résultant sont enregistrés au compte de profits et pertes de l'exercice.
Les autres postes de l'actif et du passif sont évalués individuellement au plus bas, respectivement au plus haut, de leur
valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base des cours de change en vigueur à la date de
clôture des comptes. Seules les pertes de change latentes sont enregistrées au compte de profits et pertes. Les gains de
change sont enregistrés au compte de profits et pertes au moment de leur réalisation. Les gains de change latents ne sont
donc pas enregistrés au compte de profits et pertes.
3. Actif immobilisé. En 2012 la Fondation a repris les parts de la Résidence pour personne âgées Hertha Winandy S.à
r.l. à leur valeur d'émission, soit 125 parts à EUR 100 correspondant au capital de EUR 12.500.
Le 12.11.2008 la Fondation a constitué la société Bieschbecher Atelier S.à r.l. au capital de EUR 12.500 entièrement
souscrit et libéré par la Fondation. L'objet de cette société est la reprise de l'activité du Bieschbecher Atelier à partir de
l'exercice 2009 en lieu et place de la Fondation.
Pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2014, l'évolution des actifs immobilisés s'analyse comme suit (exprimés en
EUR):
<i>Evolution des Immobilisations incorporellesi>
Licences
informatiques
Valeurs brutes au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Entrées au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 604,00
Sorties au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Valeurs brutes à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 604,00
Corrections de valeur au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Dotations de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 575,50
Reprises de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Corrections de valeur à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 575,50
Valeurs nettes à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
11 028,50
109389
L
U X E M B O U R G
<i>Evolution des immobilisations corporellesi>
Terrains
Agencements
et
aménagements
de terrains
Constructions
Autres
installations,
outillage et
mobilier et
matériel
roulant
Acomptes
versés et
immobilisations
corp. en cours
TOTAL
Valeurs brutes au
début de
l'exercice . . . . . . . . . 718 760,20
931 295,35 32 130 347,17 2 882 616,57
1 039 320,50 37 702 339,79
Entrées au cours de
l'exercice . . . . . . . . .
0,00
15 522,11
260 377,70
324 698,63
2 447 735,25 3 048 333,69
Sorties au cours de
l'exercice . . . . . . . . .
0,00
0,00
29 841,37
0,00
0,00
29 841,37
Valeurs brutes à
la fin de
l'exercice . . . . . . . . . 718 760,20
946 817,46 32 360 883,50 3 207 315,20
3 487 055,75 40 720 832,11
Corrections de valeur
au début de
l'exercice . . . . . . . . .
0,00
684 750,82 15 543 516,99 2 070 783,82
0,00 18 299 051,63
Dotations de
l'exercice . . . . . . . . .
0,00
62 504,22 1.270.597,24
245 415,75
0,00 1.578.517,21
Reprises de
l'exercice . . . . . . . . .
0,00
0,00
19.149,81
0,00
0,00
Corrections de valeur
à la fin de
l'exercice . . . . . . . . .
0,00
747 255,04 16 794 964,42 2 316 199,57
0,00 19 858 419,03
Valeurs nettes à
la fin de
l'exercice . . . . . EUR 718 760,20
199 562,42 15 565 919,08
891 115,63
3 487 055,75 20 862 413,08
<i>Evolution des immobilisations financièresi>
Parts dans des
entreprises
liées
Titres ayant le
caractère
d'immobilisations
TOTAL
Valeurs brutes au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . .
25 000,00
6 869 372,40 6 894 372,40
Entrées au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
7 500 000,00 7 500 000,00
Sorties au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
Valeurs brutes à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 000,00
14 369 372,40 14 394 372,40
Corrections de valeur au début de l'exercice . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
Dotations de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
Reprises de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
Corrections de valeur à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
0,00
Valeurs nettes à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
25 000,00
14 369 372,40 14 394 372,40
Au 31 décembre 2014, les titres ayant le caractère d'immobilisations ont une valeur de marché de EUR 14.410.037,50
4. Compte de régularisation actif. Au 31 décembre 2014 et 2013, le compte de régularisation actif de la Fondation se
décompose de la manière suivante (exprimé en EUR):
2014
2013
Intérêts courus sur valeurs mobilières de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 51.681,13
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.954,04 25.555,91
Formations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.980,00
5.000,00
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.615,09
7.700,69
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.549,13 89.937,73
109390
L
U X E M B O U R G
5. Capitaux propres. Les capitaux propres ont dès l'origine de l'Association des Aveugles et Malvoyants en 1955 été
alimentés par les apports et les résultats des exercices, déduction faite de montants affectés à divers comptes de réserves.
Ils se chiffrent à EUR 37.264.860,77 au 31.12.2014 pour EUR 36.406.505,03 l'année précédente.
5.1. Fonds associatifs
Au 31 décembre 2014 les fonds propres de la Fondation s'élèvent à EUR 21.455.193,02.
5.2. Fonds dédiés
Au 31 décembre 2014 les fonds dédiés sont constitués de EUR 1.597,88 alloués à des projets.
5.3. Subventions d'investissement en capital
Pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2014, l'évolution des subventions d'investissement s'analyse comme suit
(exprimées en EUR):
2014
2013
Valeurs brutes au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.877.829,17 15.877.829,17
Entrées au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
577.728,10
0,00
Sorties au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
Valeurs brutes à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.455.557,27 15.877.829,17
Amortissements au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.062.299,04
6.732.583,38
Dotations de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
652.512,13
664.857,83
Reprises de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
Amortissements à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.714.811,17
8.062.299,04
Valeurs nettes à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
7.740.746,10
7.815.530,13
6. Compte de régularisation passif. Au 31 décembre 2014 et 2013, le compte de régularisation passif de la Fondation se
décompose de la manière suivante (exprimé en EUR):
2014
2013
Loyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
860,00
350,00
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.475,41
0,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.335,41 350,00
7. Autres charges externes. Au 31 décembre 2014 et 2013, les autres charges externes se détaillent comme suit (exprimées
en EUR):
2014
2013
Loyers et charges locatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132.915,28 149.520,49
Sous-traitance, entretiens et réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
519.216,81 485.573,13
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.445,48
55.905,90
Primes d'assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.939,56
35.238,10
Frais de marketing et de communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.944,89
81.930,44
Personnel extérieur à l'entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.910,00
17.981,83
Charges externes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.570,19 127.734,76
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.005.942,21 953.884,65
8. Frais de personnel. L'effectif moyen était de 248 en 2014 et de 240 en 2013.
9. Autres produits d'exploitation. Au 31 décembre 2014 et 2013, les autres produits d'exploitation se détaillent comme
suit (exprimés en EUR):
2014
2013
Subventions d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 926 028,20 1.681.187,81
Indemnités d'assurance touchées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.657,25
0,00
Subvention d'investissement en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
652.512,13
664.857,83
Reprises sur provisions d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.000,00
60.374,43
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.624.197,58 2.406.420,07
<i>Récapitulatif budget ordinaire 2015i>
HOME DEPENSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -16 685 726 €
HOME RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 367 920 €
RESULTAT HOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
682 194€
FONDATION DEPENSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-676 432 €
FONDATION RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
995 000 €
RESULTAT FONDATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318 568 €
109391
L
U X E M B O U R G
BBF DEPENSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-525 441 €
BBF RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370 000 €
RESULTAT BBF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-155 441 €
BAt DEPENSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-41 500 €
BAt RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
RESULTAT BAt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-41 500 €
SANS MAISON RELAIS
TOTAL RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 732 920 €
TOTAL DEPENSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -17 929 099 €
RESULTAT GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
803 821 €
MAISON RELAIS
MAISON RELAIS DEPENSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1 764 591 €
MAISON RELAIS RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 755 091 €
RESULTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-9 500 €
TOTAL AVEC MAISON RELAIS
TOTAL RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 488 011 €
TOTAL DEPENSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -19 693 690 €
RESULTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
794 321 €
Référence de publication: 2015112179/368.
(150121547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.
Miremar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 30, rue J.-P. Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 60.591.
Les comptes annuels au 31.12.2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015113422/9.
(150121512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Premier Cru Multi Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 75.337.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 2015i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2020:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de
Gaulle, L- 1653 Luxembourg , Président;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue
Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg;
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle,
L- 1653 Luxembourg;
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2020:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2015.
Référence de publication: 2015113519/21.
(150121092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
109392
1640 Investment 3 S.à r.l.
Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg IIA
AIV SA
Baracoa S.à r.l.
BDP International S.à r.l.
Becky S.A.
Belcada (Luxembourg) Spf S. à r.l.
BP C Lux 1 S.à r.l.
Bulb S.à r.l.
Centrum Poznan S.A.
Centrum Warta S.A.
CEP III Chase S.à r.l.
CETP II Imola Finance S.à r.l.
EF Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Elzara S.à r.l.
eOffice Invest S.A.
Filauro Giuseppe Sàrl
Fondation Crèche de Luxembourg
Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung
GT Multi Alternative
"Icasa S.à r.l."
Irocy Finance S.à r.l.
Jezara Holding S.A.
Kensington Italy Retail Holdco S.à r.l.
Miremar S.A.
Opalys S.A.
OXEA FINANCE & Cy S.C.A.
Oxea S.à r.l.
Pamiga Finance S.A.
Pathway Finance
PIT D Lux S.à r.l.
P.L.T. s.à r.l.
Premier Cru Multi Investments
ProLogis European Holdings XVII S.à r.l.
ProLogis UK CC S.à r.l.
Reynolds Group Issuer (Luxembourg) S.A.
Servimat S.A.
Servimat S.A.
Silver Corporate Capital
Silver II GP Holdings S.C.A.
Skipper Holdings S.à r.l.
Société de Financement des Risques Industriels
Sophielux 2
Swiss Life (LUX) German Core Real Estate Management S.à.r.l.
Synapse Logistique Luxembourg
Tampico S.à r.l.
Tasty Strategies S.A.
Triumvirate III S.à r.l.
Zantek Capital S.A.