logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2247

26 août 2015

SOMMAIRE

ABLV Bank Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .

107812

Achem S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107810

Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg II  . .

107823

Agilis Engineering S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107811

Agilis Engineering S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107813

Aljo Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107812

Allandis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107814

Almond S.àr.l..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107818

Alpha P.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107813

Anglo Coal International  . . . . . . . . . . . . . . . . .

107813

Anglo Loma Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . .

107811

Anglo Loma Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . .

107811

Anglo Operations (International) Limited  . . .

107811

Anglo Operations (International) Limited  . . .

107811

Aqua Sanus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107814

Arendt Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107813

Argenta Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107814

Artal International Management S.A. . . . . . . .

107814

Assessor Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107812

Auda Capital Feeder SCA SICAV-SIF  . . . . . .

107812

Auda Capital SCS SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . .

107812

EGC 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107845

EOS Investment Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107856

Eurofresh Luxembourg I S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

107831

FOSCA II Manager S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

107810

Iginio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107815

Ikano S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107856

JBBK Verwaltungs S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

107816

Keiryo Packaging S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107816

Kensington Square Holding S.A.- Société de Ti-

trisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107816

King Airshare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107816

KIO Exploration Liberia  . . . . . . . . . . . . . . . . .

107856

Koch Nitrogen Finance Luxembourg S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107815

MAG Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

107830

Meritas Luxembourg Holding S.à.r.l.  . . . . . . .

107839

newLIFE Aesthetic S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

107820

Oeno-Invest Advisory S.C.P.A.  . . . . . . . . . . . .

107810

Perseus Immobilien Gesellschaft 8  . . . . . . . . .

107815

Sam HWA Steel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107817

Silicon Motion Technology (Luxembourg) Li-

mited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107810

SiXBTO Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

107810

Steinhäuser Participations, S.A. . . . . . . . . . . . .

107817

Tossebierg I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107817

107809

L

U X E M B O U R G

Oeno-Invest Advisory S.C.P.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-8325 Capellen, 98, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 144.557.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015108142/9.
(150118254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.

Silicon Motion Technology (Luxembourg) Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 179.305.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2015.

Référence de publication: 2015107028/10.
(150117582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.

SiXBTO Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 173.831.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015107029/10.
(150117142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.

FOSCA II Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 137.777.

L'adresse professionnelle de Pascale Nutz, gérant, a changé et est désormais au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Lu-

xembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2015.

Référence de publication: 2015108668/12.
(150118205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.

Achem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 83.384.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ACHEM S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015112030/13.
(150120144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

107810

L

U X E M B O U R G

Anglo Loma Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 111.827.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

Référence de publication: 2015112006/10.
(150120672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Anglo Operations (International) Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 68.630.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

Référence de publication: 2015112007/10.
(150120669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Anglo Loma Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 111.827.

Le bilan consolidé de la société Anglo American plc au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

Référence de publication: 2015112005/11.
(150120671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Anglo Operations (International) Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 68.630.

Le bilan consolidé de la société Anglo American plc au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

Référence de publication: 2015112008/11.
(150120670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Agilis Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 2, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 146.306.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07/07/2015.

G.T. Experts Comptables S.À.R.L.
Luxembourg

Référence de publication: 2015112039/12.
(150120092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

107811

L

U X E M B O U R G

Auda Capital Feeder SCA SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 189.492.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015112017/10.
(150120486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Auda Capital SCS SICAV-SIF, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.215.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015112019/10.
(150120487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Assessor Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 134.530.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015112015/11.
(150120820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

ABLV Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.048.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

ABLV Bank Luxembourg, S.A.

Référence de publication: 2015112028/11.
(150119817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Aljo Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 149.084.

Les comptes annuels au 30.11.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

ALJO PROPERTY S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015112048/12.
(150120488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

107812

L

U X E M B O U R G

Anglo Coal International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 70.044.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

Référence de publication: 2015112004/10.
(150120674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Agilis Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 2, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 146.306.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2015, G.T. Fiduciaires S.A., ayant son siège social à L-1273 Luxem-

bourg, 19, rue de Bitbourg, est nommée commissaire aux comptes de la société, pour la durée d'une année.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2015.

G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2015112040/13.
(150120396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Alpha P.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 143.414.

La Société a été constituée suivant acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3041 du

30 décembre 2008.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015112053/15.
(150119955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Arendt Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 145.917.

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration de la Société en date du 6 juillet 2015

En date du 6 juillet 2015, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Bruno GASPAROTTO, né le 8 septembre 1972 à Ixelles, Belgique, résidant professionnellement

à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société
avec effet au 1 

er

 juillet 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2015.

Arendt Services S.A.
Signature

Référence de publication: 2015112010/16.
(150120341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

107813

L

U X E M B O U R G

Artal International Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 47.798.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015112012/9.
(150120337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Aqua Sanus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3861 Schifflange, 94, rue de Noertzange.

R.C.S. Luxembourg B 172.671.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015112009/10.
(150120212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Argenta Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.000.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 188.823.

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de la Société en date du 14 octobre 2014

En date du 14 octobre 2014, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du

13, rue du Curé, L-1368 Luxembourg au:

- 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 juillet 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2015.

Argenta Holdings S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015112011/16.
(150120145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Allandis, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 148.191.

CLÔTURE DE LA LIQUIDATION

<i>Extrait

A l’issue des résolutions prises par l’Associé Unique de la Société lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue

le 30 décembre 2014 au siège social de la Société, il a été résolu ce qui suit:

- De clôturer la liquidation de la Société au 30 décembre 2014,
- De conserver les documents légaux et les livres de la Société au siège social de la Société à savoir au 174, route de

Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci pour une période de cinq ans;

- Que toutes les dettes de la Société ont été payées et toutes distributions ou provisions ont été effectuées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HALSEY S. à r.l.
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2015112049/19.
(150120492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

107814

L

U X E M B O U R G

Koch Nitrogen Finance Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 250.738,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 145.704.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2014 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 7 juillet 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2015112313/17.
(150120171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Iginio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 149.604.

Lors de l'Assemblée Générale du 15 juin 2015, Monsieur Charles Altwies, demeurant professionnellement à L-1273

Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, est nommé nouvel administrateur de la société pour une durée de six ans, en remplacement
de G.T. Fiduciaires S.A., démissionnaire.

G.T. Fiduciaires S.A., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, est nommée commissaire aux

comptes de la société pour une durée de six ans, en remplacement de G.T. Experts Comptables S.àr.l., démissionnaire.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés pour une nouvelle période de six ans

et ne se termineront que lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2015.

G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2015108758/18.
(150117922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.

Perseus Immobilien Gesellschaft 8, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 132.804.

<i>Auszug aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juli 2015

<i>Geschäftsführer

Die Hauptversammlung nahm den Rücktritt von allen Kategorie A Geschäftsführern mit sofortiger Wirkung an:
- Herr Daniel AEGERTER
- Herr Simon KÖNIG, und
- Herr Martin RECHSTEINER,
Die Hauptversammlung ernannte zum Kategorie A Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit:
- Herr Daniel MALKIN, geboren in Tel Aviv (Israel) am 29. Februar 1976 beruflich wohnhaft in 24, Avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg, und

- Frau Simone RUNGE-BRANDNER, geboren in Friedberg/Hessen (Deutschland) am 9. Januar 1976 beruflich wohn-

haft in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Référence de publication: 2015106966/19.
(150117287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.

107815

L

U X E M B O U R G

Kensington Square Holding S.A.- Société de Titrisation, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 173.110.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015112311/9.
(150120607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Keiryo Packaging S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 190.814.

Les comptes annuels du 1 

er

 octobre 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015112320/11.
(150120243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

JBBK Verwaltungs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 105.039.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 20 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n° 298 du
5 avril 2005.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JBBK Verwaltungs S.à r.l.

Référence de publication: 2015112300/14.
(150119858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

King Airshare, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.742.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 30 juin 2015

<i>Résolutions:

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 50, route d'Esch,

L-1470 Luxembourg au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 juillet 2015.

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Denis CALLONEGO de sa

fonction d'Administrateur et d'Administrateur-délégué de la Société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son
sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Antonio QUARATINO, employé privé, au 26, boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg, en qualité d'Administrateur et d'Administrateur-délégué de la Société, en remplacement de l'Administrateur
démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'Assemblée Générale de
2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KING AIRSHARE S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015112312/20.
(150120751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

107816

L

U X E M B O U R G

Sam HWA Steel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3235 Bettembourg, Krakelshaff.

R.C.S. Luxembourg B 97.172.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2015112607/12.
(150120706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Steinhäuser Participations, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 30, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 135.324.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle du commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.501 est dorénavant à L-2529 Howald, 37
rue des Scillas.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2015112592/13.
(150120365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Tossebierg I S.A., Société en Commandite simple.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 190.867.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 12 mai 2015

Est nommé administrateur unique:

- La société

IMMO TERRAINS S.A.
Route d'Arlon (Belle Etoile)
L-8050 Bertrange

Représenté par:

- Monsieur Maximilien dit "Max" LEESCH,
Route d’Arlon (Belle Etoile), L-8050 Bertrange,

Commerçant,
Administrateur-délégué

- Monsieur Joseph dit "Jeff" LEESCH,
Route d'Arlon (Belle Etoile), L-8050 Bertrange,

Employé privé,
Administrateur

- Madame Doris LEESCH,
Route d'Arlon (Belle Etoile), L-8050 Bertrange,

Employée privé,
Administratrice

Son mandat vient à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2020.
Est nommé Commissaire aux comptes:

- La société

FIDUCIAIRE MULLER &amp; ASSOCIES S.A.
Société Anonyme
121, avenue de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg

Son mandat vient à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2015.

<i>Pour la société IMMO TERRAINS S.A.
Maximilien LEESCH
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2015108320/29.
(150118401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.

107817

L

U X E M B O U R G

Almond S.àr.l.., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 155.175.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of June.
Before the undersigned Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1.  Chiltern  S.A.,  a  société  anonyme,  having  its  registered  office  at  L-2557  Luxembourg,  7A,  rue  Robert  Stümper,

registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 164063,

2. Charcoal Establishment, a institution organised under the laws of Liechtenstein, with registered office at Mühleholz

3, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, registered with the Liechtenstein register of commerce and companies under number
FL-0002.275.257-0,

here represented by Mr. Volker Becker, Conducting Officer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of two

(2) powers of attorney given under private seal.

The said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing

parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. The appearing parties are the sole shareholders (the "Shareholders") of Almond S.àr.l., a société à responsabilité limitée

incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2557 Luxembourg, 7A, rue
Robert Stümper, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155175 and incorporated
by a deed of Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, on 18 

th

 August 2010, published in the

Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 2148 of 12 

th

 October 2010, (the "Company"), and whose articles

have been amended by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on 12 

th

 November 2010,

published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 2865 of 30 

th

 December 2010;

II. The Company's share capital is currently set at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) represented

by twelve thousand and five hundred hundred (12.500) shares of one euro (EUR 1.-) each;

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company from L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper to L-5365

Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.

2. Subsequent amendment the first paragraph of article 2 of the articles of incorporation of the Company.
3. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to change the registered office of the Company from L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert

Stümper (Grand-Duchy of Luxembourg), to L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann, municipality of Schuttrange
(Grand-Duchy of Luxembourg).

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Shareholders resolved to amend the first paragraph of Article 2 of the

articles of incorporation which shall henceforth read as follows:

2. Registered office. (first paragraph).
“2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred within the boundaries of the same municipality by a resolution of the single manager, or as
the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.”

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall borne by the Company as a result of

the present deed are estimated at one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).

107818

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the notary by his surname,

first name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

1. Chiltern S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164063, et

2. Charcoal Establishment, un établissement régie par les lois en vigueur au Liechtenstein, avec son siège social à

Müehleholz 3, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Liechtenstein
sous le numéro FL-0002.275.257-0,

Toutes deux dûment représentées par M. Volker Becker, Conducting Officer, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, en vertu de deux (2) procurations données sous seing privée.

Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire soussigné de donner effet à ce

qui suit:

I. Les parties comparantes sont les seuls associés (les «Associés») de Almond S.àr.l., une société à responsabilité limitée

constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7A, rue
Robert Stümper, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155175 et constituée
suivant acte reçu par Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 août 2010, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2148 du 12 octobre 2010, (la «Société»), et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
12 novembre 2010, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2865 du 30 décembre 2010;

II. Le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisés en douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales d'un euro (1,- EUR) chacune;

III. L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société de L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper au L-5365 Munsbach, 1c,

rue Gabriel Lippmann;

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'Article 2 des statuts de la Société;
3. Divers.
Par ces motifs, les parties comparantes, agissant par l'intermédiaire de leur fondé de pouvoir, ont demandé au notaire

soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de transférer le siège social de la Société du L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper (Grand-

Duché de Luxembourg) au L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann, commune de Schuttrange (Grand-Duché de
Luxembourg).

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des

Statuts comme suit:

2. Siège social. (premier paragraphe).
2.1. Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

les limites de la même commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil
de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique
ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.”

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges de quelque nature que ce soit qui seront supportés par la

Société ou lui seront facturés du fait de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ mille cent euros (EUR
1.100,-).

107819

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare par la présente que sur demande des parties comparantes

par-devant lui, le présent acte est rédigé en anglais et est suivi d'une version française et qu'en cas de différence entre les
textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Becker, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/20163. Reçu soixante-quinze (75.-)

euros.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 7 juillet 2015.

Référence de publication: 2015112000/120.
(150120805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

newLIFE Aesthetic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 100, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 150.129.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünfundzwanzigsten Tag des Monats Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul MEYERS, mit Amtswohnsitz in Rambrouch (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft SFS, mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 100, Avenue de la Faïencerie, eingetragen im luxembur-

gischen Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 149.332,

hier vertreten durch Frau Haika SOIBELMANN, geboren am 6. August 1953 in Belzy (Russland), mit Berufsanschrift

in  L-1510  Luxembourg,  100,  avenue  de  la  Faïencerie,  handelnd  in  seiner  Eigenschaft  als  Verwaltungsratmitglied  der
Gesellschaft und durch Herr Emil SOIBELMANN, geboren am 24. Juli 1981 in Mainz (Deutschland), wohnhaft in D-60487
Frankfurt am Main, Wildunger Straße 10, aufgrund einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht.

Besagte Vollmacht bleibt nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Vertretern und den unterzeichneten Notar ge-

genwärtiger Urkunde beigebogen um mit dergleichen einregistriert zu werden.

Diese Komparentin, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar folgendes zu beurkunden:
- dass sie alleinige Besitzerin aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „newLIFE aesthetic S.à r.l.“,

eingetragen beim Handelsund Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B 150.129, mit Sitz in L-1510 Luxemburg,
100, Avenue de la Faïencerie ist gegründet durch eine Urkunde von Notar Joëlle BADEN, mit dem Amtssitz in Luxemburg,
am 4. Dezember 2009, welche im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Band C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 127 vom 21. Januar 2010 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Ur-
kunde  von  Notar  Joëlle  BADEN,  mit  dem  Amtssitz  in  Luxemburg,  am  11.  Februar  2011,  welche  im  Amtsblatt  des
Großherzogtums Luxemburg, Band C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 770 vom 22. April 2011 veröffentlicht
wurde.

- dass das Gesellschaftskapital auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt und in einhundert (100)

Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von einhundertfünfundzwanzig (EUR 125,-) eingeteilt ist.

Die alleinige Gesellschafterin erklärt vollständig über die Beschlüsse unterrichtet zu sein, die auf Basis der folgenden

Tagesordnung zu fassen sind:

<i>Tagesordnung

1. Kenntnisnahme der mit sofortiger Wirkung, getätigten Verlegung des Gesellschaftssitzes sowie des Hauptunterneh-

mens der Gesellschaft nach D-95030 Hof, Ernst-Reuter-Straße 137. Die Gesellschaft unterliegt der deutschen Gesetzge-
bung im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung;

2. Annahme der Zwischenbilanz;
3. Amtsniederlegung von Frau Haika SOIBELMANN als Geschäftsführer und spezielle Wahl der Freistellung.
4. Ernennung von Herrn Emil SOIBELMANN als alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft;
5. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft in deutscher Sprache um sie den obigen Beschlüsse anzupassen;
6. Erteilung einer Vollmacht;
7. Streichung der Gesellschaft aus dem Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (nach Eintragung im entspre-

chenden Register in Deutschland)

107820

L

U X E M B O U R G

8. Sonstiges.
und hat den unterzeichnenden Notar aufgesucht folgende einstimmige Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin stellt fest und registriert als Folge dieses Beschlusses, dass, im Einklang mit den Bes-

timmungen der anwendbaren deutschen und Luxemburger Gesetze, die Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung, der deutschen
Gesetzgebung unterliegt, dass von diesem Datum an die Gesellschaft eine durch die deutsche Gesetzgebung regierte ju-
ristische Person wird, und dass der Gesellschaftssitz sowie das Hauptunternehmen der Gesellschaft nach Deutschland
verlegt wird, sofern die Anmeldung der Gesellschaft im Handelsregister des Amtsgerichts Hof in Deutschland erfolgt ist.

Der Gesellschaftssitz sowie das Hauptunternehmen der Gesellschaft wird sich in D-95030 Hof, Ernst-Reuter-Straße 137

befinden.

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, der Gesellschaft die Form einer „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ in

Deutschland zu geben.

Die alleinige Gesellschafterin stellt fest, dass keine Anteile ohne Stimmrecht bestehen und dass die Entscheidung der

Sitzverlegung nach Deutschland und der Wechsel der Nationalität der Gesellschaft einstimmig von der alleinigen Gesell-
schafterin getroffen wurde.

Die alleinige Gesellschafterin stellt außerdem fest,
- dass jegliche Einbringungssteuer, sowie andere Steuern nach Luxemburg Recht ordnungsgemäß an die zuständigen

Behörden gezahlt wurden;

- dass das Unternehmen mit allen steuerlichen Vorschriften gemäß Luxemburger Gesetz eingehalten hat;
- dass die Sitzverlegung nach Deutschland und der Wechsel der Nationalität weder auf steuerlicher, noch auf gesell-

schaftsrechtlicher  Ebene  die  Gründung  einer  neuen  Gesellschaft  mit  sich  bringt,  sondern  die  juristische  Person  der
Gesellschaft weitergeführt wird; diese Entscheidung der alleinigen Gesellschafterin wird in Übereinstimmung mit Artikel
199 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften getroffen.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, die Zwischenbilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014, welche vom

Geschäftsführer erstellt wurde, anzunehmen.

Eine „ne varietur“ unterzeichnete Kopie dieser Zwischenbilanz bleibt dieser Urkunde beigebogen um mit ihr einregis-

triert zu werden.

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, die Amtsniederlegungen von Frau Haika SOIBELMANN, als Geschäftsführer

der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzuerkennen und ihm vollständige Freistellung (quitus) für die Ausübung seiner
Pflichten vom Datum seiner Ernennung bis zu diesem Datum zu gewähren.

<i>Vierter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, gemäß den deutschen Rechtsvorschriften, die folgende Person für einen un-

bestimmten Zeitraum als alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen:

- Herr Emil SOIBELMANN, geboren am 24. Juli 1981 in Mainz (Deutschland), wohnhaft in D-60487 Frankfurt am

Main, Wildunger Straße 10.

Der neue Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft alleine, solange er alleiniger Geschäftsführer ist, sind mehrere Ge-

schäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem
Prokuristen. Ihm ist Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt.

<i>Fünfter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, gemäß den vorerwähnten Beschlüsse, gemäß den deutschen Rechtsvorschrif-

ten, die Satzungen der Gesellschaft vollständig neuzufassen.

Demzufolge, werden die vollständigen Satzungen der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

§ 1. Firma und Sitz. Die Firma lautet
newLIFE Aestetic GmbH.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hof.

§ 2. Gegenstand des Unternehmens. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Unterhaltung von Hotels und

Gaststätten.

Zur Verwirklichung dieses Unternehmenszweckes kann jede zweckmäßige Maßnahme ergriffen werden. Die Gesell-

schaft ist berechtigt, gleichartige Gesellschaften zu gründen, zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren Vertretung
zu übernehmen und Niederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

§ 3. Stammkapital und Geschäftsanteile. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EURO.

107821

L

U X E M B O U R G

Es ist bei Gründung eingeteilt in den Geschäftsanteil Nr. 1 im Nennbetrag zu 25.000,00 EURO. Der Geschäftsanteils

Nr. 1 wird übernommen von:

SFS, Société Anonyme, L-1510 Luxembourg, 100, avenue de la Faïencerie, eingetragen im Registre de Commerce et

des Sociétés Luxembourg unter B 149332.

Die Stammeinlage ist in voller Höhe dadurch erbracht, dass die Gesellschafterin die newLIFE Aestetic S.A.R.L. unter

europarechtskonformer Anwendung der §§ 190 ff. UmwG formwechselnd in diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung
umgewandelt hat. Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der formwechselnden Umwandlung das gesamte Unternehmen
der newLIFE Aestetic S.A.R.L. mit allen Aktiva und Passiva als Sacheinlag, ehemals eingetragen beim Handels- und
Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B 150.129, mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 100, Avenue de la Faïencerie.
Sollte das nach Abzug der Schulden verbleibende (freie) Vermögen den Nennbetrag des Stammkapitals der Gesellschaft
nicht übersteigen, ist die Gesellschafterin zum Nachschuss verpflichtet. Soweit der Betrag das Stammkapital übersteigt,
wird dieser überschießende Betrag in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt.

§ 4. Veräußerung von Geschäftsanteilen. Die Veräußerung von ganzen Geschäftsanteilen ist ebenso wie die von Teilen

von Geschäftsanteilen nur mit Genehmigung der Gesellschaft zulässig.

§ 5. Gesellschafterversammlung. Beschlüsse der Gesellschafter werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men gefasst, wenn das Gesetz nicht zwingend eine höhere Mehrheit vorschreibt. Schriftliche Abstimmung ist zulässig,
wenn alle Gesellschafter zustimmen. Zu den Gesellschafterversammlungen sind die Gesellschafter mit eingeschriebenen
Briefen mindestens eine Woche vorher zu laden.

Auf je 50 EURO Geschäftsanteile entfällt eine Stimme.

§ 6. Geschäftsführer/Vertretung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer

bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemein-
schaftlich durch zwei Geschäftsführer oder gemeinschaftlich durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten.

Die Geschäftsführer können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung Einzelvertretungsbefugnis erhalten und

von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

Dies gilt auch im Liquidationsfalle für die Liquidatoren.

§ 7. Geschäftsjahr und Bekanntmachungen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 8. Gründungskosten. Die Kosten der Beurkundung des Gesellschaftsvertrages, der Anmeldung der Gesellschaft beim

und ihrer Eintragung im Handelsregister trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von 2.000 EURO; etwa darüber hi-
nausgehende Gründungskosten tragen die Gesellschafter.

<i>“Sechster Beschluss

Die  alleinige  Gesellschafterin  hat  beschlossen,  Vollmacht  zu  erteilen  an  Herr  Emil  SOIBELMANN,  wohnhaft  in

D-60487 Frankfurt am Main, Wildunger Straße 10, allein handelnd und zeichnend, mit Berechtigung zur Substitution, für
und im Namen der Gesellschaft alle Maßnahmen zu treffen, die sie nach ihrem alleinigen Ermessen für notwendig oder
ratsam hält um die obenstehenden Beschlüsse umzusetzen und alles Notwendige zu veranlassen, sowie jedwede Handlung
vorzunehmen, welche von den deutschen Behörden oder Notaren als nötig erachtet werden um dieser Beschlüsse umzu-
setzen. Der Vollmachtinhaber kann so unter anderem alle Dokumente, Formulare und Urkunden unterzeichnen und alle
notwendigen Vorgänge einleiten um diese Sitzverlegung nach Deutschland rechtskräftig eintragen, bestätigen und beur-
kunden lassen, indem er gegebenenfalls auch die vorstehenden Statuten an die deutsche Gesetzgebung anpassen kann, um
unter  anderem  sicher  zu  stellen,  dass  die  juristische  Person  der  Gesellschaft  in  Deutschland  weitergeführt  wird,  unter
deutschem Gesetz und als Gesellschaft nach deutschem Recht.

Die alleinige Gesellschafterin erteilt weiterhin Vollmacht an jeden Träger einer Ausfertigung dieser Urkunde um die

Streichung aus dem Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister zu beantragen aufgrund eines Belegs der Eintragung
der Gesellschaft im zuständigen deutschen Handelsregister.

Alle Dokumente welche die Gesellschaft in Luxemburg betreffen werden während fünf Jahren am ehemaligen Gesell-

schaftssitz der Gesellschaft verwahrt.

<i>Siebter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, dass die Beschlüsse dieser Hauptversammlung wirksam sind unter der Be-

dingung der Sitzverlegung nach Deutschland und der Eintragung der Gesellschaft im zuständigen deutschen Handelsre-
gister.

<i>Kostenabschätzung

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde

entstehen, werden auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000,-) geschätzt.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten, Datum von dem unterzeichnenden Notar in Ehlange-sur-Mess

aufgenommen wurde.

107822

L

U X E M B O U R G

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschienenen

Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar,
unterzeichnet.

Die  auftretende  Partei  bestätigt  ausdrücklich,  daß  sie  in  Deutschland  das  Kapital  auf  25.000,-  €  erhöhen  wird  und

entbindet der unterzeichneten Notar diesbezüglich.

Gezeichnet: H. Soibelmann, E. Soibelmann, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 juin 2015. Relation: EAC/2015/14890. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Ein-

tragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, den 29. Juni 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015111973/162.
(150120191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 172.888.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of June at 2.00 p.m. in the Grand-Duchy of Luxembourg

(CET);

before Maître Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, undersigned.

Was held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg II, a société à

responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 200,000, having its registered office at 6C, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxem-
bourg (Register of Trade and Companies) under number B 172.888 (the “Company”).

There appeared

Acquisitions Cogeco Cable II L.P., a Delaware limited partnership having its registered office at c/o The Corporation

Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA (the “Sole Shareholder”);

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by

virtue of powers of attorney.

The said power of attorney, initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

All the shares, with a nominal value of USD 10 each, representing the whole share capital of the Company were repre-

sented so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly
informed.

The Sole Shareholder, acting through its proxy holder, requested the notary to enact that the agenda of the meeting is

the following:

<i>Agenda

1. Suppression of the reference to the nominal value of the shares of the Company;
2. Increase of the share capital of the Company by way of the issuance of 48,915,028 mandatory redeemable preferred

shares with a global share premium attached thereto of an amount of USD 48,915,035;

3. Subscription and payment of the new mandatory redeemable preferred shares by way of a contribution in kind by the

sole shareholder of the Company;

4. Decrease of the share capital of the Company by an amount of USD 6,000,000 so as to reduce it to an amount of USD

483,350,280;

5. Subsequent amendments to articles 6, 19 and 23 of the article of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, represented as stated here-above, the following resolutions

have been taken:

<i>First resolution

It was resolved to suppress the reference to the nominal value of the 20,000 (twenty thousand) shares representing the

current share capital of the Company set at USD 200,000 (two hundred thousand US Dollars).

107823

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

It was resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 489,150,280 (four hundred eighty-

nine million one hundred fifty thousand two hundred and eighty US Dollars) so as to raise it from its current amount of
USD 200,000 (two hundred thousand US Dollars) to USD 489,350,280 (four hundred eighty-nine million three hundred
fifty thousand two hundred and eighty US Dollars) by the issuance of 48,915,028 (forty-eight million nine hundred fifteen
thousand and twenty-eight) new mandatory redeemable preferred shares of the Company with a global share premium of
an amount of USD 48,915,035 (forty-eight million nine hundred fifteen thousand and thirty-five US Dollars) exclusively
attached thereto and to be fully allocated to the non-available accounting balance sheet item “legal reserve”, as legal reserve
(the “New MRPS”);

<i>Third resolution

It was resolved to accept that the New MRPS be fully subscribed and paid-up by the Sole Shareholder by way of a

contribution in kind consisting of the Receivable (as defined hereinafter) of an amount of USD 538,065,315 (five hundred
thirty-eight million sixty-five thousand three hundred and fifteen US Dollars).

<i>Subscription - Payment

It was reported that:
- in accordance with resolutions of its board of managers taken on June 26, 2015, the Company declared to the benefit

of the Sole Shareholder, from the freely distributable share premium attached to the 10,000 (ten thousand) MRPS, an interim
dividend of an amount of USD 538,065,315 (five hundred thirty-eight million sixty-five thousand three hundred and fifteen
US Dollars) to be paid by the issuance of the New MRPS (the “Stock Dividend”); and

- as a consequence of the declaration of the Stock Dividend and until full payment of the Stock Dividend by the issuance

of the New MRPS to be approved by the present meeting, the Sole Shareholder is the holder of a receivable towards the
Company of an amount of USD 538,065,315 (five hundred thirty-eight million sixty-five thousand three hundred and fifteen
US Dollars) (the “Receivable”).

The Sole Shareholder, though its proxy holder, declared to subscribe to the above mentioned increase of capital by

subscribing to, and fully paying-up, the New MRPS for an amount of USD 489,150,280 (four hundred eighty-nine million
one hundred fifty thousand two hundred and eighty US Dollars) with the share premium exclusively attached thereto for
an amount of USD 48,915,035 (forty-eight million nine hundred fifteen thousand and thirty-five US Dollars) to be fully
allocated to the non-available accounting balance sheet item “legal reserve”, as legal reserve, the whole being fully paid-
up by contributing the Receivable.

The Sole Shareholder, though its proxy holder, further declared that the issuance of the New MRPS represents satis-

factorily payment in full of the Stock Dividend and thus, of the Receivable.

<i>Evaluation

The value of the Receivable was set at USD 538,065,315 (five hundred thirty-eight million sixty-five thousand three

hundred fifteen US Dollars).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value,

which has been produced to the notary.

<i>Evidence of the Contributions' existence

Proof of the contributions' existence has been given to the undersigned notary.

<i>Effective implementation of the Contributions

The Sole Shareholder, contributor represented as stated here-above, expressly declared that:
(i) the Receivable is certain, valid and due;
(ii) it is the sole legal owner and holder of all rights, title and interest attached to the Receivable;
(iii) the Receivable is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
(iv) the Receivable is not the object of a dispute or claim;
(v) the Receivable is freely transferable with all the rights attached thereto;
(vi) to the extent necessary all actions and formalities have been performed and all the necessary consents and approval

have been obtained to allow the transfer of the Receivable; and

(vii) all formalities subsequent to the transfer of the Receivable required under any applicable law have been or will be

carried out in order for the Receivable to be valid anywhere and towards any third party.

<i>Managers' intervention

Thereupon intervened:
Christian Jolivet, Olivier Dorier and Stewart Kam-Cheong acting in their capacity as managers of the Company, each

of them being here represented by Mr Max MAYER, prenamed, by virtue of a power of attorney.

107824

L

U X E M B O U R G

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company

by reason of the contribution described above, expressly agreed with the description of the contribution, with its valuation
and with the effective transfer of the Receivable to the Company, and confirmed the validity of the subscription and payment.

<i>Declaration

The notary declared that the documentation sustaining the existence of the Receivable has been considered convincing

as well as sufficient, and the contribution is therefore effectively implemented.

<i>Fourth resolution

It was resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of USD 6,000,000 (six million US Dollars)

so as to reduce it from USD 489,350,280 (four hundred eighty-nine million three hundred fifty thousand two hundred and
eighty US Dollars) to USD 483,350,280 (four hundred eighty-three million three hundred fifty thousand two hundred and
eighty US Dollars) without redemption and cancellation of shares of the Company.

It was subsequently noted that the amount of USD 6,000,000 (six million US Dollars), corresponding to the amount of

the decrease of the share capital of the Company, will be paid by the Company to the Sole Shareholder.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it was resolved to amend articles 6, 19 and 23 of the

articles of association of the Company to read as follows:

“ Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at USD 483,350,280 (four hundred eighty-three million three hundred

fifty thousand two hundred and eighty US Dollars) divided into the following classes of shares:

- 2,000 (two thousand) class A ordinary shares (the “Class A Ordinary Shares”);
- 8,000 (eight thousand) class B ordinary shares (the “Class B Ordinary Shares”); and
- 48,925,028 (forty-eight million nine hundred twenty-five thousand and twenty-eight) mandatory redeemable preferred

shares (the “MRPS”);

(the Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares are hereinafter collectively referred to as the “Ordinary

Shares”; the Ordinary Shares and the MRPS are hereinafter collectively referred to as the “Shares” and individually as a
“Share”).

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of

plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital.”

“ Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, where a net profit is shown in the annual accounts approved by the shareholders, it shall be allocated as

follows:

1. five percent of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to

be compulsory when and whilst the legal reserve amounts to at least one-tenth of the share capital, but must be resumed if
at any time the legal reserve falls below that amount for any reason;

2. after allocation to the legal reserve or other non distributable reserve:
i. where MRPS are not issued, the remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of

shareholders,  by  resolution  of  the  shareholders  representing  more  than  fifty  percent  (50%)  of  the  share  capital  of  the
Company, resolving to:

- distribute among the holder(s) of Ordinary Shares;
- carry it forward; or
- transfer it to a reserve distributable or not;
ii. where MRPS are issued an amount of profit up to a right to a preferential and cumulative dividend (the "Preferential

Dividend"), at the exclusion of any Ordinary Dividend (as defined hereafter), shall first be allocated to a distributable
reserve of the balance sheet of the Company that can only be distributed to the MRPS holders, such amount to be equal to:

Total Value of the MRPS X Applicable Rate - Margin being noted that:
“Applicable Rate” is equal to the one applicable to the relevant Underlying Receivable;
"Margin" is equal to
- Underlying Receivable X an appropriate rate to be determined by the sole manager or the board of managers as the

case may be, but to range in any case between 0.0819% and 0.110%

Less
- Total Value of the Class B Ordinary Shares X Applicable Rate
"Ordinary Dividend" means the dividend to be allocated to the holder(s) of Ordinary Shares;

107825

L

U X E M B O U R G

"Total Value of the MRPS" means the aggregate of (i) the accountable par of each MRPS and (ii) the share premium

amount attached to each MRPS (whether allocated to the legal reserve or not);

"Total Value of the Class B Ordinary Shares" means the aggregate of (i) the accountable par of each Class B Ordinary

Share and (ii) the share premium amount attached to each Class B Ordinary Share (whether allocated to the legal reserve
or not); and

"Underlying Receivables" means the underlying receivables financed by the MRPS and the Class B Ordinary Shares.
For sake of clarity, the Preferential Dividend will start accruing on the date of issuance of the Underlying Receivable.
Where the shareholders decide to distribute any dividend, the MRPS will be entitled to the payment of the Preferential

Dividend before any Ordinary Dividend can be paid.

The Preferential Dividend (excluding additional Preferential Dividend referred to below) shall accrue daily on the basis

of a 360 day year.

Where there is a change in the interest rate of the Underlying Receivable, the Preferential Dividend rate on the MRPS

may be amended.

The MRPS are also entitled to an additional Preferential Dividend where the Underlying Receivable includes an obli-

gation to pay to the Company a default interest equal to the one applicable to the relevant Underlying Receivable in case
of occurrence of an event constituting an event of default under the relevant Underlying Receivable. Said additional Pre-
ferential  Dividend  accumulates  for  the  financial  year  in  the  course  of  which  the  default  interest  is  disclosed  in  the
Luxembourg GAAP financial statements of the Company and shall be equal to said default interest.

The term "Preferential Dividend" mentioned in the articles of association of the Company also covers any additional

Preferential Dividend as per above (except where otherwise mentioned).

The  remaining  profit,  if  any,  shall  be  allocated  by  the  sole  shareholder,  or  in  case  of  plurality  of  shareholders,  by

resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving
to:

- distribute among the holder(s) of Ordinary Shares;
- carry it forward; or
- transfer it to a reserve distributable or not.
Any and all dividends, whether Preferential Dividend or Ordinary Dividend, to be allocated to the holder(s) of MRPS

and/or Ordinary Shares shall become due and payable only to the extent that, and as of when, declared to be due and payable
by resolution(s) of the board of managers, which resolution(s) shall set out the record date and the payment date.”

“ Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the

sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the
shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets
of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders with
the following priority order:

1. each MRPS holder(s), if any, is entitled to a preferential right of reimbursement of the contribution in consideration

of which the MRPS have been issued (accountable par plus share premium attached thereto if any, whether allocated to
the legal reserve or not) plus payment of all and any accrued but not yet declared Preferential Dividend he is entitled to as
holder of MRPS. As a consequence of the foregoing provisions, the MRPS holder(s) has, other than the preferential right
mentioned above, no right on the liquidation proceeds; and

2. the liquidation proceeds, if any, will be allocated to the holder(s) of Ordinary Shares proportionally to the Ordinary

Shares they hold.”

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 8,050.-.

The contribution is valued at EUR 480,291,281.77-
The amount of the capital reduce is valued at EUR 5,355,760.-
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour de juin à 14.00 heures au Grand-Duché de Luxembourg (CET);

107826

L

U X E M B O U R G

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg II, une société à

responsabilité limitée dûment constituée et existant valablement selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, au capital
social de 200.000 USD, ayant son siège social au 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.888 (la «Société»).

A comparu,

Acquisitions Cogeco Cable II L.P., un partnership de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o The Corporation

Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New CastleCounty, Delaware 19801, USA (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante, restera annexée au présent acte afin d'être

enregistrée avec ce dernier.

Toutes les parts sociales avec une valeur nominale de 10 USD chacune, représentant l'intégralité du capital social de la

Société étaient représentées de sorte que l'assemblée pouvait décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du
jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé.

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a prié le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la mention de la valeur nominale des parts sociales de la Société;
2. Augmentation du capital de la Société par l'émission de 48.915.028 nouvelles parts sociales préférentielles à rachat

obligatoire assorties d'une prime d'émission globale y attachée d'un montant de 48.915.035 USD;

3. Souscription et paiement des nouvelles parts sociales préférentielles à rachat obligatoire au moyen d'un apport en

nature de l'associé unique de la Société;

4. Réduction du capital social de la Société d'un montant de 6.000.000 USD afin de le réduire à un montant de 483.350.280

USD;

5. Modification subséquente des articles 6, 10, 19 et 23 des statuts de la Société;
6. Divers.
Après que l'ordre du jour a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il a été décidé de supprimer la mention de la valeur nominale des 20.000 (vingt mille) parts sociales représentant le

capital social actuel de la Société fixé à USD 200.000 (deux cent mille Dollars Américains).

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 489.150.280 USD (quatre cent

quatre-vingt-neuf millions cent cinquante mille deux cent quatre-vingt Dollars Américains) pour le porter de son montant
actuel de 200.000 USD (deux cent mille Dollars Américains) à 489.350.280 USD (quatre cent quatre-vingt-neuf millions
trois cent cinquante mille deux cent quatre-vingt Dollars Américains) par l'émission de 48.915.028 (quarante-huit millions
neuf cent quinze mille vingt-huit) nouvelles parts sociales préférentielles à rachat obligatoire assorties d'une prime d'émis-
sion globale exclusivement y attachée d'un montant de 48.915.035 USD (quarante-huit millions neuf cent quinze mille
trente-cinq Dollars Américains) et devant être entièrement allouée au poste non distribuable du bilan «réserve légale», en
tant que réserve légale (les «Nouvelles MRPS»).

<i>Troisième résolution

Il a été décidé d'accepter que les Nouvelles MRPS soient entièrement souscrites et libérées par l'Associé Unique au

moyen d'un apport en nature consistant en une Créance (telle que définie ci-après) d'un montant de 538.065.315 USD (cinq
cent trente-huit millions soixante-cinq mille trois cent quinze Dollars Américains).

<i>Souscription - Paiement

Il a été reporté que:
- conformément aux résolutions de son conseil de gérance prises le 26 Juin 2015, la Société a déclaré au bénéfice de

l'Associé Unique, un dividende intérimaire d'un montant de 538.065.315 USD (cinq cent trente-huit millions soixante-cinq
mille trois cent quinze Dollars Américains) sur la prime d'émission librement distribuable attachée aux 10.000 (dix mille)
MRPS et devant être payé par l'émission des Nouvelles MRPS (le «Stock Dividend»); et

- à la suite de la déclaration du Stock Dividend et jusqu'au paiement complet du Stock Dividend par l'émission des

Nouvelles MRPS devant être approuvée par la présente assemblée, l'Associé Unique est le détenteur d'une créance contre
la Société d'un montant de 538.065.315 USD (cinq cent trente-huit millions soixante-cinq mille trois cent quinze Dollars
Américains) (la «Créance»).

107827

L

U X E M B O U R G

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée en

souscrivant et libérant entièrement les Nouvelles MRPS pour un montant de 489.150.280 USD (quatre cent quatre-vingt-
neuf millions cent cinquante mille deux cent quatre-vingt Dollars Américains) assorties d'une prime d'émission globale
exclusivement y attachée d'un montant de 48.915.035 USD (quarante-huit millions neuf cent quinze mille trente-cinq
Dollars Américains) devant être allouée au poste non distribuable du bilan «réserve légale», en tant que réserve légale, le
tout étant entièrement libéré par apport de la Créance.

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a en outre déclaré que l'émission des Nouvelles MRPS représente le

paiement complet du Stock Dividend et donc, de la Créance.

<i>Evaluation

La valeur de la Créance a été fixée à 538.065.315 USD (cinq cent trente-huit millions soixante-cinq mille trois cent

quinze Dollars Américains).

Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport qui

a été fournie au notaire.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Mise en oeuvre effective de l'apport

L'Associé Unique, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:
(i) la Créance est certaine, liquide et exigible;
(ii) il est seul propriétaire de tous les droits, titres et intérêts attachés à la Créance;
(iii) la Créance est libre de toute charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iv) la Créance ne fait l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
(v) la Créance est librement transférable, avec tous les droits y attachés; et
(vi) pour autant que de besoin, tous les actes ou formalités ont été accomplis et tous les consentements et approbations

nécessaires ont été obtenus afin d'autoriser le transfert de la Créance; et

(vii) l'ensemble des formalités subséquentes au transfert de la Créance requise en vertu des lois applicables sera accompli

afin que l'apport de la Créance soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

<i>Intervention des gérants

Ci-après sont intervenus:
Christian Jolivet, Olivier Dorier et Stewart Kam-Cheong agissant en leur qualité de gérants de la Société, chacun étant

représenté par M. Max MAYER, préqualifié, en vertu d'une procuration,

reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité de gérants de la Société engagée en

raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, chacun d'eux accepte expressément la description de l'apport en nature, son
évaluation, et le transfert effectif de la Créance, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

<i>Déclaration

Le notaire a déclaré que la documentation relative à l'existence de la Créance a été considérée comme convaincante et

suffisante et qu'en conséquence l'apport est effectivement réalisé.

<i>Quatrième résolution

Il a été décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 6.000.000 USD (six millions de Dollars Amé-

ricains) afin de le réduire de 489.350.280 USD (quatre cent quatre-vingt-neuf millions trois cent cinquante mille deux cent
quatre-vingt Dollars Américains) à 483.350.280 USD (quatre cent quatre-vingt-trois millions trois cent cinquante mille
deux cent quatre-vingt Dollars Américains), sans rachat ni annulation de parts sociales de la Société.

Il a ensuite été noté que le montant de 6.000.000 USD (six millions de Dollars Américains), correspondant au montant

de la réduction du capital social de la Société, sera payé par la Société à l'Associé Unique.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent, il a été décidé de modifier les articles 6, 19 et 23 des

statuts de la Société afin de les lire comme suit:

« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 489.350.280 USD (quatre cent quatre-vingt-neuf millions trois cent cinquante

mille deux cent quatre-vingt Dollars Américains), divisé en différentes 1es de parts sociales comme suit:

- 2.000 (deux mille) parts sociales ordinaires de classe A (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe A»);
- 8.000 (huit mille) parts sociales ordinaires de classe B (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe B»); et
- 48.925.028 (quarante-huit millions neuf cent vingt-cinq mille vingt-huit) parts sociales préférentielles à rachat obli-

gatoire (les «MRPS»);

107828

L

U X E M B O U R G

(les Parts Sociales Ordinaires de Classe A et les Parts Sociales Ordinaires de Classe B seront ci-après désignées col-

lectivement comme les «Parts Ordinaires» et individuellement la «Part Ordinaire»; les Parts Ordinaires et les MRPS seront
ci-après désignées collectivement comme les«Parts» et individuellement la «Part»).

Chaque Part est émise avec une valeur nominale de 10 USD (dix Dollars américains). Le capital social peut être augmenté

ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.»

« Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges

et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée des associés, représente
le bénéfice net de la Société.

Chaque année, lorsqu'un bénéfice apparaît dans les comptes annuels approuvés par les associés, celui-ci doit être alloué

comme suit:

1. cinq pour cent du bénéfice net est affecté à la réserve légale de la Société. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires

lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment si celle-ci devait être
entamée pour quelque raison que ce soit jusqu'à entière reconstitution;

2. après affectation à la réserve légale ou à toute autre réserve non distribuable:
i. lorsque les MRPS ne sont pas créées, le bénéfice restant est alloué par résolution de l'associé unique ou, en cas de

pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société, décidant de:

- le distribuer au(x) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires;
- son report à nouveau; ou
- le transférer à une réserve distribuable ou non;
ii. lorsque les MRPS sont émises, un montant de bénéfice à hauteur d'un droit à un dividende cumulatif et préférentiel

(le «Dividende Préférentiel»), doit être en premier lieu être alloué à une réserve distribuable du bilan de la Société qui ne
pourra être distribué qu'aux associés détenant des MRPS à l'exclusion de tout Dividende Ordinaire (comme défini ci-après),
ce montant devant être égal à:

Montant Total des MRPS X Taux Applicable - Marge
étant précisé que:
«Taux Applicable» est égal à celui applicable aux Créances Sous-Jacentes;
«Marge» est égale à:
- Créance Sous-Jacente X un taux approprié à déterminer par le gérant unique ou le conseil de gérance le cas échéant,

devant en tout état de cause être compris entre 0,0819% et 0,110%

Moins
- Montant Total des Parts Sociales Ordinaires de Classe B X Taux Applicable
«Dividende Ordinaire» signifie le dividende devant être attribué au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires;
«Montant Total des MRPS» signifie la somme du (i) pair comptable de chaque MRPS et (ii) du montant de la prime

d'émission attachée à chaque MRPS (qu'elle soit allouée ou non à la réserve légale);

«Montant Total des Parts Sociales Ordinaires de Classe B» signifie la somme du (i) pair comptable de chaque Part

Sociale Ordinaire de Classe B et (ii) du montant de la prime d'émission attachée à chaque Part Sociale Ordinaire de Classe
B (qu'elle soit allouée ou non à la réserve légale); et

«Créance Sous-Jacente» signifie la créance sous-jacente financée par les MRPS et les Parts Sociales Ordinaires de Classe

B.

Dans un souci de clarté, le Dividende Préférentiel commence à courir à compter de la date d'émission de la Créance

Sous-Jacente.

Lorsque les associés décident de distribuer un dividende, les MRPS donnent droit au paiement du Dividende Préférentiel

avant le paiement de tout Dividende Ordinaire.

Le Dividende Préférentiel (à l'exclusion du Dividende Préférentiel additionnel décrit ci-dessous) se calcule par jour sur

la base d'une année de 360 jours.

En cas de modification du taux d'intérêt de la Créance Sous-Jacente, le taux du Dividende Préférentiel applicable peut

être modifié.

Les MRPS ont également droit à un Dividende Préférentiel additionnel lorsque les Créances Sous-Jacentes incluent

l'obligation de payer à la Société un intérêt de retard équivalent à celui applicable à la Créance Sous-Jacente concernée en
cas de survenance d'un évènement de défaut relatif à ladite Créance Sous-Jacente. Ledit Dividende Préférentiel additionnel
s'accumule au cours de l'exercice social pendant lequel l'Intérêt de retard apparaît dans les comptes sociaux de la Société
établis conformément aux PCGR (GAAP) applicables au Luxembourg et est égal au montant de la l'intérêt de retard.

Le terme «Dividende Préférentiel» mentionné dans les statuts de la Société recouvre également tout Dividende Préfé-

rentiel additionnel tel que décrit ci-dessus (sauf disposition contraire).

107829

L

U X E M B O U R G

Le bénéfice restant est affecté par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une résolution de

la majorité des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de:

- le distribuer au(x) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires;
- son report à nouveau; ou
- le transférer à une réserve distribuable ou non;
Tout dividende, qu'il s'agisse d'un Dividende Préférentiel ou d'un Dividende Ordinaire, doit être alloué au(x) détenteur

(s) de MRPS et/ou de Parts Sociales Ordinaires devient échu et exigible uniquement si, et lorsque, il est déclaré échu et
exigible par décision(s) du conseil de gérance, décision(s) devant fixer la date de comptabilisation et la date de paiement.»

« Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé

unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des
associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui déterminera
ses/leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à
l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés dans cet ordre:

1. chaque détenteur(s) de MRPS, a un droit préférentiel de restitution de l'apport en contrepartie duquel les MRPS ont

été émises (pair comptable plus prime d'émission y attachée s'il en existe une, qu'elle soit allouée ou non à la réserve légale)
et au paiement de tout dividende préférentiel couru mais non encore déclaré auquel donne droit chaque MRPS, autre le
droit préférentiel mentionné ci-dessus; pas de droit sur le boni de liquidation; et

2. le boni de liquidation sera attribué aux associés détenant des Parts Sociales Ordinaires proportionnellement au nombre

de Parts Sociales Ordinaires qu'ils détiennent.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison

des présentes ou qui pourrait être dû au regard de la de l'augmentation de capital est évalué à environ 8.050,- EUR.

Le montant de l'apport a été évalué à 480.291.281,77- EUR
Le montant de la réduction a été évalué à 5.355,760.- EUR.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 juin 2015. Relation GAC/2015/5472. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, le 08 juillet 2015.

Référence de publication: 2015111984/402.
(150120923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

MAG Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.523.

EXTRAIT

En date du 25 juin 2015, l'associé unique de la Société a nommé Reiner Beutel, né le 30 juin 1959 à Marbach am Neckar,

Allemagne, demeurant à 23 Lindenstrasse, 71634, Ludwigsburg, Allemagne avec effet au 25 juin 2015 et pour une durée
indéterminée.

Suite à ce changement, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Moshe Israel Meidar, et
- Reiner Beutel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2015.

Référence de publication: 2015112420/17.
(150120181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

107830

L

U X E M B O U R G

Eurofresh Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 198.236.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth of June.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

“CapVest Equity Partners III L.P.”, a limited partnership incorporated and existing under the laws of Jersey, registered

in Jersey under number 1539 and having its principal place of business at 44, the Esplanade St. Helier, Jersey JE4 9WG,
here represented by Mrs Nadia WEYRICH, employee, having its professional address in Belvaux, by virtue of a proxy,
given on 17 June 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the “Articles”) of “Eurofresh

Luxembourg I S.à r.l.” (the “Company”), a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended
from time to time (the “1915 Law”).

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the “Registered Office”) is established in the municipality of Sandweiler,

Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by the Board of Managers

(as defined in article 8.2) if the Company has at the time a Board of Managers; or

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution

of the shareholders of the Company (a “Shareholders' Resolution”) passed in accordance with these Articles - including
article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law (“Luxembourg
Law”).

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which

would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such  time  as  the  situation  becomes  normalised;  such  temporary  measures  will  not  have  any  effect  on  the  Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Managers as
appropriate.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the

Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and
other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments,
and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the

undertaking of the Company, for such consideration as the Board of Managers think fit, including for shares, debentures
or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part)
similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage,
develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any
part of the property and rights of the Company;

3.3 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the

business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.4 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Board of Managers think fit and to lend

money and give credit in each case to any person with or without security;

3.5 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Board of Managers think fit, including by the issue

(to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise,

107831

L

U X E M B O U R G

convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled
capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.6 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the

sharing  of  profits,  union  of  interests,  co-operation,  joint  venture,  reciprocal  concession  or  otherwise  with  any  person,
including any employees of the Company;

3.7 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee

and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital,
principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on
shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest
or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is
associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or
advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the
Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this
article 3.7 “guarantee” includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or sa-
tisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of
assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise
be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.8 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,

agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or
with another person or persons;

3.9 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements

with or in favor of any person) that are in the opinion of the Board of Managers incidental or conducive to the attainment
of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.

4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

5. Share capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.00) each having such rights and obligations as set out in these
Articles. In these Articles, “Shareholders” means the holders at the relevant time of the Shares and “Shareholder” shall be
construed accordingly.

5.2 The Company may establish a share premium account (the “Share Premium Account”) into which any premium

paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities

in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of
doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.

5.4 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the

Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that repre-
sentative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other
payment rights.

7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders

holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding

at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by
article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

107832

L

U X E M B O U R G

8. Management.
8.1 The Company will be managed by at least one class A manager (the “Class A Manager”) and one class B manager

(the “Class B Manager” and together referred to as the “Managers”) who shall be appointed by a Shareholders' Resolution
passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil

de gérance (the “Board of Managers”).

8.3 A Manager may be removed at any time for any legitimate reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance

with Luxembourg Law and these Articles.

9. Powers of the managers. The Board of Managers, may take all or any action, which is necessary or useful to realise

any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided
upon by the Shareholders.

10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to represent

and/or bind the Company:

10.1 if the Company has more than one Manager, one Class A Manager together with one Class B Manager;
10.2 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.

11. Agent of the managers. Any Manager may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc

agents and will determine any such agent’s powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period
of representation and any other relevant conditions of its agency.

12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers (“Board Meetings”) may be convened by any Manager. The Board of Managers

shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or

any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a “Manager's

Representative”) at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or
participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of

conference telephone, video conference or similar form of communications equipment (initiated from Luxembourg) pro-
vided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person
participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled
to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these
Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number
of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)

shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned. For the avoidance
of doubt, written resolution shall be avoided in case the Company has to decide any important or strategic decisions.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified

by any Manager present at the Meeting.

13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by

Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultations, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution
may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their

participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject as provided in article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered

Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing
three quarters of the Shares.

107833

L

U X E M B O U R G

13.5 A resolution to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be

passed by at least half of the Shareholders representing three quarters of the Shares.

13.6 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening

requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either
in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed

by written vote of Shareholders rather than at a meeting of Shareholders provided that each Shareholder receives the precise
wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.

14. Business year.

14.1 The Company’s financial year starts on 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December each year.

15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be

deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders

declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.

15.3 The Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end

of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of
the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward
losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any
such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder
(s).

16. Dissolution and liquidation.  The  liquidation  of  the  Company  shall  be  decided  by  the  Shareholders'  meeting  in

accordance with Luxembourg Law and article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.

17. Interpretation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a “person” includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,

state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications)

thereof.

17.1.2 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by “CapVest Equity Partners III L.P.”, pren-

amed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.00), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2015.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.

107834

L

U X E M B O U R G

<i>Resolutions of the sole shareholder

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Ganash LOKANATHEN, director, born on 5 July 1978 in Pahang, Malaysia, residing professionally at 7, rue Lou

Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duchy of Luxembourg, as Class A Manager; and

- Mrs. Hana BALAJKOVA, client relationship manager, born on 24 February 1983 in Zlin, Czech Republic, residing

professionally at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duchy of Luxembourg, as Class B Manager.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Belvaux, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

«CapVest Equity Partners III L.P.», un limited partnership, constitué et régi d’après les lois de Jersey, immatriculé à

Jersey  sous  le  numéro  1539  et  ayant  son  siège  social  principal  au  44,  the  Esplanade  St.  Helier,  Jersey  JE4  9WG,  ici
représentée par Madame Nadia WEYRICH, employée privée, avec adresse professionnelle à Belvaux, en vertu d’une
procuration sous seing privé donnée le 17 juin 2015.

La procuration, signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

1. Forme et nom. Ce document constitue les statuts (les «Statuts») de «Eurofresh Luxembourg I S.à r.l.» (la «Société»),

une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg notamment la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le «Siège Social») est établi dans la commune de Sandweiler, Grand-Duché de Lu-

xembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand-Duché de Luxembourg par le Conseil de Gérance

(tel que défini à l'Article 8.3) si la Société administrée par un Conseil de Gérance; ou

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par résolution des

associés de la Société (une «Résolution des Associés») prise en conformité avec ces Statuts - notamment l'article 13.4 - et
les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la «Loi Luxembourgeoise»).

2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité

normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré
provisoirement  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure  provisoire  n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera de
nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Conseil de gérance, le
cas échéant.

2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3. Objet. L'objet de la Société est:
3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la

Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou autre)
la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute personne
et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;

3.2 de vendre, louer, échanger, de mettre ou de prendre en location et de disposer de tout bien immeuble ou meuble et/

ou de la totalité ou d'une partie du fonds de commerce de la Société, pour toute contrepartie que le Conseil de Gérance
estime adéquate, incluant pour les actions, obligations ou autres titres, totalement ou partiellement libérés, de toute personne,
ayant ou non (en totalité ou en partie) un objet similaire à celui de la Société; de détenir toutes actions, obligations et autres

107835

L

U X E M B O U R G

titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options
sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la Société;

3.3 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une partie

des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;

3.4 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Conseil de Gérance estime

adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans garantie;

3.5 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que le Conseil de Gérance estime

adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et autres titres ou instruments
financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens de la Société
(présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.6 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits,

l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant
tout employé de la Société;

3.7 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et octroi

de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal, les
primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre titres)
par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne
étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute activité ou
entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par engagement
personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des actifs ou du
capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent article 3.7
«garantie» inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la
satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat d'actifs ou de services),
d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de payement, ou d'être responsable, de toute autre
manière, des dettes de toute autre personne;

3.8 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que

commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou
autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);

3.9 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec ou en

faveur de toute personne) que le Conseil de Gérance considère comme incitant ou propice à l’accomplissement de tout ou
partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie des pouvoirs de celle-ci;

SOUS RESERVE que la Société n’entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du

secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation
requise par celle-ci.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par douze mille cinq

cents (12.500) parts sociales, d’une valeur d’un euro (EUR 1.00) chacune (les «Parts Sociales»), ayant les droits et obli-
gations tel que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au moment opportun de
Parts Sociales et «Associé» devra être interprété conformément.

5.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent
être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.

5.3 La Société peut, sans restriction, accepter de l'equity ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou

d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions
relatives à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et aux
présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions au contributeur.

5.4 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.
5.5 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses Parts Sociales conformément à la Loi de 1915.

6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plusieurs personnes sous réserve que tous les détenteurs d'une Part

Sociale notifient par écrit à la Société lequel d'entre eux devra être considéré comme leur représentant; la Société s'adressera
à ce représentant comme s'il était l'unique associé au regard de cette Part Sociale notamment eu égard à l'exercice du droit
de vote, aux dividendes ainsi qu'à tous autres droits à paiement.

7. Transfert des parts.
7.1 Dans l’hypothèse où la Société ne comprend qu'un seul Associé, les Parts Sociales seront librement transmissibles.

107836

L

U X E M B O U R G

7.2 Dans l’hypothèse où la Société comprend plusieurs Associés:
7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas transmissibles autrement qu'à cause de mort à d'autres personnes que les Associés

à moins que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales aient accepté le transfert en assemblée
générale;

7.2.2 Les Parts Sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à d'autres personnes que les Associés à moins que

les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales détenues par les ayants droit aient accepté le transfert ou
dans les circonstances prévues par l'article 189 de la Loi de 1915;

7.2.3 Le transfert de Parts Sociales est soumis aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par au moins un gérant de catégorie A (le «Gérant de Catégorie A») et un gérant de

catégorie B (le «Gérant de Catégorie B», ensemble référencés comme étant les «Gérants») nommés par une Résolution des
Associés prise en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.

8.2 En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
8.3 Un gérant pourra être révoqué à tout moment, pour toute cause légitime, par Résolution des Associés prise en

conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.

9. Pouvoirs des gérants. Le Conseil de Gérance, peut prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de la Société, à l'exception de celles requérant une décision des Associés conformément à la Loi Luxem-
bourgeoise ou aux présents Statuts.

10. Représentation de la société. Sous réserve des dispositions prévues par la Loi Luxembourgeoise et les présents

Statuts, les personnes suivantes son autorisées à représenter et/ou engager la Société:

10.1 En cas de pluralité de gérants, un Gérant de Catégorie A avec un Gérant de Catégorie B;
10.2 Toute personne à qui le pouvoir aura été délégué en conformité avec l'article 11.

11. Agent des gérants. Tout Gérant, peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches

déterminées et détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de tout mandataire, la durée de
représentation de la Société ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les «Réunions du Conseil de Gérance») sont convoquées par tout Gérant. Le

Conseil de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil de Gérance

sans convocation préalable si tous les gérants ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite
Réunion du Conseil de Gérance en personne ou par un représentant autorisé.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une Réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant (à

l'exclusion de toute autre personne), pour assister, délibérer, voter et exécuter ses fonctions en son nom lors de cette Réunion
du Conseil de Gérance. Un Gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs autres Gérants lors d'une Réunion du
Conseil de Gérance sous réserve que (et tant que les conditions de quorum sont satisfaites) au moins deux Gérants soient
physiquement présents à la Réunion du Conseil de Gérance tenue en personne ou participent à la Réunion du Conseil de
Gérance tenue conformément à l'article 12.5.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 Tout Gérant ou son représentant peut valablement participer à une Réunion du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire (initiée depuis le Luxembourg) sous
réserve que chaque participant est en mesure d’entendre et d’être entendu par tous les autres participants tout au long de
la réunion. Ledit participant sera réputé présent à la réunion, sera comptabilisé dans le quorum et habilité à prendre part au
vote. Conformément à la Loi Luxembourgeoise, toute affaire conclue de telle manière par les Gérants sera, pour les besoins
de ces Statuts, réputée valablement et effectivement conclu par le Conseil de Gérance, nonobstant le fait que le nombre de
Gérants (ou leur représentant) physiquement présents au même endroit est inférieur au nombre requis.

12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou pour tout Gérant, son représentant), est valide et effective

comme si elle avait été adoptée lors d’une Réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue et peut être docu-
mentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu, signés par ou au nom d'un ou
plusieurs des Gérants. Les résolutions écrites devront être évitées en cas de prise de décisions importantes et stratégiques.

12.7 Les procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance sont signés et les extraits de ces procès-verbaux certifiés

par tous les Gérants présents aux réunions.

13. Résolutions des associés.
13.1 Tout Associé dispose d'un vote pour chaque action qu'il détient.
13.2 Comme prévu aux articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valablement prises seulement si

les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent, toutefois si le quorum n'est pas atteint lors de la

107837

L

U X E M B O U R G

première réunion ou première consultation écrite, les Associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois, par
lettre recommandée avec accusé de réception et la résolution pourra être prise à la majorité des votes enregistrés, sans tenir
compte du nombre de Parts Sociales représentées.

13.3 Le changement de nationalité de la Société ainsi que l'accroissement des participations des Associés dans la Société

requièrent l'unanimité.

13.4 Tel qu'il est prévu à l'article 13.3, toute résolution modifiant les Statuts (y compris un changement de Siège Social)

ne peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.

13.5 Une résolution visant à déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou à nommer les liquidateurs ne peut

être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.

13.6 Une assemblée des Associés peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous

les Associés ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite assemblée en personne ou par
représentant autorisé.

13.7 Un Associé pourra être représenté à une assemblée des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.8 S’il y a moins de vingt-cinq Associés, les Résolutions des Associés pourront être prises par écrit et non en assemblée,

sous réserve que chaque Associé reçoive le texte exact des résolutions et des décisions à adopter et donne son vote part
écrit.

14. Exercice social.

14.1 L’année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre chaque année.

15. Distribution des parts.
15.1 Du bénéfice net, déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent seront prélevés et alloués

à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint
dix pour cent du capital nominal de la Société.

15.2 Dans le respect de la Loi luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société peut distribuer des dividendes con-

formément aux droits respectifs des Associés.

15.3 Le Conseil de Gérance, le cas échéant, peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la

fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la
distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis
la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes
reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon les présents Statuts et que (ii) de telles sommes
distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l’associé(s).

16. Dissolution et liquidation. La dissolution de la Société sera décidée par l'assemblée des Associés en conformité avec

la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13. Si à tout moment il n’y a qu'un seul Associé, celui-ci peut à sa propre discrétion,
décider de liquider la Société en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et dettes, connus ou inconnus, de la
Société.

17. Interprétation et loi luxembourgeoise.
17.1 Dans les présents Statuts:
17.1.1 Une référence à:
(a) un genre inclut tous les genres;
(b) (à moins que le contexte ne requiert autrement) l'utilisation du singulier inclut le pluriel et inversement;
(c) une «personne» inclut la référence à tout particulier, entreprise, corporation et autre entité sociétaire, gouvernement,

état ou organisme d'état ou toute société commune, association ou partenariat, ou tout corps syndical (qu'il ait ou non une
personnalité juridique propre);

(d) une disposition légale ou loi inclut toutes modifications et toutes refontes de celle-ci (avec ou sans modification).
17.1.2 Les titres contenus dans les présents Statuts n'affectent pas leur interprétation.
17.2 En sus des présents Statuts, la Société est aussi soumise à toutes dispositions applicables de la Loi Luxembourgeoise.

<i>Souscription et libération

L’ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales a été souscrit par «CapVest Equity Partners III L.P.»,

précitée.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,00) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2015.

107838

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une

assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Ganash LOKANATHEN, directeur, né le 5 juillet 1978 à Pahang, Malaisie, demeurant professionnellement

au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, aux fonctions de Gérant de Catégorie A; et

- Madame Hana BALAJKOVA, client relationship manager, née le 24 février 1983 à Zlin, République Tchèque, de-

meurant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, aux fonctions de Gérant
de Catégorie B.

Dont acte, passé à Belvaux, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. WEYRICH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 juin 2015. Relation: EAC/2015/14783. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015111314/465.
(150120504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

Meritas Luxembourg Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 41.916.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 124.415.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of June,
Before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

Meritas (Gibraltar) Holdings Limited, a private limited liability company incorporated and registered under the laws of

Gibraltar, with registered office situated at 28 Irish Town, Gibraltar, and registered with the Gibraltar Companies Registry
under number 98190 (the "Sole Shareholder"),

represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains,
pursuant to a power of attorney under private seal given on June 25, 2015, which, after having been initialled and signed

"ne varietur" by the holder and the undersigned notary, will be appended to the present instrument for the purpose of
registration.

The Sole Shareholder, represented as above stated, declares that it currently holds all the shares of Meritas Luxembourg

Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Lu-
xembourg, pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing then in Mersch, of 27 December 2006
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 674 of 21 April 2007, having its registered
office at 6, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, having a share capital of EUR 41,916,000 and being registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number
B 124415 (the "Company"). The Company's articles of association (the "Articles") have been amended for the last time by
a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing then in Mersch, of 3 May 2007 published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2249 of 9 October 2007.

The Sole Shareholder declared to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1.  To  acknowledge  the  resignation  of  the  following  persons  from  their  position  as  manager  of  the  Company,  with

immediate effect:

- Mr. Benjamin CHOURAKI, category B manager,
- Mr. Marc CHONG KAN, category B manager,

107839

L

U X E M B O U R G

- Mr. Andrew SZAFRAN, category A manager,
- Mr. Jonathan GAMSE, category A manager,
- Mr. Ronan DESEROUX, category A manager,
- Mr. Eric ISRAEL, category A manager, and
- Mrs. Susan Kay KISSEL, category A manager.
2. To grant discharge for the performance of their duties as managers to the resigning managers mentioned under item

1. of this agenda, except in case of fraud, wilful misconduct or criminal offences (décharge), provided however that con-
firmation of such discharges is so resolved by the Sole Shareholder when approving the annual accounts for the relevant
financial periods.

3. To appoint the following persons as new managers of the Company with immediate effect and for an undetermined

period:

- Mr. Andrew Fitzmaurice, born in Liverpool, United-Kingdom, on 2 October 1960 and residing professionally at Flat

A, 27/F., Aigburth, 12 Tregunter Path, Hong Kong, as category A manager,

- Mr. Graeme Robert Halder, born in Deal, United Kingdom, on 26 December 1962 and residing professionally at Flat

A, 53/F., The Summit, 41C Stubbs Road, Hong Kong, as category A manager,

- Mrs. Emilie Morel, born in Saint-Dié, France, on 31 January 1982, and residing professionally at 40, Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as category B manager, and

- Mr. Wayne Patrick Fitzgerald, born in Waterford, Ireland, on 11 May 1976, and residing professionally at 40, Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as category B manager.

4. To transfer the registered office of the Company from its current location to 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.

5. To amend Article 13 (Meetings of the Board of Managers) of the Articles, which shall forthwith read as follows:

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. If the Company has a single Manager, the latter will exercise the powers

granted by the Law to the Board of Managers.

The Board of Managers may appoint a chairperson (the "Chair") from amongst its members. It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager, to keep minutes of meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet further to a notice sent by the Chair (if any) or at the request of any Manager. The

Chair (if any) will preside over all meetings of the Board of Managers. In the Chair's absence, the Board of Managers may
appoint any Manager as pro tempore chair by a majority vote of those present or represented at the relevant meeting.

Except in urgent cases or with the prior consent of all those entitled to attend the meeting, at least twenty-four hours'

written notice of a Board meeting must be given. Any such notice shall specify the place, date, time and agenda of the
meeting.

The abovementioned notice requirement may be waived unanimously in writing by all Managers, either at the meeting

or otherwise. No separate notice is required for meetings held at a time and place previously approved by the Board of
Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or another location indicated in the notice.
A Manager may appoint in writing another Manager to represent him/her at any meeting of the Board of Managers. A

Manager may represent more than one Manager at a meeting of the Board of Managers.

The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies and obligatorily with at least the presence or the representation of one Category A Manager and one Category
B Manager. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favourable
vote of one Category A Manager and one Category B Manager. In case of ballot, the Chair or, as the case may be, the pro
tempore chair, has a casting vote.

Any Manager may participate in a meeting of the Board of Managers by conference call, videoconference or any other

means  of  communication  allowing  several  persons  to  communicate  simultaneously  with  each  other.  Such  methods  of
participation are considered equivalent to physical presence at the meeting.

A written decision signed by all Managers is proper and valid as if it had been adopted at a duly convened and held

meeting of the Board of Managers. Such a decision can be enacted either in a single document or in several documents
with the same content, each signed by one or more Managers.

The minutes of meetings of the Board of Managers or, as the case may be, written decisions taken by the sole Manager,

or as the case may be, the Board of Managers, shall be drawn up and signed by the Chair or, as the case may be, the pro
tempore chair. Any proxies shall remain appended thereto."

6. Miscellaneous.
Thereupon, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

107840

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVED acknowledge the resignation of the following persons from their position as manager

of the Company, with immediate effect:

- Mr. Benjamin CHOURAKI, category B manager,
- Mr. Marc CHONG KAN, category B manager,
- Mr. Andrew SZAFRAN, category A manager,
- Mr. Jonathan GAMSE, category A manager,
- Mr. Ronan DESEROUX, category A manager,
- Mr. Eric ISRAEL, category A manager, and
- Mrs. Susan Kay KISSEL, category A manager (all together, the "Resigning Managers").

<i>Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to grant discharge for the performance of their duties as managers to the Resigning

Managers, except in case of fraud, wilful misconduct or criminal offences (décharge), provided however that confirmation
of such discharges is so resolved by the Sole Shareholder when approving the annual accounts for the relevant financial
periods.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to appoint the following persons as new managers of the Company with immediate

effect and for an undetermined period:

- Mr. Andrew Fitzmaurice, born in Liverpool, United-Kingdom, on 2 October 1960 and residing professionally at Flat

A, 27/F., Aigburth, 12 Tregunter Path, Hong Kong, as category A manager,

- Mr. Graeme Robert Halder, born in Deal, United Kingdom, on 26 December 1962 and residing professionally at Flat

A, 53/F., The Summit, 41C Stubbs Road, Hong Kong, as category A manager,

- Mrs. Emilie Morel, born in Saint-Dié, France, on 31 January 1982, and residing professionally at 40, Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as category B manager, and

- Mr. Wayne Patrick Fitzgerald, born in Waterford, Ireland, on 11 May 1976, and residing professionally at 40, Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as category B manager.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to transfer the registered office of the Company from its current location to 40,

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to amend Article 13 (Meetings of the Board of Managers) of the Articles, which

shall forthwith read as follows:

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. If the Company has a single Manager, the latter will exercise the powers

granted by the Law to the Board of Managers.

The Board of Managers may appoint a chairperson (the "Chair") from amongst its members. It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager, to keep minutes of meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet further to a notice sent by the Chair (if any) or at the request of any Manager. The

Chair (if any) will preside over all meetings of the Board of Managers. In the Chair's absence, the Board of Managers may
appoint any Manager as pro tempore chair by a majority vote of those present or represented at the relevant meeting.

Except in urgent cases or with the prior consent of all those entitled to attend the meeting, at least twenty-four hours'

written notice of a Board meeting must be given. Any such notice shall specify the place, date, time and agenda of the
meeting.

The abovementioned notice requirement may be waived unanimously in writing by all Managers, either at the meeting

or otherwise. No separate notice is required for meetings held at a time and place previously approved by the Board of
Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or another location indicated in the notice.
A Manager may appoint in writing another Manager to represent him/her at any meeting of the Board of Managers. A

Manager may represent more than one Manager at a meeting of the Board of Managers.

The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies and obligatorily with at least the presence or the representation of one Category A Manager and one Category
B Manager. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favourable
vote of one Category A Manager and one Category B Manager. In case of ballot, the Chair or, as the case may be, the pro
tempore chair, has a casting vote.

107841

L

U X E M B O U R G

Any Manager may participate in a meeting of the Board of Managers by conference call, videoconference or any other

means  of  communication  allowing  several  persons  to  communicate  simultaneously  with  each  other.  Such  methods  of
participation are considered equivalent to physical presence at the meeting.

A written decision signed by all Managers is proper and valid as if it had been adopted at a duly convened and held

meeting of the Board of Managers. Such a decision can be enacted either in a single document or in several documents
with the same content, each signed by one or more Managers.

The minutes of meetings of the Board of Managers or, as the case may be, written decisions taken by the sole Manager,

or as the case may be, the Board of Managers, shall be drawn up and signed by the Chair or, as the case may be, the pro
tempore chair. Any proxies shall remain appended thereto."

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euros (EUR 1.500,-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing party's proxyholder known to the notary by name, first name, civil

status and residence, the appearing party's proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de juin,
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Meritas (Gibraltar) Holdings Limited, une société à responsabilité limitée constituée et enregistrée selon les lois de

Gibraltar, ayant son siège social à 28 Irish Town, Gibraltar, et enregistrée auprès du Registre des Sociétés de Gibraltar sous
le numéro 98190 (l'"Associé Unique"),

représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 25 juin 2015, qui après avoir été paraphée et signée "ne

varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare qu'il détient actuellement toutes les parts sociales de

Meritas Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, par un
acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant alors à Mersch, du 27 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 674 du 21 avril 2007, ayant son siège social à 6, Rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg,, ayant un capital social de 41.916.000 EUR et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 124415 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la
dernière fois par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant alors à Mersch, du 3 mai 2007 publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2249 du 9 octobre 2007.

L'Associé Unique, a déclaré avoir été entièrement informé des résolutions devant être adoptées sur la base de l'agenda

suivant:

<i>Agenda

1. Prendre connaissance de la démission des personnes suivantes de leur poste de gérant de la Société, avec effet im-

médiat:

- M. Benjamin CHOURAKI, gérant de catégorie B,
- M. Marc CHONG KAN, gérant de catégorie B,
- M. Andrew SZAFRAN, gérant de catégorie A,
- M. Jonathan GAMSE, gérant de catégorie A,
- M. Ronan DESEROUX, gérant de catégorie A,
- M. Eric ISRAEL, gérant de catégorie A, et
- Mme. Susan Kay KISSEL, gérante de catégorie A.
2. Accorder la décharge pour l'exercice de leurs fonctions en tant que gérants aux gérants démissionnaires mentionnés

au point 1. du présent ordre du jour, sauf en cas de fraude, de fautes intentionnelles ou d'infractions pénales, à condition
toutefois que ces décharges soient ainsi décidées par l'Associé Unique lors de l'approbation des comptes annuels pour les
exercices donnés.

107842

L

U X E M B O U R G

3. Nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat et pour une période

indéterminée:

- M. Andrew Fitzmaurice, né à Liverpool, Royaume-Uni, le 2 octobre 1960 et ayant sa résidence professionnelle à Flat

A, 27/F., Aigburth, 12 Tregunter Path, Hong Kong, en tant que gérant de catégorie A,

- M. Graeme Robert Halder, né à Deal, Royaume-Uni, le 26 décembre 1962 et ayant sa résidence professionnelle à Flat

A, 53/F., The Summit, 41C Stubbs Road, Hong Kong, en tant que gérant de catégorie A,

- Mme. Emilie Morel, née à Saint-Dié, France, le 31 janvier 1982, et ayant sa résidence professionnelle à 40, Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de catégorie B, et

- M. Wayne Patrick Fitzgerald, né à Waterford, Irlande, le 11 mai 1976, et ayant sa résidence professionnelle à 40,

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B.

4. Transférer le siège social de la Société de sa localisation actuelle au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

5. Modifier l'article 13 (Réunions du Conseil de Gérance) des Statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir

octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance pourra choisir parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un

secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président (le cas échéant) ou à la demande d'un Gérant. Le Président

(le cas échéant) présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance. En son absence, le Conseil de Gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes ou représentées à une telle réunion un Gérant en tant que président pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute

réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation
indiquera le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion.

II pourra être renoncé à cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une

convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit préalablement approuvés par
le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Un Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme

son mandataire. Un Gérant peut représenter plus d'un Gérant.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est

présente ou représentée par procurations et avec obligatoirement au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie
B présent ou représenté. Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à la majorité simple, avec au moins le vote
affirmatif d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B. En cas de ballotage, le Président ou, le cas échéant, le
président pro tempore, a un vote prépondérant.

Chaque Gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

tout moyen de télécommunication permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une
avec l'autre. De telles méthodes de participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à
la réunion.

Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée

à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Les procès-verbaux de la réunion du Conseil de Gérance ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant unique,

doivent être établies par écrit et signées par tous le Président ou le cas échéant, par le président pro tempore. Toutes les
procurations seront annexées."

6. Divers.
Là-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique a DECIDE de prendre connaissance de la démission des personnes suivants de leur poste de gérant

de la Société, avec effet immédiat:

- M. Benjamin CHOURAKI, gérant de catégorie B,
- M. Marc CHONG KAN, gérant de catégorie B,
- M. Andrew SZAFRAN, gérant de catégorie A,
- M. Jonathan GAMSE, gérant de catégorie A,
- M. Ronan DESEROUX, gérant de catégorie A,
- M. Eric ISRAEL, gérante de catégorie A, et

107843

L

U X E M B O U R G

- Mme. Susan Kay KISSEL, gérant de catégorie A (ensemble, les "Gérants Démissionnaires").

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a DECIDE d'accorder la décharge pour l'exercice de leurs fonctions en tant que gérants aux Gérants

Démissionnaires, sauf en cas de fraude, de fautes intentionnelles ou d'infractions pénales, à condition toutefois que ces
décharges soient ainsi décidées par l'Associé Unique lors de l'approbation des comptes annuels pour les exercices donnés.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique a DECIDE de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet

immédiat et pour une période indéterminée:

- M. Andrew Fitzmaurice, né à Liverpool, Royaume-Uni, le 2 octobre 1960 et ayant sa résidence professionnelle à Flat

A, 27/F., Aigburth, 12 Tregunter Path, Hong Kong, en tant que gérant de catégorie A,

- M. Graeme Robert Halder, né à Deal, Royaume-Uni, le 26 décembre 1962 et ayant sa résidence professionnelle à Flat

A, 53/F., The Summit, 41C Stubbs Road, Hong Kong, en tant que gérant de catégorie A,

- Mme. Emilie Morel, née à Saint-Dié, France, le 31 janvier 1982, et ayant sa résidence professionnelle à 40, Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de catégorie B, et

- M. Wayne Patrick Fitzgerald, né à Waterford, Irlande, le 11 mai 1976, et ayant sa résidence professionnelle à 40,

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique a DECIDE de transférer le siège social de la Société de sa localisation actuelle au 40, Avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique a DECIDE de modifier l'article 13 (Réunions du Conseil de Gérance) des Statuts, qui aura dorénavant

la teneur suivante:

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir

octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance pourra choisir parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un

secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président (le cas échéant) ou à la demande d'un Gérant. Le Président

(le cas échéant) présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance. En son absence, le Conseil de Gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes ou représentées à une telle réunion un Gérant en tant que président pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute

réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation
indiquera le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion.

II pourra être renoncé à cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une

convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit préalablement approuvés par
le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Un Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme

son mandataire. Un Gérant peut représenter plus d'un Gérant.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est

présente ou représentée par procurations et avec obligatoirement au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie
B présent ou représenté. Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à la majorité simple, avec au moins le vote
affirmatif d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B. En cas de ballotage, le Président ou, le cas échéant, le
président pro tempore, a un vote prépondérant.

Chaque Gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

tout moyen de télécommunication permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une
avec l'autre. De telles méthodes de participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à
la réunion.

Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée

à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Les procès-verbaux de la réunion du Conseil de Gérance ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant unique,

doivent être établies par écrit et signées par tous le Président ou le cas échéant, par le président pro tempore. Toutes les
procurations seront annexées."

107844

L

U X E M B O U R G

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de cet acte sont

estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état

civil et demeure, ce mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 30 juin 2015. GAC/2015/5495. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 3 juillet 2015.

Référence de publication: 2015109538/318.
(150119121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.

EGC 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 198.147.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of the month of June;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

APPEARED:

The public limited company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “FINEX.LU

S.A. SOPARFI”, with registered office in L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, registered with the Trade and
Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 144705,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean

Engling, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne
varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded
with it.

Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association of a

private limited liability company (“Gesellschaft mit beschränkter Haftung”) to establish as follows:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There is hereby established a private limited company („Gesellschaft mit beschränkter

Haftung“) under the name “EGC 3 SARL” (hereinafter the “Company”) governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles”).

Art. 2. Purpose.
2.1 The object of the Company is the administration of the Company's own assets, the acquisition of participations,

interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests
and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2 The Company may borrow and raise funds in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private

placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds
including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities such as, among others, the providing of loans and
the granting of guarantees or securities in any kind or form, to its subsidiaries or companies in which it has a direct or
indirect interest, even not substantial, or to any company being a direct or indirect corporate unit holder of the Company
or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Affiliated Companies”).
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Affiliated Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create securities over all or over
some of its assets.

107845

L

U X E M B O U R G

2.3 Furthermore, the Company may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other

intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.

2.5 The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect invest-

ments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting,
dividing, exhausting, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6 The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not restrictive.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of corporate unit

holders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered' office.
4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-

bourg).

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of corporate unit holders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of asso-
ciation.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Corporate capital - Corporate units

Art. 5. Corporate Capital.
5.1 The corporate capital is set at twelve thousand six hundred Euros (12,600.- EUR), represented by one hundred twenty

six (126) corporate units with a nominal value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

5.2 The Company’s capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of corporate unit holders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own corporate units.

Art. 6. Corporate units.
6.1 The Company’s capital is divided into corporate units, each of them having the same nominal value.
6.2 The corporate units of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several corporate unit holders, with a maximum of forty (40) corporate unit holders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the corporate unit holders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of corporate units - Transfer of corporate units.
7.1 A register of corporate unit holders shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available

for inspection by any corporate unit holder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates
of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant corporate unit holder.

7.2 The Company will recognise only one holder per corporate unit. In case a corporate unit is owned by several persons,

they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to
suspend the exercise of all rights attached to that corporate unit until such representative has been appointed.

7.3 The corporate units are freely transferable among corporate unit holders.
7.4 Inter vivos, the corporate units may only be transferred to new corporate unit holders subject to the approval of such

transfer given by the corporate unit holders at a majority of three quarters of the corporate capital.

7.5 Any transfer of corporate units shall become effective towards the Company and third parties through the notification

of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the corporate units of the deceased corporate unit holder may only be transferred to new

corporate unit holders subject to the approval of such transfer given by the surviving corporate unit holders at a majority

107846

L

U X E M B O U R G

of three quarters of the corporate capital. Such approval is, however, not required in case the corporate units are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased corporate unit holder.

C. Decisions of the corporate unit holders

Art. 8. Collective decisions of the corporate unit holders.
8.1 The general meeting of corporate unit holders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

8.2 Each corporate unit holder may participate in collective decisions irrespective of the number of corporate units which

he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) corporate unit holders, collective decisions

otherwise conferred on the general meeting of corporate unit holders may be validly taken by means of written resolutions.
In such case, each corporate unit holder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded
and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole corporate unit holder, such corporate unit holder shall exercise the powers granted to the general

meeting of corporate unit holders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In
such case, any reference made herein to the “general meeting of corporate unit holders” shall be construed as a reference
to the sole corporate unit holder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting
of corporate unit holders shall be exercised by the sole corporate unit holder.

Art. 9. General meetings of corporate unit holders. In case the Company has more than twenty-five (25) corporate unit

holders, at least one general meeting of corporate unit holders shall be held within six (6) months of the end of each financial
year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening
notice of such meeting. Other meetings of corporate unit holders may be held at such place and time as may be specified
in the respective convening notices of meeting. If all of the corporate unit holders are present or represented at a general
meeting of corporate unit holders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior
notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each corporate unit holder is entitled to as many votes as he holds corporate units.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

corporate unit holders are only validly taken in so far as they are adopted by corporate unit holders holding more than half
of the corporate capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the corporate unit
holders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time
by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast
whichever is the fraction of the corporate capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The corporate unit holders may change the nationality of the Company only by unanimous

consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of corporate unit holders (ii) representing three quarters of the corporate capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of corporate unit holders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of corporate unit holders which shall determine their

remuneration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the corporate unit holders representing more than half of the Company’s corporate capital.

14.3 The general meeting of corporate unit holders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being

class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the
relevant corporate unit holders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

107847

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of corporate unit holders which shall resolve on
the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of corporate unit holders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of corporate unit holders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
corporate unit holders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such
minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman, if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of corporate unit holders has appointed
different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by
one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the individual signature of any manager.

The Company may also be bound by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory

power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

107848

L

U X E M B O U R G

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) corporate unit holders, the operations of the

Company shall be supervised by one or several internal auditors (Rechnungskommissar(e)). The general meeting of cor-
porate unit holders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of corporate unit holders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the corporate unit holders of the Company appoint one or more independent qualified auditors (unabhängige(r)

qualifizierte(r) Wirtschaftsprüfer) in accordance with article 69 of the law of December 19, 2002 regarding the trade and
companies’ register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor
(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of corporate unit holders with cause or with

its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the corporate capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a corporate unit holder may also be allocated to the legal reserve

if the contributing corporate unit holder agrees with such allocation.

22.4 In case of a corporate capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the corporate capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of corporate unit holders shall determine

how the remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the corporate unit holders in proportion to the number of corporate units they hold

in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the corporate

unit holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of corporate unit
holders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise pro-
vided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities
of the Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the corporate unit holders in proportion to the number of corporate units of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitory disposition

The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and ends on December 31, 2015.

107849

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the twelve thousand six hundred (12,600) corporate units have been subscribed

by the sole shareholder “FINEX.LU S.A. SOPARFI”, pre-designated and represented as said before, and fully paid up by
the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand six hundred Euros (12,600.- EUR) is
from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who
expressly attests thereto.

<i>Verification

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of

the amended law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Decisions taken by the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the

subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1) The registered office of the Company is established at 25A, Boulevard Royal in L-2449 Luxembourg.
2) The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined duration:
- Przemysław Adam MAZUREK, ‘companies’ director, born in Łódź, Poland, on August 2, 1981, residing in 94-007

Łódź, Maratońska 95 m.72 (Poland);

- Tomasz Michał KĘCERSKI, ‘companies’ director, born in Łódź, Poland, on May 28, 1979 residing in 92-432 Łódź,

Skrzetuskiego 10 m.1 (Poland); and

- Tomasz Jerzy CHMIELECKI, ‘companies’ director, born in Łódź, Poland, on May 15, 1979 residing in 94-221 Łódź,

Złotno 86J (Poland).

<i>Costs and expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

name, first name and residence, the said Proxyholder has signed with Us the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunzehnten Tag des Monats Juni;
Vor dem unterzeichnenden Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Aktiengesellschaft „FINEX.LU S.A.

SOPARFI”, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25A, Boulevard Royal, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 144705,

hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean

Engling, (der „Bevollmächtigte“), auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht, nach
„ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen
bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu gründ-

enden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Gegründet wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung

„EGC 3 SARL“ (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung (die „Statuten“) unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen

und Anteilsscheinen in jeglicher Form in Luxemburg oder im Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile
und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien,
Anteile und andere Genussscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und ganz

107850

L

U X E M B O U R G

allgemein alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen gleich
welcher Art begeben wurden.

2.2 Die Gesellschaft kann Mittel in jeglicher Form, außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot, aufnehmen und

beschaffen. Sie kann - ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung - Notes, Anleihen und Schuldverschreibungen sowie
Schuldtitel und/oder Aktienwerte emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen
und/oder Emissionen von Schuldtiteln, unter anderem die Gewährung von Darlehen, Garantien oder Sicherheiten in jeg-
licher Art und Weise, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesell-
schafter  der  Gesellschaft  oder  einer  zur  gleichen  Gruppe  wie  die  Gesellschaft  gehörenden  Konzerngesellschaft  sind
(nachfolgend als die „verbundenen Unternehmen“ bezeichnet). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicher-
heiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu
besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder
in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.

2.3 Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder sons-

tigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

2.4  Die  Gesellschaft  kann  im  Allgemeinen  alle  Methoden  und  Instrumente  für  ihre  Investitionen  zum  Zwecke  des

effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen
Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.

2.5 Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten

Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb, Ei-
gentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Erschließung,
Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise
von beweglichem Vermögen oder Immobilien.

2.6 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen

Anspruch auf Vollständigkeit.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  durch  Beschluss  des  Rates  der  Geschäftsführer  im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro (12.600,- EUR), aufgeteilt in einhundertsechsund-

zwanzig (126) Anteile zu je einhundert Euro (100,- EUR), welche voll eingezahlt sind.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten

darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

107851

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustim-
mung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen
werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-

lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit
statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in
einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die
Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schrift-
lichen  Konsultation  der  Gesellschafter  nicht  erreicht  wird,  können  die  Anteilseigner  ein  weiteres  Mal  mit  derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1  Die  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer  geleitet.  Falls  die  Gesellschaft  mehrere  Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

107852

L

U X E M B O U R G

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der beziehungsweise die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Be-

züge und Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem  Amt  ausscheidet,  muss  die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-

punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-

ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-

führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2  Sitzungen  des  Rates  der  Geschäftsführer  werden,  falls  vorhanden,  durch  den  Vorsitzenden  des  Rates  der  Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore
ernennen.

17.3  Jeder  Geschäftsführer  kann  an  einer  Sitzung  des  Rates  der  Geschäftsführer  teilnehmen,  indem  er  ein  anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit

107853

L

U X E M B O U R G

der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie
B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B),
werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers wirksam verpflichtet.

Die Gesellschaft kann ebenfalls durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person

(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet
werden.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung ernennt die
Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen  Fassung,  einen  oder  mehrere  unabhängige  qualifizierte  Wirtschaftsprüfer  ernennen,  entfällt  die  Funktion  des
Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-

sellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-

klang  mit  den  gesetzlichen  Anforderungen  ein  Inventar  der  Aktiva  und  Passiva,  eine  Bilanz  und  eine  Gewinn-  und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-

falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

107854

L

U X E M B O U R G

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von
1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an

die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Vorübergehende Bestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die zwölftausendsechshundert (12.600) Anteile durch

„FINEX.LU S.A. SOPARFI“, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt worden,
so dass der Betrag von zwölftausendsechshundert Euro (12.600,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht,
was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Beglaubigung

Der  unterzeichnende  Notar  gibt  hiermit  an,  beglaubigt  und  ausdrücklich  vermerkt  zu  haben,  dass  die  aufgezählten

Bedingungen des Artikels 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hier erfüllt
worden sind.

<i>Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterin

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienen Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-

schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird festgelegt auf 25A, Boulevard Royal in L- L- 2449 Luxemburg.
2) Folgende Personen werden zu Geschäftsführern auf unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Przemysław Adam MAZUREK, August 2, 1981 in Łódź (Polen), wohnhaft in 94-007 Łódź, Maratońska 95 m.

72 (Polen);

- Herr Tomasz Michał KĘCERSKI, geboren Mai 28, 1979 in Łódź (Polen), wohnhaft in 92-432 Łódź, Skrzetuskiego

10 m.1 (Polen); und

- Herr Tomasz Jerzy CHMIELECKI, geboren Mai 15, 1979 in Łódź (Polen), wohnhaft in 94-221 Łódź, Złotno 86J

(Polen).

<i>Kosten und Auslagen

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausend Euro.

107855

L

U X E M B O U R G

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben

genannten erschienen Partei, die vorliegenden Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Fassung; gemäß dem Wunsch derselben erschienen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
deutschen Text, ist die English Fassung maßgebend.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, handelnd wie zuvor er-

wähnt, dem Notar mit Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte mit Uns,
dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré a Luxembourg A.C. 2, le 26 juin 2015. 2LAC/2015/14259. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 3 juillet 2015.

Référence de publication: 2015108608/598.
(150118675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.

Ikano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R.C.S. Luxembourg B 87.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015108763/9.
(150118145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.

KIO Exploration Liberia, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 164.285.

Le bilan consolidé de la société Anglo American plc au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 juillet 2015.

Référence de publication: 2015112329/11.
(150119627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2015.

EOS Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 126.923.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 08 mai 2015

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg, représentée par Anne-Marie GOFFINET, Messieurs Olivier

MASSE, Baudouin DU PARC LOCMARIA et Georges JACOBS, en qualité d’administrateurs, pour le terme d’un an,
prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016,

2. de réélire KPMG Luxembourg, Société Coopérative, en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour le terme d’un an,

prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.

Luxembourg, le 6 juillet 2015.

<i>Pour EOS INVESTMENT SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S. A.
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2015108615/18.
(150118670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

107856


Document Outline

ABLV Bank Luxembourg S.A.

Achem S.A.

Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg II

Agilis Engineering S.A.

Agilis Engineering S.A.

Aljo Property S.A.

Allandis

Almond S.àr.l..

Alpha P.S. S.A.

Anglo Coal International

Anglo Loma Investments

Anglo Loma Investments

Anglo Operations (International) Limited

Anglo Operations (International) Limited

Aqua Sanus S.à r.l.

Arendt Services S.A.

Argenta Holdings S.à r.l.

Artal International Management S.A.

Assessor Invest S.A.

Auda Capital Feeder SCA SICAV-SIF

Auda Capital SCS SICAV-SIF

EGC 3 S.à r.l.

EOS Investment Sicav

Eurofresh Luxembourg I S.à r.l.

FOSCA II Manager S.à r.l.

Iginio S.A.

Ikano S.A.

JBBK Verwaltungs S.à r.l.

Keiryo Packaging S.A.

Kensington Square Holding S.A.- Société de Titrisation

King Airshare

KIO Exploration Liberia

Koch Nitrogen Finance Luxembourg S.àr.l.

MAG Investments S.à r.l.

Meritas Luxembourg Holding S.à.r.l.

newLIFE Aesthetic S.à r.l.

Oeno-Invest Advisory S.C.P.A.

Perseus Immobilien Gesellschaft 8

Sam HWA Steel S.A.

Silicon Motion Technology (Luxembourg) Limited

SiXBTO Investments S.A.

Steinhäuser Participations, S.A.

Tossebierg I S.A.