This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2199
24 août 2015
SOMMAIRE
A.C.I. Roads S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105510
A.C.I. Wines S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105510
Agence Immobilière du Luxembourg S.A. . . .
105508
Agrochim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105510
Apollo HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105514
Arche Associates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105509
Argyle Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105508
Assembly Team Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
105508
B28 Beat Weight s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105511
BAF LATAM REAL ASSETS FUND . . . . . . .
105508
Capac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105545
Cetrel Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105510
Clayax Acquisition Luxembourg 5 . . . . . . . . .
105507
Computer Associates Luxembourg S.à r.l. . . .
105509
Corporate Executive Board Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105511
Crevest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105548
eBay International Treasury Center 2 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105509
Ethna-DEFENSIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105543
Fate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105547
FCP OP Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105543
Gestman S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105544
Goodman Lemon Logistics (Lux) S.à r.l. . . . .
105506
Goodman Princeton Investments (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105551
Kantec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105512
Kennametal Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
105513
Kestrel Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
105511
Letzre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105506
LFPI Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105506
Multimedia Global Finance S.A. . . . . . . . . . . .
105550
OCM Luxembourg POF IV GLP Blocker S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105506
Pamiga Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105552
Revetas GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105534
RH Paris 2 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105507
Schaeffer Marketing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
105507
SEA Glass S.à r.l.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105543
Selp (Bischofsheim II) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
105507
Selp (Bischofsheim I) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
105506
SES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105551
SGC Energia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105544
Simelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105507
SINEK Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105551
Singulier Pluriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105552
Société de Promotion et de Développement de
l'Aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
105511
Swan Investment Company . . . . . . . . . . . . . . .
105543
TCP Lux Eurinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
105552
Techniplan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105546
Tiar Publications S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105543
Trinacria Capital S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105547
Turf Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105552
Universal Strategy Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105547
Vauban Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
105513
Victory Asset Management S.A. . . . . . . . . . . . .
105512
Victory Asset Management S.A. . . . . . . . . . . . .
105512
Vida Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105551
Wedidit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105513
Weisgerberarchitecte S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
105513
Z-Wind S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105512
105505
L
U X E M B O U R G
Goodman Lemon Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 162.350.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100463/9.
(150110459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
OCM Luxembourg POF IV GLP Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 133.293.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2015.
Référence de publication: 2015100672/10.
(150110219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Letzre, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 49.760.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société LETZRE
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2015100584/11.
(150110256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
LFPI Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.639.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LFPI Property S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015100586/11.
(150110861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Selp (Bischofsheim I) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 188.775.
Par résolutions signées en date du 16 juin 2015, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société
du 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 35-37, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg avec effet au 30
juin 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2015.
Référence de publication: 2015103408/13.
(150112981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
105506
L
U X E M B O U R G
RH Paris 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.140,00.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 136.968.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015103352/9.
(150112921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Schaeffer Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 26-30, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 32.372.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SCHAEFFER MARKETING S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015103396/10.
(150112416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Simelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang.
R.C.S. Luxembourg B 143.095.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 30 juin 2015.
Référence de publication: 2015103376/10.
(150113438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
Clayax Acquisition Luxembourg 5, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 161.832.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2014 de sa société
mère, Spie BondCo 3 S.C.A. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2015.
Référence de publication: 2015103722/12.
(150114012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
Selp (Bischofsheim II) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 188.777.
Par résolutions signées en date du 16 juin 2015, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société
du 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 35-37, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg avec effet au 30
juin 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2015.
Référence de publication: 2015103409/13.
(150112980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.
105507
L
U X E M B O U R G
Assembly Team Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9779 Eselborn, 20, Op der Sang.
R.C.S. Luxembourg B 185.420.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015103621/10.
(150113823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
Argyle Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.745.
Les statuts coordonnés au 1
er
juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015103613/11.
(150114504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
Agence Immobilière du Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 158.501.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2015.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2015103632/14.
(150113568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
BAF LATAM REAL ASSETS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stûmper.
R.C.S. Luxembourg B 189.315.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 29 juin 2015i>
L'assemblée décide à l'unanimité des voix de révoquer José Frene, né le 26 octobre 1973 à Buenos Aires, Argentine
avec adresse professionnelle World Trade Center FZ Tower, Dr. Luis Bonavita 1294, 22
nd
Floor, (CP 11300) Montevideo,
Uruguay en tant qu'administrateur de la Société, de révoquer Dominik Kurt, né le 29 avril 1984 à Basel, Suisse avec adresse
professionnelle à Totentanz 1, 4051, Basel Suisse en tant qu'administrateur de la Société, de nommer Mr Alain Leonard,
né le 18 mars 1968 à Ixelles, Belgique avec adresse professionnelle 7A, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg, en
tant qu'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui doit se tenir en 2016 et de nommer Mr Donald
Villeneuve, né le 23 avril 1963 à Quebec, Canada avec adresse professionnelle 7A, rue Robert Stümper, L -2557 Luxem-
bourg en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui doit se tenir en 2016.
Luxembourg, le 29 juin 2015.
<i>Pour BAF LATAM REAL ASSET FUND
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015103682/19.
(150114644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
105508
L
U X E M B O U R G
Arche Associates, Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 172.756.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015103612/9.
(150114281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
Computer Associates Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.463.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 103.372.
En date du 26 juin 2015, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Démission de Martin Paul Galliver, de son poste de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 22 mai 2015;
- Nomination de Jana Strischek, née le 12 juin 1975 à Potsdam, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle le 46A,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B avec effet au 23 mai 2015 et
pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Computer Associates Luxembourg S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015103728/17.
(150113719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
eBay International Treasury Center 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 183.681.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 11 juin 2015i>
L'associé unique prend acte des démissions de M. Omar Paz, de M. Fiachre O'Neill et de Mme Meredith Vance de leurs
mandats de gérant de la Société avec effet au 8 juin 2015.
<i>Conseil de gérancei>
En date du 11 juin 2015, l'associé unique a décidé de nommer comme gérant de la Société, avec effet au 8 juin 2015, et
pour une durée indéterminée:
- Mme Winkie Choi, née le 19 décembre 1972 à Hong Kong, Chine, demeurant professionnellement au 22-24, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, gérant;
- M. Michael Verlaque, né le 11 décembre 1968 à Ravensden, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 22-24,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, gérant; et
- Mme Cynthia Tornsey, née le 27 novembre 1959 en Californie, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement
au 2211 North First Street, San Jose, CA 95131, Etats-Unis d'Amérique, gérant.
En conséquence de quoi, le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Winkie Choi, gérant;
- M. Michael Verlaque, gérant; et
- Mme Cynthia Tornsey, gérant;
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
eBay International Treasury Center 2 S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015103580/28.
(150113896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
105509
L
U X E M B O U R G
A.C.I. Roads S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.153.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015103588/11.
(150113522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
A.C.I. Wines S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.154.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26.06.2015.
Référence de publication: 2015103590/11.
(150113538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
Agrochim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.935.
<i>Extrait de résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 26 juin 2015i>
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Rainer Konrad KRAUS de sa fonction d'administrateur
de classe C avec effet immédiat.
Conformément aux dispositions de l'article 14.1 des statuts, l'actionnaire de catégorie C nomme Monsieur George
SHEKRILADZE, demeurant professionnellement à 0159 Tbilisi (Georgie), Paichadze Street, III Block, Digomi Township,
à la fonction d'administrateur de classe C jusqu'à l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015103634/14.
(150113564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
Cetrel Securities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 117.298.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société en date du 13 mai 2015i>
En date du 13 mai 2015, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de renouveler les mandats d'Ad-
ministrateurs de la Société des personnes ci-dessous, dont le mandat s'achèvera à la fin de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires de la Société approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2015.
- M. Roland Ludwig;
- Mme. Annette Brewer;
- M. Jörg Buser.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2015.
<i>Pour CETREL Securities S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015103718/18.
(150113832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
105510
L
U X E M B O U R G
B28 Beat Weight s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4832 Rodange, 408, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 142.227.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015103708/10.
(150113911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
Société de Promotion et de Développement de l'Aéroport de Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1499 Luxembourg, 4, place de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 57.494.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015105341/11.
(150115576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2015.
Kestrel Participations S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 68.698.
EXTRAIT
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision du Conseil d'Administration en date du 12 février 2015, ROOSEVELT SERVICES S.A., société anonyme,
15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B-42.411, a été nommée dépositaire
des actions au porteur de la société KESTREL PARTICIPATIONS S.A..
Luxembourg, le 6 juillet 2015.
<i>Pour la société KESTREL PARTICIPATIONS S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2015108015/15.
(150118413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Corporate Executive Board Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.531.
Suite aux résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 25 juin 2015, les décisions suivantes ont été
prises:
1. Démission de Monsieur Patrick Leonardus Cornells van Denzen de sa fonction de Gérant B de la Société, à compter
du 25 juin 2015.
2. Nomination de Madame Martha Sofia Caballero Elizondo, née le 12 novembre 1981 à Nuevo Leon, au Méxique, et
ayant pour adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Gérant B de la Société
à compter du 25 juin 2015 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Martha Caballero
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015103731/18.
(150114349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
105511
L
U X E M B O U R G
Victory Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 120.438.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015107134/9.
(150116945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.
Z-Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 139.949.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TCG Gestion SA
Signatures
Référence de publication: 2015107149/11.
(150117207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.
Kantec, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 82, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 118.316.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Kantec
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015107998/12.
(150118521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Victory Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 120.438.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2015i>
L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui
se tiendra en 2015 et approuvant les comptes de l'exercice 2014:
- S.A.R. le Prince Guillaume de Luxembourg, demeurant 53, rue des Prés, L-5316 Contern
- Monsieur Jean-Philippe Hottinger, demeurant 21, Hottingersstrasse, CH-8024 Zurich
- Monsieur Eric Sauzedde, demeurant 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
- Monsieur Jean-Conrad Hottinger, demeurant 21, Hottingersstrasse, CH-8024 Zurich
- Monsieur Philippe Cerf, demeurant 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
- Monsieur Jean-François Blouet, demeurant 10, rue Remusat, F-75016 Paris
- Monsieur Franck Provost, demeurant 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
- Monsieur Stanley Yu-Chung Chou, demeurant 61, South Bay Road, HK Hong-Kong
Le mandat de Monsieur Eric Sauzedde en tant que Président du Conseil d'Administration est renouvelé jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015 et approuvant les comptes 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015107135/22.
(150117583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.
105512
L
U X E M B O U R G
Wedidit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.144.012,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 182.396.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015107140/9.
(150117521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.
Vauban Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 10, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 75.531.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
Référence de publication: 2015107131/10.
(150117639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.
Weisgerberarchitecte S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 86, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 107.607.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015107141/10.
(150116970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.
Kennametal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 599.938,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 139.714.
Par décision suivante du 22 juin 2015 les associés de la Société ont décidé à l'unanimité de transférer 271.481 parts
sociales de la Société détenues par Kennametal Inc., une société constituée et existant valablement selon les lois de Penn-
sylvanie, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1600 Technology Way, Latrobe, Pennsylvanie 15650, Etats-
Unis d'Amérique à Kennametal Holdings Europe Inc., une société constituée et existant valablement selon les lois de l'Etat
du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis
d'Amérique et inscrite auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 3213757.
Par décision suivante du 22 juin 2015, les associés de la Société ont ensuite décidé de transférer les 271.481 parts sociales
détenues par Kennametal Holdings Europe Inc., précité, à Kennametal Holdings, LLC Luxembourg S.C.S., une société en
commandite simple valablement constituée et existante sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.217.
Enfin, conformément à un contrat d'apport en date du 22 juin 2015, Kennametal Holdings, LLC Luxembourg S.C.S.,
précité, a transféré les 271.481 parts sociales qu'il détenait dans la Société à Kennametal Luxembourg Holding S.à. r.l. ,
une société à responsabilité limitée valablement constituée et existante sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 43, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, et enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.168
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015108005/25.
(150118140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.
105513
L
U X E M B O U R G
Apollo HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 172.233.
PROPOSAL FOR A CROSS-BORDER MERGER
The management boards of:
1. Cidron Ollopa B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered seat in Amsterdam (the Nether-
lands) and its business office at Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam (the Netherlands), registered with the trade
register of the Dutch Chambers of Commerce under number 63393883 (the "Acquiring Company"); and
2. Apollo HoldCo S.à r.l. a private limited company (société a responsabilité limitée) validly existing under the laws of
the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in 29 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 172.233,
(the "Disappearing Company"),
- the Acquiring Company and the Disappearing Company hereinafter jointly referred to as: the "Merging Companies",
Whereas:
(A) the management board of the Acquiring Company and the management board of the Disappearing Company consider
it desirable that the Merging Companies should merge in order to reduce the number of companies within the Cidron Ollopa
acquisition structure and to decrease the overall operating and administrative costs, such in accordance with Section 2:309
et seq. jo. Title 3A of Book 2 of the Dutch Civil Code ("DCC"), Article 257 et seq. of the Luxembourg law dated 10 August
1915 on commercial companies as amended from time to time ("LSC") and the provisions of the Directive 2005/56/EC of
the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies
(the "Directive") and the provisions of the Directive, as a result of which:
(i) the Disappearing Company will cease to exist;
(ii) the Acquiring Company will acquire the assets and liabilities of the Disappearing Company under a universal title
of succession; and
(iii) the shares in the capital of the Disappearing Company will be cancelled and no new shares will be allocated by the
Acquiring Company by way of compensation.
The aforementioned will hereinafter be referred to as: the "Cross-Border Merger";
(B) the Acquiring Company is a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid) incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands and the Disappearing Company is a private
limited company (société à responsabilité limitée) validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg.
The Merging Companies are limited liability companies as referred to in Article 2 of the Directive;
(C) the Merging Companies have their registered office located in two different member states of the European Union
(i.e. the Acquiring Company having its registered seat and its business office in the Netherlands and the Disappearing
Company having its registered office in the Grand-Duchy of Luxembourg). The Cross-Border Merger procedure, as defined
in the relevant provisions of both the Dutch and Luxembourg law which result from the implementation of the Directive,
as well as in the Directive, will be applied to the Cross-Border Merger. The Directive was implemented in the Netherlands
by the law of 27 June 2008, published on 10 July 2008 in the Bulletin of Acts and Decrees (Staatsblad), which took effect
on 15 July 2008, and in Luxembourg by the law of 10 June 2009, published in the Luxembourg Official State Gazette
(Memorial A, Recueil de Legislation) dated 29 June 2009, which took effect at the same date;
(D) the general meeting of the Acquiring Company and the general meeting of the Disappearing Company have not
passed any resolution for voluntary winding up; the Merging Companies are solvent and no court order for compulsory
winding up or suspension of payments (surséance van betaling) has been made in respect of either of them;
(E) the entire issued share capital in the total amount of EUR 106,759,925 of the Disappearing Company, represented
by 106,759,925 shares, is wholly owned by the Acquiring Company. The entire issued share capital in the total amount of
EUR 1 of the Acquiring Company, represented by 1 share, is wholly owned by Cidron Ollopa Holding B.V.;
(F) the share in the capital of the Acquiring Company and the shares in the capital of the Disappearing Company are
paid up in full; no depository receipts have been issued for said shares, none of said shares are encumbered with any usufruct
and none of said shares are subject to any attachment or lien; the shares in the capital of the Disappearing Company are
not encumbered with a right of pledge, the share in the capital of the Acquiring Company is encumbered with a right of
pledge in favour of Natixis;
(G) no new shares are issued by the Acquiring Company or are exchanged against shares of the Disappearing Company
and in view of the fact stated under (E) and in view of the fact the provisions of Section 2:333 paragraph 1 jo. 2:308
paragraph 3 DCC, Article 278 LSC and Article 15 paragraph 1 of the Directive apply to the intended Cross-Border Merger,
no accountant or independent expert as referred to in Section 2:328 jo 2:393 DCC and Article 278 paragraph 1 LSC jo.
Article 266 LSC has been appointed, respectively no merger audit or independent expert report on the Cross-Border Merger
must be conducted. Sections 2:326 DCC up to and including 2:328 DCC and Article 266 LSC do not apply;
105514
L
U X E M B O U R G
(H) neither the Acquiring Company nor the Disappearing Company have a statutory duty to institute a works council
(ondernemingsraad);
(I) the Cross-Border Merger does not constitute a notifiable concentration in the terms of the Competition Act ("Me-
dedingingswet"); and
(J) the Disappearing Company does not own real estate.
Data to be mentioned pursuant to Section 2:312 paragraph 2 jo. Section 2:333d DCC. Article 261 jo. 263 jo. 265 jo. 273
jo. 279 LSC and Article 5 jo. Article 15 of the Directive are as follows:
a. The form, name and registered seat or office of the Merging Companies (Section 2:312 paragraph 2 under a jo. Section
2:333d under a DCC, Article 261 (2) a) LSC and Article 5 under a of the Directive).
1. Cidron Ollopa B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered seat in Amsterdam (the Nether-
lands) and its business office at Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam (the Netherlands), registered with the trade
register of the Dutch Chambers of Commerce under number 63393883; and
2. Apollo HoldCo S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) validly existing under the laws
of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in 29 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 172.233.
b. Articles of association of the Acquiring Company (Section 2:312 paragraph 2 under b DCC, Article 261 (4) a LSC
and Article 5 under i of the Directive). The present articles of association of the Acquiring Company were drawn up by
Anton Arnaud Voorneman, civil-law notary, practicing in Amsterdam (the Netherlands), on 27 May 2015.
The current text of the above-mentioned articles of association is attached to this Cross-Border Merger proposal as
Annex and will not be amended in connection with the Cross-Border Merger and forms an integral part of the present
Cross-Border Merger proposal.
c. Rights given and compensations paid to be chargeable to the Acquiring Company (Section 2:312 paragraph 2 under
c jo. 2:320 DCC, Article 261 (2) f LSC and Article 5 under g of the Directive). As there are no persons who, in any other
capacity than as shareholder, have special rights against the Disappearing Company, such as profit distribution or share
subscription rights, no special rights will be given and no compensations will be paid to anyone in accordance with Section
2:320 DCC.
d. Benefits to be granted to the members of the management boards of both Merging Companies or to third parties in
connection with the Cross-Border Merger (Section 2:312 paragraph 2 under d DCC, Article 261 (2) g) LSC and Article 5
under h of the Directive). No special rights or advantages within the meaning of Section 2:312 paragraph 2 under d DCC
and Article 261 (2) g) LSC are granted to any member of the administrative, representative, supervisory or control bodies
of the Merging Companies, nor to any expert or to any other person involved in the merger. Also, no special measures have
been recommended or are anticipated for these persons.
e. Intentions with regard to the composition of the management board of the Acquiring Company after the Cross-Border
Merger (Section 2:312 paragraph 2 under e DCC). The present composition of the management board of the Acquiring
Company is as follows:
- Andreas Georg Christian Demmel (managing director A); and
- Marcus Jacobus Maria Hollander (managing director A).
There is no intention to change the composition of the management board after the Cross-Border Merger.
f. Date from which the financial data of the Disappearing Company will be accounted for in the annual accounts of the
Acquiring Company (Section 2:312 paragraph 2 under f DCC, Article 261 (2) e) LSC and Article 5 under f of the Direc-
tive). The transfer of the assets of the Disappearing Company shall be effected in the internal relationship between the
Merging Companies and for accounting purposes with effect as from 31 July 2015. As from this date, all actions and
business of the Disappearing Company shall be deemed to be made for the account of the Acquiring Company. The financial
information of the Disappearing Company over the current financial year, up to the moment the merger will take legal
effect, shall be accounted for in the annual accounts of the Acquiring Company.
g. Proposed measures in connection with the conversion of the shareholdership of the Disappearing Company (Section
2:312 paragraph 2 under g DCC and Article 261 (2) b) LSC). No measures will be taken in connection with the transfer of
share ownership pursuant to Section 2:312 paragraph 2 under g DCC and Article 261 (2) b) LSC. For the Cross-Border
Merger no securities or shares will be issued, therefore information with respect to the exchange ratio, the payment on
shares or the date of share ownership is not applicable pursuant to Section 2:333 paragraph 1 DCC and Article 261 (2) b)
LSC.
h. Intentions involving continuance or termination of activities (Section 2:312 paragraph 2 under h DCC). The Acquiring
Company intends to carry on its current activities and those of the Disappearing Company. The Acquiring Company does
not intend to discontinue any activities as a result of the Cross-Border Merger.
105515
L
U X E M B O U R G
i. Approval of the resolution to effect the Cross-Border Merger (Section 2:312 paragraph 2 under i DCC and Article
279 (2) LSC). Pursuant to Section 2:317 paragraph 1 DCC and the articles of association of the Acquiring Company, the
general meeting of the Acquiring Company shall resolve upon the Cross-Border Merger. The approval of any other body
of the Acquiring Company is not required.
Pursuant to Article 263 (1) LSC, the general meeting of the Disappearing Company shall resolve upon the Cross-Border
Merger. The approval of any other body of the Disappearing Company is not required.
j. Consequences of the Cross-Border Merger for the goodwill and the distributable reserves of the Acquiring Company
(Section 2:312 paragraph 4 DCC). The Cross-Border Merger will have no effect on the size of the goodwill and the
distributable reserves of the Acquiring Company.
k. Effect of the Cross-Border Merger on the employment of the employees of the Merging Companies (Section 2:333d
under b DCC, Article 261 (4) b LSC and Article 5 under d of the Directive). The Cross-Border Merger will have no effect
on the employment of the Merging Companies, as the Merging Companies do not employ any personnel and no employee
representatives were elected for the Merging Companies. Therefore, the Cross-Border Merger will not affect the employ-
ment at the level of the Acquiring Company. In particular, the Cross-Border Merger will not lead to any decrease in the
employment level at the Acquiring Company. The actions connected with management of the assets of the Disappearing
Company will be entrusted to the employees of the Acquiring Company, but the scope of these actions will not be signi-
ficantly changed, and consequently will not result in any increase in the employment level at the Acquiring Company.
The merger will not have any effect on employees of subsidiaries of the Merging Companies.
l. Employee participations arrangements (rights) (Section 2:333d under c jo. Section 2:333k DCC, Article 261 (4) c)
LSC and Article 5 under j jo. Article 16 of the Directive). Neither of the Merging Companies have more than 500 employees.
There are no employee participation systems as referred to in Section 2:333k DCC, Article 261 (4) c)
LSC and Article 16 of the Directive within any of the Merging Companies and neither of these systems would be required
by the laws applying to either of the Merging Companies. Therefore, the Acquiring Company will not be required to have
any employee participation system as referred to in Section 2:333k DCC, Article 261 (4) c) LSC and Article 16 of the
Directive and no process of negotiating with a special negotiation body on the establishment of such system have to be
carried out.
m. Information on the evaluation of the assets and liabilities which are transferred in respect of the Cross-Border Merger
(Section 2:333d under d DCC, Article 261 (4) d) LSC and Article 5 under k of the Directive). The transition of the assets
of the Disappearing Company onto the accepting Acquiring Company is made at book value. Pursuant such valuation
method, the value of the assets and liabilities being transferred is estimated at EUR 106,898,493.22. The assets and liabilities
being transferred to the Acquiring Company are disclosed in the accounts of the Disappearing Company, prepared in view
of the Cross-Border Merger.
Since the entire issued share capital of the Disappearing Company is held by the Acquiring Company, no new shares
will be issued, no exchange ratio needs to be determined and no further information on the evaluation of the assets and
liabilities which are transferred is required.
n. Dates of the Merging Companies' accounts used for determination of the conditions of the Cross-Border Merger
(Section 2:333d under e DCC, Article 261 (4) e) LSC and Article 5 under I of the Directive). The balance sheet date of the
accounts of the Merging Companies that are used to establish the conditions of the Cross-Border Merger is:
- for the Acquiring Company 30 June 2015; and
- for the Disappearing Company 30 June 2015.
o. Compensations to the shareholder of the Disappearing Company to be chargeable to the Acquiring Company (Section
2:333d paragraph f jo. Section 2:333h DCC). These provisions do not apply to the Cross-Border Merger, since the Acquiring
Company is the sole shareholder of the Disappearing Company.
p. Explanatory notes/Written report of the management boards of both Merging Companies (Section 2:313 DCC, Article
265 LSC and Article 7 of the Directive). The management boards of the Merging Companies will draw up explanatory
notes in relation to the Cross-Border Merger, explaining and justifying, from a legal, economic and social perspective, the
grounds of the Cross-Border Merger.
q. Filing and publication (Section 2:314 DCC, Article 262 in conjunction with Article 9 LSC and Article 6 of the
Directive). The Cross-Border Merger proposal will be filed with the trade register of the Chamber of Commerce in Ams-
terdam (the Netherlands), the jurisdiction in which the Acquiring Company has its registered office.
The Cross-Border Merger proposal will be filed with the Luxembourg Trade and Companies Register in Luxembourg
(Grand-Duchy of Luxembourg), the place where the Disappearing Company has its registered office.
The Cross-Border Merger proposal, the explanatory notes/written report, the annual accounts, the management reports
of the Merging Companies of the last three financial years (in as far as applicable), and the interim accounts of the Merging
Companies dated 30 June 2015 will be deposited at the offices of the Merging Companies for inspection by the shareholder
(s) of each of the Merging Companies, who may obtain copies thereof, free of charge, at least one month before the date
of the general meeting of the Acquiring Company called to approve the Cross-Border Merger.
105516
L
U X E M B O U R G
A notice of the above acts of filing will be published in the Dutch State Gazette ("Staatscourant"), a Dutch daily news-
paper ("Trouw") and in a Luxembourg Gazette ("Memorial C, Recueil des Sociétés et Association").
r. Language versions. This Cross-Border Merger Proposal has been drawn up in two language versions: English and
French. In the event of any discrepancies between the French version and English version, the English version shall prevail.
s. Miscellaneous. Amendments and supplements to this proposal for the Cross-Border Merger, including this paragraph,
must be made in writing, except to the extent notarization is required.
To the extent that individual provisions of this proposal for the Cross-Border Merger are or become invalid or cannot
be performed, this does not affect the validity of the other provisions. In this case such valid provision shall apply that
comes closest to the economic intentions of the parties signing this proposal for the Cross-Border Merger. The same shall
apply mutatis mutandis in case of gaps.
Drawn up and signed by the members of the management boards of both Merging Companies.
On 18 August 2015.
Cidron Ollopa B.V.
Marcus Jacobus Maria Hollander / Andreas Georg Christian Demmel
<i>Managing director A / Managing director A
i>Apollo HoldCo S.à r.l.
Claes Johan Gustaf Geijer
<i>Manageri>
PROPOSITION EN VUE D'UNE FUSION TRANSFRONTALIÈRE
Les conseils de direction de:
1. Cidron Ollopa B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid),
constituée selon les lois des Pays-Bas et ayant son siège social et son bureau d'affaires sis 201, Barbara Strossilaan, 1083
HN, Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au Registre de Commerce des Chambres néerlandaises sous le numéro 63393883 (la
«Société Acquérant»); et
2. Apollo HoldCo S.à r.l. une société à responsabilité limité, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et ayant son siège social sis 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.233 (la «Société Disparaissant»),
- la Société Acquérant et la Société Disparaissant, ci-après dénommées conjointement: Les «Sociétés Fusionnantes»),
Alors que:
(A) le conseil de direction de la Société Acquérant et le conseil de direction de la Société Disparaissant considèrent qu'il
convient que les Sociétés Fusionnantes devraient fusionner afin de réduire le nombre de Sociétés au sein de l’opération
d'acquisition de Cidron Ollopa et de restreindre les frais d'exploitation et les dépenses administratives, conformément à
Section 2:309 et s. Titre 3A du Livre 2 du Code Civil Néerlandais («DCC»). Article 257 et s. de la loi luxembourgeoise
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, modifiée de temps en temps (“LSC”) et les provisions de la directive
2005/56/EC du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de
capitaux (la «Directive») et les provisions de la Directive, ayant comme conséquence:
(i) la Société Disparaissant cesse d'exister;
(ii) la Société Acquérant acquerra les droits et les obligations de la Société Disparaissant par titre universel de succession;
et
(iii) les actions de la Société Disparaissant seront supprimées et aucune nouvelle action ne sera attribuée par la Société
Acquérant par moyen de compensation.
Le susmentionné sera dénommé ci-après: la «Fusion Transfrontalière»;
(B) La Société Acquérant est une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aanspakelijkheid)
constituée selon les lois des Pays-Bas et la Société Disparaissant est une société à responsabilité limitée et constituée selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg. Les Sociétés Fusionnantes sont des sociétés à responsabilité limitée comme visé
à l’Article 2 de la Directive;
(C) les Sociétés Fusionnantes ont leur siège social dans deux états membres différents de l’Union Européenne (la Société
Acquérant à son siège social et ses bureaux d'affaires aux Pays-Bas et la société Disparaissant a son siège social au Grand-
Duché du Luxembourg). La procédure de Fusion Transfrontalière, comme définie dans les dispositions pertinentes des
deux, la loi néerlandaise et la loi luxembourgeoise, qui résultent de la transposition de la Directive, s'appliquera à la Fusion
Transfrontalière. La Directive a été transposée aux Pays-Bas par la loi du 27 juin 2008, publiée le 10 juillet 2008 dans le
Bulletin des Actes et Décrets (Staatsblad), qui a pris effet le 15 juillet 2008, et au Luxembourg par la loi du 10 juin 2009,
publiée dans La Gazette officielle du Luxembourg (Mémorial A, Recueil de Législation) datée 29 juin 2009, qui a pris effet
à la même date.
(D) L'assemblée générale de la Société Acquérant et l’assemblée générale de la Société Disparaissant n'a aucune réso-
lution concernant la liquidation volontaire; les Sociétés Fusionnantes sont solvables et aucun ordre judiciaire pour une
105517
L
U X E M B O U R G
liquidation judiciaire obligatoire ou une suspension des paiements (surséance van betaling) n'a été pris relatif à une d'entre
elles.
(E) l’entièreté du capital social émis d'un montant de EUR 106.759.925 de la Société Disparaissant, représenté par
106.759.925 actions, est en propriété exclusive de la Société Acquérant. L'entier capital social émis d'un montant total de
EUR 1 de la Société Acquérant, représenté par 1 action, est en propriété entière de Cidron Ollopa Holding B.V.;
F) les actions du capital de la Société Acquérant et les actions du capital de la Société Disparaissant sont entièrement
libérées; aucun certificat représentatif n'a été émis pour les actions décrites, aucune des actions décrites est grevée d'un
usufruit et aucune des actions décrites est sujet d'une saisie ou d'un privilège; les actions de la Société Disparaissant ne sont
pas grevées d'un droit de gage, les actions de la Société Acquérant sont grevées d'un droit de gage en faveur de Natixis;
(G) il ne sera pas émis de nouvelles actions par la Société Acquérant ou échangées contre des actions de la Société
Disparaissant et au regard du fait décrit sous (E) et au regard du fait des dispositions de la Section 2:333 paragraphe 1
conjointement avec 2:308 paragraphe 3 DDC, Article 278 LSC et Article 15 paragraphe 1 de la Directive s'appliquant à la
fusion prévue, aucun comptable ou expert comme précisé à la Section 2:333 jo. 2:308 DDC, Article 278 paragraphe 1 LSC
conjointement avec Article 266 LSC a été désigné, respectivement aucun audit de fusion ou rapport d'un expert indépendant
concernant la Fusion Transfrontalière ne doit être réalisé. Sections 2:328 DDC et Article 266 LSC ne sont pas d'application;
(H) ni la Société Acquérant, ni la Société Disparaissant n'ont l’obligation statutaire d'établir un conseil du travail (on-
dernemingsraad);
(I) la Fusion Transfrontalière ne constitue pas une concentration soumise à notification aux termes de la Loi sur la
Consurrence («Mededingingswet»); et
(J) la Société Disparaissant ne possède pas de biens immobiliers.
Donnés à mentionner en application de Section 2:312 paragraphe 2 conjointement avec Section 2:333d DDC, Article
261 conjointement avec 263 conjointement avec. 265 conjointement avec 273 conjointement avec 279 LSC et Article 5
conjointement avec Article 15 de la Directive comme suit:
a. La forme, le nom et le siège social des Sociétés Fusionnantes (Section 2:312 paragraphe 2 conjointement avec Section
2:333d DDC, Article 261 (2) a) LSC et Article 5 de la Directive).
1. Cidron Ollopa B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid),
constituée selon les lois des Pays-Bas et ayant son siège social sis 201, Barbara Strossilaan, 1083 HN, Amsterdam, Pays-
Bas, inscrite au Registre de Commerce des Chambres néerlandaises sous le numéro 63393883; et
2. Apollo HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limité, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et ayant son siège social sis 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.233
b. Les statuts de la Société Acquérant (Section 2:312 paragraphe 2 sous b DCC, Article 261 (4) a LSC et Article 5 sous
i de la Directive). Les présents statuts de la Société Acquérant ont été établis par Anton Arnaud Voorneman, notaire civil-
pénal, instrument à Amsterdam (Pays-Bas), au 27 Mai 2015.
Le texte actuel des statuts mentionnés ci-avant est annexé à cette proposition de Fusion Transfrontalière en tant qu'An-
nexe et ne sera pas reformé en connexion avec la Fusion Transfrontalière et forme une part intégrale de cette proposition
de Fusion Transfrontalière.
c. Droits accordés et compensations payées à charge de la Société Acquérant (Section 2:312 paragraphe 2 sous c con-
jointement avec 2:320 DCC, Article 261 (2) f LSC et Article 5 sous g de la Directive). Puisqu'il n'y a pas de personne qui,
dans une autre capacité que celle d'actionnaire, a des droits spéciaux à l’égard de la Société Disparaissant, tels que droits
aux répartitions des bénéfices ou droits de souscription, aucun droit spécial ne sera accordé et aucune compensation ne sera
payée à personne conformément à Section 2:320 DCC.
d. Avantages à être accordés aux membres des conseils de direction des deux Sociétés Fusionnantes ou aux parties
tierces en connexion avec la Fusion Transfrontalière (Section 2:312 paragraphe 2 sous d DCC, Article 261 (2) g) LSC and
Article 5 sous h de la Directive). Aucuns droits spéciaux ou avantages au sens prévu de Section 2:312 paragraphe 2 sous
d DCC and article 261 (2) g) LSC ne sont accordés à aucun membre de l’organe administratif, représentatif, de surveillance
ou de contrôle des Sociétés Fusionnantes, ni à tout expert ou toute autre personne impliquée dans la fusion. Egalement,
aucune mesure particulière n'a été recommandée ou sont anticipées pour ces personnes.
e. Intentions au regard de la composition du conseil de direction de la Société Acquérant après la Fusion Transfrontalière
(Section 2:312 paragraphe 2 sous e DDC). La composition actuelle du conseil de gestion de la Société Acquérant:
- Andreas Georg Christian Demmel (managing director A); and
- Marcus Jacobus Maria Hollander (managing director A).
Il n'existe aucune intention de changer la composition du conseil de direction après la Fusion Transfrontalière.
f. Date à partir de laquelle les données financières de la Société Disparaissant seront comptabilisées dans les comptes
annuels de la Société Acquérant (Section 2:312 paragraphe 2 sous f DCC, Article 261 (2) e) LSC et Article 5 sous f de la
Directive). Le transfert des actifs de la Société Disparaissant sera d'effet dans la relation interne entre les Sociétés Fusion-
nantes dès le 31 Juillet 2015. A partir de cette date, toutes les actions et le commerce de la Société Disparaissant seront
105518
L
U X E M B O U R G
réputés être effectués pour le compte de la Société Acquérant. L'information financière de la Société Disparaissant sur
l’année financière en cours, jusqu'au moment où la Fusion prendra effet juridique, devront être comptabilisées dans les
comptes annuels de la Société Acquérant.
g. Les mesures proposées en connexion avec la conversion de l’actionnariat de la Société Disparaissant (Section 2:312
paragraphe 2 sous g DCC et Article 261 (2) b) LSC). Aucunes mesures ne seront prises en connexion avec le transfert de
l’actionnariat en application de Section 2:312 paragraphe 2 sous g DCC et Article 261 (2) b) LSC. Concernant la Fusion
Transfrontalière aucunes sécurités ou actions seront émises, en conséquence l’information relative au ratio d'échange,
le paiement sur actions ou la date de d'actionnariat n'est pas applicable en application de Section 2:333 paragraphe 1 DDC
et Article 261 (2) b) LSC.
h. Intentions concernant la continuité ou la cessation des activités (Section 2:321 paragraphe 2 sous h DDC). La Société
Acquérant entend maintenir ses activités présentes et celles de la Société Disparaissant. La Société Acquérant n'entend pas
mettre fin à aucune des activités en conséquence de la Fusion Transfrontalière.
i. Approbation de la résolution afin de réaliser la Fusion Transfrontalière (Section 2:312 paragraphe 2 sous i DDC et
Article 279 (2) LSC). En application de Section 2:312 paragraphe 1 DDC et des statuts de la Société Acquérant, l’assemblée
générale de la Société Acquérant devra se prononcer sur la Fusion Transfrontalière. L'approbation de tout autre organe de
la Société Acquérant n'est pas requise.
En application de l’Article 263 (1) LSC, l’assemblée générale de la Société Disparaissant devra se prononcer sur la
Fusion Transfrontalière. L'approbation de tout autre organe de la Société Acquérant n'est pas requise.
j. Conséquences de la Fusion Transfrontalière sur l’écart d'acquisition et les réserves distribuables de la Société Ac-
quérant (Section 2:312 paragraphe 4 DDC). la Fusion Transfrontalière n'aura pas d'effet sur la taille de l’écart d'acquisition
et les réserves distribuables de la Société Acquérant.
k. L'effet de la Fusion Transfrontalière sur l’emploi des employées des Sociétés Fusionnantes (Section 2:333d sous b
DCC, Article 261 (4) b LSC et Article 5 sous d de la Directive). La Fusion Transfrontalière n'aura pas d'effet sur l’emploi
des Sociétés Fusionnantes, étant donné que les Sociétés Fusionnantes n'emploient aucun personnel et aucuns employés
représentatifs n'ont été élus pour les Sociétés Fusionnantes. Par conséquent, la Fusion Transfrontalière n'affectera pas
l’emploi au niveau de la Société Acquérant. En particulier, la Fusion Transfrontalière ne mènera à aucune réduction au
niveau de l’emploi de la Société Acquérant. Les actions en connexion avec la gestion des actifs de la Société Disparaissant
seront confiées aux employés de la Société Acquérant, mais l’étendue de ces actions ne sera pas considérablement changée,
et en conséquence il n'en résultera aucune augmentation de l’emploi au niveau de la Société Acquérant.
La fusion n'aura aucun effet sur les employés des filiales des Sociétés Fusionnantes.
l. Modalités relatives à la participation des travailleurs (droits) (Section 2:333d sous c jo. Section 2:333k DCC, Article
261 (4) c) LSC et Article 5 sous j conjointement avec Article 16 de la Directive). Aucune des Sociétés Fusionnantes a plus
que 500 employés. Il existe aucun système de participation représentative comme décrit à la Section 2:333k DCC, Article
261 (4) c) LSC et Article 16 de la Directive dans une des Sociétés Fusionnantes et aucun de ces systèmes est requis par les
lois applicables à une des Sociétés Fusionnantes. En conséquence, la Société Acquérant n'est pas obligée d'avoir un système
de participation d'employé comme précisé à la Section 2:333k DCC, Article 261 (4) c) LSC et Article 16 de la Directive
et aucun processus de négociation avec un organe spécial de négociation sur l’établissement d'un tel système ne doit être
mis en œuvre.
m. Information sur l’évaluation des actifs et passifs qui sont transférés en vertu de la Fusion Transfrontalière (Section
2:333d sous d DCC, Article 261 (4) d) LSC et Article 5 sous k de la Directive). La transition des actifs de la Société
Disparaissant au-dessus de la Société Acquérant acceptante est effectuée à valeur comptable. En application de la méthode
d'estimation, les actifs et passifs transférés sont estimés à EUR 106,898,493.22. Les actifs et passifs transférés à la Société
Acquérant sont exposés dans les comptes de la Société Disparaissant, préparés en vue de la Fusion Transfrontalière.
Etant donné que l’entièreté du capital social émis de la Société Disparaissant est tenu par la Société Acquérant, aucunes
nouvelles actions ne seront issues, aucun ratio d'échange ne devra être déterminé et aucune information ultérieure sur
l’évaluation des actifs et passifs qui sont transférés n'est requise.
n. Dates des comptes des Sociétés Fusionnantes utilisées pour la détermination des conditions de la Fusion Transfron-
talière (Section 2:333d sous e DCC, Article 261 (4) e) LSC et Article 5 sous I de la Directive).
La date du bilan des comptes des Sociétés Fusionnantes qui sont utilisés afin d'établir les conditions de la Fusion
Transfrontalière est:
- pour la Société Acquérant 30 juin 2015; et
- pour la Société Disparaissant 30 juin 2015.
o. Compensations aux actionnaires de la Société Disparaissant imputables à la Société Acquérant (Section 2:333d
paragraphe f conjointement avec Section 2:333h DCC). Ces provisions ne s'appliquent pas à la Fusion Transfrontalière,
étant donné que la Société Acquérant est l’actionnaire de la Société Disparaissant.
105519
L
U X E M B O U R G
p. Notes explicatives/rapport écrit des conseils de direction des deux Sociétés Fusionnantes (Section 2:313 DCC, Article
265 LSC et Article 7 de la Directive). Les conseils de direction des Sociétés Fusionnantes établiront des notes explicatives
en relation avec la Fusion Transfrontalière, expliquant et justifiant, d'un point de vue juridique, économique et social, les
fondements de la Fusion Transfrontalière.
q. Classement et publication (Section 2:314 DCC, Article 262 en conjonction avec Article 9 LSC et Article 6 de la
Directive). La proposition de Fusion Transfrontalière sera classée dans le registre de commerce de la Chambre de Commerce
à Amsterdam (Pays-Bas), la juridiction dans laquelle la Société Acquérant a son siège social.
La proposition de Fusion Transfrontalière sera classée dans le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg au
Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), le lieu où la Société Disparaissant a son siège social.
La proposition de Fusion Transfrontalière, les notes explicatives/rapport écrit, les comptes annuels, les rapports de
gestion des Sociétés Fusionnantes des trois dernières années comptable (pour autant qu'applicable), et les comptes intér-
imaires des Sociétés Fusionnantes datant de 30 juin 2015 seront déposés aux bureaux des Sociétés Fusionnantes, en vue
de l’inspection par les actionnaires de chaque Société Fusionnante, qui peut obtenir des copies de ceux-ci, sans frais, au
moins un mois précédant la date de l’assemblée générale de la Société Acquérant appelée à approuver la Fusion Trans-
frontalière.
Une notice des actes de classement ci-dessus sera publiée dans la Gazette étatique néerlandaise («Staatscourant»), un
journal quotidien néerlandais («Trouw») et dans une Gazette luxembourgeoise («Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association»).
r. Versions linguistiques. Cette proposition de Fusion Transfrontalière a été établie en deux langues: Anglais et Français.
Dans le cas de contradictions entre la version française et la version anglaise, la version anglaise prévaut.
s. Dispositions diverses. Amendements et compléments à cette proposition pour la Fusion Transfrontalière, incluant ce
paragraphe, devront être effectués par écrit, sauf dans la mesure où une notarisation est requise.
Dans la mesure où des dispositions individuelles de cette proposition pour la Fusion Transfrontalière sont ou deviennent
nul ou ne peuvent pas être exécutées, cela n'a pas d'effet sur la validité des autres dispositions. Dans ce cas une telle
disposition valable sera d'application la plus conforme dans l’intérêt des intentions économiques des parties signant cette
proposition pour la Fusion Transfrontalière. Le même sera d'application mutatis mutandis en cas de lacunes.
Etablie et signée par les membres des conseils de direction des deux Sociétés Fusionnantes.
Annex:
Articles of association of the Acquiring Company
TRUE COPY
of the deed of incorporation and the articles of association of the private company with limited liability:
Cidron Ollopa B.V. with statutory seat in Amsterdam
executed on the 27
th
day of May 2015 before Anton A. Voorneman civil law notary in Amsterdam
Annexed: English text of the deed of incorporation and the articles of association
OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Op zevenentwintig mei tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Anton Arnaud Voorneman, notaris te Amsterdam, ver-
schenen:
de heer mr. drs. Guillaume Pierre Mounier, met kantooradres 1083 GV Amsterdam, Axent Janszoon Ernststraat 199,
geboren te Waalwijk op zestien mei negentienhonderd tachtig,
als schriftelijk gevolmachtigde van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Cidron Ollopa Holding B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1083 HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 201, aangeboden
ter inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Voormelde volmacht zal aan deze akte worden gehecht.
De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard hierbij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
Art. 1. Begripsbepalingen. In deze Statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
“aandeel” betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
“aandeelhouder” betekent een houder van één of meer aandelen;
“algemene vergadering” betekent het orgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van
aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten;
“bestuurder” betekent een lid van het bestuur;
“bestuur” betekent het bestuur van de vennootschap;
105520
L
U X E M B O U R G
“schriftelijk” betekent bij brief, telefax of e-mail, of enig ander langs elektronische weg toegezonden leesbaar en re-
produceerbaar bericht;
“uitkeerbare eigen vermogen” betekent het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat groter is dan de
reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden;
“vennootschap” betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze Statuten;
“vergaderrecht” betekent het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te
wonen en daar het woord te voeren.
Art. 2. Naam en zetel.
1. De vennootschap draagt de naam:
Cidron Ollopa B.V.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
Art. 3. Doel. De vennootschap heeft ten doel:
- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en
vennootschappen;
- het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van
ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen;
- het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- het lenen en verstrekken van gelden;
- het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- het exploiteren en verhandelen van octrooien, merken, vergunningen, know-how en intellectuele eigendomsrechten;
- het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Art. 4. Aandelen.
1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen met een nominale waarde van een euro (EUR 1,00)
elk.
2. Ten minste één (1) aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de
vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
3. De aandelen luiden op naam.
4. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven.
Art. 5. Register van aandeelhouders.
1. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met
vermelding van de darum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de darum van erkenning of betekening alsmede met
vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. Op het register is artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Art. 6. Uitgifte van aandelen.
1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover door de
algemene vergadering geen ander orgaan is aangewezen.
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde
notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
3. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen wordt bepaald of aandeelhouders een voorkeursrecht hebben, met inachtneming
van het ter zake in de wet bepaalde.
4. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het
nominale bedrag of een deel daarvan eerste behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de ven-
nootschap het zal hebben opgevraagd. Na oprichting kan storting in een andere geldeenheid dan waarin de nominale waarde
luidt slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.
5. Het bestuur is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering rechtshandelingen aan te
gaan als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
Art. 7. Eigen aandelen.
1. De vennootschap mag - met inachtneming van artikel 4 lid 2 en het dienaangaande in de wet bepaalde - volgestorte
eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen.
2. De vennootschap kent geen vergaderrecht toe aan houders van certificaten van aandelen in haar kapitaal.
105521
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht.
1. Voor de levering van een aandeel, de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde
ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden
rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend
overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.
3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht aan de vruchtgebruiker of de
pandhouder worden toegekend, mits de overgang van stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
Art. 9. Blokkeringsregeling. Aanbieding.
1. Een aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst te vervreemden, is verplicht die aandelen eerst, overeenkomstig
het hierna in dit artikel bepaalde, te koop aan te bieden aan zijn mede-aandeelhouders. Deze aanbiedingsverplichting geldt
niet, indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke
goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is. Evenmin geldt deze aanbiedingsverplichting in het geval
de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
Onder vervreemding wordt onder meer mede begrepen inbreng in en verdeling van enigerlei gemeenschap.
2. De aandeelhouders, die gegadigden zijn voor de aangeboden aandelen, zijn verplicht het bestuur daarvan schriftelijk
in kennis te stellen, onder opgave van het aantal aandelen, dat zij wensen over te nemen, binnen twee maanden na het
aanbod, bij gebreke waarvan zij geacht zullen worden niet gegadigd te zijn voor de aangeboden aandelen. De prijs, waarvoor
de aandelen door de andere aan deelhouders kunnen worden overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn
mede-aandeelhouders.
Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek
van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van het Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(NBA), tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken. De mede-aandeelhouders zijn verplicht
binnen dertig dagen na de prijsvast-stelling aan de aanbieder, bij aangetekend schrijven, mede te delen of en in hoeverre
zij op de aangeboden aandelen reflecteren, onder voorwaarde van contante betaling, bij gebreke waarvan zij geacht worden
het aanbod niet te hebben aanvaard.
3. Indien de mede-aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden
aandelen tussen hen worden verdeeld, zoveel mogelijk in verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, doch
met inachtneming van het aantal aandelen, waarop zij gereflecteerd hebben.
4. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand, nadat hem bekend is aan
welke gegadigde hij al die aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
5. Indien vaststaat, dat de mede-aandeelhouders het aanbod niet aanvaarden of dat niet al de aandelen, waarop het aanbod
betrekking heeft, tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vasts-
telling vrijelijk mogen overdragen.
6. Ingeval van faillissement van een aandeelhouder, van overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon of van
liquidatie of ontbinding van een aandeelhouderrechtspersoon, moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder wor-
den aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het plaatsvinden van de betreffende
gebeurtenis. Indien alsdan op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd, kan het aanbod niet worden ingetrokken.
Art. 10. Bestuur.
1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders A en/of één of meer bestuurders B. Zowel
natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn.
2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en is bevoegd hen te allen tijde te ontslaan of te schorsen.
3. De algemene vergadering stelt de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast.
Art. 11. Bestuurstaak. Besluitvorming.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Het bestuur kan, met inachtneming van deze Statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, hem intern
betreffende, worden geregeld.
3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de
algemene vergadering
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en iedere bes-
tuurder heeft ingestemd met deze wijze van besluitvorming.
6. De algemene vergadering is bevoegd bestuursbesluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits daarvan schriftelijk
opgave wordt gedaan aan het bestuur.
105522
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Vertegenwoordieing.
1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede
aan toe aan een bestuurder A en een bestuurder B, gezamenlijk handelend.
2. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen, waarbij de vennootschap wordt verte-
genwoordigd door deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden
aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.
3. Lid 2 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedungen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoe-
fening van de vennootschap behoren.
Art. 13. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overige bestuurders of is de overige
bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, terwijl ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders
of van de enige bestuurder tijdelijk met het bestuur is belast, de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt
aangewezen. Onder belet wordt te dezen verstaan schorsing en de onmogelijkheid contact te maken gedurende tenminste
zeven dagen wegens ziekte of onbereikbaarheid.
Art. 14. Boekiaar en jaarrekening.
1. Het boekjaar begint op één juli van elk kalenderjaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
2. Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het betrokken boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten
hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden -, wordt door het bestuur
een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
Binnen bedoelde periode worden de jaarrekening en het jaarverslag ten kantore van de vennootschap voor de verga-
dergerechtigden ter inzage neergelegd.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Art. 15. Winst.
1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is
bepaald en tot vaststelling van het uitkeerbare eigen vermogen.
2. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goed-
keuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien
dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de
bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap
hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan
en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
4. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.
Art. 16. Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd of in de
gemeente waar zij haar woonplaats heeft, dan wel te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering gehouden, waarin onder
meer de jaarrekening en de winstbestemming worden vastgesteld, dan wel wordt een besluit genomen overeenkomstig
artikel 21.
Art. 17.
1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door het bestuur niet later dan op de achtste dag vóór die van
de vergadering.
2. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden tot algemene vergaderingen opgeroepen per brief, gezonden
aan de adressen volgens het bij artikel 5 bedoelde register, dan wel met instemming van de vergadergerechtigde op andere
schriftelijke wijze.
Art. 18. Besluitvorming zonder oproeping. Aantekeningen.
1. Wanneer de oproepingstermijn als bedoeld in artikel 17 lid 1 niet is nageleefd of de oproeping niet heeft plaats gehad,
dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de
besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies
uit te brengen.
2. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd
wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de
vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de verga-
dergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen
ten hoogste de kostprijs.
105523
L
U X E M B O U R G
Art. 19.
1. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal kunnen de daaraan verbonden stemrechten door de
vennootschap niet worden uitgeoefend.
Op die aandelen vindt generlei uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
2. Bij de vaststelling van enige meerderheid of enig quorum, vereist bij de besluitvorming van de algemene vergadering,
worden de door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal buiten beschouwing gelaten.
Art. 20.
1. De algemene vergaderingen voorzien zelf in haar voorzitterschap.
2. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
3. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.
4. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere vergadergerechtigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk
gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin
het woord te voeren en -als vergadergerechtigde met stemrecht- het stemrecht uit te oefenen, mits de vergadergerechtigde
via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen
ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
5. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voor-
waarden bij de oproeping bekend gemaakt.
6. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening; artikel 18 lid 2 van deze Statuten is van overeenkomstige
toepassing.
Art. 21. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.
1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergaderge-
rechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk hebben ingestemd. Alle bestuurders worden voorafgaand aan de
besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. leder van de vergadergerechtigden is verplicht er
voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur
worden gebracht.
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen
wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
Art. 22. Statutenwijziging. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, dient
tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van
de vennootschap ter inzage te worden gelegd voor diegenen, die volgens de wet tot inzage zijn gerechtigd, tot de afloop
van de betreffende vergadering.
Art. 23. Vereffening.
1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders
belast met de vereffening van het vermogen van de vennootschap tenzij de algemene vergadering anders besluit.
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van het ter zake in de wet bepaalde.
4. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredi-
gheid van het gezamenlijk bedrag van ieders
5. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten voor zover mogelijk van kracht.
<i>Overganesbepalingi>
Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op dertig juni tweeduizend vijftien. De onderhavige bepaling komt te
vervallen na ommekomst van het eerste boekjaar van de vennootschap.
<i>Slotverklaringeni>
Tenslotte verklaarde de comparant als volgt:
1. Voor de eerste maal worden tot bestuurders A van de vennootschap benoemd:
- de heer Marcus Jacobus Maria Hollander, wonende te 1961 JM Heemskerk, Graaf Willem II laan 12, geboren te
Heemskerk op twee maart negentienhonderd tweeënzestig; en
- de heer Andreas Georg Christian Demmel, wonende te 1054 AB Amsterdam, Nassaukade 367 2, geboren te München,
Duitsland, op elf april negentienhonderd negenenzestig.
2. In het kapitaal van de vennootschap wordt door de oprichter, voornoemd, deelgenomen voor één (1) aandeel, met een
nominale waarde van één euro (EUR 1,00); het geplaatste kapitaal bedraagt: één euro (EUR 1,00).
105524
L
U X E M B O U R G
3. De plaatsing geschiedt à pari. Het nominale bedrag op het aandeel zal eerst in geld worden gestort nadat de vennoot-
schap het zal hebben opgevraagd.
4. De vennootschap verbindt zich tot het betalen van kosten die met de oprichting verband houden.
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud der akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht.
Deze heeft daarna verklaard van de inhoud der akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(w.g.) G.P. Mounier, A.A. Voormeman
VOOR AFSCHRIFT
The undersigned,
Anton Arnaud Voorneman, civil law notary in Amsterdam,
certifies that the attached document is a fair English translation of the deed of incorporation and the articles of association
of the private company with limited liability:
Cidron Ollopa B.V.,
with statutory seat in Amsterdam.
In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity.
Inevitably, differences may occur in translation, and if so the Dutch text will by law govern.
Amsterdam, the 28
th
day of May 2015.
Signature.
English translation
INCORPORATION PRIVATE COMPANY WITH LIMITED LIABILITY
On the twenty-seventh day of May two thousand fifteen appeared before me,
Anton Arnaud Voorneman, civil law notary in Amsterdam: Mr Guillaume Pierre Mounier, with office address at 1083
GV Amsterdam, Arent Janszoon Ernststraat 199, born in Waalwijk on the sixteenth day of May nineteen hundred eighty,
in this respect acting as duly authorized representative of:
the private company with limited liability:
Cidron Ollopa Holding B.V.,
with statutory seat in Amsterdam and offices at 1083 HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 201, offered for registration
at the Trade Register of the Chamber of Commerce.
The aforementioned power of attorney shall be attached to this deed.
The appearer, acting as aforementioned, has declared to incorporate a private company with limited liability and thereto
to lay down the following Articles of Association:
Art. 1. Definitions. In these articles, the following terms are defined as follows:
“share” means a share in the capital of the company; “shareholder” means a holder of one or more shares;
“general meeting” means the body of a company formed by the shareholders or a gathering of shareholders (or their
representatives) and other persons with meeting rights;
“managing director” means a member of the managing board;
“managing board” means the managing board of the company;
“in writing” means by letter, facsimile or e-mail, or by any other electronic form of message delivery, as long as it is
readable and reproducible;
“distributable net assets” means the amount of the net assets of the company as far as it exceeds the reserves which must
be maintained by virtue of law or the articles of association;
“company” means the company which internal organisation is governed by these articles of association;
“meeting rights” means the right to, either in person or by proxy authorized in writing, attend the general meeting and
to address such meeting.
Art. 2. Name and seat.
1. The name of the company is:
Cidron Ollopa B.V.
2. The statutory seat of the company shall be in Amsterdam.
Art. 3. Purposes. The purposes of the company are:
- to incorporate, to participate in any way whatsoever, to manage and to supervise enterprises and companies;
105525
L
U X E M B O U R G
- to render guarantees and to bind the company or assets of the company on behalf of enterprises and companies with
which the company forms a group;
- to render services to enterprises and companies;
- to finance enterprises and companies;
- to lend and to borrow money;
- to obtain, alienate, manage and to exploit real estate and items of property in general;
- to exploit and to trade patents, marks, licenses, know-how and intellectual rights of property;
- to perform all kind of industrial, financial and commercial activities;
and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all this to be interpreted in the widest sense.
Art. 4. Shares.
1. The capital of the company consists of one or more shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
2. At least one (1) share with voting rights is held by a person other than and other than for the account of the company
or one of its subsidiaries.
3. The shares are registered in the name of the holders.
4. No share certificates shall be issued.
Art. 5. Shareholders register.
1. The managing board shall keep a register in which the names and addresses of all shareholders shall be recorded,
with mention of the date they acquired the shares, the date of acknowledgement or service as well as the amount paid in
on each share.
2. The provisions of article 2:194 Dutch Civil Code are applicable.
Art. 6. Issue of shares.
1. The issue of shares shall be effected pursuant to a resolution of the general meeting insofar as the general meeting
has not designated another body of the company in this respect.
2. For the issue of a share further an appropriate notarial deed, executed by a civil law notary, officiating in the Nether-
lands, in which deed all parties involved are represented, shall be required.
3. A resolution for the issue of shares shall stipulate whether shareholders have a right to pre-emption, with due obser-
vance of the provisions of the Law.
4. The full nominal amount of each share must be paid in on issue. It may be stipulated that the nominal amount or a
part of it must be paid in after a certain amount of time or upon request by the company. After incorporation payment in
foreign currency can be made only after approval by the company.
5. The managing board is entitled without prior approval of the general meeting of shareholders to perform acts in law
as mentioned in article 2:204 paragraph 1 Dutch Civil Code.
Art. 7. Own shares.
1. The company shall be entitled - subject to due observance of article 4 paragraph 2 and the relevant provisions of the
law - to acquire its own fully paid in shares or the depositary receipts thereof.
2. The company shall not grant meeting rights to holders of depositary receipts.
Art. 8. Transfer of shares. Usufruct. Pledging.
1. The transfer of shares as well as the creation or transfer of a limited right thereon, shall require an appropriate notarial
deed, executed by a civil law notary, officiating in the Netherlands, in which deed all parties involved are represented.
2. The rights attached to the shares cannot be exercised by the new shareholder before the legal act has been acknowledged
by the company or has been serviced on the company, according to the relevant provisions of the law, unless the company
itself is a party to the legal act.
3. If a right of usufruct is created or if shares are pledged, the voting rights can be assigned to the usufructuary or the
pledgee, provided that the transfer of voting rights has been approved by the general meeting.
Art. 9. Restrictions on transfer of shares.
1. If any shareholder (offerer) wishes to dispose of all or any part of his shareholding, he must first offer those shares
to his co-shareholders (offerees) for sale unless all shareholders have given a written approval of the disposal concerned,
which approval is valid for a period of three months only. Nor is this obligation to offer applicable in case a shareholder
is obliged to offer his shares to a previous shareholder by virtue of the law.
Inter alia contribution to and division of any community is considered to be a transfer.
2. The shareholders who are interested to take over the offered shares, are obliged to notify the managing board in writing
of the number of shares they want to take over, within two months after the offer, failing which the shareholders concerned
shall be deemed not to be interested.
The price at which the shares can be taken over by the offerees shall be as agreed between the offerer and the offerees.
105526
L
U X E M B O U R G
Failing agreement between the parties about the price, the price shall be set by an independent expert to be appointed
by the chairman of the Dutch Professional Organisation of Accountants (NBA) on request of the most interested party,
unless the parties previously reach agreement on the appointment of the expert. The offerees are obligated to notify the
offerer by registered letter, within thirty days upon the determination of the price, if and to which extent they are interested
in the offered shares against cash payment, failing such notice they shall be deemed to have rejected the offer.
3. If the offerees jointly are interested in purchasing more shares than have been offered, the shares offered shall be
distributed among them insofar as possible in proportion to the number of their present shareholding, but with due obser-
vance of the number of shares reflected upon by each offeree.
4. The offerer is entitled to withdraw his offer, provided he does so within one month after the parties which are interested
to purchase all the shares concerned in the offer and the price, are disclosed to the offerer.
5. If it is definitely established that the offerees do not accept the offer or that not all shares offered shall be purchased
against payment in cash, the offerer is free to transfer the shares within three months after the date, on which the price has
been ascertained, to whomever he wishes.
6. In case of bankruptcy of a shareholder, of decease of a shareholder-natural person, of winding up or of dissolution of
a shareholder-legal entity, the shares of the shareholder concerned are to be offered to the other shareholders as set out
above within three months of the event.
Offers made under this requirement may not be withdrawn, provided all offered shares are taken up.
Art. 10. Managing board.
1. The company shall have a managing board, consisting of one or more managing directors A (bestuurders A) and one
or more managing directors B (bestuurders B). Both natural persons and legal persons can be managing director.
2. The general meeting shall appoint the managing directors and shall be competent to dismiss or to suspend them at
any time.
3. The general meeting shall determine the remuneration and further conditions of employment for each managing
director.
Art. 11. Task and decision making.
1. The managing board shall be entrusted with the management of the company.
2. With due observance of these articles of association, the managing board may adopt rules governing its internal
proceedings.
3. If a managing director has a direct or indirect personal conflict of interest with the company, he shall not participate
in the deliberations and the decisionmaking process concerned in the managing board. If as a result thereof no resolution
of the managing board can be adopted, the resolution is adopted by the general meeting.
4. The managing board shall adopt its resolutions by an absolute majority of votes cast. In a tie vote, the general meeting
shall decide.
5. The managing board may also decide outside of a meeting, provided that all managing directors have been consulted
and that each of them has consented to this manner of decision making.
6. The general meeting shall be authorized to submit certain resolutions by the managing board to its approval, provided
the general meeting shall notify the managing board in writing thereof.
Art. 12. Representation.
1. The managing board shall be authorized to represent the company.
A managing director A and a managing director B are also authorized to represent the company, acting jointly.
2. All legal acts of the company vis-à-vis a holder of all of the shares, whereby the company is represented by such
shareholder, shall be put down in writing. For the application of the foregoing sentence, shares held by the company or its
subsidiaries shall not be taken into account.
3. Paragraph 2 does not apply to legal acts that, under their agreed terms, form part of the normal course of business of
the company.
Art. 13. In case one or more members of the managing board are prevented or incapacitated to act, the remaining members
or the remaining member of the managing board shall be temporarily entrusted with the full management of the company,
whereas in case all members of the managing board or the sole member of the managing board are prevented or incapacitated
to act, the management shall be temporarily entrusted to the person to be designated thereto by the general meeting. The
term prevented to act is taken to mean a suspension or the impossibility to make contact during at least seven days due to
illness or inaccessibility.
Art. 14. Financial year and annual accounts.
1. The financial year shall begin on the first of July of each calendar year and shall end on the thirtieth of June of the
following year.
105527
L
U X E M B O U R G
2. Annually, within five months after the end of the financial year concerned - unless this term is extended by the general
meeting with not more than six months by reason of special circumstances -, the managing board shall draw up the annual
accounts consisting of a balance-sheet, a profit and loss account and explanatory notes.
Within said period the annual accounts and the annual report shall be available at the company's office for inspection
by the persons with meeting rights.
3. The general meeting adopts the annual accounts.
Art. 15. Profits.
1. The general meeting is authorized to distribute the profits which have been determined by the adoption of the annual
accounts and to determine the distributable net assets.
2. A resolution of the general meeting to distribute shall have no effect as long as it has not been approved by the
managing board. The managing board shall only refuse approval if it knows or within reason is supposed to foresee that
the company, after distribution, shall no longer be able to pay its debts due.
3. The managing directors who, at the time of the distribution, knew or were supposed to foresee that the company would
no longer be able to pay its debts due, shall be jointly and severally liable to the company for the deficit which exists due
to the distribution, together with the legal interest (wettelijke rente) since the day of the distribution. A managing director
that proves that he is not to be blamed for the distribution by the company and who has not been negligent in taking measures
to avert the consequences, shall not be liable.
4. The claim of a shareholder for payment of dividend shall expire after a period of five years.
Art. 16. General meetings of shareholders.
1. The general meetings shall be held in the place where the company has its statutory seat as well as where the company
holds its offices or at Schiphol (municipality Haarlemmermeer).
2. A general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year concerned in which
among other matters the annual accounts shall be adopted and the appropriation of profits shall be decided upon or a
resolution shall be taken in accordance with article 21.
Art. 17.
1. The managing board shall convene the general meeting not later than on the eighth day prior to the meeting.
2. Shareholders and other persons with meetings rights shall be convened to general meetings by letters sent to their
addresses as per the register as mentioned in article 5, or with the consent of persons with meeting rights by any other form
of writing.
Art. 18. Decision making without convention. Notes.
1. If the term for convention as mentioned in article 17 paragraph 1 has not been held up or if the convention has not
taken place, then no valid decisions can be made, unless all persons with meeting rights consent to the decision making
taking place and the managing directors have been granted the opportunity to advise beforehand.
2. The managing board keeps a record of the resolutions made. If the managing board is not represented at a meeting,
the chairman of the meeting shall provide the managing board with a transcript of the resolutions made as soon as possible
after the meeting. The records shall be deposited at the offices of the company for inspection by the persons with meeting
rights. Upon request each of them shall be provided with a copy or an extract of such record at not more than the actual
costs.
Art. 19.
1. On shares in its own capital acquired by the company no voting rights shall be exercised by the company.
Payment to the company on these shares shall not take place.
2. At the determination of any majority or any quorum, required for passing of a resolution by the general meeting, the
shares in its own capital acquired by the company shall be left out of consideration.
Art. 20.
1. The general meeting shall appoint the chairman of the meeting.
2. The general meeting decides with an absolute majority of votes, validly cast.
3. Each share confers the right to cast one vote.
4. If provided for at the notice for general meetings, each person entitled to attend the general meeting has the right to
take note of the meeting by electronic means of communication, either in person or by a proxy authorized in writing, to
address the meeting and - if the person is entitled to vote - to exercise voting rights, provided that, such person must be
identifiable through the electronic means of communication and is able to directly observe the proceedings at the meeting
and be able to directly participate in the proceedings at the meeting.
5. The general meeting may attach conditions to the use of the electronic means of the communication. The notice of
the meeting shall set out these conditions or state where they can be consulted.
6. The managing board keeps a record of the resolutions made;
105528
L
U X E M B O U R G
article 18 paragraph 2 of the articles of association is equally applicable.
Art. 21. Resolutions outside meetings. Notes.
1. Resolutions of the shareholders may instead of in general meetings also be taken in writing provided that all persons
with meeting rights agree with this manner of decision making. All managing directors shall be granted the opportunity to
advise beforehand.
2. The managing board shall keep a record of the resolutions thus made.
Each of the persons with meeting rights must procure that the managing board is informed in writing of the resolutions
made in accordance with paragraph 1 as soon as possible.
The records shall be deposited at the offices of the company for inspection by the persons with meeting rights. Upon
request each of them shall be provided with a copy or an extract of such record at not more than the actual costs.
Art. 22. Amendment. In case a proposal for amendment of the articles of association is submitted to the general meeting
simultaneously a copy of the proposal in which the verbatim text of the proposed amendment is embodied has to be deposited
at the company's office for inspection by those who are entitled thereto by law, until the end of the meeting concerned.
Art. 23. Dissolution.
1. At the dissolution of the company by virtue of a resolution of the general meeting, the liquidation shall be effected
by the managing board, unless the general meeting shall decide otherwise.
2. The general meeting shall fix the remuneration of the liquidators.
3. The liquidation shall be effected with due observance of the applicable provisions of the law.
4. The remainder of the assets of the company after payment of all creditors shall be transferred to the shareholders in
proportion to the nominal value of their shareholding.
5. The liquidation shall be subject to the provisions of Title 1 of Book 2 Dutch Civil Code.
6. During the liquidation the articles of association shall remain applicable insofar as possible.
<i>Transitory clausei>
The first financial year of the company ends on the thirtieth day of June two thousand fifteen.
<i>Final Provisionsi>
Finally the appearer declared as follows:
1. For the first time are appointed as managing directors A of the company:
- Mr Marcus Jacobus Maria Hollander, residing at 1961 JM Heemskerk, Graaf Willem II laan 12, born at Heemskerk
on the second of March nineteen hundred and sixty-two; and
- Mr Andreas Georg Christian Demmel, residing at 1054 AB Amsterdam, Nassaukade 367 2, born at München on the
eleventh of April nineteen hundred and sixty-nine.
2. In the issued capital of the company is participated by the incorporator aforementioned with one (1) share, with a
nominal value of one euro (EUR 1.00); the issued capital amounts to one euro (EUR 1.-).
3. The issue shall take place at par. Upon request of the company, the nominal amount on the share will be paid up in
cash.
4. The company is obligated to reimburse all costs in relation to the incorporation. The appearer is known to me, notary.
THIS DEED, drawn up, has been executed at Amsterdam, on the day and year mentioned in the heading in this deed.
The contents of this deed were stated and explained in substance to the appearer. The appearer then declared to be well
informed on and to agree with the contents of this deed and not to care for a reading out in full.
Immediately after partial reading, the appearer and I, notary, signed this deed,
(w.s.) G.P. Mounier, A.A. Voorneman
Privatgesellschaft mit Beschränkter Haftung
Art. 1. Definitionen. In der vorliegenden Satzung werden die folgenden Ausrücke wie folgt definiert:
“Anteil” meint einen Anteil am Gesellschaftskapital;
“Ausschüttungsfähiger Nettoerlös” meint den Betrag des Nettoerlöses der Gesellschaft, insoweit er den Grundbetrag,
der per Gesetz oder per Satzung aufrechtzuerhalten ist, übersteigt;
“Geschäftsführerratsmitglied” meint ein Mitglied des Geschäftsführerrats der Gesellschaft;
“Geschäftsführerrat” meint den Geschäftsführerrat der Gesellschaft;
“Gesellschaft” meint diejenige Gesellschaft, deren interne Organisation durch diese Satzung geregelt wird;
“Gesellschafter” meint den Inhaber eines oder mehrerer Anteile;
“Gesellschafterversammlung” meint das Organ einer Gesellschaft bestehend aus den Gesellschaftern, oder eine Ver-
sammlung von Gesellschaftern (oder deren Vertretern) oder anderer Personen mit Rechten der Teilnahme an einer
Gesellschafterversammlung;
105529
L
U X E M B O U R G
“Gesellschafterversammlungsrechte” meint das Recht, entweder persönlich oder mit einer schriftlich erteilten Vollmacht
ausgestattet, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen und sich an diese zu richten.
“Schriftlich” meint Brief, Fax oder E-Mail, oder jede andere elektronische Form von Mitteilungen, Lesbarkeit und
Reproduzierbarkeit vorausgesetzt;
Art. 2 Name und Sitz.
(1) Der Name der Gesellschaft ist: Cidron Ollopa B. V.
(2) Der satzungsgemäße Sitz der Gesellschaft ist Amsterdam.
Art. 3. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft ist:
Die Gründung, Beteiligung - in welcher Weise auch immer -, die Führung und Aufsicht an und von Unternehmen und
Gesellschaften;
- Garantien auszustellen und die Gesellschaft sowie Vermögen der Gesellschaft im Namen von Unternehmen und Ge-
sellschaften, mit denen die Gesellschaft eine Unternehmensgruppe bildet, rechtlich zu binden;
- Unternehmen und Gesellschaften Serviceleistungen zur Verfügung zu stellen;
- Unternehmen und Gesellschaften zu finanzieren;
- Finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen und selbst auszuleihen;
- Immobilien sowie Eigentum im Allgemeinen zu erwerben, abzutreten, zu verwalten und fruchtbar zu machen;
- Die Fruchtbarmachung von Patenten, Markenrechten, Lizenzen, Know-How und geistigem Eigentum;
- Alle Arten von industriellen, finanziellen und kommerziellen Aktivitaeten;
sowie sämtliche hiermit verbundenen oder möglicherweise hiervon mit betroffenen Aktivitäten; dies ist möglichst weit
auszulegen.
Art. 4. Anteile.
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Anteilen, mit einem Nominalwert von jeweils
einem Euro (EUR 1.00).
(2) Mindestens ein (1) Anteil mit Stimmrechten wird von einer Person gehalten, die nicht die Gesellschaft selbst oder
eine ihrer Tochtergesellschaften ist, oder für diese handelt.
(3) Die Anteile werden unter den Namen der Inhaber registriert.
(4) Es werden keine Anteilsurkunden ausgestellt.
Art. 5. Anteilsregister.
(1) Der Geschäftsführerrat verwaltet ein Register, das die Namen und Adressen aller Gesellschafter sowie das Datum
des Anteilserwerbs enthält, sowie den Zeitpunkt der Anerkennung oder der Zustellung, wie auch den je Anteil bezahlten
Betrag.
(2) Die Vorschriften des Artikel 2:194 des niederländischen Zivilgesetzbuches werden für anwendbar erklärt.
Art. 6. Ausgabe von Anteilen.
(1) Die Ausgabe von Anteilen erfolgt entsprechend einer Vorgabe der Gesellschafterversammlung, sofern nicht die
Gesellschafterversammlung ein anderes Gesellschaftsorgan hierfür bestimmt hat.
(2) Des Weiteren ist für die Ausgabe eines Anteils eine entsprechende notarielle Beurkundung erforderlich, die von
einem im Zivilrecht tätigen und in den Niederlanden zugelassenen Notar ausgestellt wurde, und die alle beteiligten Personen
ausweist.
(3) Bei der Ausgabe von Anteilen legt ein Beschluss fest, ob die Gesellschafter, unter Beachtung des geltenden Rechts,
ein Vorkaufsrecht erhalten.
(4) Bei der Ausgabe muss der volle Nennbetrag hinsichtlich jedes Anteils gezahlt werden. Es kann festgelegt werden,
dass der Nennbetrag oder ein Teil hiervon nach Ablauf einer bestimmten Zeit oder nach Aufforderung durch die Gesellschaft
zu zahlen ist. Nach Gründung der Gesellschaft kann in einer fremden Währung nur noch mit Zustimmung der Gesellschaft
gezahlt werden.
(5) Der Geschäftsführerrat ist befugt, ohne vorherige Erlaubnis durch die Gesellschafterversammlung Rechtsgeschäfte,
die in Artikel 2:204 Abschnitt 1 des Niederländischen Zivilgesetzbuches aufgeführt sind, durchzuführen.
Art. 7. Eigentum an Anteilen.
(1) Die Gesellschaft ist befugt - vorbehaltlich der Beachtung von Artikel 4 Absatz 1 und der einschlägigen Rechtsvor-
schriften - Anteile an ihr selbst durch Zahlung in bar oder durch Hinterlegungsscheine zu erwerben.
(2) Die Gesellschaft ist nicht befugt, Inhabern von Hinterlegungsscheinen Gesellschafterversammlungsrechte zu ver-
leihen.
105530
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Anteilsübertragung. Niessbrauch. Pfändung.
(1) Die Übertragung von Anteilen wie auch die Begründung oder die Übertragung beschränkter Rechte diesbezüglich
erfordern eine entsprechende notarielle Beurkundung, ausgeführt von einem im Zivilrecht tätigen und in den Niederlanden
zugelassenen Notar. Die Urkunde muss alle beteiligten Personen ausweisen.
(2) Die mit den Anteilen verbundenen Rechte können von einem neuen Gesellschafter nicht ausgeübt werden, bevor
das Rechtsgeschäft durch die Gesellschaft anerkannt wurde, oder bevor dieser der Gesellschaft entsprechend den einschlä-
gigen Rechtsvorschriften zugestellt wurde, es sei denn, die Gesellschaft ist selbst Partei des Rechtsgeschäftes.
(3) Wird ein Nießbrauchrecht eingeräumt oder werden Anteile gepfändet, können die Stimmrechte dem Nießbrauch-
nehmer oder dem Pfandgläubiger übertragen werden, vorausgesetzt die Übertragung von Stimmrechten wurde von der
Gesellschafterversammlung gebilligt.
Art. 9. Beschränkung der Übertragung von Anteilen.
(1) Will ein Gesellschafter (Anbieter) seine Anteile ganz oder teilweise abstoßen, so muss er jene Anteile zunächst
seinen Mitgesellschaftern (Angebotsempfänger) zum Kauf anbieten, es sei denn, alle Gesellschafter haben ihr schriftliches
Einverständnis zum betreffenden Abstoßen der Anteile erteilt. Ein solches Einverständnis ist lediglich für eine Zeit von
drei Monaten wirksam. Das vorgenannte Erstandienungsrecht ist nicht einschlägig, wenn ein Gesellschafter rechtlich dazu
verpflichtet ist, seine Anteile einem früheren Mitgesellschafter anzubieten. Die Zuteilung innerhalb sowie die Aufteilung
einer Gemeinschaft ist als Übertragung von Anteilen anzusehen.
(2) Die an einer Übernahme der angebotenen Anteile interessierten Gesellschafter sind dazu verpflichtet, den Ge-
schäftsführerrat schriftlich und innerhalb von zwei Monaten ab dem Angebot über die Anzahl der zu übernehmenden
Anteile in Kenntnis zu setzen, andernfalls gelten die Gesellschafter als nicht interessiert. Der Preis für die Anteile bestimmt
sich nach der Vereinbarung zwischen Anbieter und Angebotsempfänger. Existiert keine Vereinbarung hinsichtlich des
Preises, so soll der Preis von einem unabhängigen Sachverständigen, der durch den Vorsitzenden der Dutch Professional
Organisation of Accountants (NBA) bestimmt wird, ermittelt werden. Dies geschieht auf Aufforderung durch die Partei
mit dem größten Interesse, es sei denn, die Parteien erzielen zuvor eine Einigung über die Benennung eines Sachverstän-
digen. Die Angebotsempfänger sind verpflichtet dem Anbieter mittels eingeschriebenen Briefes und innerhalb von dreißig
Tagen ab der Bestimmung des Preises zu erklären, ob und in welchem Umfang sie an der Übernahme der angebotenen
Anteilen gegen Barzahlung interessiert sind, andernfalls gilt das Angebot als durch die Angebotsempfänger abgelehnt.
(3) Übertrifft die Zahl der Anteile, an denen Erwerb die Angebotsempfänger in ihrer Gesamtheit interessiert sind, die
Zahl der angebotenen Anteile, so werden die angebotenen Anteile unter ihnen soweit möglich entsprechend der Anzahl
ihrer derzeitigen Anteile verteilt, jedoch unter Beachtung der Anzahl der Anteile eines jeden Angebotsempfängers.
(4) Der Anbieter ist berechtigt sein Angebot zurückzuziehen, vorausgesetzt er tut dies innerhalb eines Monats nachdem
ihm die Identität derjenigen Parteien, die am Erwerb aller betroffenen Anteile zum angebotenen Preis, mitgeteilt wurde.
(5) Steht zweifelsfrei fest, dass die Angebotsempfänger das Angebot nicht annehmen, oder dass nicht alle angebotenen
Anteile gegen Barzahlung erworben werden sollen, so kann der Anbieter die Anteile innerhalb von drei Monaten nach dem
Datum der Festlegung des Preises frei übertragen.
(6) Im Falle der Insolvenz eines Gesellschafters, des Ablebens eines Gesellschafters bei einer natürlichen Person als
Gesellschafter, oder einer Abwicklung oder Auflösung eines Gesellschafters bei einer juristischen Person als Gesellschaf-
ter, werden die Anteile des betroffenen Gesellschafters den anderen Gesellschaftern entsprechend den obigen Regeln
innerhalb von drei Monaten nach dem Ereignis angeboten. Solche Angebote können nicht zurückgenommen werden,
vorausgesetzt alle angebotenen Anteile werden übernommen.
Art. 10. Geschäftsführerrat.
(1) Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführerrat bestehend aus einem oder mehreren Geschäftsführern der Klasse A
(bestuurders A) und einem oder mehreren Geschäftsführern der Klasse B (bestuurders B). Sowohl natürliche als auch
juristische Personen können Geschäftsführer sein.
(2) Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Geschäftsführer und hat das Recht, Letztere jederzeit zu entlassen
oder zu suspendieren.
(3) Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Vergütung und weitere Beschäftigungskonditionen für jeden Ge-
schäftsführer.
Art. 11. Aufgaben und Entscheidungsfindung.
(1) Der Geschäftsführerrat wird mit dem Management der Gesellschaft betraut.
(2) Der Geschäftsführerrat kann, unter Einhaltung dieser Satzung, Regeln für interne Abläufe erlassen.
(3) Besteht ein unmittelbarer oder mittelbarer Interessenkonflikt zwischen einem Geschäftsführer und der Gesellschaft,
so nimmt er nicht an den betroffenen Verhandlungen und dem Abstimmungsprozess des Geschäftsführerrats teil. Kann als
Folge dessen der Geschäftsführerrat keine Entscheidung treffen, so wird die Entscheidung durch die Gesellschafterver-
sammlung getroffen.
(4) Der Geschäftsführerrat trifft seine Entscheidungen mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Gesellschafterversammlung.
105531
L
U X E M B O U R G
(5) Der Geschäftsführerrat kann auch außerhalb einer Sitzung Entscheidungen treffen, vorausgesetzt alle Geschäfts-
führer wurden vorab befragt, und haben, jeder einzeln, ihre Zustimmung zu dieser Art der Entscheidungsfindung gegeben.
(6) Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt, bestimmte Entscheidungen des Geschäftsführerrats unter den Vor-
behalt seiner Zustimmung zu stellen, vorausgesetzt die Gesellschafterversammlung hat den Geschäftsführerrat hierüber
schriftlich vorab in Kenntnis gesetzt.
Art. 12. Vertretung.
(1) Der Geschäftsführerrat ist berechtigt die Gesellschaft zu vertreten. Ein Geschäftsführer der Klasse A und ein Ge-
schäftsführer der Klasse B sind ebenso berechtigt, gemeinsam die Gesellschaft zu vertreten.
(2) Alle rechtlichen Handlungen der Gesellschaft gegenüber dem Inhaber aller Gesellschaftsanteile, bei denen die Ge-
sellschaft durch diesen Inhaber der Gesellschaftsanteile vertreten wird, bedürfen der Schriftform. Dieses Schriftformer-
fordernis findet keine Anwendung hinsichtlich von Gesellschaftsanteilen, die von der Gesellschaft oder deren
Tochtergesellschaften gehalten werden.
(3) Artikel 12 Abs. 2 findet keine Anwendung auf rechtliche Handlungen, die, in ihren vereinbarten Bedingungen,
Bestandteil des gewöhnlichen Geschäftsablaufs der Gesellschaft sind.
Art. 13. Sind ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführerrats daran gehindert ihrer Tätigkeit nachzugehen oder
handlungsunfähig, sind die verbliebenen Mitglieder oder das verbliebene Mitglied des Geschäftsführerrats vorübergehend
mit der Geschäftsführung der Gesellschaft betraut; sind hingegen alle Mitglieder des Geschäftsführerrats oder das einzige
Mitglied des Geschäftsführerrats daran gehindert ihrer Tätigkeit nachzugehen oder handlungsunfähig, ist eine Person, die
von der Gesellschafterversammlung bestimmt wird, vorübergehend mit der Geschäftsführung betraut. Der Ausdruck „daran
gehindert der Tätigkeit nachzugehen“ meint in diesem Zusammenhang die Aufhebung oder Unmöglichkeit des Herstellens
eines Kontakt für eine Dauer von mindestens sieben Tagen aufgrund von Krankheit oder Nichterreich barkeit.
Art. 14. Geschäftsjahrund Jahresabschlüsse.
(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Juli eines Jahres und endet am 31. Juni des darauffolgenden
Jahres.
(2) Der Geschäftsführerrat stellt jährlich, innerhalb von fünf Monaten nach dem Ende des betroffenen Geschäftsjahres,
wenn dieser Zeitabschnitt nicht aufgrund besonderer Umstände von der Gesellschafterversammlung um nicht mehr als
sechs Monate verlängert wurde, den Jahresabschluss der Gesellschaft auf, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie den sonstigen Anmerkungen besteht. Innerhalb des genannten Zeitraums werden der Jahresabschluss und
der Jahresabschlussbericht am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme der hierzu berechtigten Personen ausgelegt.
(3) Die Gesellschafterversammlung verabschiedet die Jahresabschlüsse.
Art. 15. Gewinne.
(1) Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt, die Gewinne, die bestimmt werden durch die Verabschiedung der
Jahresabschlüsse, auszuschütten und den auszuschüttenden Nettogewinn zu bestimmen.
(2) Der Gesellschafterbeschluss über die Gewinnausschüttung ist nichtig, wenn er nicht vom Geschäftsführerrat ge-
nehmigt wurde. Der Geschäftsführerrat versagt seine Genehmigung nur, wenn er weiß oder berechtigterweise davon
ausgeht vorherzusehen, dass die Gesellschaft nach der Gewinnausschüttung nicht länger in der Lage sein wird ihre fälligen
Verbindlichkeiten zu begleichen.
(3) Die Geschäftsführer, die zum Zeitpunkt der Ausschüttung wussten oder eine Annahme hatten zu wissen, dass die
Gesellschaft nicht länger in der Lage sein würde ihre fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen, sind der Gesellschaft
gegenüber gesamtschuldnerisch haftbar für den Verlust, der aufgrund der Ausschüttung besteht, und für die gesetzlichen
Zinsen (wettelijke rente) ab dem Tag der Ausschüttung. Ein Geschäftsführer ist nicht haftbar, wenn er beweist, dass ihm
die Ausschüttung durch die Gesellschaft nicht vorgeworfen werden kann, und wenn er nicht nachlässig gewesen ist be-
züglich des Ergreifens von Maßnahmen zur Abwendung der Folgen.
(4) Nach dem Ablauf von fünf Jahren erlischt der Anspruch eines Gesellschafters auf Dividendenzahlung.
Art. 16. Gesellschafterversammlung.
(1) Die Gesellschafterversammlungen werden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, an den Orten, an denen die Ge-
sellschaft einen Firmensitz unterhält oder in Schiphol (gemeente Haarlemmermeer) abgehalten.
(2) Eine Gesellschafterversammlung wird jährlich innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des betroffenen Ge-
schäftsjahres abgehalten, in der, neben anderen Dingen, die Jahresabschlüsse der Gesellschaft verabschiedet werden und
die Gewinnverwendung bestimmt oder eine Beschlussfassung in Übereinstimmung mit Artikel 21 erfolgt.
Art. 17.
(1) Der Geschäftsführerrat beruft die Gesellschafterversammlung spätestens am achten Tag vor der Versammlung ein.
(2) Gesellschafter und andere Personen, die ein Recht auf Teilnahme an der Gesellschafterversammlung haben, werden
durch Briefe zu den Gesellschafterversammlungen einberufen, die an ihre Adressen, die im in Artikel 5 genannten An-
teilsregister eingetragen sind, gesendet werden, oder durch jede andere Art der Schriftform, der der jeweilige Gesellschafter
oder an der Teilnahme zur Gesellschafterversammlung Berechtigte zugestimmt hat.
105532
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Beschlussfassung ohne Einberufung. Hinweise.
(1) Wenn der Zeitraum für die Einberufung wie in Artikel 17 Abs. 1 vorgeschrieben nicht eingehalten wurde oder eine
Einberufung nicht stattgefunden hat, können keine wirksamen Beschlüsse gefasst werden, es sei denn, all Personen, die
ein Recht auf Teilnahme an der Gesellschafterversammlung haben, stimmen der Beschlussfassung zu und die Geschäfts-
führer haben die Gelegenheit gehabt, hierzu im Vorhinein einen Ratschlag zu erteilen.
(2) Der Geschäftsführerrat protokolliert die gefassten Beschlüsse. Ist der Geschäftsführerrat bei der Gesellschafterver-
sammlung nicht vertreten, erteilt der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung dem Geschäftsführerrat schnellstmöglich
nach der Versammlung ein Protokoll der gefassten Beschlüsse. Das Protokoll wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft
zur Einsichtnahme durch Personen mit Teilnahmerechten an der Gesellschafterversammlung hinterlegt. Auf Anforderung
wird jeder derjenigen Personen, die ein Recht auf Teilnahme an der Gesellschafterversammlung haben, mit einer Kopie
oder einem Auszug eines solchen Protokolls zu nicht mehr als den hierfür angefallenen Kosten versorgt.
Art. 19.
(1) Für die Anteile an der Gesellschaft, die von der Gesellschaft selbst gekauft worden sind, übt die Gesellschaft keine
Stimmrechte aus. Für solche Anteile findet eine Auszahlung an die Gesellschaft nicht statt.
(2) Die Anteile an der Gesellschaft, die von der Gesellschaft selbst gekauft worden sind, bleiben unberücksichtigt bei
der Bestimmung der Mehrheit oder eines jeden Quorums, das zur Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung er-
forderlich ist.
Art. 20.
(1) Die Gesellschafterversammlung ernennt einen Vorsitzenden der Versammlung.
(2) Die Gesellschafterversammlung entscheidet mit absoluter Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen.
(3) Jeder Gesellschaftsanteil beinhaltet das Recht, eine Stimme abzugeben.
(4) Sieht das Einberufungsschreiben für eine Gesellschafterversammlung dies vor, hat jede Person, die berechtigt ist an
der Gesellschafterversammlung teilzunehmen, das Recht Kenntnis zu nehmen von der Versammlung durch elektronische
Kommunikationsmittel, entweder persönlich oder durch eine schriftlich bevollmächtigte Person, um sich an die Versamm-
lung zu richten und, falls diese Person stimmberechtigt ist, Stimmrechte auszuüben, vorausgesetzt, dass diese Person durch
das elektronische Kommunikationsmittel identifizierbar ist, dass sie dazu in der Lage ist, die Abläufe der Versammlung
unmittelbar zu verfolgen, und dass sie direkt teilnehmen kann an den Abläufen der Versammlung.
(5) Die Gesellschafterversammlung kann Bedingungen an den Gebrauch elektronischer Kommunikationsmittel stellen.
Das Einberufungsschreiben legt diese Bedingungen fest oder gibt an, wo diese erfragt werden können.
(6) Der Geschäftsführerrat behält ein Protokoll der gefassten Beschlüsse; Artikel 18 Abs. 2 der Satzung findet Anwen-
dung.
Art. 21. Beschlussfassung ausserhalb von Gesellschafterversammlungen. Hinweise.
(1) Gesellschafterbeschlüsse können anstatt durch Gesellschafterversammlungen auch schriftlich gefasst werden, vo-
rausgesetzt dass alle Personen, die über Teilnahmerechte an der Gesellschafterversammlung verfügen, dieser Art der
Beschlussfassung zustimmen. Alle Geschäftsführer sind berechtigt, über diese Möglichkeit der Beschlussfassung im Vor-
hinein Ratschlag zu erteilen.
(2) Der Geschäftsführerrat behält eine schriftliche Aufzeichnung der so gefassten Beschlüsse. Jede Person, die über
Teilnahmerechte an der Gesellschafterversammlung verfügt, muss sicherstellen, dass der Geschäftsführerrat frühestmög-
lich über die in Übereinstimmung mit Artikel 21 Abs. 1 gefassten Beschlüsse informiert worden ist. Die Protokolle werden
am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die mit Teilnahmerechte an der Gesellschafterversammlung ausgestat-
teten Personen ausgelegt. Auf Anforderung wird jeder dieser Personen mit einer Kopie oder einem Auszug eines solchen
Protokolls zu nicht mehr als den hierfür angefallenen Kosten versorgt.
Art. 22. Änderungen. Wird der Gesellschafterversammlung der Vorschlag zur Änderung der Satzung unterbreitet, muss
gleichzeitig eine Kopie des Vorschlags, in welcher der genaue Wortlaut der Änderung niedergeschrieben ist, am Sitz der
Gesellschaft ausgelegt werden zur Einsicht derjenigen, die hierzu gesetzlich berechtigt sind, bis zum Ende der betroffenen
Versammlung.
Art. 23. Auflösung.
(1) Bei Auflösung der Gesellschaft durch entsprechenden Beschluss der Gesellschafterversammlung wird die Abwick-
lung bewirkt durch den Geschäftsführerrat, solange die Gesellschafterversammlung nichts anderes beschließt.
(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt die Vergütung der Liquidatoren.
(3) Die Auflösung wird bewirkt unter Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften.
(4) Der Restbetrag des Gesellschaftsvermögens nach Befriedigung aller Gläubiger wird an die Gesellschafter im Ver-
hältnis zum Nominalwert ihrer Gesellschaftsanteile übertragen.
(5) Die Auflösung unterliegt den Bestimmungen von Titel 1 Buch 2 des niederländischen Zivilgesetzbuches.
105533
L
U X E M B O U R G
(6) Während der Auflösung der Gesellschaft bleibt die Satzung der Gesellschaft soweit möglich anwendbar.
Référence de publication: 2015141854/1099.
(150154716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.
Revetas GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 199.070.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-seventh day of July.
Before the undersigned Me Karine REUTER, a notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Revetas GP II Limited, a limited company, incorporated and organised under the laws of Guernsey, having its registered
office at 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 2HL, registered with the Registry of Guernsey under
number 58742,
here represented by Richel van Weij
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power
of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - registered office - object - duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Revetas GP S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may be appointed and act as the general partner (associé commandité et/ou associé commandité
gérant) and or have similar functions under Luxembourg and/or foreign law, in one or more partnership(s), or any other
similar entity under Luxembourg and/or foreign law, in which it holds participations and/or shares. In this respect, the
Company may provide other companies, partnership(s), or any other similar entity under Luxembourg and/or foreign law
with services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and
retain the assistance of other advisors. The Company may carry out any activities connected to the function of general
partner (associé commandité et/ou associé commandité gérant).
3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies which form part of the same group of
companies as the Company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company which form part of
105534
L
U X E M B O U R G
the same group of companies as the Company, and, generally, for its own benefit and that of any other company which
form part of the same group of companies as the Company. The Company may furthermore grant security interests over
and may pledge its shares. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector
activities without having obtained the requisite authorisation.
3.4. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. The transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least
three-quarters of the share capital.
6.4. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.5. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.6. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results in a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by a sole manager or by a board of managers, composed of at least one (1) manager
A and at least (1) one manager B appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The
managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle
shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented. Board resolutions
105535
L
U X E M B O U R G
shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the
managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one manager A and one
manager B of the Company.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
105536
L
U X E M B O U R G
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders'
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. The annual General Meeting shall be held at the registered office of the Company at such time as may be specified
in the convening notices of the meeting.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be su-
pervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved
external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General
Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Com-
pany's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
105537
L
U X E M B O U R G
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2015.
<i>Subscription and paymenti>
Revetas GP II Limited S.à r.l., represented as stated above, subscribes for twelve thousand and five hundred (12,500)
shares in registered form, having a nominal value of on euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution
in cash of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500),
The amount of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500) is at the Company's disposal and evidence of such
amount has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately EUR 1.350.- (one thousand three hundred fifty euros).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. Appointment of Mrs. Charlotte Lahaije-Hultman, Director, born in Barnarp, Sweden on 24
th
March 1975, whose
address is at 15, Rue Edward Steichen, 4
th
Floor, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager of the
Company for an indefinite period.
2. The registered office of the Company is located at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le vingt-septième jour de juillet.
Par devant le soussigné Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
Revetas GP II Limited, une société de droit de Guernsey, dont le siège est établi à 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter
Port, Guernsey GY1 2HL, inscrite au registre de Guernsey sous le numéro 58742,
représentée par Richel van Weij
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, lesdites pro-
curations resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter de la façon
suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Revetas GP S.à r.l." (la Société). La Société est une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
105538
L
U X E M B O U R G
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature
à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut être nommée ou agir en qualité d'associé commandité et/ou associé commandité gérant et/ou avoir
des fonctions similaires, que ce soit en vertu du droit de Luxembourg et/ou du droit étranger, dans un ou plusieurs partenariat
(s), ou tout autre entité similaire régie par le droit de Luxembourg et/ou par le droit étranger, dans laquelle elle détient des
participations et/ou actions. À cet égard, la Société peut fournir à d'autres sociétés, partenariat(s), ou à tout autre entité
similaire régie par le droit de Luxembourg et/ou du droit étranger, les services nécessaires à leur administration, à leur
contrôle et à leur développement. À cette fin, la Société peut requérir et conserver l'assistance d'autres conseillers. La
Société peut effectuer toutes les activités liées à la fonction d'associé commandité et/ou associé commandité gérant.
3.3. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu'à toutes autres sociétés faisant partie du même groupe
de sociétés que la Société. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement
créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre
société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute
autre société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut également consentir des suretés ou
nantissements sur ses parts sociales. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du
secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.4. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.
3.5. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. La cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au
moins les trois-quarts du capital social.
6.4. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.5. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
105539
L
U X E M B O U R G
6.6. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte en la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un gérant ou par un conseil de gérance, composé d'au moins un (1) gérant A et au moins
un (1) gérant B, nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas
nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au
Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions
du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été
nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant A et d'un
gérant B de la Société.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées
en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
105540
L
U X E M B O U R G
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au
moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
13.5. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social de la Société et à l'heure indiquée dans la
convocation.
Art. 14. Commissaires / réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréé. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
105541
L
U X E M B O U R G
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions
du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Revetas GP II Limited S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement
par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), Le montant de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent
approximativement à EUR 1.350.- (mille trois cent cinquante euros).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Nomination de Mme Charlotte Lahaije-Hultman, gérant, né à Barnarp, Suède, le 24 mars 1975, dont l'adresse est 15,
Rue Edward Steichen, 4e étage, L-2540 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en qualité de gérant de la Société
pour une durée indéterminée.
2. Le siège social de la Société est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête des parties comparantes que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
105542
L
U X E M B O U R G
Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire des parties comparantes.
Signés: R. Van WEIJ, K. REUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 27 juillet 2015. Relation: 2LAC/2015/16965. Reçu soixante-quinze euros
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME
Luxembourg, le 5 août 2015.
Référence de publication: 2015134154/497.
(150145347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
Ethna-DEFENSIV, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Ethna-DEFENSIV modifié au 1
er
août 2015 a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, août 2015
ETHENEA Independent Investors S.A.
Référence de publication: 2015133723/10.
(150144982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
FCP OP Medical, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - FCP OP Medical - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l
Référence de publication: 2015141014/9.
(150152987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.
SEA Glass S.à r.l.-SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 192.894.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100785/9.
(150111038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Swan Investment Company, Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.
R.C.S. Luxembourg B 74.884.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100819/9.
(150110972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Tiar Publications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 141.124.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
105543
L
U X E M B O U R G
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015100830/10.
(150110872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Gestman S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 37.378.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 4 juin
2015 que:
- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:
* Madame Joëlle MAMANE, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc) le 14/01/1951, demeurant professionnel-
lement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
* Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc) le 22/10/1966, demeurant profession-
nellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
- A été élu à la fonction d'administrateur en remplacement de Cofidom-Gestman Sàrl, dont le mandat n'a pas été reconduit:
* Monsieur Lionel Elie MAMANE, informaticien, né à Ixelles (Belgique) le 5 mai 1979, demeurant professionnellement
à L-1118 Luxembourg, 23 rue Aldringen.
Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle MAMANE a été confirmé pour une durée indéterminée.
- A été élue au poste de commissaire en remplacement de MONTBRUN REVISION S.à r.l. dont le mandat n'a pas été
reconduit:
* NOVIPA S.A., immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 33405, et ayant son siège social au 23, rue
Aldringen - L-1118 Luxembourg.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2021.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015106695/26.
(150117724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.
SGC Energia S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 98.436.
<i>Extract of the resolutions taken by the sole shareholderi>
The mandate of the Directors of category A of
- Mr. Juan Miguel MARTIN IGLESIAS, companies director, residing rua Ilha dos Amores, 53, 1990371 Moscavide,
Portugal
- Mr. Luis Miguel DIAS DA SILVA SANTOS, companies director, residing 18, rua Soldados da India, 1400-340
Lisbonne, Portugal
and the mandate of the Directors of category B of
- Mr. Alain RENARD, companies director, residing 17 rue Eisenhower, 8321 Olm, Luxembourg
- Mrs. Isabelle SCHUL, employee, residing professionnaly, 41, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg
are renewed for a new period of 1 year. Their mandate will lapse at the Annual General meeting of 2016.
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of one category A Director and one catgory B
Director.
The mandate of FISCOGES, with registered office in L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, as Statutory Auditor is
renewed for a new period of 1 year. Its mandate will lapse at the Annual General meeting of 2016 deliberating on the annual
accounts as at December 31
st
, 2015.
June 17
th
, 2015.
Certified and true
SGC ENERGIA S.A.
<i>The Board of Directorsi>
105544
L
U X E M B O U R G
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire uniquei>
Le mandat des Administrateurs de catégorie A de
- M. Juan Miguel MARTIN IGLESIAS, administrateur de sociétés, demeurant rua Ilha dos Amores, 53, 1990-371
Moscavide, Portugal
- M. Luis Miguel DIAS DA SILVA SANTOS, administrateur de sociétés, demeurant 18, rua Soldados da India, 1400-340
Lisbonne, Portugal
Et le mandat des Administrateurs de catégorie B de
- M. Alain RENARD, administrateur de sociétés, demeurant au 17, rue Eisenhower, 8321 Olm, Luxembourg
- Mme Isabelle SCHUL, employée, demeurant professionnellement au 41, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Lu-
xembourg
sont renouvelés pour une nouvelle période de 1 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de 2016.
La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Administrateur de catégorie A et d'un Admi-
nistrateur de catégorie B.
Le mandate de FISCOGES, avec siège social à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, en tant que Commissaire aux
Comptes est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de 2016 délibérant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015.
Le 17 juin 2015.
Pour extrait sincère et conforme
SGC ENERGIA S.A.
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015100797/47.
(150110449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Capac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 67, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 111.440.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de juin;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
La société à responsabilité limité de droit luxembourgeois “E. & D. CONSULTANTS (Luxembourg) S.à r.l.”, établie
et ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 67, avenue Guillaume, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 42794,
ici dûment représentée par son gérant unique Monsieur Pier Andrea AMEDEO, administrateur de société, demeurant à
L-1651 Luxembourg, 67, avenue Guillaume.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société anonyme “CAPAC S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 67, avenue Guil-
laume, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111440, (la “Société”),
a été constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, notaire alors de résidence à Eschsur-Alzette (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 15 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 242 du 2
février 2006,
et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Aloyse BIEL:
- en date du 16 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2449 du 12
novembre 2010, et
- en date du 17 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1836 du 11 août 2011;
2) Que le capital social est fixé à trente-six mille euros (36.000,- EUR), divisé en trois cent soixante (360) actions avec
une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées;
3) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les
actions de la Société (l'“Actionnaire Unique”);
4) Que l’Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que l’Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en
date de ce jour;
105545
L
U X E M B O U R G
6) Que l’Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins
pouvoirs d’établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
7) Que l’Actionnaire Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de
la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre
il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation
irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;
8) Que l’Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l’actif de la Société et qu'il s’engagera à régler tout le passif de
la Société indiqué au point 7);
9) Que l’Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
10) Que l’Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
relatifs à l’émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;
11) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur
mandat;
12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la
Société.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent soixante euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au représentant légal de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. A. AMEDEO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 30 juin 2015. 2LAC/2015/14436. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 3 juillet 2015.
Référence de publication: 2015108534/61.
(150117863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2015.
Techniplan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 184.928.
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
A comparu:
Madame Katia ALLEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:
Madame Naïma OUADAH, aide auxiliaire de vie, née à Mostaganem (Algérie) le 5 mars 1978, demeurant à F-57190
Florange, 34, rue Jean Jaurès,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée.
Laquelle procuration après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera
annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante dûment représentée, agissant en sa qualité d'associée unique et de gérante administrative de la
société à responsabilité limitée "TECHNIPLAN S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-4123 Esch-sur-Alzette, 3,
rue du Fossé constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date
du 21 février 2014, publié au Mémorial C numéro 1168 du 8 mai 2014, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés Luxembourg sous le numéro B 184928.
Ensuite la comparante, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué à la présente
assemblée, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'associée décide d'ajouter un nouvel alinéa à l'objet social de la société, de sorte qu'il y a lieu de modifier l'article 2 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
105546
L
U X E M B O U R G
« Art. 2. La société a pour objet:
- l'étude, le dessin et le suivi de tous projets industriels dans le domaine de la tuyauterie et de la chaudronnerie;
- tous travaux de terrassement, d'excavation, de canalisation, d'asphaltage et de bitumage;
- tous travaux de pose de jointements et toutes activités de ferrailleur pour béton armé;
- la prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères;
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, la comparante a déclaré close la présente assemblée.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante connue du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: ALLEK, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25/06/2015. Relation: EAC/2015/14374. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 26/06/2015.
Référence de publication: 2015100849/46.
(150110975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Fate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 187.460.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015105788/2.
(150116117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2015.
Universal Strategy Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 148.877.
Le Rapport Annuel Révisé pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014 et l’allocation du résultat relative à l’as-
semblée générale ordinaire du 10 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2015.
Référence de publication: 2015101814/11.
(150111419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
Trinacria Capital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 124.418.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2015.
Référence de publication: 2015100871/10.
(150110877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
105547
L
U X E M B O U R G
Crevest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 34.300.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the fifteen day of June.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
APPEARED:
Mr. Minos ZOMBANAKIS, manager, born on July 16
th
, 1926 in Kalyves, Grece, having his address at Kalyves
Armenon, 73003 Chania, Crète Grèce, being the Sole shareholder of the Company, hereby represented Mrs Cristiana
VALENT, employee, residing professionnally in Junglinster, by virtue of a proxy delivered to her under private seal.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as above stated, declares and requests the notary to act the following:
1.- That the limited company (société anonyme) "CREVEST HOLDING S.A.", governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté, registered with the
Luxembourg Trade and Companies registry, section B, under number 34.300, (hereinafter referred to as the “Company”),
has been incorporated pursuant to a deed of Maître Marc ELTER, then notary residing in Luxembourg, dated 25 June 1990,
published in the Mémorial C number 9 of 10
th
January 1991.
2.- That the share capital of the Company is fixed at thirty thousand nine hundred eighty six euros and sixty nine cents
(EUR 30.986,69) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without a par value.
3.- That the sole shareholder is the sole owner of all the shares of the Company.
4.- That the sole shareholder acting as sole shareholder at an extraordinary shareholders’ meeting amending the articles
of the Company declares the dissolution of the Company with immediate effect and the commencement of the liquidation
process.
5.- That the sole shareholder appoints itself as liquidator of the Company and in its capacity as liquidator of the Company
has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
6.- That the sole shareholder decides to immediately convene the second and third general meeting of shareholders in
accordance with article 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies and to immediately hold these
meetings one after the other.
7.- That the sole shareholder declares that it takes over all the assets of the Company, and that it will assume any presently
known or unknown debts of the Company.
8.- That the sole shareholder further declares in its capacity as sole shareholder of the Company having thorough know-
ledge of the Company's articles of incorporation and of the financial situation of the Company, to waive its right to appoint
an auditor to the liquidation.
9. That the sole shareholder decides to immediately approve the liquidation report and accounts.
10.- That the sole shareholder in the third extraordinary general meeting of shareholders, declares that the liquidation
of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities
shall be cancelled. It confirms that the Company has definitely ceased to exist.
11.- That full discharge is granted to the directors of the Company and the statutory auditor for their mandates.
12.- That all books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at the
former registered office of the Company at L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.
<i>Costsi>
The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and
charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at one thousand euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil status
and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.
105548
L
U X E M B O U R G
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le quinze juin.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Minos ZOMBANAKIS, administrateur, né le 16 juillet 1926 à Kalyves (Grèce), demeurant à Kalyves Ar-
menon, 73003 Chania, Crète Grèce («l’Actionnaire Unique»),
ici représenté par Madame Cristiana VALENT, employée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de partie comparante
et le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte avec lequel elle est enregistrée.
Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, déclare et requière le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1.- Que la société anonyme "CREVEST HOLDING S.A", régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à L-1931
Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 34.300, (ci-après nommée la “Société”), a été constituée suivant acte du notaire Maître Marc ELTER, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1990, publié au Mémorial C numéro 9 du 19 janvier 1991.
2.- Que le capital social de la Société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six et soixante-neuf cents euros (EUR
30.986,69) représenté par mille deux cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.
3.- Que l’actionnaire unique est seule propriétaire de toutes les actions de la Société.
4.- Que l’actionnaire unique agissant comme actionnaire unique siégeant en assemblée générale extraordinaire des
actionnaires modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et
la mise en liquidation.
5.- Que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d’établir, signer, exécuter
et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en
exécution les dispositions du présent acte.
6.- Que l’actionnaire unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l’article
151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.
7.- Que l’actionnaire unique déclare qu'elle reprend tout l’actif de la Société et qu'elle s’engagera à régler tout le passif
impayé présent et futur de la Société.
8.- Que l’actionnaire unique en sa qualité d’actionnaire unique de la Société ayant pleine connaissance des statuts de la
Société et de la situation financière de la Société, renonce à son droit de nommer un commissaire à la liquidation.
9.- Que l’actionnaire unique décide par conséquent d’approuver immédiatement le rapport et les comptes de liquidation.
10.- Que l’actionnaire unique, constituée en troisième assemblée générale extraordinaire, déclare que la liquidation de
la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l’émission des parts sociales ou de tous autres titres
seront annulés. Elle constate que la Société a définitivement cessé d’exister.
11.- Que décharge est donnée aux administrateurs de la Société et au commissaire aux comptes de la Société, pour leurs
mandats.
12.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien
siège social de la Société à L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison de cet acte, est dès lors évalué à mille euros
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 juin 2015. Relation GAC/2015/5124. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2015100326/107.
(150111467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
105549
L
U X E M B O U R G
Multimedia Global Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 69.812.
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «MULTIMEDIA GLOBAL FINANCE S.A.»
établie et ayant son siège social à L-8011 Strassen, 389, Route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard
LECUIT, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 23 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 560 du 21 juillet
1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 69.812.
Les statuts de la société ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Tom METZLER, alors notaire de résidence
à Luxembourg-Bonnevoie en date du 17 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 700 du 27 septembre 2000.
La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean François BELLEFLAMME, demeurant à
B-4020 Liège, 37, rue du Parc.
Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Michèle SENSI-BERGAMI, clerc de notaire, demeurant
professionnellement à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de L- 8011 Strassen, 389, Route d'Arlon à L-1128 Luxembourg, Val Saint
André, 37, et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.
2.- Divers.
II.- Qu'il résulte d'une liste de présence que les QUATRE CENT HUIT (408) actions A et les TROIS CENT QUATRE-
VINGT-DOUZE (392) actions B d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000.-) chacune, représentant l'intégralité
du capital social de HUIT CENT MILLE EUROS (€ 800.000,-) sont dûment présentes ou représentées à la présente
assemblée; cette liste de présence ainsi que les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
par les membres du bureau, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est en conséquence régulièrement constituée
et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée,
a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8011 Strassen, 389, Route d'Arlon, à L-1128
Luxembourg, Val Saint André, 37, et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
"Le siège social de la société est établi à Luxembourg".
Les autres alinéas de l'article 2 restent inchangés.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,
états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: BELLEFLAMME, SENSI-BERGAMI, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25/06/2015. Relation: EAC/2015/14371. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 26/06/2015.
Référence de publication: 2015100642/55.
(150110938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
105550
L
U X E M B O U R G
Vida Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.988.150,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 144.574.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2015.
Référence de publication: 2015100893/10.
(150110900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Goodman Princeton Investments (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 153.623.
<i>Extrait des résolutions en date du 17 juin 2015:i>
1. Il est mis fin en date du 17 juin 2015 au mandat de gérant à savoir:
M. Jean-Bernard Zeimet, gérant de classe B
2. Le gérant suivant est nommé en date du 17 juin 2015 et cela pour une durée illimitée:
M. Miroslav Stoev, né le 4 janvier 1976 à Sofia (Bulgarie), de résidence professionnelle: 28, boulevard d'Avranches,
L-1160 Luxembourg;
- Le conseil de Gérance se compose comme suit:
M. Dominique Prince, gérant de classe A
M. Philippe Van der Beken, gérant de classe A
M. Sansal Ozdemir, gérant de classe B
M. Philip Lance Kianka, gérant de classe B
M. Miroslav Stoev, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Christina Mouradian
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015105831/24.
(150116616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2015.
SES, Société Anonyme.
Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 81.267.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015101731/10.
(150111802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
SINEK Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 109.016.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS FAS
Référence de publication: 2015101737/10.
(150111770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
105551
L
U X E M B O U R G
Singulier Pluriel, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 148.116.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015101738/10.
(150111337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
Pamiga Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 169.627.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 juin 2015 que:
- Madame Renée Chao Beroff, avec adresse au 6, rue Dulong, F-75017 Paris (France), administrateur-délégué;
- Monsieur Ira Lieberman, avec adresse au 5903, Conway Road, MD 20814 Bethesda (Etats-Unis d'Amérique), admi-
nistrateur et président;
- Monsieur Robin McPhail, avec adresse professionnelle au 7, rue Taylor 75010 Paris (France), administrateur;
- Monsieur Massimo Longoni, demeurant au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, administrateur
et délégué à la gestion journalière;
- Monsieur Bruno Tassart, avec adresse professionnelle au 7, rue Taylor F-75010 Paris (France), administrateur;
- Monsieur Kimanthi Mutua avec adresse professionnelle au 7, rue Taylor F-75010 Paris (France), administrateur;
- Monsieur Mathieu Merceret, avec adresse 29, avenue de la République, F-75011 Paris (France), administrateur;
- Deloitte Audit S.à r.l, B 67895, avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, réviseur d'entreprises
agréé.
Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et du réviseur d'entreprises agréé viendront à échéance lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2015.
Référence de publication: 2015106111/24.
(150116033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2015.
Turf Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 102.265.
Les comptes consolidés au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015101783/9.
(150112221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
TCP Lux Eurinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 157.686.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015101784/9.
(150111170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
105552
A.C.I. Roads S.à r.l.
A.C.I. Wines S.à r.l.
Agence Immobilière du Luxembourg S.A.
Agrochim S.A.
Apollo HoldCo S.à r.l.
Arche Associates
Argyle Luxco 2 S.à r.l.
Assembly Team Luxembourg S.à r.l.
B28 Beat Weight s.à r.l.
BAF LATAM REAL ASSETS FUND
Capac S.A.
Cetrel Securities S.A.
Clayax Acquisition Luxembourg 5
Computer Associates Luxembourg S.à r.l.
Corporate Executive Board Luxembourg S.à r.l.
Crevest Holding S.A.
eBay International Treasury Center 2 S.à r.l.
Ethna-DEFENSIV
Fate S.A.
FCP OP Medical
Gestman S.A.
Goodman Lemon Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Princeton Investments (Lux) S.à r.l.
Kantec
Kennametal Luxembourg S.à r.l.
Kestrel Participations S.A.
Letzre
LFPI Property S.à r.l.
Multimedia Global Finance S.A.
OCM Luxembourg POF IV GLP Blocker S.à r.l.
Pamiga Finance S.A.
Revetas GP S.à r.l.
RH Paris 2 S.àr.l.
Schaeffer Marketing S.à r.l.
SEA Glass S.à r.l.-SPF
Selp (Bischofsheim II) S.à r.l.
Selp (Bischofsheim I) S.à r.l.
SES
SGC Energia S.A.
Simelux S.A.
SINEK Capital S.A.
Singulier Pluriel
Société de Promotion et de Développement de l'Aéroport de Luxembourg
Swan Investment Company
TCP Lux Eurinvest S.à r.l.
Techniplan S.à r.l.
Tiar Publications S.à r.l.
Trinacria Capital S.à.r.l.
Turf Capital S.A.
Universal Strategy Fund
Vauban Development S.A.
Victory Asset Management S.A.
Victory Asset Management S.A.
Vida Investments S.à r.l.
Wedidit S.à r.l.
Weisgerberarchitecte S.A.
Z-Wind S.à r.l.