logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2198

24 août 2015

SOMMAIRE

Alphastock Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105498

Axa World Funds II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105460

Care Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105500

CompAM FUND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105497

Crown Premium GP VI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

105494

Devonport Maritime Inc S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

105502

Ethna - AKTIV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105503

Ethna-DYNAMISCH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105503

Fortuna Select Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105462

Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105496

Landmark S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105495

NGP IX Northern Blizzard S.à r.l. . . . . . . . . . .

105503

Oriflame Cosmetics S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105458

Oriflame Cosmetics S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105463

Over the Rainbow A.s.b.l. - International

School  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105499

OVER THE RAINBOW - Ecole Maternelle &

Primaire Multilingue A.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . .

105499

Pacific S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105496

Perseus Real Estate Investment S.à r.l.  . . . . . .

105499

Pfizer PFE Luxembourg Holding 3 S.à r.l.  . . .

105494

Pfizer PFE Luxembourg Holding 4 S.à r.l.  . . .

105494

Pfizer PFE Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

105494

Prevalux Conseil s. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105496

Private Equity Global Select II, Sicar S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105496

Private Equity Global Select IV, Sicar S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105496

Private Equity Plus OP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105495

Ravago Production S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105497

Ravago S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105497

Ravago S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105497

Ravara S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105497

REF Eastern European Opportunities Luxem-

bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105498

Reservjagd Aktiengesellschaft  . . . . . . . . . . . . .

105499

Roose S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105499

Savim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105502

Scarabeo Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

105502

Société Anonyme Paul WURTH  . . . . . . . . . . .

105500

Société de Radiodiffusion Luxembourgeoise

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105500

Stena Carron Lux 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

105501

Stena Drillmax Lux 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

105501

Stena Forth Lux 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

105501

Stena Midwater S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105502

Tishman Speyer 33 Holborn S.à r.l. . . . . . . . . .

105504

105457

L

U X E M B O U R G

Oriflame Cosmetics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 8.835.

The

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

("EGM") of Oriflame Cosmetics S.A. (the "Company") in relation to items 1 to 9 of the agenda below will be held before

a Luxembourg notary on <i>25 September 2015 at 9:00 a.m.

<i>Agenda:

1. Approval of the common Merger Agreement (projet commun de fusion) (the "Merger Agreement"), as approved by

the Company and Oriflame Holding AG (the "Absorbing Company");

2. Approval of the common management's report on the Merger, as approved by the Company and the Absorbing

Company (the "Merger Report");

3. Approval of the audit report issued by an independent auditor in accordance with article 266 of the Luxembourg law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law");

4. Acknowledgement  of  the  confirmation  letter  issued  by  the  Company's  management,  certifying  that  no  material

changes have occurred in the circumstances detailed in the Merger Report (including the Merger's Interim Accounts)
since its issuance and ascertaining the deposit at the registered office of the Company and/or the publication on the
website of the Company of all the required documents (the "Confirmation Letter");

5. Approval of (i) the cross-border merger whereby the Company will be absorbed by OHAG as Absorbing Company

(the "Merger"), (ii) the transfer of the assets and liabilities of the Company to the Absorbing Company, and (iii) the
dissolution without liquidation of the Company;

6. Ratification of any actions carried out by the directors of the Company and Mr. Gabriel Bennet in relation to the

Merger, including without limitation the actions relating to the transfer of any existing agreements and commitments
of the Company to the Absorbing Company;

7. Acknowledgement of the dissolution without liquidation of the Company;
8. Authorization to any one director of the Company and to Mr. Gabriel Bennet, each acting individually under her/his

sole signature, in the name and on behalf of the Company, to do whatever is necessary, useful or desirable in her/his
sole opinion to implement the resolutions to be adopted on the basis of the present agenda and/or which may be
required for the purpose of making the Merger fully effective amongst its parties and vis-à-vis any third parties in
any concerned jurisdictions; an

9. Any other business.

Notice to SDR holders

Holders of Swedish Depository Receipts of the Company ("SDRs") who wish to attend and/or vote at the EGM must:

i. be directly registered or have a voting-right registration in the register kept by Euroclear Sweden AB ("Euroclear")

on 11 September 2015 (i.e. the Record Date), and

ii. if they wish to attend the EGM, notify Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") of their intention to attend

the EGM no later than on 21 September 2015.

SDR holders who wish to attend the EGM must give their notice by sending attendance cards (available upon request

to the Company to be submitted to corporate.governance@oriflame.com) by post to Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ), Issuer Agent Department, RB6, SE-106 40 Stockholm, Sweden. They may also send the attendance card by e-mail
to issuedepartment2@seb.se. All attendance cards must be received by SEB no later than 5:00 p.m. CET on 21 September
2015. The attendance card must be completed in full and duly signed.

<i>Voting instructions for SDR holders

For SDR holders voting is not carried out by attending the EGM. Voting can only be carried out by giving a voting

proxy to SEB. Proxy cards (available upon request to the Company to be submitted to corporate.governance@oriflame.com)
must  be  used.  Fully  completed  and  signed  proxy  cards  must,  in  order  to  be  included  in  the  votes,  be  sent  by  post  to
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Issuer Agent Department, RB6, SE-106 40 Stockholm, Sweden or by e-mail
to issuedepartment2@seb.se and shall be received by SEB no later than 5:00 p.m. CET on 21 September 2015. If the proxy
card is issued on behalf of a legal entity, a certified copy of a registration certificate or corresponding document shall be
appended. If sent by e-mail, then the original proxy card and, where applicable, the certificate should be received in original
by SEB at the postal address indicated above no later than 9:00 a.m. CET on 24 September 2015.

Only directly registered SDRs are registered in the name of the holder in the register kept by Euroclear. SDR holders

registered in the name of a nominee (which may be a broker or a bank) must have their SDRs registered in their own names
in the Euroclear register to be entitled to attend and/or give instructions to SEB to vote at the EGM. SDR holders whose
holdings are registered with a nominee should therefore request their nominee to request a temporary owner registration

105458

L

U X E M B O U R G

(so-called voting-right registration) well ahead of the Record Date if they wish to attend at the EGM and/or exercise their
voting right.

SDR holders that have not given SEB instruction as to the exercise of the voting rights pertaining to the shares represented

by their respective SDRs at the EGM by sending/delivering to SEB a completed and signed proxy card, shall be deemed
to have instructed SEB to give a proxy to a person designated by the Company to vote for the shares in the same manner
and in the same proportion as all other shares in the Company represented by SDRs that are being voted for at the EGM.
However, no such instruction from the SDR holders to SEB shall be deemed given with respect to any matter where giving
such instructions and/or discretionary proxy would not be permitted by applicable law.

It should be noted that a SDR holder resident or located in the United States is not entitled to vote or authorise/instruct

an attorney to vote on the merger matters contemplated under the above Agenda at the shareholders' meeting and any vote
and authorisation/instruction given in violation of this restriction will be disregarded by SEB in consultation with the
Company.

Notice to shareholders

Shareholders who wish to attend and/or vote at the EGM must:

i. in case of registered shareholders, be registered as shareholders in the share register of the Company by midnight CET

on 11 September 2015 (the "Record Date"), or

ii. in case of bearer shareholders, must prove their status as registered bearer shareholders at the Record Date by sub-

mitting to the Company no later than 21 September 2015 a certificate issued by the depositary agent appointed by the
Company (i.e. Mr. François Brouxel, Avocat à la Cour, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg) attesting the
number of shares they hold at the Record Date, and

iii. notify the Company of their intention to attend and/or vote at the EGM no later than on the Record Date.

Shareholders (bearer or registered) who wish to attend and/or vote at the EGM must give notice of their intention to

attend  and/or  vote  by  sending  attendance  cards  (available  upon  request  to  the  Company  to  be  submitted  to
corporate.governance@oriflame.com) to the registered address of the Company as stated above of this Convening Notice
or  by  fax  (+352  26  20  32  34).  They  may  also  send  the  attendance  card  by  email  to  the  Company
(corporate.governance@oriflame.com). All attendance cards must be received by the Company no later than the Record
Date. The attendance card must be completed in full and duly signed.

Shareholders (bearer or registered) and their proxy holders, as the case may be, who intend to attend the EGM in person,

shall present an official identification document (e.g. passport, identity card, etc.) upon their entry in the EGM. Corporate
shareholders represented by authorized representatives shall in addition supply evidence of the authority given to those
persons to represent them at the EGM.

<i>Proxy voting instructions for shareholders (bearer or registered)

Shareholders need not to be present at the EGM in person and may appoint any person to be their proxy. The proxy

holder shall be appointed in writing and such appointment shall be notified to the Company by using the proxy cards
available upon request to the Company to be submitted to corporate.governance@oriflame.com. In order to be included in
the votes, such proxy cards shall be duly completed and signed and shall be sent by postal services to the Company at the
registered address of the Company as stated above of this Convening Notice or by fax (+352 26 20 32 34) or by email
(corporate.governance@oriflame.com) and received by the Company no later than 5:00 p.m. CET on 21 September 2015.
If the proxy card is issued on behalf of a legal entity, a certified copy of a registration certificate or corresponding document
shall be appended. The original proxy card and, where applicable, the certificate should be received by the Company at the
address indicated above no later than 5:00 p.m. CET on 24 September 2015.

General information for SDR holders and shareholders

In accordance with Luxembourg law, shareholders and SDR holders holding individually or collectively at least ten per

cent (10%) of the issued share capital of the Company have the right to put items on the Agenda of the EGM and to table
draft resolutions for items included or to be included on the Agenda of the EGM. These rights shall be exercised upon
written requests of the shareholders and SDR holders submitted to the Company by postal services at the registered address
of the Company or by email (corporate.governance@oriflame.com). The requests shall be accompanied by a justification
and/or a draft resolution to be adopted by the EGM and shall include the electronic or mailing address at which the Company
can acknowledge receipt of these requests. The requests from the shareholders and SDR holders shall be received by the
Company at the latest on 4 September 2015.

The EGM can be validly held with a quorum of at least fifty percent (50%) of the share capital and resolutions shall be

validly adopted at the EGM if approved by a two-third (2/3) majority of the shares present or represented and authorized
to vote.

105459

L

U X E M B O U R G

<i>Further information on the corporate website

This Notice, attendance and proxy cards for shareholders, any supporting documentation with respect to the items of

the agenda of the EGM, as well as the draft resolutions for each item of the agenda of the convened general meetings and
as the case may be the draft resolutions submitted by the shareholders are, as from the publication date of this Convening
Notice, deposited and made available to the public at the Company's registered office and on the website of the Company
at investors.oriflame.com under the heading "General Meetings" as of the day of publication of this Notice.

Shareholders and SDR holders of the Company may obtain a copy of the full, unabridged text of the document to be

submitted to the EGM and of the draft resolutions proposed to be adopted by the EGM by addressing their request to the
Company by email (corporate.governance@oriflame.com) or by post at the registered office of the Company.

Luxembourg, in August 2015
Oriflame Cosmetics S.A.
The Board of Directors

Référence de publication: 2015141220/123.

Axa World Funds II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 27.526.

Nous portons par la présente à l'attention des actionnaires de la Société (les " Actionnaires ") que, à la suite d'une décision

du conseil d'administration de la Société (le " Conseil d'administration "), l'assemblée générale annuelle des Actionnaires
(l'" Assemblée ") qui s'est tenue le 20 août 2015 à 11h00 (heure de Luxembourg) au 49, Avenue J-F Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été ajournée, le quorum requis pour délibérer n'ayant pas été atteint.

Les Actionnaires sont dès lors invités à participer à la :

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>25 septembre 2015 à 11h00 (heure de Luxembourg) au 49, Avenue J-F Kennedy,

L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

En vue de délibérer sur les points suivants

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des modifications et mises à jour suivantes des statuts de la Société (les " Statuts ")

a) Etant donné que les Statuts n'ont jamais été modifiés depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2010
relative aux organismes de placement collectif (la " Loi de 2010 "), remplacement de toutes les références à la " Loi
de 2002 " par des références à la " Loi de 2010 " et, en conséquence, modification de l'Article 3 comme suit :
" L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de tous types et tous
autres actifs financiers liquides autorisés dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses
actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
La Société peut prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au
développement de son objet au sens le plus large permis par la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de
placement collectif ou par toute loi s'y substituant ou la modifiant (la " Loi de 2010 "). " ;
b) Modification de l'Article 4 afin (i) d'introduire la possibilité pour le conseil d'administration de la Société (le "
Conseil ") de transférer de façon permanente le siège de la Société au sein de la même commune et (ii) de préciser
que son transfert dans une autre commune du Grand-Duché de Luxembourg peut être décidé par une assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts ;
c) Modification de l'Article 5 afin d'introduire la possibilité pour le Conseil de modifier les droits attachés à une
classe d'actions de la Société de manière à l'incorporer dans une autre classe d'actions, dès lors que la valeur des
actifs d'une classe d'actions au sein d'un compartiment tombe en deçà de ou n'atteint pas un montant considéré par
le Conseil comme le seuil minimum en dessous duquel la classe en question ne peut plus fonctionner d'une manière
économiquement viable, ou à des fins de rationalisation ;
d) Modification de l'Article 6 afin de stipuler que les certificats d'actions peuvent également être signés, conjointement
ou individuellement, par un Administrateur et/ou un fondé de pouvoir dûment autorisé à cet effet par le Conseil ;
e) Modification de l'Article 8 afin de mettre à jour la définition de " citoyen des Etats-Unis ";
f) Modification de l'Article 11 afin de supprimer son dernier paragraphe en conséquence de la modification apportée
à l'Article 5 ;
g) Modification de l'Article 14 afin de refléter l'obligation pour le Conseil de choisir un président parmi ses membres
conformément à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la " Loi de 1915
") ;
h) Modification de l'Article 16 afin notamment (i) d'introduire la possibilité pour la Société, conformément à la Loi
de 2010, de recourir à des structures maître-nourricier, ainsi qu'à des participations croisées entre compartiments de

105460

L

U X E M B O U R G

la Société, et d'investir dans d'autres actifs dans la mesure permise par la Loi de 2010, et (ii) de simplifier la formu-
lation des restrictions d'investissement fixées conformément à la Loi de 2010 ;
i) Modification de l'Article 19 afin de préciser que la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle ou conjointe de tout Administrateur et/ou fondé de pouvoir auquel
pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil ;
j) Modification de l'Article 21 afin de (i) clarifier que, sauf décision contraire du Conseil, un actionnaire peut non
seulement convertir ses actions d'une classe d'un compartiment en actions de la même classe au sein d'un autre
compartiment, mais aussi convertir ses actions d'une classe en actions d'une autre classe au sein du même compar-
timent ou d'un autre, (ii) remplacer la référence aux distributions en numéraire par une référence à des rachats en
nature et (iii) stipuler que le prix de rachat sera normalement payé dans les quatre jours ouvrés suivant la Date
d'évaluation considérée au lieu de trois ;
k) Modification de l'Article 22 afin de stipuler que la Société (i) peut suspendre temporairement la détermination de
la valeur nette d'inventaire par action de la Société en cas de suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire ou
des  droits  de  souscription,  de  rachat  ou  de  conversion  par  le/les  fonds  d'investissement  dans  lequel/lesquels  un
compartiment investit, ainsi qu'à la suite de la suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire par action/part, de
l'émission, du rachat et/ou de la conversion d'actions/de parts au niveau d'un fonds maître dans lequel un compartiment
de la Société investit en qualité de fonds nourricier dudit compartiment maître et (ii) suspendra immédiatement, au
lieu de pourra suspendre, l'émission, la conversion et le rachat d'actions lors de la survenance d'un événement en-
traînant sa liquidation ainsi que sur ordre de l'autorité de tutelle ;
l) Modification de l'Article 23 afin (i) d'ajouter un point (9) de manière à clarifier la méthode d'évaluation applicable
aux actions ou parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC dans lesquels la Société peut investir, (ii) de supprimer le para-
graphe relatif à la valeur de tous les actifs et passifs libellés dans une autre devise que la devise de référence d'une
classe ou d'un compartiment dans la mesure où il est redondant avec le point (7) et (iii) de clarifier le paragraphe
concernant le mécanisme de swing pricing appliqué par la Société ;
m) Modification de l'Article 24 afin de préciser que les montants dus au titre de la souscription d'actions de la Société
doivent être payés dans un délai maximum de quatre jours ouvrés au lieu de trois à compter de la date d'évaluation
considérée ;
n) Insertion d'un nouvel Article 25 stipulant (i) que la souscription d'actions peut s'effectuer en France dans le cadre
d'un plan d'épargne retraite populaire, (ii) que la Société se soumettra dès lors aux contrôles et aux évaluations
effectués sur la base de justificatifs et in situ par le Comité de supervision du plan et (iii) que les Administrateurs et
les réviseurs d'entreprises de la Société devront, dans ce contexte, fournir à ce comité toutes les informations qu'il
pourra requérir ;
o) Suppression de la dernière phrase de l'Article 25 actuel étant donné que la Société n'est plus tenue, aux termes de
la Loi de 2010, de joindre une copie des comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultat et le rapport du
Conseil, à l'avis de convocation envoyé aux actionnaires enregistrés dès lors que ledit avis indique le lieu où et les
modalités selon lesquelles ces documents peuvent être obtenus et spécifie que tout actionnaire peut demander à ce
qu'ils lui soient envoyés ;
p) Modification de l'Article 27 actuel afin de clarifier que le gestionnaire financier peut, avec l'accord du Conseil et
sous son contrôle, déléguer tout ou partie de ses fonctions de gestion à des sous-gestionnaires financiers en vertu de
contrats de délégation de gestion ;
q) Modification de l'Article 28 actuel afin (i) d'insérer une référence à la Loi de 1915 et (ii) de mettre à jour la
procédure de fusion, telle que modifiée par la Loi de 2010 ;
r) Apport de modifications mineures à plusieurs Articles pour des raisons stylistiques ou afin de corriger des fautes
de frappe.

2. En conséquence du point 1) ci-dessus, approbation des Statuts coordonnés
3. Divers

La version préliminaire des Statuts révisés peut être consultée au siège de la Société.
Cette assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour quelle que soit la

proportion du capital représentée et les points à l'ordre du jour seront adoptés s'ils obtiennent au moins deux tiers des votes
valablement exprimés lors de l'assemblée.

La majorité requise lors de cette assemblée générale extraordinaire sera déterminée en fonction des actions émises par

la Société et en circulation à minuit (heure de Luxembourg) le cinquième jour précédant l'assemblée générale (la " Date
d'enregistrement "). Les droits d'un actionnaire d'assister et de voter à l'assemblée générale extraordinaire sont déterminés
en fonction des actions détenues par l'actionnaire en question à la Date d'enregistrement.

Chaque action entière donne droit à une voix. Les actionnaires peuvent agir lors de toute assemblée au moyen d'une

procuration.

Si vous prévoyez de ne pas assister à l'assemblée en personne, veuillez signer et dater le formulaire de procuration que

vous pourrez obtenir auprès de la Société et le renvoyer dès que possible par fax au numéro suivant : (+ 352) 464 010 413,
puis par poste aérienne au siège de la Société à l'adresse suivante :

State Street Bank Luxembourg
49, Avenue JF Kennedy

105461

L

U X E M B O U R G

L-1855 Luxembourg
A l'attention de Mme Marie-Hélène Iagnemma
Pour être valables aux fins de ladite assemblée, les procurations devront parvenir au siège social de la Société pour le

23 septembre 2015, avant la fermeture des opérations.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015142586/755/111.

Fortuna Select Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 88.201.

Les actionnaires Fortuna Select Fund ont été convoqués à l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 20 août

2015 à 14 heures à l'étude de Maître Henri Hellinckx, au 101, Rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg et aucun quorum n'a été atteint.

Par conséquent, un avis est donné par les présentes aux actionnaires qu'une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires se tiendra le <i>25 septembre 2015 avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social au 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand Duché de Luxembourg ;
2. Modification des articles 3, 16 et 20 des statuts pour remplacer la référence à la loi du 20 décembre 2002 par la

référence à la loi du 17 décembre 2010 et introduction de titres sous chaque numéro d'article ;

3. A l'article 4, ajout des deux paragraphes suivants:

"Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du Conseil d'administration." ;

4. Modification de l'article 5 afin de transférer le sujet de la fermeture, fusion, scission et liquidation des compartiments

et actions aux nouveaux articles 10 et 11 par souci de clarté ;

5. Modification des articles 6 et 8 afin de supprimer la possibilité d'émettre des parts au porteur.
6. Fusion des anciens articles 9 à 12 en un unique article 12 concernant les assemblées générales et insertion du nouveau

siège social au sein du nouvel article 12;

7. Ajout de nouveaux articles 10 et 11 des statuts pour mise en concordance avec la loi du 17 décembre 2010. Les

anciens articles 22 et 23 deviennent un seul article 21. En conséquence, les articles numérotés 24 à 29, dans la
précédente version seront désormais respectivement les articles numérotés 23 à 28 ;

8. Modification de l'article 16 afin d'y insérer la possibilité pour le conseil d'administration de créer des compartiments

de type maître-nourricier ;

9. Dans un souci de cohérence, (i) l'ancien article 21 sur les rachats a été déplacé et devient article 9 ; (ii) les anciens

articles 22 et 23 concernant la valeur nette d'inventaire ont été fusionnés dans un nouvel article 21 (iii) le nouvel
article 22 concerne désormais uniquement la suspension de la valeur nette d'inventaire pour plus de clarté;

VOTE
Comme l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires Fortuna Select Fund tenue le 20 août 2015, avec le même

ordre du jour, n'a pas atteint le quorum requis, la deuxième assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer
sur les points de l'ordre du jour quelle que soit le pourcentage du capital représenté.

Les résolutions sur l'ordre du jour de la deuxième assemblée générale extraordinaire ne nécessiteront pas de quorum et

seront adoptées par les deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés à cette assemblée générale extraordi-
naire.

La  procuration  émise  pour  la  première  assemblée  générale  extraordinaire  restera  valable  pour  l'assemblée  générale

extraordinaire reconvoquée.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent confirmer leur présence par fax au +352.26.39.60.02 ou par

email à domiciliation@lemanik.lu en précisant leurs coordonnées au moins deux jours francs avant la tenue de l'assemblée.

Les actionnaires peuvent assister en personne à l'assemblée générale extraordinaire ou se faire représenter par un re-

présentant. Un formulaire de procuration peut être obtenu au siège social de Fortuna Select Fund et va être envoyé par
courrier le 9 septembre 2015 à tous les actionnaires. Si le soussigné est une société, la procuration doit être établie par un
représentant légal de la société.

Remplir et envoyer la procuration n'exclura pas la possibilité pour les actionnaires de participer et de voter en personne

lors de l'assemblée. Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d'assister à l'Assemblée générale extraordinaire sont priés
de remplir la procuration et l'envoyer à Mme Candice Mayembo, au plus tard le 22 septembre 2015 midi si possible tout
d'abord par fax, au numéro +352 26.39.60.02 et puis la copie originale doit être envoyée par courrier au siège social de

105462

L

U X E M B O U R G

Fortuna Select Fund. Les procurations qui seront reçues au siège social de Fortuna Select Fund après cette date ne seront
plus prises en considération.

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social du Fonds, obtenir le texte complet des modifications aux

statuts.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015142588/755/58.

Oriflame Cosmetics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 8.835.

FUSIONSVERTRAG

vom 18. August 2015
zwischen
Oriflame Cosmetics S.A.
24, Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg: B 8835)
ÜBERTRAGENDE GESELLSCHAFT oder OCSA
und
Oriflame Holding AG
c/o Oriflame Global Management AG
Bleicheplatz 3
8200 Schaffhausen
Schweiz
(Firmennummer CHE-134.446.883)
Übernehmende Gesellschaft oder OHAG
Zusammen die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN

1. Vorbemerkung. Dieser Fusionsvertrag (der FUSIONSVERTRAG) wurde gemeinsam von den Verwaltungsräten der

fusionierenden Gesellschaften gemäss Art. 265 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften, in geltender Fassung (das LUXEMBURGISCHE GESETZ OBER DAS GESELLSCHAFTSRECHT) und
Art. 3 ff. des Schweizer Fusionsgesetzes (das FusG) erarbeitet.

1.1. OCSA
OCSA ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gemäss Art. 2 ff. des LUXEMBURGISCHEN GESETZES ÜBER

DAS GESELLSCHAFTSRECHT, mit Sitz und Hauptverwaltung in Luxemburg. Das Aktienkapital der OCSA beträgt
EUR 71'527'465 und ist eingeteilt in 57'221'972 Aktien ohne einen bezeichneten Nennwert, eingeteilt in 678 voll liberierte
Inhaberaktien (die OCSA INHABERAKTIEN) und 57'221'294 voll liberierte Namenaktien. OCSA und Skandinaviska
Enskild  Banken  AB,  Stockholm,  Schweden  (SEB),  haben  am  1.  März  2014  einen  Vertrag  geschlossen,  wonach  SEB
Namenaktien an OCSA auf einem Wertpapierdepot bei einer Luxemburger Depotbank halten und je Namenaktie an OCSA
ein Schwedisches Depositary Receipts (SDRs) betreffend zugrundeliegende voll liberierte Namenaktien, ohne einen be-
zeichneten Nennwert, an OCSA (die Oriflame SDRs) ausgeben soll. Die Oriflame SDRs sind bei Euroclear Sweden AB,
Stockholm, Schweden, unter dem ISIN-Code SE0001174889 registriert und waren von März 2004 bis zum 2. Juli 2015 an
der Nasdaq Stockholm unter dem Ticker-Symbol ORI SDB kotiert und wurden dort täglich gehandelt. Heute sind bei
EUROCLEAR 2'084'374 Oriflame SDRs (repräsentierend 2'084'374 Namenaktien an OCSA; die OCSA SDR-AKTIEN)
registriert. Die übrigen 55'136'920 voll liberierten OCSA Namenaktien sind nicht durch SDRs vertreten (die NICHT KO-
TIERTEN OCSA NAMENAKTIEN). Von diesen 55'136'920 NICHT KOTIERTEN OCSA NAMENAKTIEN hält OCSA
1'613'409 Aktien als eigene Aktien ohne Stimmrecht (die EIGENEN OCSA AKTIEN; die OCSA INHABERAKTIEN,
die OCSA SDR-AKTIEN und die NICHT KOTIERTEN OCSA NAMENAKTIEN, zusammen, die OCSA AKTIEN und
jede als OCSA AKTIE).

Die OCSA AKTIEN sind weder mit Nutzniessungs-, Pfand-, oder Sicherungsrechten noch mit Gebühren belastet.
Per heutigem Datum hält die OCSA die 1'613'409 EIGENEN OCSA AKTIEN. Per heutigem Datum hält die OHAG 0

OCSA INHABERAKTIEN, 869'411 OCSA SDR-AKTIEN und 53'327'563 NICHT KOTIERTE OCSA NAMENAK-
TIEN.  Folglich  halten  per  heutigem  Datum  andere  Aktionäre  mit  Ausnahme  der  OCSA  oder  OHAG  678  OCSA
INHABERAKTIEN, 1'214'963 OCSA SDR-AKTIEN und 195'948 NICHT KOTIERTE OCSA NAMENAKTIEN.

1.2. OHAG

105463

L

U X E M B O U R G

Die OHAG (Firmennummer CHE-134.446.883) ist eine Aktiengesellschaft Gemäss Art, 620 ff. des Schweizerischen

Obligationenrechts (das OR) mit Sitz in Schaffhausen, mit dem Zweck der Verwaltung und die Veräusserung von Betei-
ligungen  an  in-  und  ausländischen  Unternehmen,  insbesondere  im  Bereich  Produkte  und  Dienstleistungen  für  die
Schönheitsindustrie.

Das Aktienkapital der OHAG beträgt per heutigem Datum CHF 81'445'461; eingeteilt in 54'296'974 voll liberierte

Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.50 pro Aktie (die OHAG AKTIEN, jede eine OHAG AKTIE).

Die ausserordentliche Generalversammlung der OHAG hat am 19. Juni 2015 beschlossen, den Verwaltungsrat zu er-

mächtigen,  das  Aktienkapital  um  bis  zu  CHF  24'000'000  zu  erhöhen  durch  Ausgabe  von  bis  zu  16'000'000  voll  zu
liberierenden OHAG Aktien, worunter der Verwaltungsrat bis zum heutigen Datum bereits 5'805'527 OHAG Aktien aus-
gegeben hat, so dass noch ein genehmigtes Kapital im Betrag von CHF 15'291'709.50 zur Verfügung steht.

Per heutigem Datum hält die OCSA 100'000 OHAG Aktien mit einem Nennwert von CHF 1.50 pro Aktie.
1.3. Fusion
OCSA, OHAG und ihre Tochtergesellschaften (zusammen die GRUPPE) verfolgen eine betriebsinterne Reorganisation

mit dem Zweck, die rechtliche Struktur der GRUPPE an die funktionale und operative Struktur der GRUPPE anzupassen.
Dieser Anpassungsprozess beinhaltet die Verlegung der rechtlichen, funktionalen und operativen Struktur der GRUPPE
in die Schweiz. Vor diesem Hintergrund hat die OHAG am 8. Mai 2015 ein Tauschangebot von OCSA AKTIEN gegen
OHAG AKTIEN angekündigt, um alle OCSA AKTIEN ZU erwerben, d.h. ein öffentliches Übernahmeangebot von OHAG
für alle ausstehenden OCSA AKTIEN (wie unten in dieser Ziffer definiert) unterbreitet und dies in Übereinstimmung mit
dem schwedischen Gesetz über den Handel mit finanziellen Instrumenten (1991:980) (Sw.lagen (1991:980) om handel
med finansiella Instrument), dem schwedischen Börsengesetz (Übernahmeangebote) (2006:451) (Sw. lagen (2006:451)
om offentliga uppköpserbjudanden pä aktiemarknaden), den Richtlinien der NASDAQ Stockholm betreffend die Über-
nahmeangebote an der Börse, und dem einschlägigen schweizerischen Recht (das TAUSCHANGEBOT).

OHAG hat jedem Inhaber von OCSA AKTIEN eine neue OHAG AKTIE pro OCSA AKTIE angeboten.
Das TAUSCHANGEBOT wurde von mehr als der benötigten Mindestanzahl von Aktionären der OCSA (d.h. von mehr

als zwei Dritteln) akzeptiert, um dieses erfolgreich durchzuführen und ist folglich zustande gekommen. In Folge der dem
TAUSCHANGEBOT nachgehenden Abwicklungen im Zusammenhang mit dem TAUSCHANGEBOT wurde die OHAG
Mehrheitsaktionärin der OCSA und die neue Muttergesellschaft der GRUPPE.

Im Zusammenhang mit dem TAUSCHANGEBOT können im Rahmen der zusätzlichen Annahmefristen zwischen dem

heutigen Datum und dem Datum, an welchem die ausserordentlichen Generalversammlungen der OCSA und OHAG die
FUSION genehmigen werden, weitere Abwicklungen erfolgen. Folglich können sich sowohl das ordentliche Kapital sowie
die Anzahl Aktien an der OHAG erhöhen und das genehmigte Aktienkapital der OHAG kann sich reduzieren.

Im Anschluss an die erfolgreichen Abwicklungen des TAUSCHANGEBOTES und wie in der Dokumentation betreffend

das TAUSCHANGEBOT informiert, wird beabsichtigt, dass die OCSA-als letzter Schritt im Reorganisationsprozess der
GRUPPE - mittels grenzüberschreitender Absorptionsfusion gemäss schweizerischem und luxemburgischen Rechts, von
der OHAG übernommen wird.

Die FUSION steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die ausserordentlichen Generalversammlungen der FU-

SIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN ihre Zustimmung erteilen,

1.4. Information der Arbeitnehmer
OCSA hat per Datum der RECHTSWIRKUNG DER FUSION (wie in Ziffer 2.2 unten definiert) keine Arbeitnehmer

und im Besonderen keine Arbeitnehmer in Luxemburg und/oder solche, welche luxemburgischem Arbeitsrecht unterstehen.
Folglich sind weder die Bestimmungen betreffend die Informations- und Konsultationspflicht gemäss luxemburgischem
Recht anwendbar und insbesondere erfüllt die OCSA weder die Voraussetzungen des Kapitels I des Titels 1 des luxem-
burgischen Arbeitsrechtes betreffend die Verpflichtung einen Arbeitsrat zu wählen noch die in Buch IV Kapitel IV Titel
2 des luxemburgischen Arbeitsgesetzes aufgestellten Voraussetzungen betreffend die Beteiligung der Arbeitnehmer am
Management von Aktiengesellschaften (sociétés anonymes).

OHAG bestätigt, dass die Arbeitnehmer über die beabsichtigte FUSION (wie in Ziffer 2.1 unten definiert) mit Schreiben

vom 13. Juli 2015 informiert worden sind.

Die Arbeitnehmer wurden insbesondere über Folgendes informiert:
(a) Die Gründe für die FUSION (wie in Ziffer 2.1 unten definiert); und
(b) Die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen der FUSION (wie in Ziffer 2.1 unten definiert) für die

Angestellten.

Die Arbeitnehmer haben keine Kommentare abgegeben und falls doch, waren diese irrelevant.

2. Fusion.
2.1. Grundsatz
Die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN stimmen hiermit der FUSION gemäss Art. 163a des Schweizer Bun-

desgesetzes  über  das  Internationale  Privatrecht  (das  IPRG)  in  Verbindung  mit  Art.  3  ff.  FusG  sowie  Art.  261  ff.  des
LUXEMBURGISCHEN  GESETZES  ÜBER  DAS  GESELLSCHAFTSRECHT  zu,  womit  alle  Aktiven  und  Passiven
(Fremdkapital) der OCSA kraft Universalsukzession auf die OHAG übergehen und die OCSA im Anschluss an diese

105464

L

U X E M B O U R G

Übertragung -ohne Liquidation - aufgelöst wird (die FUSION). Demzufolge werden die Aktiven in der Höhe von CHF
369'163'602 (entsprechend EUR 354'521'850 umgerechnet in CHF gemäss Preisfestsetzung der Europäischen Zentralbank,
publiziert am 30. Juni 2015, abrufbar unter folgender offizieller Internetseite http://www.ecb.europa.eu/stats/ exchange/
eurofxref/html/index.en.html) und die Passiven (Fremdkapital) in der Höhe von CHF 654731 (entsprechend EUR 628'283
umgerechnet in CHF gemäss Preisfestsetzung der Europäischen Zentralbank, publiziert am 30. Juni 2015, abrufbar unter
folgender offizieller Internetseite http://www.ecb.europa.eu/stats/ exchange/eurofxref/htmt/index.en.html) der OCSA und
somit einen Nettoaktivenüberschuss von CHF 368'509'371 (entsprechend EUR 353'893'567 umgerechnet in CHF gemäss
Preisfestsetzung der Europäischen Zentralbank, publiziert am 30. Juni 2015, abrufbar unter folgender offizieller Internet-
seite http://www.ecb.europa.eu/stats/ exchange/eurofxref/htmi/index.en.html) wie in ihrer geprüften Zwischenbilanz (und
Erfolgsrechnung) per 30. Juni 2015 verbucht -erstellt gemäss Lux GAAP und in Überstimmung mit den Bestimmungen
des Art. 267 des LUXEMBURGISCHEN GESETZTES ÜBER DAS GESELLSCHAFTSRECHT (Beilage 1) - kraft Uni-
versalsukzession auf die OHAG per DATUM DER RECHTSWIRKUNG DER FUSION (wie in Ziffer 2.2 unten definiert)
übertragen, wie insbesondere in Art. 3 Abs. 1 lit. a FusG und Art. 274 des LU XEMBURGISCHEN GESETZ ÜBER DAS
GESELLSCHAFTSRECHT dargelegt.

Die 100'000 OHAG Aktien, welche die OCSA besitzt, werden kraft Universalsukzession im Rahmen der FUSION von

OHAG erworben und zu eigenen Aktien der OHAG.

Die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN vereinbaren, dass sie die FUSION gestützt auf die geprüfte Zwischen-

bilanz der OCSA per 30. Juni 2015 vornehmen werden. Die Handlungen, welche OCSA ab dem 1. Juli 2015 vornimmt,
gelten als für die Rechnung der OHAG vorgenommen. OHAG akzeptiert alle Änderungen, welche seit diesem Zeitpunkt
betreffend die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) im Vergleich zur geprüften Zwischenbilanzen der OCSA per 30. Juni
2015 eingetreten sind. OCSA wird - nach Erhalt (i) eines die Eintragung der FUSION bestätigenden Handelsregisteraus-
zuges von der OHAG und (ii) einer das DATUM DER RECHTSWIRKUNG DER FUSION (wie in Ziffer 2.2 unten
definiert) bescheinigende Mitteilung durch einen luxemburgischen o-der Schweizer Notar - aus dem luxemburgischen
Handelsregister gelöscht.

Da die FUSION nicht gemäss der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26. Oktober

2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten umgesetzt werden kann und
unter Berücksichtigung, dass das LUXEMBURGISCHE GESETZ ÜBER DAS GESELLSCHAFTSRECHT das zu be-
folgende Verfahren bei einer Fusion zwischen zwei Gesellschaften, welche Sitz in Luxemburg und der Schweiz haben,
nicht spezifisch regelt, sind die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN übereingekommen, dass die FUSION mit den
gesetzlichen Auflagen beider Länder übereinstimmen soll.

In dieser Hinsicht erlaubt Art. 257 des LUXEMBURGISCHEN GESETZES ÜBER DAS GESELLSCHAFTSRECHT

ausdrücklich grenzüberschreitende Fusionen, (d.h. Fusionen einer luxemburgischen Gesellschaft mit einer ausländischen
Gesellschaft) vorausgesetzt, dass das auf die ausländische Gesellschaft anwendbare Recht die Fusion ebenfalls erlaubt und
das ausländische Recht eingehalten wird. Gleichermassen sieht Art. 163a IPRG vor, dass eine schweizerische Gesellschaft
eine  ausländische  Gesellschaft  übernehmen  kann,  wenn  das  auf  die  ausländische  Gesellschaft  anwendbare  Recht  dies
gestattet und dessen Voraussetzungen erfüllt sind.

Keine  der  FUSIONIERENDEN  GESELLSCHAFTEN  wurde  aufgelöst,  für  zahlungsunfähig  erklärt  oder  unterliegt

einem Zahlungsaufschub und über die OCSA wurde kein Konkursverfahren eröffnet, der OCSA wurde kein Zahlungsauf-
schub gewährt (sursis de paiement), das Management der OCSA wird nicht kontrolliert (gestion contrôlée), die OCSA wird
nicht  gerichtlich  liquidiert  (liquidation  judiciaire)  und  die  OCSA  hat  auch  keine  Vereinbarungen  oder  Vergleiche  mit
Gläubigern abgeschlossen (concordat préventif de faillite) und es sind auch keine anderen luxemburgischen oder auslän-
dischen  Gesetzesbestimmungen  bezüglich  Zahlungsaufschub,  kontrolliertes  Management,  betrügerischer  Übertragung,
Abschluss von Vereinbarungen oder Vergleichen mit Gläubigern oder ähnlichen luxemburgischen oder ausländischen
Bestimmungen - welche die Rechte der Gläubiger verletzten könnten - im vorliegenden Fall anwendbar.

OHAG  und  OCSA  werden  gemeinsam  den  Fusionsbericht  (der  FUSIONSBERICHT)  ausarbeiten  und  für  jede  der

FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN einen Prüfungsbericht eines unabhängigen Revisors gemäss Art. 15 FusG und
Art. 266 des LUXEMBURGISCHEN GESETZES ÜBER DAS GESELLSCHAFTSRECHT,- für OHAG durch die KPMG
AG, Zürich und für die OCSA durch die KPMG SA, Luxemburg (zusammen die PRÜFUNGSBERICHTE DER REVI-
SOREN)  -  erstellen  lassen,  um  diesen  FUSIONSVERTRAG,  den  FUSIONSBERICHT  und  die  GEPRÜFTEN  ZWI-
SCHENBILANZEN (wie in Ziffer 2.6 unten definiert) zu überprüfen und um einen Bericht gemäss Art. 15 FusG und Art.
266 des LUXEMBURGISCHEN GESETZES ÜBER DAS GESELLSCHAFTSRECHT zu erstellen.

2.2. Zeitpunkt der Wirkung des Fusionsvertrages
Die FUSION wird - gemäss Art. 163a Abs. 2 IPRG in Verbindung mit Art. 22 FusG - am Datum der effektiven Eintragung

der  Beschlüsse  der  Generalversammlungen  der  FUSIONIERENDEN  GESELLSCHAFTEN  beim  Handelsregister  des
Kantons Schaffhausen wirksam (inter partes und gegenüber Dritten) (das DATUM DER RECHTSWIRKUNG DER FU-
SION), d.h. in Überstimmung mit dem Recht der ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT.

Die FUSION wird zwischen den FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN buchhalterisch - nicht aber rechtlich -

rückwirkend  per  1.  Juli  2015  wirksam.  Die  Handlungen,  welche  OCSA  ab  dem  1.  Juli  2015  vornimmt,  gelten  aus
buchhalterischer - nicht aber aus steuerlicher - Sicht als von der OHAG vorgenommen. OHAG akzeptiert alle Änderungen,

105465

L

U X E M B O U R G

welche seit diesem Zeitpunkt betreffend die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) im Vergleich zur geprüften Zwischen-
bilanzen der OCSA per 30. Juni 2015 eingetreten sind.

2.3. Umtauschverhältnis
OHAG wird im Rahmen der FUSION aus ihrem genehmigten Aktienkapital neue OHAG AKTIEN an die OCSA Ak-

tionäre, mit Ausnahme der OCSA und OHAG, ausgeben, um deren Anteils- und Mitgliedschaftsrechte gemäss Art. 9 FusG
zu wahren. Dementsprechend wird das Aktienkapital der OHAG erhöht. OHAG wird so viele voll liberierte OHAG AK-
TIEN mit einem Nennwert von je CHF 1.50 ausgeben wie am 25. September 2015 OCSA Aktien von Aktionären der
OCSA, mit Ausnahme der OHAG und OCSA, gehalten werden. Der Ausgabepreis für die neuen OHAG AKTIEN entspricht
dem Nennwert von CHF 1.50 pro neue OHAG AKTIE. Der gesamte Ausgabebetrag entspricht der Anzahl neuer OHAG
AKTIEN multipliziert mit dem Ausgabebetrag von CHF 1.50 pro neue OHAG AKTIE. Die neuen OHAG AKTIEN werden
aus dem Gesamtbetrag der Nettoaktiven der OCSA in der Höhe von CHF 368'509'371 (entsprechend EUR 353'893'567
umgerechnet in CHF gemäss Preisfestsetzung der Europäischen Zentralbank, publiziert am 30. Juni 2015, abrufbar unter
folgender  offizieller  Internetseite  http://www.ecb.europa.eu/stats/  exchange/eurofxref/html/index.en.html)  geteilt  durch
die Gesamtanzahl aller OCSA AKTIEN multipliziert mit der Anzahl OCSA AKTIEN aller OCSA Aktionäre mit Ausnahme
von OHAG und OCSA per 25. September 2015 (die ANTEILIGEN NETTOAKTIVEN) voll liberiert.

Nicht nur die Nettoaktiven der OCSA, als übertragende Gesellschaft, sondern auch bloss deren ANTEILIGE NET-

TOAKTIVEN  übersteigen  den  Nominalwert  und  damit  auch  den  oben  genannten  Ausgabepreis  der  im  Rahmen  der
Kapitalerhöhung neu ausgegebenen OHAG AKTIEN.

Der Verwaltungsrat der OHAG wird die Kapitalerhöhung, gestützt auf das genehmigte Kapital der OHAG, sofort nach

Genehmigung der FUSION durch die ausserordentliche Generalversammlung der OHAG, beschliessen.

Das Umtauschverhältnis - das die Anzahl OHAG AKTIEN bestimmt, welche die OCSA Aktionäre mit Ausnahme der

OCSA und O-HAG bei der FUSION erhalten - entspricht einer OHAG AKTIE für jede OCSA AKTIE.

Die Verwaltungsräte beider FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN berücksichtigten, dass die Bewertungsmetho-

de zur Berechnung dieses Umtauschverhältnisses sachbezogen und gerecht ist und im Zuge der FUSION nicht zum Nachteil
der OHAG Aktionäre.

Den OCSA Aktionären wird infolge der FUSION keine Ausgleichszahlung gewährt.
2.4. Modalitäten für den Umtausch
Die neuen OHAG AKTIEN werden aus dem vorhandenen genehmigten Aktienkapital der OHAG ausgegeben unter

Ausschluss der Bezugsrechte der bisherigen OHAG Aktionäre, welche gestützt auf Art. 3bis Abs. 3 lit. a der Statuten der
OHAG aus wichtigen Gründen entzogen werden.

Die neuen OHAG AKTIEN, die an OCSA Aktionäre ausgegeben werden, welche OCSA SDR-AKTIEN halten, werden

OHAG AKTIEN in Form von Bucheffekten, basierend auf Wertrechten, sein, welche bei der Euroclear Schweden via SIX
SIS AG registriert werden. Solche 0-HAG AKTIEN werden von der SEB, weiche von der OCSA beauftragt wurde, die
OCSA SDR-AKTIEN im Auftrag der SDR Aktionäre in einem Wertschriftendepot zu halten und für jede OCSA SDR-
AKTIE eine SDR auszugeben hat, ausgetauscht.

Neue OCSA AKTIEN, die an OCSA Aktionäre ausgegebenen werden, welche OCSA INHABERAKTIEN oder NICHT

KOTIERTE OCSA NAMENAKTIEN halten, werden OHAG AKTIEN in Form von Wertrechten sein. Solche OHAG
AKTIEN werden im Aktienbuch und im Wertrechtebuch der OHAG registriert, welche auf dem Aktienbuch und Inhaber-
verzeichnis der OCSA unmittelbar vor des Abschlusses der FUSION basieren.

2.5. Berechtigung am Bilanzgewinn
Die im Zusammenhang mit der FUSION neu auszugebenden OHAG AKTIEN sind für das gesamte Geschäftsjahr 2015

dividendenberechtigt (falls solche ausgeschüttet werden). Weitere Besonderheiten betreffend die Dividendenberechtigung
bestehen keine (Art. 163a Abs. 2 IPRG in Verbindung Art. 13 Abs. 1 lit. e FusG).

2.6. Änderungen In den Vermögenslagen
Die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN stellen fest, dass seit Abschluss der geprüften Zwischenbilanzen (und

Erfolgsrechnungen) der OCSA sowie der OHAG (Beilage 2) per 30. Juni 2015 (die GEPRÜFTEN ZWISCHENBILAN-
ZEN)  keine  wichtigen  Änderungen  in  den  Vermögenslagen  und/oder  Bilanzen  der  FUSIONIERENDEN  GESELL-
SCHAFTEN eingetreten sind, welche die Vermögenslage und/oder Bilanzen der OHAG und OCSA im Sinne von Art.
163a Abs. 2 IPRG in Verbindung mit Art. 11 FusG beeinflussen würde. Die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN
sind sich darüber im Klaren, dass OHAG a) seit dem 30. Juni 2015 ihr ordentliches Aktienkapital um CHF 8708'290.50
durch Ausgabe von 5'805'527 OHAG Aktien mit einem Nennwert von CHF 1.50 - jede Aktie als Gegenleistung für die
früheren OCSA Aktionäre, welche ihre OCSA AKTIEN (mit Ausnahme der eigenen OCSA AKTIEN) im Rahmen des
TAUSCHANGEBOTES während der zusätzlichen Annahmefrist angedient haben - erhöht hat und b) zwischen dem heu-
tigen  Datum  und  dem  Datum,  an  welchem  die  ausserordentlichen  Generalversammlungen  der  OCSA  und  OHAG  die
FUSION genehmigen werden, ihr ordentliches Aktienkapital, auch für ehemalige OCSA Aktionäre, welche ihre OCSA
AKTIEN  (mit  Ausnahme  der  EIGENEN  OCSA  Aktien)  im  Zusammenhang  mit  dem  TAUSCHANGEBOT  in  dieser
Zeitspanne andienen werden, erhöhen wird, dies aber nicht als substanzielle Änderung der Vermögenslage von OHAG
qualifizieren. Sollten nach der Unterzeichnung des FUSIONSVERTRAGES bei einer der beteiligten Gesellschaften we-
sentliche Veränderungen im Aktiv- oder Passiwermögen eintreten, werden die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN

105466

L

U X E M B O U R G

darüber entscheiden, ob der FUSIONSVERTRAG, gegebenenfalls in angepasster Form, fortbestehen soll. Gemäss Art.
163a Abs. 2 IPRG in Verbindung mit Art. 17 FusG sind die OHAG und die OCSA verpflichtet, sich gegenseitig über
allfällige wesentliche Veränderungen zu informieren. Können sich die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN nicht
einigen, hat die von der Veränderung nicht betroffene Partei das Recht, vom FUSIONSVERTRAG zurück zu treten.

2.7. Gewährung von Rechten
Im Rahmen dieser FUSION gibt es keine Inhaber von Sonderrechten oder von Genussscheinen.
2.8. Abfindung
Im Rahmen dieser FUSION wird keine Abfindung gemäss Art. 163a Abs. 2 IPRG in Verbindung mit Art. 8 FusG

gewährt

2.9. Besondere Vorteile
Im Rahmen dieser FUSION wird weder den Verwaltungsratsmitgliedern der OHAG noch den Verwaltungsratsmitglie-

dern der OCSA ein besonderer Vorteil gewährt.

2.10. Gesellschafter mit unbeschränkter Haftung
Bei dieser FUSION sind keine Gesellschafter mit unbeschränkter Haftung beteiligt.
2.11. Informationsrecht
Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht, welcher zugleich einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR darstellt,

die GEPRÜFTEN ZWISCHENBILANZEN, die PRÜFUNGSBERICHTE DER REVISOREN, die geprüfte Jahresrech-
nung des Geschäftsjahres 2014 der OHAG sowie die geprüften Jahresrechnungen und Konzernabschlüsse zusammen mit
den zugehörigen Geschäftsleitungsberichten über die letzten drei Geschäftsjahre der OCSA, können sowohl an den Haupt-
sitzen der OHAG und der OCSA (gemäss der obenstehenden Adresse) als auch auf der Website der GRUPPE unter <http://
investors.oriflame.com> von den Aktionären eingesehen werden.

3. Zustimmungen.
3.1. Verwaltungsrat der OHAG
Das für die OHAG handelnde Mitglied des Verwaltungsrates bestätigt, dass die zustimmende Beschlussfassung des

Verwaltungsrates der OHAG zu diesem FUSIONSVERTRAG bereits erfolgt ist und dass der Verwaltungsrat den Vollzug
dieses FUSIONSVERTRAGES im Namen und im Auftrag der OHAG genehmigt hat.

3.2. Verwaltungsrat der OCSA
Das für die OCSA handelnde Mitglied des Verwaltungsrates bestätigt, dass die zustimmende Beschlussfassung des

Verwaltungsrates der OCSA zu diesem FUSIONSVERTRAG bereits erfolgt ist und dass der Verwaltungsrat den Vollzug
dieses FUSIONSVERTRAGES im Namen und im Auftrag der OCSA genehmigt hat.

3.3. Fusionsbeschluss
Dieser FUSIONSVERTRAG bedarf der Zustimmung durch die Generalversammlung der OHAG und durch die Gene-

ralversammlung der OCSA.

4. Durchführung.
4.1. Zeltliches
Die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN verpflichten sich, alles vernünftigerweise Vertretbare zu unternehmen,

um die in diesem FUSIONSVER TRAG vorgesehene Transaktion gemäss dem in diesem FUSIONSVERTRAG verein-
barten Zeitplan oder so rasch wie möglich zu vollziehen. Dabei werden sie eng kooperieren und die notwendigen Eingaben
und Behördenkontakte miteinander absprechen. Ist die Eintragung der FUSION beim zuständigen Handelsregister bis zum
31. Dezember 2015 nicht möglich, so kann jede Partei von diesem FUSIONSVERTRAG folgenlos zurücktreten

4.2. Konsequenzen der Fusion
Als Folge der Fusion werden:
- alle Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der OCSA kraft Universalsukzession auf die O-HAG übertragen;
- die OCSA Aktionäre (mit Ausnahme von OCSA und OHAG)-als Gegenleistung für die Übertragung der Aktiven und

Passiven (Fremdkapital) von OCSA auf OHAG - für jede OCSA AKTIE eine neue OHAG AKTIE erhalten;

- die OCSA wird ohne Liquidation aufgelöst; und
- die Aktionäre der OCSA (mit Ausnahme von OCSA und OHAG) Aktionäre der OHAG.

5. Geschäftsführung. Im Zeitraum von der Unterzeichnung dieses Fusionsvertrages bis zum Vollzug der FUSION wer-

den die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN ihr Geschäft im Einklang mit der bisherigen Praxis und, wo nötig, zur
Förderung der Fusion weiterführen.

6. Statuten und Organisation der OHAG nach Vollzug. Die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN nehmen zur

Kenntnis, dass die Generalversammlung der OHAG - im Zusammenhang mit der Durchführung der Kapitalerhöhung im
Rahmen der Fusion - verpflichtet ist, Art. 3 (Aktienkapital) und Art. 3bis (genehmigtes Aktienkapital) der Statuten der
OHAG zu revidieren. Der Entwurf der revidierten Statuten der OHAG nach Durchführung der Kapitalerhöhung im Zuge
der FUSION ist in Beilage 3 angehängt.

105467

L

U X E M B O U R G

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der OHAG ändert sich im Zusammenhang mit

dem Vollzug dieses FUSIONSVERTRAGS nicht.

7. Öffentliche Mitteilungen, Handelsregisteranmeldung, Schuldenruf und Grundbuchanmeldungen.
7.1. Öffentliche Mitteilungen
Die FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN werden die Öffentlichkeit über den Inhalt und die Unterzeichnung

dieses FUSIONSVERTRAGES orientieren. Zu diesem Zwecke und in Überstimmung mit Art. 262 des LUXEMBURGI-
SCHEN GESETZES ÜBER DAS GESELLSCHAFTSRECHT wird dieser FUSIONSVERTRAG beim luxemburgischen
Handelsregister eingereicht und darüber hinaus im luxemburgischen Handelsamtsblatt publiziert.

7.2. Handelsregisteranmeldung
Die Beschlüsse der Generalversammlungen der FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN betreffend die Genehmi-

gung der FUSION werden wie folgt publiziert (i) OHAG wird die Anmeldung der Beschlüsse der Aktionäre der OHAG
beim Handelsregister des Kantons Schaffhausen vornehmen und (ii) die notarielle Urkunde betreffend die Beschlüsse der
Generalversammlung der OSCA betreffend die Genehmigung der FUSION wird beim luxemburgischen Handelsregister
angemeldet und darüber hinaus im luxemburgischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.

7.3. Hinweis betreffend Rechte zur Sicherstellung
Sofern nicht ein zugelassener Revisionsexperte bis zur Eintragung der FUSION im Handelsregister des Kantons Schaff-

hausen schriftlich bestätigt hat, dass keine Forderungen bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befriedigung das freie
Vermögen der OHAG nicht ausreicht, ist die OHAG verpflichtet, ihre Gläubigerinnen und Gläubiger im Schweizerischen
Handelsamtsblatt auf ihre Rechte zur Sicherstellung der Forderungen gemäss Art. 163a Abs. 2 IPRG in Verbindung mit
Art. 25 Abs. 1 und 2 FusG hinzuweisen und OHAG wird einen Schuldenruf nach Eintragung der FUSION im Handelsre-
gister vornehmen.

Gemäss Art. 268 des LUXEMBURGISCHEN GESETZES ÜBER DAS GESELLSCHAFTSRECHT können Gläubiger

der OCSA (inklusive Inhaber von Anleihen und Inhaber von Schuldverschreibungen) deren Forderungen schon vor der
Publikation  der  Beschlüsse  der  Generalversammlung  der  OCSA  betreffend  die  Genehmigung  der  FUSION  bestanden
haben, gerichtlich innerhalb von zwei Monaten seit Publikationsdatum, Sicherheiten für ihre Forderungen verlangen -
unabhängig davon ob diese fällig sind oder nicht - wenn die FUSION einen solchen Schutz notwendig macht. Gläubiger
und Inhaber von Anleihen können nach gültiger FUSION von der übernehmenden Gesellschaft verlangen, dass ihre For-
derungen sichergestellt werden und dass, aus dieser Perspektive, die FUSION ihre Rechte nicht beeinträchtigen wird.

7.4. Grundbuchanmeldung
OHAG wird ermächtigt, alle allfälligen Änderungen, die sich für das Grundbuch aus dieser FUSION ergeben, unmit-

telbar nach erfolgter Eintragung der FUSION ins Handelsregister des Kantons Schaffhausen beim zuständigen Grundbu-
chamt anzumelden.

8. Schlussbestimmungen.
8.1. Änderungen und Ergänzungen
Dieser FUSIONSVERTRAG kann nur geändert werden, wenn beide FUSIONIERENDEN GESELLSCHAFTEN ein

schriftliches und unterzeichnetes Dokument vorweisen, welches vom Verwaltungsrat beider FUSIONIERENDER GE-
SELLSCHAFTEN genehmigt worden ist.

8.2. Kosten und Steuern
Sämtliche im Zusammenhang mit dieser FUSION entstehenden Steuern, Abgaben und Kosten trägt die OHAG.
8.3. Salvatorische Klausel
Sollten Teile dieses FUSIONSVERTRAGES nichtig, unwirksam oder sonst aus irgendeinem Grund nicht vollstreckbar

sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieses FUSIONSVERTRAGES im Übrigen nicht berührt. Die Parteien werden
diesen FUSIONSVERTRAG dann so auslegen und gestalten, dass der mit den nichtigen oder rechtsunwirksamen Teilen
angestrebte Zweck soweit als möglich trotzdem erreicht wird.

8.4. Vertragsexemplare
Dieser FUSIONSVERTRAG wird in drei Exemplaren unterzeichnet.
8.5. Beilage
Folgende Beilagen bilden einen integrierenden Bestandteil des vorliegenden FUSIONSVERTRAGES:
(a) Geprüfte Zwischenbilanz (und Erfolgsrechnung) der OCSA per 30. Juni 2015 zusammen mit einer deutschen Über

setzung (Beilage 1);

(b) Geprüfte Zwischenbilanz (und Erfolgsrechnung) der OHAG per 30. Juni 2015 zusammen mit einer deutschen Über-

setzung (Beilage 2); und

(c) Entwurf der revidierten Statuten der OHAG nach der Fusion Version vom 25. September 2015 (Beilage 3).
8.6. Konflikt
Bei Unklarhelten zwischen der deutschen und der englischen Version dieses FUSIONSVERTRAGES geht der deutsche

Wortlaut vor.

105468

L

U X E M B O U R G

9. Anwendbares Recht / Gerichtsstand. Dieser FUSIONSVERTRAG untersteht dem materiellen Schweizer Recht.
Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem FUSIONSVERTRAG gilt als Gerichtsstand Schaffhau-

sen.

MERGER AGREEMENT

as per 18 August 2015
between
Oriflame Cosmetics S.A.
24, Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg: B 8835)
Acquired Company or OCSA
and
Oriflame Holding AG
c/o Oriflame Global Management AG
Bleicheplatz 3
8200 Schaffhausen
Switzerland
(registration number CHE-134.446.883)
Acquiring Company or OHAG
Together the Merging Companies

1. Preamble. This merger agreement (the Merger Agreement) has been jointly prepared by the board of directors of the

Merging Companies in accordance with art. 265 of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on Commercial Companies,
as amended (the Luxembourg Companies Act) and art. 3 et seq. of the Swiss Merger Act (the SMA).

1.1. OCSA
OCSA  is  a  Luxembourg  public  limited  liability  company  (société  anonyme)  pursuant  to  art.  2  of  the  Luxembourg

Companies Act, having its registered office and central administration in Luxembourg. The share capital of OCSA amounts
to EUR 71,527,465 and is divided into 57,221,972 shares without designated nominal value, which are divided into 678
fully paid-in bearer shares (the OCSA Bearer Shares) and 57,221,294 fully paid-in registered shares. On 1 March 2014,
OCSA and Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm, Sweden (SEB), have entered into a contract, according to
which SEB shall hold registered shares in OCSA in a custody account with a Luxembourgian custodian bank and shall
issue one Swedish Depositary Receipts (SDRs) regarding fully paid-in underlying registered shares in OCSA, without
designation of nominal value (the Oriflame SDRs) per registered shares.

The Oriflame SDRs are registered with Euroclear Sweden AB, Stockholm, Sweden, with the ISIN-Code SE0001174889

and were listed on Nasdaq Stockholm with the Ticker-Symbol ORISDB from March 2004 until 2 July 2015 and have been
traded daily. As of today, 2,084,374 Oriflame SDRs (representing 2,084,374 registered shares in OCSA; the OCSA SDR
Shares) are registered. The remaining 55,136,920 fully paid-in OCSA registered shares are not represented by SDRs (the
Non Registered OCSA Shares). OCSA holds 1,613,409 shares out of these 55,136,920 Non Registered OCSA Shares as
treasury shares with no voting rights attached thereto (the OCSA Treasury Shares; the OCSA Bearer Shares, the OCSA
SDR Shares and the Non Registered OCSA Shares, collectively, the OCSA Shares and an OCSA Share each).

No rights of usufruct or pledge, charge or security interests over the OCSA Shares are in existence.
As of the date hereof, OCSA owns the 1,613,409 OCSA Treasury Shares. As of the date hereof, OHAG owns 0 OCSA

Bearer Shares, 869,411 OCSA SDR Shares and 53,327,563 Non Registered OCSA Shares. Accordingly, as of the date
hereof, 678 OCSA Bearer Shares, 1,214,963 OCSA SDR Shares and 195,948 Non Registered OCSA Shares are held by
shareholders other than OCSA or OHAG.

1.2. OHAG
OHAG (identification number CHE-134.446.883) is a corporation pursuant to art. 620 et seq. of Swiss Code of Obli-

gations  (the  CO)  having  its  registered  seat  in  Schaffhausen,  with  the  purpose  to  acquire,  hold,  administrate  and  sell
participations in enterprises in Switzerland and abroad, especially in the field of products and services within the beauty
industry.

As of the date hereof, OHAG's share capital amounts to CHF 81,445,461; divided into 54,296,974 fully paid-in registered

shares with a nominal value of CHF 1.50 each (the OHAG Shares, each a OHAG Share),

The extraordinary general shareholders' meeting of OHAG has resolved on 19 June 2015 to authorize the board of

directors to increase the share capital by up to CHF 24,000,000 by issuing up to 16,000,000 fully paid-in OHAG Shares,
whereunder the board has already issued 5,805,527 OHAG Shares. Thus, an authorized capital in the amount of CHF
15,291,709.50 remains.

105469

L

U X E M B O U R G

As of the date hereof, OCSA owns 100,000 OHAG shares with a nominal value of CHF 1,50 each.
1.3. Merger
OCSA, OHAG and its subsidiaries (collectively the Group) are pursuing an internal reorganisation to align the Group's

legal structure with its functional and operative structure. Such streamlining process involves the relocation of the legal,
functional and operational structure of the Group to Switzerland. Against this background, OHAG announced on 8 May
2015 a share-for-share exchange offer to acquire all OCSA Shares, i.e. a public takeover offer by OHAG for all outstanding
OCSA  Shares,  launched  in  accordance  with  the  Swedish  Financial  Instruments  Trading  Act  (1991:980)  (Sw.lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument), the Swedish Stock Market (Takeover Bids) Act (2006:451) (Sw. lagen
(2006:451) om offentliga uppköpserbju-danden pa aktiemarknaden), the NASDAQ Stockholm's Rules concerning Take-
over Bids on the Stock Market, and relevant Swiss laws (the Exchange Offer).

OHAG offered to each holder of OCSA Shares one new OHAG Share per one OCSA Share.
The Exchange Offer was accepted by more than the minimum required number of shareholders of OCSA (i.e. more than

two-third) to be successfully undertaken and thus materialized. Following the consequential settlements resulting from the
Exchange Offer, OHAG became the majority shareholder of OSCA and the new ultimate parent company of the Group.

There may be further settlements in connection with the Exchange Offer during additional acceptance periods between

the date hereof and the date upon which the extraordinary general shareholders' meetings of OCSA and OHAG will approve
the Merger (as defined below in Section 2.1). Accordingly, the ordinary share capital as well as the number of shares of
OHAG may further increase and the authorized share capital of OHAG may further decrease.

Following the successful settlements of the Exchange Offer, and as informed in the Exchange Offer documentation, the

intention is that OCSA, as a final step in the reorganisation of the Group, will merge into OHAG by way of a cross-border
merger by absorption subject to Swiss and Luxembourg laws.

The Merger (as defined below in Section 2.1) is conditional upon its approval by the extraordinary general shareholders'

meetings of the Merging Companies.

1.4. Information of Employees
OCSA has no employees and in particular no employees located in Luxembourg and/or subject to Luxembourg labour

law as of the Merger Effective Date (as defined below in Section 2.2). No information and consultation of the employees
requirements were therefore applicable under Luxembourg law, and more particularly, OCSA does not fulfil the conditions
precedent of Chapter I of Title 1 of the Luxembourg Labour Code relating to the general obligation to elect a work council
nor does it fulfil the conditions set forth in Book IV Chapter IV Title 2 of the Luxembourg Labour Code relating to the
participation of employees in the management of public companies with limited liability (sociétés anonymes).

OHAG confirms that the employees have been informed on the envisaged Merger (as defined below in Section 2.1) by

letters dated 13 July 2015.

The employees have been informed in particular on:
(a) the reasons for the Merger (as defined below in Section 2.1); and
(b) the legal, economic and social consequences of the Merger (as defined below in Section 2.1) for the employees.
The employees did not provide any comments or, if provided, they were not substantial.

2. Merger.
2.1. General
The Merging Companies hereby agree on the merger pursuant to art. 163a Swiss Federal Act on International Private

Law (the PIL) in connection with art. 3 et seq. SMA, and articles 261 et seq. of the Luxembourg Companies Act, whereby
OHAG will acquire all the assets and liabilities (without equity) of OCSA by means of universal succession of title and by
which OCSA will cease to exist further its dissolution without liquidation (the Merger). Therefore by this Merger, the assets
of CHF 369,163,602 (corresponding to EUR 354,521,850 converted into CHF at the according fixing price of the European
Central bank as published on 30 June 2015 under the following official webpage http://www.ecb.europa.eu/stats/ exchange/
eurofxref/html/index.en.html) and the liabilities (without equity) of CHF 654,231 (corresponding to EUR 628,283 con-
verted into CHF at the according fixing price of the European Central bank as published on 30 June 2015 under the following
official webpage http://www.ecb.europa.eu/stats/ exchange/eurofxref/html/tndex.en.html) of OCSA and therefore a net
asset surplus of CHF 368,509,371 (corresponding to EUR 353,893,567 converted into CHF at the according fixing price
of the European Central bank as published on 30 June 2015 under the following official webpage http://www.ecb.europa.eu/
stats/ exchange/eurofxref/html/index.en.html) as booked in its audited interim accounts as per 30 June 2015, prepared in
Lux GAAP and in accordance with the provisions of art. 267 of the Luxembourg Companies Act (Annex 1), will be
transferred to OHAG by means of a universal succession of title, as specifically set forth in art, 3 para 1 lit. a SMA and art.
274 of the Luxembourg Companies Act on the Merger Effective Date (as defined below in Section 2.2).

The 100,000 OHAG shares owned by OCSA will be acquired by OHAG by means of the universal succession of title

in the course of the Merger and become treasury shares of OHAG.

The Merging Companies agree to perform the Merger based on the audited interim accounts of OCSA as per 30 June

2015. Activities of OCSA carried out from 1 July 2015 on, are considered having been carried out on account of OHAG.
OHAG accepts all changes occurred since then with respect to the assets and the liabilities (without equity) compared to

105470

L

U X E M B O U R G

audited interim accounts of OCSA as per 30 June 2015. OCSA will be deregistered from the Luxembourg Register of Trade
and Companies upon receipt (i) of an excerpt of OHAG reflecting the registration of the Merger in the Register of Commerce
and (ii) of a notification from a Luxembourg or Swiss notary attesting the Effective Date of the Merger (as defined below
in Section 2.2).

As the Merger cannot be pursued according to the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and the Council

of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies, and considering that the Luxembourg Com-
panies  Act  do  not  specifically  establish  the  procedure  to  be  followed  for  mergers  between  companies  registered  in
Luxembourg and Switzerland, it is agreed among the Merging Companies that the Merger should comply with the legal
requirements set forth by both countries,

In this respect, art. 257 of the Luxembourg Companies Act expressly allows for cross-border mergers (i.e. mergers of

a Luxembourg entity with a foreign entity) as long as the law of the jurisdiction of the foreign entity allows the same and
is complied with. Likewise art. 163a PIL provides that a Swiss company may acquire a foreign company if the law applicable
to the foreign company so permits and the conditions fixed by such law are satisfied.

None  of  the  Merging  Companies  has  been  dissolved,  declared  bankrupt,  or  is  under  moratorium  of  payments  nor,

regarding OCSA, under bankruptcy adjudication, filing for moratorium or reprieve from payment (sursis de paiement),
controlled management (gestion contrôlée), judicial liquidation (liquidation judiciaire) or general settlement or composition
with creditors (concordat préventif de faillite), nor any Luxembourg or foreign legal provisions relating to reprieve from
payment, controlled management, fraudulent conveyance, general settlement or composition with creditors, reorganisation
or similar Luxembourg or foreign laws affecting the rights of creditors generally be applicable to it.

OHAG and OCSA will draw up a joint merger report (the Merger Report) and for each of the Merging Companies a

report from an independent auditor will be drawn-up, pursuant to art. 15 SMA and art. 266 of the Luxembourg Companies
Act, by KPMG AG, Zurich with respect to OHAG and KPMG Luxembourg, Société cooperative with respect to OCSA
(collectively the Merger Auditors Reports), to examine this Merger Agreement, the Merger Report and the Merger Interim
Accounts (as defined below in Section 2.6) and to issue a report pursuant to art. 15 SMA and art. 266 of the Luxembourg
Companies Law.

2.2. Effective Date of the Merger
The Merger will be effective (inter partes and vis-a-vis third parties) on the date of effective registration of the share-

holders resolutions of the Merging Companies in the Register of Commerce of the canton of Schaffhausen, in accordance
with art. 163a section 2 PIL in connection with art. 22 SMA (the Merger Effective Date), i.e. in accordance with the law
of the Acquiring Company.

Among the Merging Companies the Merger will have accounting (but not legal] retroactive effect as per 1 July 2015.

Accordingly, activities of OCSA carried out from 1 July 2015 on, will be considered, from an accounting, but not fiscal,
point of view, having been carried out on account of OHAG. OHAG accepts all changes occurred since then with respect
to the assets and the liabilities (without equity) compared to the audited interim accounts of OCSA as per 30 June 2015.

2.3. Exchange Ratio
OHAG will as part of the Merger issue out of its existing authorized share capital new OHAG Shares to OCSA share-

holders other than OCSA and OHAG in order to safeguard their participation and membership rights pursuant to art. 9
SMA. Accordingly, the share capital of OHAG will be increased. OHAG will issue as many fully paid-in registered OHAG
Shares, with a nominal value of CHF 1.50 each, as OCSA Shares held by shareholders of OCSA other than OHAG or
OCSA on 25 September 2015. The issue price per new OHAG Share corresponds to the nominal value of each new OHAG
Share of CHF 1.50. The aggregate issue amount will be the number of new OHAG Shares multiplied with the issue price
of each new OHAG Share of CHF 1.50. The new OHAG Shares will be paid-in by the aggregate net assets of OCSA of
CHF 368,509,371 (corresponding to EUR 353,893,567 converted into CHF at the according fixing price of the European
Central bank as published on 30 June 2015 under the following official webpage-http://www.ecb.europa.eu/stats/ exchange/
eurofxref/html/index.en.html) divided by the aggregate number of all OCSA Shares multiplied with the number of OCSA
shares of all OCSA shareholders besides OHAG and OCSA as per 25 September 2015 (the Prorated Net Assets).

Not only the net assets of OCSA, as the acquired entity, but also its Prorated Net Assets, exceed the nominal value and,

hence, the aforementioned aggregate issue price of the shares newly issued by OHAG in the course of the capital increase.

The capital increase out of the existing authorized share capital of OHAG will be resolved by the board of directors of

OHAG immediately after the extraordinary general shareholders' meeting of OHAG has approved the Merger.

The exchange ratio - which determines the number of OHAG Shares that OCSA shareholders will receive under the

merger - is one fully paid-in OHAG Share for each OCSA Share.

The board of directors of both Merging Companies consider that the valuation method used for such ratio calculation

is relevant and fair, and will not be detrimental to OHAG' shareholders upon the Merger.

No cash consideration is intended to be paid to any OCSA shareholders as a result of the Merger.
2.4. Manner in which the Exchange will be made
The new OHAG Shares will be issued out of the existing authorized share capital of OHAG with the exclusion of the

preemptive subscription rights of the OHAG shareholders, which shall be withdrawn for valid reasons as set forth in
accordance with art. 3bis para. 3 lit. a of the articles of association of OHAG.

105471

L

U X E M B O U R G

New OHAG Shares, issued to OCSA shareholders holding OCSA SDR Shares, will be OHAG Shares in the form of

book entry securities (Bucheffekten) based on uncertificated securities (Wertrechte) which will be registered with Euroclear
Sweden through SIX SIS AG. Such OHAG Shares will be exchanged by SEB who has been commissioned by OCSA to
hold the OCSA SDR Shares, on behalf of SDR hold-ers, in a custody account and to issue one SDR for each OCSA SDR
Share.

New OHAG Shares, issued to OCSA shareholders holding Bearer Shares or Non Registered OCSA Shares, will be

OHAG Shares in the form of uncertificated securities (Wertrechte). Such OHAG Shares will be registered in the share
ledger (Aktienbuch) and the ledger of uncertificated securities (Wertrechteb-uch) of OHAG based on the share ledger as
well as the bearer share register of OCSA immediately prior to completion of the Merger,

2.5. Eligibility regarding Balance Sheet Profit
The OHAG Shares to be newly issued as consideration within the Merger are eligible for dividends (if any) for all of

the business year 2015. There are no further particularities regarding the eligibility for dividends (art. 163a sec. 2 PIL in
connection with art. 13 sec. 1 lit. e SMA).

2.6. Changes in Financial Position
The Merging Companies state that since the date of the audited interim accounts as per 30 June 2015 of OCSA as well

as the audited interim accounts as per 30 June 2015 of OHAG attached hereto as Annex 2, used in furtherance of the Merger
(the Merger Interim Accounts), no substantial changes in the financial and/or accounting positions of the Merging Com-
panies which would affect the financial and/or accounting situation of the Merging Companies in the sense of art. 163a
sec. 2 PIL in connection with art. 11 SMA of OHAG and OCSA occurred. The Merging Companies are aware that OHAG
a) since 30 June 2015 increased its ordinary share capital by CHF 8,708,290.50 through the issuance of 5,805,527 OHAG
shares with a nominal value of CHF 1.50 each as consideration for former OCSA shareholders who tendered their OCSA
Shares in connection with the Exchange Offer during the additional acceptance periods and b) will between the date hereof
and  the  date  upon  which  the  extraordinary  general  shareholders'  meeting  of  OHAG  approves  the  Merger  increase  its
ordinary share capital also for former OCSA shareholders who tendered their OCSA Shares in connection with the Exchange
Offer during this period, but do not qualify this as substantial changes in the financial positions of OHAG. In case that any
substantial changes in the assets or liabilities of the involved companies should occur after the signing of this Merger
Agreement, the Merging Companies will decide, whether the Merger Agreement shall, if indicated adapted, continue.
According to art. 163a sec. 2 PIL in connection with art. 17 SMA OHAG and OCSA are obligated to inform each other
about possible substantial changes. In case the Merging Companies do not agree, the party not affected by the changes has
the right to withdraw from this Merger Agreement.

2.7. Grant of Rights
There are no holders of special rights, or profit sharing certificates in the context of the Merger.
2.8. Cash or Other Compensation
No cash or other compensation in the meaning of art. 163a sec. 2 PIL in connection with art. 8 SMA shall be granted

in connection with the Merger.

2.9. Special Advantages
No special advantage shall be granted to the members of the boards of directors of OHAG or OCSA or to their respective

independent auditor in connection with the Merger.

2.10. Partners with Unlimited Liability
There are no partners with unlimited liability involved in the Merger.
2.11. Information right
The Merger Agreement, the Merger Report, the Merger Interim Accounts, the Merger Auditors Reports, the audited

annual accounts of the business year 2014 of OHAG as well as the audited annual accounts and consolidated accounts
together with the related management reports for the last three business years of OCSA, are available for inspection by the
shareholders at OHAG's and OCSA's headquarters (at the addresses indicated above), as well as on the Group's website
under http://investors.oriflame.com.

3. Approvals.
3.1. Board of Directors of OHAG
The acting member of the board of directors of OHAG confirms that the board of directors of OHAG has approved this

Merger Agreement and that the board has authorized the execution, in the name and on behalf of OHAG, of this Merger
Agreement.

3.2. Board of Directors of OCSA
The acting member of the board of directors of OCSA confirms that the board of directors of OCSA has approved this

Merger Agreement and that the board has authorized the execution, in the name and on behalf of OCSA, of this Merger
Agreement.

3.3. Merger Resolution
The Merger Agreement requires the consent of the extraordinary general meeting of shareholders of both, OHAG and

OCSA.

105472

L

U X E M B O U R G

4. Execution.
4.1. Timing
The Merging Companies undertake to do whatever is commercially reasonable so that the transactions envisaged in the

Merger Agreement can be completed pursuant to the timetable set forth in the Merger Agreement or as soon as possible.
They shall cooperate and agree on all necessary filings and contacts with authorities. Each party may withdraw from the
Merger Agreement without any consequences if the due registration of the Merger with the competent registers of commerce
is not possible by 31 December 2015.

4.2. Consequences of the Merger
As a result of the Merger:
- All OCSA assets and liabilities (without equity) will be transferred to OHAG by means of universal succession of title;
- OCSA shareholders (besides OCSA and OHAG) will receive one new OHAG Share per OCSA Share, in consideration

for the transfer of OCSA's assets and liabilities (without equity) to OHAG;

- OCSA will cease to exist following its dissolution without liquidation; and
- The shareholders of OCSA (besides OCSA and OHAG) will become shareholders of OHAG.

5. Management. For the period between the signing of the Merger Agreement and the completion of the Merger, the

Merging Companies shall conduct their businesses in accordance with past practice and in furtherance of the Merger, where
necessary.

6. Articles of Association and Organisation of OHAG after execution. The Merging Companies take note, that the

general shareholders meeting of OHAG is required to amend the art. 3 (Share Capital) and art. 3bis (Authorized Share
Capital) of the articles of association of OHAG in connection with the completion of share capital increase required in
connection with the Merger. The draft of the articles of association of OHAG as so amended after the capital increase in
connection with the Merger as indicated in Annex 3.

The composition of the board of directors and the management of OHAG shall not be modified in connection with the

execution of this Merger Agreement.

7. Public Announcements, Application to the Register of Commerce, Creditor's claim, Application for Entry in to the

Land Register.

7.1. Public Announcements
The Merging Companies shall inform the public about the content and signing of this Merger Agreement. To that end

and in accordance with art. 262 of the Luxembourg Companies Act, this Merger Agreement will be filed with the Lux-
embourg trade and companies register and further published in the Luxembourg official gazette.

7.2. Application to the Register of Commerce
The shareholder's resolutions of the Merging Companies approving the Merger will be made public, to the extent (i)

OHAG shall file an application to the Register of Commerce of the canton of Schaffhausen for the registration of the OHAG'
shareholders resolutions and (ii) the notarial deed recording OCSA' shareholders resolutions approving the Merger will be
filed with the Luxembourg trade and companies register and further published in the Luxembourg official gazette.

7.3. Remark regarding Security of Creditors' Claims
Unless a specially licensed audit expert confirms in writing prior to the registration of the Merger into the Register of

Commerce of the canton of Schaffhausen that no claims are known or to be expected that could not be satisfied through
the disposable assets of OHAG, OHAG is required to notify its creditors in the Swiss Official Gazette of Commerce about
their rights to demand security for their claims as set forth in art. 163a sec. 2 PIL in connection with art. 25 sec. 1 and 2
SMA and OHAG shall be responsible for such creditors call upon registration of the Merger in the Register of Commerce.

According to art. 268 of the Luxembourg Companies Act, creditors (including bonds and notes holders) of OCSA whose

claims predate the date of publication of the OCSA' shareholders resolutions approving the Merger may judicially request
within a two-month period after such publication date, that appropriate safeguards of collateral be provided to them with
respect to their claims, whether mature or immature, where the Merger would render such protection necessary. Creditors
and bondholders may, upon effective Merger, demand request of their claim from the Acquiring Company and, from that
perspective, the Merger will not affect their rights.

7.4. Application for Entry into the Land Register
OHAG shall be authorized to apply for entry into the competent land register all changes resulting for the land register

immediately upon registration of the Merger into the Register of Commerce of the canton of Schaffhausen

8. Miscellaneous.
8.1. Modification
This Merger Agreement may only be modified by an instrument in writing signed by both Merging Companies and

approved by the board of directors of both Merging Companies.

8.2. Costs and Taxes
All taxes, charges and costs arising out of this Merger shall be borne by OHAG.

105473

L

U X E M B O U R G

8.3. Severability
Should parts of this Merger Agreement be or become void, ineffective or unenforceable for any other reason, the validity

of the remaining provisions of the Merger Agreement shall not be affected. Accordingly, the parties shall interpret and
perform the Merger Agreement to the effect that the purpose intended with the void or legally ineffective parts will none-
theless be achieved as far as legally possible.

8.4. Copies
This Merger Agreement is executed in three copies.
8.5. Annexes
The following annexes shall be an integral part of this Merger Agreement:
(a) Audited interim accounts of OCSA as per 30 June 2015 together with a German translation (Annex 1);
(b) Audited interim accounts of OHAG as per 30 June 2015 together with a German translation (Annex 2); and
(c) Draft version of the articles of association of OHAG as amended upon the Merger as of 25 September 2015 (Annex

3).

8.6. Conflict
In case of any inconsistencies between the German and the English version of this Merger Agreement, the German

wording shall prevail.

9. Applicable Law / Jurisdiction. This Merger Agreement shall be governed by and construed in accordance with the

substantive laws of Switzerland.

All disputes arising out of or in connection with this Merger Agreement shall be submitted to the jurisdiction of Schaff-

hausen.

OCSA / OHAG
Magnus Brännström / Gabriel Bennet

<i>Balance Sheet As at 30 June 2015

European central bank as per June 30 

th

 CHF / EUR 1,0413

ASSETS

EURO

CHF

Fixed Assets
Financial Fixed Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 501 419 357 688 028
Shares in affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 266 215 314 749 810
Own shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 235 204

42 938 218

343 501 419 357 688 028

Current Assets
Debtors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 631 434

8 987 912

Amounts owed by affiliated undertakings
becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 209 250

8 548 292

Other receivables
becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

422 184

439 620

Cash at bank, cash in postal cheque accounts, cheques and cash in hand . . . . . . . . . . . . .

2 388 997

2 487 663

11 020 431

11 475 575

TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 521 850 369 163 602
LIABILITIES
Capital and reserves
Subscribed capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 527 465

74 481 549

Share premium and similar premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 032 425

16 694 564

Reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 265 742

47 135 217

Legal reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 435 399

7 742 481

Reserve for own shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 235 204

42 938 218

Other reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3 404 861

-3 545 482

Profit or loss brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 406 385 230 550 469
Profit or loss for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-338 450

-352 428

353 893 567 368 509 371

Non-subordinated debts
Amounts owed to credit institutions

-

becoming due and payable within one year

-

105474

L

U X E M B O U R G

Amounts owed to affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137 684

143 370

becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137 684

143 370

becoming due and payable after more than one year

-

Tax and social security debts

-

Tax debts

-

Other creditors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 599

510 861

becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 599

510 861

628 283

654 231

Deferred Income

628 283

654 231

TOTAL LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 521 850 369 163 602

<i>Bilanz vom 30. Juni 2015

Europäische Zentralbank per 30. Juni CHF / EUR 1,0413

Aktiven

EURO

CHF

Anlagevermögen
Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 501 419 357 688 028
Anteile an verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 266 215 314 749 810
Eigene Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 235 204

42 938 218

343 501 419 357 688 028

Umlaufvermögen
Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 631 434

8 987 912

Forderungen gegenüber verbundenen Untemehmen
fällig und zahlbahr innert eines Jahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 209 250

8 548 292

Andere Forderungen
fällig und zahlbahr innert eines Jahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

422 184

439 620

Bank- und Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 388 997

2 487 663

11 020 431

11 475 575

Total Aktiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 521 850 369 163 602
Passiven
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 527 465

74 481 549

Ausgabeagio und vergleichbare Agien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 032 425

16 694 564

Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 265 742

47 135 217

Gesetzliche Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 435 399

7 742 481

Reserven für eigene Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 235 204

42 938 218

Sonstige Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3 404 861

-3 545 482

Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 406 385 230 550 469
Ergebnis für das Geschäftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-338 450

-352 428

353 893 567 368 509 371

Nicht nachrangige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

-

fällig und zahlbahr innert eines Jahres

-

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137 684

143 370

fällig und zahlbahr innert eines Jahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137 684

143 370

fällig und zahlbahr innert mehr als einem Jahr

-

Steuer- und Sozialversicherungsverbindlichkeiten

-

Steuerschulden

-

Weitere Gläubiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 599

510 861

fällig und zahlbahr innert eines Jahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 599

510 861

628 283

654 231

Transitorische Passiven

-

628 283

654 231

Total Passiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 521 850 369 163 602

105475

L

U X E M B O U R G

<i>Profit and Loss Statement As at 30 June 2015

CHARGES

EUR

CHF

Use of merchandise, raw materials and consumable materials

-

Other external charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 223 279 301
Staff costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 229 281 389
Salaries and wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 000 253 036
Social security on salaries and wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 229

28 354

Value adjustments on formation expenses and on tangible and on intangible fixed assets

-

Other operating charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 352 131 570
Value adjustments and fair value adjustments in respect of financial fixed assets

-

Interest and other financial charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 639 114 167
Other interest and similar financial charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 639 114 167
Income tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 607 120 382
Profit for the financial year

-

Total charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 050 926 809
INCOME
Net turnover

-

Reversal of value adjustments on current assets

-

Other operating income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 600

53 731

Income from financial fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 520 650
derived from affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 520 650
Other interest and other financial income

-

Other interest and similar financial income

-

Loss for the financial period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 450 352 428
Total income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 050 926 809
Aufwand
Materialaufwand

-

Sonstiger externer Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 223 279 301
Personalaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 229 281 389
Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 000 253 036
Sozialversicherungsaufwand für Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 229

28 354

Wertberichtigungen zu Gründungskosten, Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten

-

Sonstiger betrieblicher Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 352 131 570
Wertberichtigungen und Anpassungen auf den niedrigeren, beizulegenden Zeitwert (Fair Value)
der Finanzanlagen

-

Zinsen und ähnlicher finanzieller Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 639 114 167
Sonstige Zinsen und ähnliche finanzieller Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 639 114 167
Steuern auf das Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 607 120 382
Gewinn des Geschäftsjahres

-

Total Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 050 926 809
Ertrag
Nettoumsatzerlös

-

Auflösungen von Wertberichtigungen zu Gegenständen des Umsatzvermögens

-

Sonstiger betrieblicher Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 600

53 731

Ertrag aus Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 520 650
von verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 520 650
Sonstige Zinsen und ähnliche finanzielle Erträge

-

Sonstige Zinsen und ähnliche finanzielle Erträge

-

Verlust des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 450 352 428
Total Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 050 926 809
Balance sheet as at

Notes

30 June 2015

31 December 2014

Assets

EUR

CHF

EUR

CHF

Cash and cash equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

570 430

593 987

632 085

759 988

Other short-term receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 259

19 013

5 088

6 118

105476

L

U X E M B O U R G

due from third parties
Prepaid expenses/accrued income . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 372

10 800

-

-

Total current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

599 061

623 800

637 173

766 106

Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

651 610 354 680 867 659

-

-

Total non-current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

651 610 354 680 867 659

-

-

Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

652 209 415 681 491 459

637 173

766 106

Liabilities
Other short-term liabilities
due to shareholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

83 533

100 436

due to third parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 090

81 315

-

-

Accrued expenses and deferred Income . . . . . . . . . . . .

1 190 854

1 240 036

13 896

16 708

Total current liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 268 944

1 321 351

97 429

117 144

Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

69 592 309

72 737 171

124 254

150 000

Legal capital reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

582 639 317 608 880 489

497 018

600 000

- reserves from capital contribution . . . . . . . . . . . . . . .

6/7

* reserves for treasury shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

627 272

750 000

-

-

* other reserves from capital contributions . . . . . . . . . .

582 018 045 608 130 489

497 018

600 000

Accumulated losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 291 155)

(1 447 552)

(81 528) (101 038)

- toss brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(81 528)

(98 960)

-

-

- loss for the period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 209 627)

(1 278 836)

(81 528)

(98 960)

- currency conversion reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

(69 756)

-

(2 078)

Shareholders' equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

650 940 471 680 170 108

539 744

648 962

Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

652 209 415 681 491 459

637 173

766 106

Bilanz per

Bemerkungen

30. Juni 2015

31. Dezember 2014

Aktiven

EUR

CHF

EUR

CHF

Liquide Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

570 430

593 987

632 085

759 988

Sonstige kurzfristige Forderungen
von Dritten geschuldet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 259

19 013

5 088

6 118

Transitorische Aktiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 372

10 800

-

-

Total Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

599 061

623 800

637 173

766 106

Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

651 610 354 680 867 659

-

-

Total Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

651 610 354 680 867 659

-

-

Total Aktiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

652 209 415 681 491 459

637 173

766 106

Passiven
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
gegenüber Aktionären . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

83 533

100 436

gegenüber Dritten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 090

81 315

-

-

Transitorische Passiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 190 854

1 240 036

13 896

16 708

Total kurzfristige Verbindlichkeiten . . . . . . . . .

1 268 944

1 321 351

97 429

117 144

Aktienkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

69 592 309

72 737 171

124 254

150 000

Gesetzliche Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

582 639 317 608 880 489

497 018

600 000

- Reserven aus Kapitaleinlagen . . . . . . . . . . . . .

6/7

* Reserven für eigene Aktien . . . . . . . . . . . . . .

621 272

750 000

-

-

* Weitere Reserven aus Kapitaleinlagen . . . . . .

582 018 045 608 130 489

497 018

600 000

Bilanzverluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 291 155)

(1 447 552)

(81 528) (101 038)

- Verlustvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(81 528)

(98 960)

-

-

- Vertust aus Periode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 209 627)

(1 278 836)

(81 528)

(98 960)

- Währungsumrechnungsreserven . . . . . . . . . . .

-

(69 756)

-

(2 078)

Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

650 940 471 680 170 108

539 744

648 962

Total Passiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

652 209 415 681 491 459

637 173

766 106

Income statement for the period

Note

01.01.2015 - 30.06.2015

06.10.2014 - 31.12.2014

EUR

CHF

EUR

CHF

Financial expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(15 695)

(16 593)

(446)

(541)

Non-operating expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

(80 804)

(98 082)

105477

L

U X E M B O U R G

Non-recurring expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

(1 176 171)

(1 243 466)

-

-

Result before taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 191 866)

(1 260 059)

(81 250)

(98 623)

Direct taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(17 761)

(18 777)

(278)

(337)

Loss for the period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 209 627)

(1 278 836)

(81 528)

(98 960)

Erfolgsrechnung

Bemerkungen

01.01.2015 - 30.06.2015

06.10.2014 - 31.12.2014

EUR

CHF

EUR

CHF

Finanzielle Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . .

(15 695)

(16 593)

(446)

(541)

Nicht-operative Aufwendungen . . . . . . . . . . .

-

-

(80 804)

(98 082)

Einmalige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . .

11

(1 176 171)

(1 243 466)

-

-

Ergebnis vor Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 191 866)

(1 260 059)

(81 250)

(98 623)

Direkte Steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(17 761)

(18 777)

(278)

(337)

Verlust für die Periode . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 209 627)

(1 278 836)

(81 528)

(98 960)

STATUTEN

der
Oriflame Holding AG
(Oriflame Holding SA)
(Oriflame Holding Ltd)
mit Sitz in Schaffhausen

1. Firma, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Firma und Sitz. Unter der Firma Oriflame Holding AG (Oriflame Holding SA) (Oriflame Holding Ltd) besteht

eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR und den vorliegenden Statuten mit Sitz in Schaffhausen. Die Dauer der
Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 2. Zweck.
1 Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in-

und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich Produkte und Dienstleistungen für die Schönheitsindustrie.

2 Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In-

und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen.

3 Die Gesellschaft kann Betriebsgrundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
4 Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck

der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

5 Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren

direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte
Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich
ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktio-
nären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels
Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob ent-
geltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der
Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich
(Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft
und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

2. Aktienkapital

Art. 3. Aktienkapital. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 83'562'844.50 und ist eingeteilt in 55'708'563

Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.50. Die Aktien sind vollständig liberiert.

Art. 3 

bis

 . Genehmigtes Aktienkapital.

1 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt (einschliesslich im Falle eines Öffentlichen Angebots für Aktien der Gesellschaft),

jederzeit bis zum 19. Juni 2017 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 13'174'326 durch Ausgabe von höchstens
8'782'884 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.50 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen
sind gestattet.

2 Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wird für maximal [3'024'998 (dieser Betrag wird sich um die Anzahl

Aktien der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg und Oriflame SDRs (wie nachfolgend definiert) reduzieren, welche im
Rahmen künftiger Nachfristen des Tauschangebots (wie nachfolgend definiert) angedient werden)] Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 1.50 entzogen und SEB (wie nachfolgend definiert), handelnd als Umtauschagent namens und für
Rechnung der Eigentümer von Oriflame SDRs (wie nachfolgend definiert), welche das Tauschangebot (wie nachfolgend
definiert) im Rahmen der allenfalls verlängerten Nachfrist(en) annehmen, oder François Brouxel (wie nachfolgend defi-

105478

L

U X E M B O U R G

niert), handelnd als Umtauschagent namens und für Rechnung der Namen- und Inhaberaktionäre der Oriflame Cosmetics
S.A., Luxembourg, welche das Tauschangebot im Rahmen der allenfalls verlängerten Nachfrist(en) annehmen, zugewiesen.

3 Der Verwaltungsrat ist ferner (einschliesslich im Falle eines öffentlichen Angebots für Aktien der Gesellschaft) er-

mächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben oder Dritten zuzuweisen, auch bezüglich des
genehmigten Aktienkapitals gemäss Art. 3bis Abs. 2 (soweit dieses genehmigte Aktienkapital im Rahmen der Abwicklung
und nach Abschluss des Vollzugs des Tauschangebotes nicht mehr benötigt wird), im Falle der Verwendung der Aktien:

(a) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder für neue Investitionsvorhaben

oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen;

(b) für Zwecke der Beteiligung strategischer Partner oder zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises in bes-

timmten Investorenmärkten oder im Zusammenhang mit der Kotierung der Aktien an inländischen oder an ausländischen
Börsen, inklusive im Zusammenhang mit der Gewährung einer Mehrzuteilungsoption an ein Bankenkonsortium;

(c) für Beteiligungen von Mitarbeitern oder Verwaltungsräten der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften;
(d) für die rasche und flexible Beschaffung von Eigenkapital durch eine Aktienplatzierung, welche mit Bezugsrechten

nur schwer möglich wäre.

4 Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Bestim-

mungen gemäss Art. 5 der Statuten.

5 Der Verwaltungsrat legt den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien, die

Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat
neue  Aktien  mittels  Festübernahme  durch  eine  Bank,  ein  Bankenkonsortium  oder  einen  Dritten  und  anschliessendem
Angebot an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen,
oder er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen
platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

Art. 3 

ter

 . Bedingtes Aktienkapital.

1 Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 3'621'000.00 erhöht durch Ausgabe von höchs-

tens 2'414'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.50, entweder durch Ausgabe
von Aktien an Mitarbeiter oder Verwaltungsräte der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften oder durch Ausübung
von Optionsrechten, die Mitarbeitern oder Verwaltungsräten der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften gewährt
werden, jeweils gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat auszuarbeitenden Plänen und unter Berücksichtigung
der Leistungen, Funktionen, Verantwortungsstufen und Rentabilitätskriterien. Die Ausgabe von solchen Aktien oder Be-
zugsrechten darauf kann zu einem unter dem Börsenkurs liegenden Preis erfolgen.

2 Das Vorwegzeichnungsrecht und das Bezugsrecht der Aktionäre sind ausgeschlossen. Der Erwerb der Namenaktien

durch die Ausübung von Optionsrechten sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Bestimmungen
gemäss Art. 5 der Statuten.

Art. 3 

quater

 . Sacheinlage.  Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 19. Juni 2015 (i) gemäss Sa-

cheinlagevertrag vom 19. Juni 2015 im Austausch gegen 47'779'545 Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je
CHF 1.50 47'779'545 an der Nasdaq Stockholm kotierte und gehandelte Depositary Receipts betreffend zugrundeliegende
voll liberierte Namenaktien, ohne einen bezeichneten Nennwert, an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg (die Ori-
flame SDRs; ISIN-Code: SE0001174889; Ticker-Symbol: ORI SDB) von Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm,
Schweden (SEB), handelnd als Umtauschagent namens und für Rechnung der Eigentümer von Oriflame SDRs, welche das
Tauschangebot der Gesellschaft vom 8. Mai 2015 betreffend alle Oriflame SDRs und allen Namen- und Inhaberaktien an
der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg (das Tauschangebot), per 15. Juni 2015, 17:00 MEZ, angenommen haben und
(ii) gemäss Sacheinlagevertrag vom 19. Juni 2015 von François Brouxel, c/o Wildgen, Partners in Law, Luxembourg,
Luxembourg (Francois Brouxel), handelnd als Umtauschagent namens und für Rechnung der Namenaktionäre der Oriflame
Cosmetics S.A., Luxembourg, welche das Tauschangebot per 15. Juni 2015, 17:00 MEZ, angenommen haben, 611'902
voll liberierte Namenaktien, ohne einen bezeichneten Nennwert, an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg im Aus-
tausch gegen 611'902 Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je CHF 1.50. Die Differenz in der Höhe von CHF
608'280'488.79 zwischen dem totalen Nennwert der ausgegebenen Namenaktien an der Gesellschaft und dem Übernah-
mewert  der  Sacheinlage  im  Gesamtbetrag  von  CHF  680'867'659.29  wird  als  Agio  den  Kapitaleinlagereserven  der
Gesellschaft gutgeschrieben.

Art. 3 

quinquies

 . Sacheinlage.  Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 8. Juli 2015 (i) gemäss Sa-

cheinlagevertrag vom 8. Juli 2015 im Austausch gegen 4'393'829 Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je CHF
1.50 4'393'829 Swedische Depositary Receipts betreffend zugrundeliegende voll liberierte Namenaktien, ohne einen be-
zeichneten Nennwert, an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg (die Oriflame II SDRs; ISIN-Code: SE0001174889)
von  SEB  (wie  in  Art.  3 

quater

  definiert),  handelnd  als  Umtauschagent  namens  und  für  Rechnung  der  Eigentümer  von

Oriflame II SDRs, welche das Tauschangebot (wie in Art. 3 

quater

 definiert) während der ersten Nachfrist per 3. Juli 2015,

17:00 MEZ, angenommen haben und (ii) gemäss Sacheinlagevertrag vom 8. Juli 2015 von François Brouxel (wie in Art.

quater

 definiert), handelnd als Umtauschagent namens und für Rechnung der Namenaktionäre der Oriflame Cosmetics

S.A., Luxembourg, welche das Tauschangebot während der ersten Nachfrist per 3. Juli 2015, 17:00 MEZ, angenommen

105479

L

U X E M B O U R G

haben, 122767 voll liberierte Namenaktien, ohne einen bezeichneten Nennwert, an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxem-
bourg, im Austausch gegen 122767 Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je CHF 1.50. Die Differenz in der
Höhe von CHF 57'089773.44 zwischen dem totalen Nennwert der ausgegebenen Namenaktien an der Gesellschaft und
dem Übernahmewert der Sacheinlage im Gesamtbetrag von CHF 63'864'667.44 wird als Agio den Kapitaleinlagereserven
der Gesellschaft gutgeschrieben.

Art. 3 

sexies

 . Sacheinlage.  Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 13. August 2015 (i) gemäss

Sacheinlagevertrag vom 13. August 2015 im Austausch gegen 869'411 Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von
je CHF 1.50 869'411 Schwedische Depositary Receipts betreffend zugrundeliegende voll liberierte Namenaktien, ohne
einen  bezeichneten  Nennwert,  an  der  Oriflame  Cosmetics  S.A.,  Luxembourg  (die  Oriflame  III  SDRs;  ISIN-Code:
SE0001174889)  von  SEB  (wie  in  Art.  3 

quater

  definiert),  handelnd  als  Umtauschagent  namens  und  für  Rechnung  der

Eigentümer von Oriflame III SDRs, welche das Tauschangebot (wie in Art. 3 

quater

 definiert) während der zweiten Nachfrist

per 7. August 2015, 17:00 MEZ, angenommen haben und (ii) gemäss Sacheinlagevertrag vom 13. August 2015 von Francois
Brouxel (wie in Art. 3 

quater

 definiert), handelnd als Umtauschagent namens und für Rechnung der Namenaktionäre der

Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, welche das Tauschangebot während der zweiten Nachfrist per 7. August 2015,
17:00 MEZ, angenommen haben, 419'520 voll liberierte Namenaktien, ohne einen bezeichneten Nennwert, an der Oriflame
Cosmetics S.A., Luxembourg, im Austausch gegen 419'520 Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je CHF 1.50.
Die Differenz in der Höhe von CHF 16'872'106.79 zwischen dem totalen Nennwert der ausgegebenen Namenaktien an der
Gesellschaft und dem Übernahmewert der Sacheinlage im Gesamtbetrag von CHF 18'805'503.29 wird als Agio den Ka-
pitaleinlagereserven der Gesellschaft gutgeschrieben.

Art. 3 

septies

 . Sacheinlage.  Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 10. September 2015 (i) gemäss

Sacheinlagevertrag vom 10. September 2015 im Austausch gegen - Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je
CHF 1.50 - Schwedische Depositary Receipts betreffend zugrundeliegende voll liberierte Namenaktien, ohne einen be-
zeichneten Nennwert, an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg (die Oriflame IV SDRs; ISIN-Code: SE0001174889)
von  SEB  (wie  in  Art.  3 

quater

  definiert),  handelnd  als  Umtauschagent  namens  und  für  Rechnung  der  Eigentümer  von

Oriflame IV SDRs, welche das Tauschangebot (wie in Art. 3 

quater

 deflniert) während der dritten Nachfrist per 7. September

2015, 17:00 MEZ, angenommen haben und (ii) gemäss Sacheinlagevertrag vom 10 September 2015 von François Brouxel
(wie in Art. 3 

quater

 definiert), handelnd als Umtauschagent namens und für Rechnung der Namen- und Inhaberaktionäre

der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, welche das Tauschangebot während der dritten Nachfrist per 7. September
2015, 17:00 MEZ, angenommen haben, - voll liberierte Namen- und Inhaberaktien, ohne einen bezeichneten Nennwert,
an der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, im Austausch gegen - Namenaktien der Gesellschaft zum Nennwert von je
CHF 1.50. Die Differenz in der Höhe von CHF - zwischen dem totalen Nennwert der ausgegebenen Namenaktien an der
Gesellschaft und dem Übernahmewert der Sacheinlage im Gesamtbetrag von CHF - wird als Agio den Kapitaleinlagere-
serven der Gesellschaft gutgeschrieben.

Art. 4. Form der Aktien, Umwandlung von Aktien.
1 Die Gesellschaft gibt ihre Namenaktien in Form von Einzelurkunden, Globalurkunden oder Wertrechten aus. Der

Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Namenaktien
jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form umzuwandeln. Sie trägt dafür die Kosten.

2 Die Gesellschaft führt über die von ihr ausgegebenen Wertrechte ein Buch (Wert-rechtebuch), in das die Anzahl und

Stückelung der ausgegebenen Wertrechte sowie die Gläubiger eingetragen werden. Das Wertrechtebuch ist nicht öffentlich.
Die Wertrechte entstehen mit Eintragung in das Wertrechtebuch und bestehen nur nach Massgabe dieser Eintragung.

3 Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Umwandlung von in bestimmter Form ausgegebenen Aktien in eine andere

Form. Der Aktionär kann jedoch von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm
gemäss Aktienregister gehaltenen Aktien verlangen.

4 Wertrechte können nur durch Zession übertragen werden. Eine solche Zession bedarf zur Gültigkeit der Anzeige an

die Gesellschaft. Ihre Verpfandung richtet sich nach den Vorschriften über das Pfandrecht an Forderungen. Bucheffekten,
denen Namenaktien der Gesellschaft zugrunde liegen, können indessen nicht durch Zession übertragen werden. An diesen
Bucheffekten können auch keine Sicherheiten durch Zession bestellt werden. Namenaktien der Gesellschaft, die gemäss
Art. 5 Abs. 3 der Statuten in einem Wertschriftenregister gemäss dem Schwedischen Financial Instruments Accounts Act
(1998:1479) oder anderweitig gemäss schwedischem Recht registriert sind, sind in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen dieses Gesetzes und anderer anwendbaren schwedischen Gesetze zu übertragen. Unverbriefte Namenaktien der
Gesellschaft, die gemäss Artikel 5 Abs. 3 der Statuten in einem Wertschriftenregister gemäss dem Schwedischen Financial
Instruments Accounts Act (1998:1479) oder anderweitig gemäss schwedischem Recht registriert sind, können nach Mass-
gabe dieses oder anderer anwendbaren schwedischen Gesetze verpfändet werden.

Art. 5. Aktienbuch, Übertragung von Aktien.
1 Die Gesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen

und Adresse eingetragen werden. Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über den Erwerb der Aktie zu
Eigentum oder die Begründung einer Nutzniessung voraus. Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär oder als
Nutzniesser nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Wechselt eine im Aktienbuch eingetragene Person Ihre

105480

L

U X E M B O U R G

Adresse, so hat sie dies der Gesellschaft mitzuteilen. Solange dies nicht geschehen ist, erfolgen alle brieflichen Mitteilungen
rechtsgültig an die bisher im Anteilbuch eingetragene Adresse.

2 Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen.
3 Ungeachtet der Abs. 1 und 2 dieses Artikels und solange die Gesellschaft Partei eines Affiliation Agremeents mit

Euroclear Sweden AB in Schweden ist, können die Aktien der Gesellschaft sowie die Erwerber dieser Aktien in ein Werts-
chriftenregister  gemäss  dem  Schwedischen  Financial  Instruments  Accounts  Act  (1998:1479)  und  anderweitig  gemäss
schwedischem Recht eingetragen werden.

4 Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten und trifft die zur Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen notwendigen

Anordnungen. Er kann diese Aufgaben delegieren.

3. Organisation

Art. 6. Organe der Gesellschaft. Die Organe der Gesellschaft sind:
(a) Die Generalversammlung
(b) Der Verwaltungsrat
(c) Die Revisionsstelle
3.1. Die Generalversammlung

Art. 7. Befugnisse. Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende unübertragbaren

Befugnisse zu:

(a) Festsetzung und Änderung der Statuten;
(b) Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und aus diesen Mitgliedern Wahl des Präsidenten des Verwal-

tungsrates und Einzelwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses sowie Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
und der Revisionsstelle;

(c) Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie Beschlussfassung über die

Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende;

(d) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen (Geschäfts-

leitung);

(e) Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung gemäss Statuten;
(f) Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten

sind oder ihr durch den Verwaltungsrat vorgelegt werden.

Art. 8. Versammlungen.
1 Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäfts-

jahres statt.

2 Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, so oft es notwendig ist, insbesondere in den vom Gesetz

vorgesehenen Fällen.

3 Ausserdem müssen ausserordentliche Generalversammlungen durch den Verwaltungsrat einberufen werden auf Bes-

chluss  einer  Generalversammlung  oder  wenn  es  ein  oder  mehrere  Aktionäre,  welche  zusammen  mindestens  10%  des
Aktienkapitals vertreten, schriftlich und unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge, bei Wahlen der
Namen der vorgeschlagenen Kandidaten, verlangen.

Art. 9. Einberufung und Traktandierung.
1  Die  Generalversammlung  wird  durch  den  Verwaltungsrat,  nötigenfalls  durch  die  Revisionsstelle  einberufen.  Das

Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren zu.

2 Die Generalversammlung wird durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft eingeladen, und zwar min-

destens 20 Tage vor dem Versammlungstag. Die Aktionäre können überdies auch schriftlich (mit uneingeschriebenem
Brief) orientiert werden. Die Gesellschaft stellt die Einladung auch auf ihrer Website zur Verfügung. Solange Namenaktien
der Gesellschaft an einer Schwedischen Börse kotiert sind, kann die Gesellschaft gleichzeitig mit der Einladung auch einen
Hinweis auf die Einladung in einer Schwedischen Tageszeitung publizieren. Die Einberufung erfolgt in englischer Sprache
und kann ins Schwedische übersetzt werden.

3 Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Lagebericht, der Vergütungsbericht und der

Revisionsbericht  am  Sitz  der  Gesellschaft  zur  Einsicht  der  Aktionäre  aufzulegen.  In  der  Einberufung  zur  Generalver-
sammlung ist auf diese Auflegung und auf das Recht der Aktionäre hinzuweisen, die Zustellung dieser Unterlagen verlangen
zu können.

4 In der Einberufung sind neben Tag, Zeit und Ort der Versammlung die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge

des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die
Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

5 Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen Aktien im Nennwert von mindestens CHF 1'000'000 oder mindestens

10% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen verlangen. Das Begehren

105481

L

U X E M B O U R G

hat schriftlich und unter genauer Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge 45 Tage vor der Generalver-
sammlung zu erfolgen.

6 Zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden. Hiervon sind

jedoch der Beschluss über den in einer Generalversammlung gestellten Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen
Generalversammlung sowie derjenige auf Durchführung einer Sonderprüfung ausgenommen.

7 Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung

bedarf es nicht der vorgängigen Ankündigung.

Art. 10. Vorsitz, Protokolle.
1 Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident, bei dessen Verhinderung ein anderes Mitglied des Ver-

waltungsrates oder ein anderer von der Generalversammlung gewählter Tagespräsident, der nicht Aktionär sein muss.

2 Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzähler, die nicht Aktionäre sein müssen.
3 Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung der Protokolle, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unter-

zeichnen sind.

Art. 11. Stimmrecht, Vertretung.
1 Vorbehaltlich Art. 5 der Statuten berechtigt jede Aktie zu einer Stimme.
2 Jeder Aktionär kann sich In der Generalversammlung durch einen Dritten, welcher nicht Aktionär sein muss und sich

durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Vorbe-
halten bleibt die gesetzliche Vertretung.

3 Zur Teilnahme an der Generalversammlung und Ausübung des Stimmrechts in der Generalversammlung sind dieje-

nigen Aktionäre berechtigt, die an dem jeweils vom Verwaltungsrat bezeichneten Stichtag im Aktien buch als Aktionäre
mit Stimmrecht eingetragen sind.

4 Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird von der Generalversammlung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der

nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dessen Amtsdauer abläuft,
ist sofort wieder wählbar. Die Pflichten des unabhängigen Stimmrechtsvertreters bestimmen sich nach anwendbaren Ge-
setzen, Regeln und Richtlinien. Die Generalversammlung kann den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit Wirkung auf
das Ende der Generalversammlung abberufen.

5  Hat  die  Gesellschaft  keinen  unabhängigen  Stimmrechtsvertreter,  ernennt  der  Verwaltungsrat  den  unabhängigen

Stimmrechtsvertreter für die nächste Generalversammlung.

6 Der Verwaltungsrat erlässt die Verfahrensvorschriften über die Teilnahme und Vertretung an der Generalversamm-

lung.

Art. 12. Quoren und Beschlüsse.
1 Die Generalversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre oder der vertre-

tenen Aktien.

2 Wahlen und Abstimmungen erfolgen in der Regel offen, sofern der Vorsitzende nicht eine schriftliche oder elektro-

nische Wahl oder Abstimmung anordnet. Der Vorsitzende kann jederzeit im Interesse der Zuverlässigkeit des Ergebnisses
geheime Abstimmung anordnen. In diesem Fall gilt die vorausgegangene offene Wahl oder Abstimmung als nicht gesche-
hen.

3 Der Verwaltungsrat kann Vorschriften für Abstimmungen und Wahlen mittels elektronischem Verfahren erlassen.

Elektronische Wahlen und Abstimmungen sind geheimen Wahlen und Abstimmungen gleichgestellt.

4 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen

Aktienstimmen, soweit nicht zwingendes Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten.

5 Kommt im ersten Wahlgang eine Wahl nicht zustande und stehen mehr als ein Kandidat zur Wahl, ordnet der Vorsi-

tzende einen zweiten Wahlgang an, in dem das relative Mehr entscheidet

6 Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute

Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist für die im Gesetz genannten Fälle erforderlich.

3.2. Der Verwaltungsrat

Art. 13. Wahl, Konstituierung.
1 Der Verwaltungsrat besteht aus zwei oder mehreren Mitgliedern.
2 Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Amtsdauer von einem Jahr einzeln gewählt. Als Jahr gilt die

Zeit von einer ordentlichen Generalversammlung zur nächsten. Unter dem Jahr gewählte neue Mitglieder setzen die Amts-
dauer ihres Vorgängers fort.

3 Die Mitglieder und der Präsident des Verwaltungsrates können beliebig oft wieder gewählt werden.
4 Soweit in den Statuten nicht anders vorgesehen, konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Er bezeichnet aus seiner

Mitte nach Bedarf einen oder mehrere Vizepräsidenten. Der Verwaltungsrat bezeichnet ferner einen Sekretär, der nicht
Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht.

105482

L

U X E M B O U R G

5 Ist das Präsidium des Verwaltungsrates vakant, kann der Verwaltungsrat aus seinen Mitgliedern einen neuen Präsi-

denten für die verbleibende Amtsdauer bezeichnen.

Art. 14. Oberleitung, Delegation.
1 Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft und die Überwachung der Geschäftsführung. Er

vertritt die Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglementen
einem anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind.

2 Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte ständige oder ad hoc Ausschüsse bestellen, welche mit der Vorbereitung

und Ausführung seiner Entscheide oder der Aufsicht bestimmter Geschäftsbereiche betraut sind. Der Verwaltungsrat stellt
sicher, dass er umfassend informiert bleibt.

3 Der Verwaltungsrat kann, unter Vorbehalt der unübertragbaren Aufgaben, einen Teil seiner Befugnisse oder alle seine

Befugnisse nach Massgabe eines von Verwaltungsrat zu erlassenden Organisationsreglements an einzelne oder mehrere
Mitglieder der Geschäftsleitung oder Vertreter der Gesellschaft, Verwaltungsräte, Ausschüsse oder Dritte übertragen, wel-
che nicht Aktionäre sein müssen.

Art. 15. Aufgaben. Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
(a) Oberleitung des Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen;
(b) Festlegung der Organisation;
(c) Ausgestaltung Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;
(d) Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen und Regelung der

Zeichnungsberechtigung;

(e) Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der

Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;

(f) Erstellung des Geschäftsberichtes und des Vergütungsberichtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und

Ausführung ihrer Beschlüsse;

(g) Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;
(h) Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig liberierte Aktien;
(i) Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statutenänderungen;
(j) Prüfung der fachlichen Voraussetzungen der Revisionsstelle;
(k) die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben gemäss den auf die Gesellschaft anwendbare Gesetze oder Ve-

rordnungen.

Art. 16. Organisation, Protokolle.
1 Sitzungsordnung, Beschlussfähigkeit (Präsenz) und Beschlussfassung des Verwaltungsrates richten sich nach dem

Organisationsreglement. Die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrates ist auch auf dem Wege einer Telefon- oder
Videokonferenz möglich ist.

2 Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Der Vorsitzende

hat den Stichentscheid.

3 Für öffentlich zu beurkundende Feststellungsbeschlüsse genügt die Anwesenheit eines einzigen Mitglieds des Ver-

waltungsrates (Art. 634a, 651a, 652g, 653g, 653i OR).

4 Beschlüsse auf dem Zirkularweg oder per Telefax, E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den

Nachweis des Beschlusses durch Text ermöglicht, sind statthaft sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt.

5 Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom

Vorsitzenden und vom Sekretär zu unterzeichnen.

6 Der Verwaltungsrat ordnet im Übrigen und vorbehaltlich der Statuten seine Organisation und Beschlussfassung durch

ein Organisationsreglement.

Art. 17. Vergütungsausschuss.
1 Der Vergütungsausschuss besteht aus mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Jedes Mitglied des Vergü-

tungsausschusses  wird  einzeln  von  der  Generalversammlung  für  eine  Amtsdauer  bis  zum  Abschluss  der  nächsten
ordentlichen Generalversammlung gewählt. Mitglieder des Vergütungsausschusses, deren Amtsdauer abläuft, sind sofort
wieder wählbar. Bei Vakanzen im Vergütungsausschuss kann der Verwaltungsrat die fehlenden Mitglieder aus seinen
Mitgliedern für die verbleibende Amtsdauer bezeichnen.

2 Der Vergütungsausschuss konstituiert sich selbst und wählt einen Vorsitzenden aus seinen Mitgliedern. Er bestimmt

seinen Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates oder des Vergütungsausschusses sein muss.

3 Der Vergütungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Festsetzung und Überprüfung der Vergütungsstra-

tegie und -richtlinien der Gesellschaft und der Leistungskriterien sowie bei der Vorbereitung der Anträge zuhanden der
Generalversammlung betreffend die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Er kann dem Verwal-
tungsrat  Vorschläge  und  Empfehlungen  zu  weiteren  Vergütungsfragen  unterbreiten.  Der  Verwaltungsrat  erlässt  ein
Reglement, welches Zweck, Zusammensetzung und Verfahrensregeln des Vergütungsausschusses bestimmt, einschliess-

105483

L

U X E M B O U R G

lich seinen Aufgaben und Befugnissen zur Stellung von Anträgen und Fassung von Beschlüssen bezüglich der Vergütung
der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und regulatori-
schen  Anforderungen,  diesen  Statuten  und  dem  vom  Verwaltungsrat  von  Zeit  zu  Zeit  genehmigten  entsprechenden
Vergütungssystem. Der Verwaltungsrat kann dem Vergütungsausschuss weitere Aufgaben und Befugnisse zuweisen.

3.3. Die Revisionsstelle

Art. 18. Wählbarkeit, Aufgaben.
1 Die Generalversammlung wählt jedes Jahr einen oder mehrere Revisoren als Revisionsstelle, welche unabhängig von

der Gesellschaft sein und die gesetzlichen besonderen fachlichen Voraussetzungen erfüllen müssen. Die Revisionsstelle
kann wiedergewählt werden.

2 Die Revisionsstelle hat die Rechte und Pflichten gemäss den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Sie ist verp-

flichtet, den Generalversammlungen, für welche sie Bericht zu erstatten hat, beizuwohnen.

4. Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Art. 19. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
1 Die Generalversammlung genehmigt jährlich und mit bindender Wirkung die Anträge des Verwaltungsrates in Bezug

auf:

(a) den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer;
(b) den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli des Jahres der

ordentlichen Generalversammlung bis zum 30. Juni des folgenden Jahres;

(c) den Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr.
2 Der Verwaltungsrat kann der Generalversammlung abweichende oder zusätzliche Anträge in Bezug auf die gleichen

oder andere Zeitperioden zur Genehmigung vorlegen.

3 Genehmigt die Generalversammlung einen Antrag des Verwaltungsrates nicht, setzt der Verwaltungsrat in einem

neuen Antrag den entsprechenden (maximalen) Gesamtbetrag respektive die (maximalen) Gesamtbeträge oder den ents-
prechenden  (maximalen)  Teilbetrag  respektive  die  (maximalen)  Teilbeträge  unter  Berücksichtigung  aller  relevanten
Faktoren fest, und unterbreitet den oder die so festgesetzten Beträge derselben Generalversammlung, einer ausserordent-
lichen Generalversammlung oder der nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Genehmigung.

4 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Unternehmen können Vergütungen vor der Genehmigung durch die Ge-

neralversammlung unter Vorbehalt der nachträglichen Genehmigung durch eine Generalversammlung und anwendbarer
Rückforderungsbestimmungen (Claw-back) ausrichten oder zuteilen.

Art. 20. Zusatzbetrag für Wechsel In der Geschäftsleitung. Reicht der bereits von der Generalversammlung genehmigte

maximale Gesamtbetrag der Vergütung für die Vergütung einer Person, die Mitglied der Geschäftsleitung wird oder in-
nerhalb der Geschäftsleitung befördert wird, nicht aus, nachdem die Generalversammlung die Vergütung genehmigt hat,
sind die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Unternehmen ermächtigt, jedem solchen Mitglied während der Dauer der
bereits genehmigten Vergütungsperiode(n) einen Zusatzbetrag auszurichten oder zuzuteilen. Der Zusatzbetrag darf je Ver-
gütungsperiode und Mitglied 50% der letzten von der Generalversammlung gemäss Art. 19 der Statuten genehmigten
Gesamtbeträge der Vergütung der Geschäftsleitung nicht übersteigen.

Art. 21. Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
1 Zusätzlich zu einer fixen Vergütung kann den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung eine variable

Vergütung, die sich nach der Erreichung bestimmter Leistungsziele richtet, ausgerichtet werden.

2 Die Leistungsziele können persönliche Ziele, Ziele der Oriflame-Gruppe oder bereichsspezifische Ziele und im Ver-

gleich zum Markt, anderen Unternehmen oder vergleichbaren Richtgrössen berechnete Ziele umfassen, unter Berücksich-
tigung von Funktion und Verantwortungsstufe des Empfängers der variablen Vergütung. Der Verwaltungsrat oder, soweit
an ihn delegiert, der Vergütungsausschuss legen die Gewichtung der Leistungsziele und die jeweiligen Zielwerte fest.

3 Die Vergütung kann in der Form von Geld, Aktien, Finanzinstrumenten oder -einheften oder Sach- oder Dienstleis-

tungen ausgerichtet werden. Der Verwaltungsrat oder, soweit an ihn delegiert, der Vergütungsausschuss legen Zuteilungs-,
vesting-, Ausübungs- und Verfallsbedingungen fest. Sie können vorsehen, dass aufgrund des Eintritts im Voraus bestimmter
Ereignisse wie einem Kontrollwechsel oder der Beendigung eines Arbeits- oder Mandatsverhältnisses vesting- oder Au-
sübungsbedingungen weitergehen, verkürzt oder aufgehoben werden, Vergütungen unter Annahme der Erreichung der
Zielwerte ausgerichtet werden oder Vergütungen verfallen. Der Verwaltungsrat oder, soweit an ihn delegiert, der Vergü-
tungsausschuss können dabei die Fähigkeit der Gesellschaft, am Arbeitsmarkt die geeigneten Personen rekrutieren und die
Angestellten an die Gesellschaft binden zu können, berücksichtigen. Die Vergütung ist gemäss allgemein anerkannten
Bewertungsmethoden per Datum der Zuteilung des betreffenden Vergütungselements zu bewerten. Die Gesellschaft kann
die auszugebenden oder auszuliefernden Aktien, soweit verfügbar, in der Form einer bedingten Kapitalerhöhung oder durch
Verwendung von auf dem Markt erworbenen eigenen Aktien bereitstellen.

4 Die Vergütung kann durch die Gesellschaft oder durch von ihr kontrollierte Gesellschaften ausgerichtet oder zugeteilt

werden.

105484

L

U X E M B O U R G

5. Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, externe Mandate, Kredite und Dar-

lehen

Art. 22. Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
1 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften können mit Mitgliedern des Verwaltungsrates unbefristete

oder befristete Verträge über deren Vergütung abschliessen. Die Dauer und Beendigung richten sich nach Amtsdauer und
Gesetz.

2 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften können mit Mitgliedern der Geschäftsleitung unbefristete

oder befristete Arbeitsverträge abschliessen. Befristete Arbeitsverträge haben eine Höchstdauer von einem Jahr. Eine Er-
neuerung ist zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge haben eine Kündigungsfrist von maximal zwölf Monaten.

3 Mitglieder der Geschäftsleitung, die einer Kündigungsfrist unterliegen, können von ihrer Arbeitspflicht befreit werden.

Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften können Aufhebungsvereinbarungen abschliessen.

4 Arbeitsverträge mit Mitgliedern der Geschäftsleitung können Konkurrenzverbote für die Zeit nach Beendigung eines

Arbeitsvertrags für eine Dauer von bis zu zwei Jahren enthalten. Die jährliche Abgeltung eines solchen Konkurrenzverbots
darf 50% der zuletzt an dieses Mitglied der Geschäftsleitung ausbezahlten jährlichen Vergütung nicht übersteigen.

Art. 23. Externe Mandate.
1 Kein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehr als zehn (10) zusätzliche Mandate wahrnehmen.
2 Kein Mitglied der Geschäftsleitung kann mehr als fünf (5) zusätzliche Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr als

ein (1) Mandat in börsenkotierten Unternehmen.

3 Die folgenden Mandate fallen nicht unter diese Beschränkungen gemäss vorstehenden Abs. 1 und 2:
(a) Mandate in Unternehmen, die durch die Gesellschaft kontrolliert werden oder die Gesellschaft kontrollieren;
(b) Mandate, die auf Anordnung der Gesellschaft oder von ihr kontrollierten Unternehmen wahrgenommen werden.

Kein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung kann mehr als fünf (5) solche Mandate wahrnehmen;

(c) Mandate in Vereinen, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Trusts, Personalfürsorgestiftungen, Investment-

gesellschaften,  Equity  Partnerships  oder  Limited  Liability  Partnerships.  Kein  Mitglied  des  Verwaltungsrates  oder  der
Geschäftsleitung kann mehr als fünfzehn (15) solche Mandate wahrnehmen.

4 Als Mandate gelten Mandate im obersten Leitungsorgan einer Rechtseinheit, die zur Eintragung ins Handelsregister

oder in ein vergleichbares ausländisches Register verpflichtet ist. Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten, die unter
gemeinsamer Kontrolle stehen, gelten als ein Mandat.

5 Der Verwaltungsrat stellt in jedem Fall sicher, dass die Anzahl externer Mandate, die von Mitgliedern des Verwal-

tungsrates oder der Geschäftsleitung wahrgenommen werden, mit deren Einsatz, Verfügbarkeit, Leistungsvermögen und
Unabhängigkeit, die für die Erfüllung deren Amtes als Mitglied des Verwaltungsrates bzw. der Geschäftsleitung erforder-
lich sind, vereinbar ist.

Art. 24. Kredite und Darlehen. Kredite und Darlehen an Mitglieder der Geschäftsleitung dürfen zu den für die Oriflame-

Group  anwendbaren  Mitarbeiterbedingungen  gewährt  werden.  Der  Gesamtbetrag  solcher  ausstehenden  Kredite  und
Darlehen darf je Mitglied der Geschäftsleitung CHF 500'000 nicht übersteigen.

6. Geschäftsjahr und Gewinnverteilung

Art. 25. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr wird durch den Verwaltungsrat festgelegt.

Art. 26. Gewinnverteilung.
1 Unter Vorbehalt der Statuten und der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung, insbesondere Art. 671 ff.

OR, steht der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung.

2 Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Gesetz entsprechenden Zuweisungen an die gesetzlichen

Reserven vom Gewinn abgezogen worden sind.

3 Alle Dividenden, welche innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht bezogen worden sind, verfallen zu-

gunsten der Gesellschaft.

7. Beendigung

Art. 27. Auflösung, Liquidation.
1 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Zuständigkeiten kann die Generalversammlung jederzeit die Auflösung und Li-

quidation der Gesellschaft nach Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beschliessen.

2 Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat durchgeführt, sofern sie nicht durch die Generalversammlung anderen

Personen übertragen wird.

3 Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe von Art. 742 ff. OR. Die Liquidatoren sind ermächtigt, Aktiven

(Grundstücke eingeschlossen) auch freihändig zu verkaufen.

105485

L

U X E M B O U R G

8. Benachrichtigung

Art. 28. Mitteilungen und Bekanntmachungen. Soweit das Gesetz nicht zwingend eine persönliche Mitteilung verlangt,

erfolgen sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen und sonstigen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre gültig durch
die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre können auch durch
gewöhnlichen Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs erfolgen.

Art. 29. Publikationsorgan. Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB).

Art. 30. Auslegung. Ausschliesslich die deutsche Fassung dieser Statuten ist rechtsverbindlich. Die englische Überse-

tzung dieser Statuten hat keinerlei Rechtswirkungen und kann nicht zur Auslegung des deutschen Textes herangezogen
werden.

ARTICLES OF ASSOCIATION

of
Oriflame Holding AG
(Oriflame Holding SA)
(Oriflame Holding Ltd)
with its registered seat in Schaffhausen

1. Company Name, Registered Seat, Purpose and Duration of the Company

Art. 1. Company Name and Registered Seat. Under the Company name Oriflame Holding AG (Oriflame Holding SA)

(Oriflame Holding Ltd), a corporation with its registered seat in Schaffhausen is established pursuant to articles 620 et seq.
of the Swiss Code of Obligations (CO) and these articles of association (the Articles of Association). The duration of the
Company shall be unlimited.

Art. 2. Purpose.
1 The purpose of the Company is to acquire, hold, administrate and sell participations in enterprises in Switzerland and

abroad, especially in the field of products and services within the beauty industry.

2 The Company may establish branch offices and subsidiaries in Switzerland and abroad and participate in such enter-

prises.

3 The Company may acquire, hold and sell real estate for permanent business establishments and intellectual property

rights.

4 The Company may perform any commercial, financial or other activities which are directly or indirectly linked to the

purpose of the Company.

5 The Company may grant to its direct or indirect subsidiaries as well as to third parties, including its direct or indirect

shareholders as well as their direct or indirect subsidiaries, direct or indirect financing and may further provide collateral
of any kind for its own liabilities and for liabilities of such other third parties (including its direct or indirect subsidiaries
as third parties, including its direct or indirect shareholders as well as their direct or indirect subsidiaries), including by
way of pledge rights or fiduciary full title transfers of its assets or guarantees of any kind, whether with or without remu-
neration. In addition, the Company may with such other companies referred to above enter into cash pooling transactions,
including cash pooling with zero balancing, with or without interest, under the exclusion of the corporate purpose to make
profit and the Company may take bulk risks under such transactions.

2. Share Capital

Art. 3. Share Capital. The share capital of the Company amounts to CHF 83,562,844,50 and is divided into 55,708,563

registered shares with a nominal value of CHF 1.50 each. The shares are fully paid-in.

Art. 3 

bis

 . Authorized Share Capital.

1 The Board of Directors shall be authorized (including in case of a public offer for shares of the Company) to increase

the share capital in an amount not to exceed CHF 13,174,326 through the issuance of up to 8,782,884 fully paid-in registered
shares with a nominal value of CHF 1.50 per share by not later than 19 June 2017. Increases in partial amounts shall be
permitted.

2 The pre-emptive subscription rights of the shareholders of the Company are withdrawn and revoked for up to [3,024,998

(such amount will be reduced by the number of shares of Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg and Oriflame SDRs (as
defined hereinafter) tendered within further acceptance periods under the Exchange Offer (as defined hereinafter))] fully
paid-in registered shares with a nominal value of CHF 1.50 per share and allocated to SEB (as defined hereinafter), acting
as exchange agent, in the name and for the account of the holders of Oriflame SDRs (as defined hereinafter), who accept
the Exchange Offer (as defined hereinafter) within (a) potentially extended acceptance period(s), or to François Brouxel
(as defined hereinafter), acting as exchange agent, in the name and for the account of the holders of registered shares and
bearer shares in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, who accept the Exchange Offer within (a) potentially extended
acceptance period(s).

105486

L

U X E M B O U R G

3 The Board of Directors is further authorized (including in case of a public offer for shares of the Company) to restrict

or  deny  the  pre-emptive  subscription  rights  of  shareholders  or  allocate  such  rights  to  third  parties,  also  regarding  the
authorized capital according to art. 3bis section 2 (to the extent such authorized share capital is no longer required for the
purposes of and upon completion of the execution of the Exchange Offer), if the shares are to be used:

(a) for the acquisition of enterprises, parts of enterprises, or participations, or for new investments, or for the financing

or refinancing of such transactions;

(b) for the purpose of the participation of a strategic partner or for the purpose of broadening the shareholder constituency

in certain investor markets or in connection with a listing of the shares on domestic or foreign stock exchanges, including
in connection with the grant of an over-allotment option to a consortium of banks;

(c) for the participation of employees or members of the Board of Directors of the Company or of group companies;
(d) in order to quickly and flexibly raise equity capital by a share placement, which would be difficult to achieve with

preferential subscription rights.

4 The subscription and acquisition of the new shares, as well as each subsequent transfer of the shares, shall be subject

to the provisions of art. 5 of the Articles of Association.

5 The Board of Directors shall determine the issue price, the type of payment, the date of issue of new shares, the

conditions for the exercise of the pre-emptive subscription rights, and the beginning date for dividend entitlement. In this
regard, the Board of Directors may issue new shares by means of a firm underwriting through a banking institution, a
syndicate or another third party and a subsequent offer of these shares to the current shareholders. The Board of Directors
may permit pre-emptive subscription rights that have not been exercised to expire or it may place these rights and shares
to which pre-emptive subscription rights have been granted but not exercised, at market conditions or use them for other
purposes in the interest of the Company.

Art. 3 

ter

 . Conditional Share Capital.

1 The share capital of the Company shall be increased by a maximum aggregate amount of CHF 3,621,000.00 through

the issuance of a maximum of 2,414,000 registered shares, which shall be fully paid-in, with a nominal value of CHF 1.50
per share by either the issuance of shares to employees or members of the Board of Directors of the Company or of group
companies or the exercise of option rights which are granted to employees or members of the Board of Directors of the
Company or of group companies, both according to one or more plan(s) to be drawn up by the board of directors, taking
into account performance, functions, levels of responsibility and profitability criteria. Such shares or subscription rights
may be issued at a price lower than that quoted on the stock exchange.

2 The advance subscription right and the pre-emptive subscription rights of the shareholders are excluded. The acquis-

ition of registered shares through the exercise of option rights and each subsequent transfer of the shares shall be subject
to the provisions of art. 5 of the Articles of Association.

Art. 3 

quater

 . Contribution in Kind.  In course of the capital increase as of 19 June 2015, the Company acquires (i)

pursuant to a contribution in kind agreement as of 19 June 2015 in exchange for 47,779,545 registered shares of the Company
with a nominal value of CHF 1.50 each 47,779,545 Depositary Receipts regarding fully paid-in underlying registered shares
in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, without designation of nominal value, listed and traded on Nasdaq Stockholm
(the Oriflame SDRs; ISIN-Code: SE0001174889; Ticker-Symbol: ORI SDB) from Skandinaviska Enskilda Banken AB,
Stockholm, Sweden (SEB) acting as exchange agent, in the name and for the account of the holders of the Oriflame SDRs,
who have by 15 June 2015, 17:00 CET, accepted the Company's exchange offer dated 8 May 2015 regarding all Oriflame
SDRs and all registered shares and bearer shares in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg (the Exchange Offer) and (ii)
pursuant to a contribution in kind agreement as of 19 June 2015, from François Brouxel, c/o Wildgen, Partners in Law,
Luxembourg, Luxembourg (François Brouxel), acting as exchange agent in the name and for the account of the holders
registered shares in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, who have by 15 June 2015, 17:00 CET, accepted the Exchange
Offer, 611,902 fully paid-in registered shares in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, without designation of nominal
value, in exchange for 611,902 registered shares of the Company with a nominal value of CHF 1.50 each. The difference
in the amount of CHF 608,280,488.79 between the aggregate nominal value of the newly issued registered shares and the
aggregate valuation of the contribution in kind in the aggregate amount of CHF 680,867,659.29 is credited as share premium
(paid-in surplus) to the capital contribution reserves of the Company.

Art. 3 

quinquies

 . Contribution in Kind.  In course of the capital increase as of 8 July 2015, the Company acquires (i)

pursuant to a contribution in kind agreement as of 8 July 2015 in exchange for 4,393,829 registered shares of the Company
with a nominal value of CHF 1.50 each 4,393,829 Swedish Depositary Receipts regarding fully paid-in underlying regis-
tered shares in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, without designation of nominal value, (the Oriflame II SDRs; ISIN-
Code: SE0001174889) from SEB (as defined in Art. 3 

quater

 ) acting as exchange agent, in the name and for the account

of the holders of the Oriflame II SDRs, who have by 3 July 2015, 17:00 CET, during the first extended acceptance period,
accepted the Exchange Offer (as defined in Art. 3 

quater

 ) and (ii) pursuant to a contribution in kind agreement as of 8 July

2015, from François Brouxel (as defined in Art. 3 

quater

 ), acting as exchange agent in the name and for the account of the

holders of registered shares in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, who have by 3 July 2015, 17:00 CET, during the
first extended acceptance period, accepted the Exchange Offer, 122,767 fully paid-in registered shares in Oriflame Cos-

105487

L

U X E M B O U R G

metics S.A., Luxembourg, without designation of nominal value, in exchange for 122,767 registered shares of the Company
with a nominal value of CHF 1.50 each. The difference in the amount of CHF 57,089,773.44 between the aggregate nominal
value of the newly issued registered shares and the aggregate valuation of the contribution in kind in the aggregate amount
of CHF 63,864,667.44 is credited as share premium (paid-in surplus) to the capital contribution reserves of the Company.

Art. 3 

sexies

 . Contribution in Kind.  In course of the capital increase as of 13 August 2015, the Company acquires (i)

pursuant to a contribution in kind agreement as of 13 August 2015 in exchange for 869,411 registered shares of the Company
with a nominal value of CHF 1.50 each 869,411 Swedish Depositary Receipts regarding fully paid-in underlying registered
shares in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, without designation of nominal value, (the Oriflame III SDRs; ISIN-
Code: SE0001174889) from SEB (as defined in Art. 3 

quater

 ) acting as exchange agent, in the name and for the account

of the holders of the Oriflame III SDRs, who have by 7 August 2015, 17:00 CET, during the second extended acceptance
period, accepted the Exchange Offer (as defined in Art. 3 

quater

 ) and (ii) pursuant to a contribution in kind agreement as

of 13 August 2015, from François Brouxel (as defined in Art. 3 

quater

 ), acting as exchange agent in the name and for the

account of the holders of registered shares in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, who have by 7 August 2015, 17:00
CET, during the second extended acceptance period, accepted the Exchange Offer, 419,520 fully paid-in registered shares
in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, without designation of nominal value, in exchange for 419,520 registered shares
of the Company with a nominal value of CHF 1.50 each. The difference in the amount of CHF 16,872,106.79 between the
aggregate nominal value of the newly issued registered shares and the aggregate valuation of the contribution in kind in
the aggregate amount of CHF 18,805,503.29 is credited as share premium (paid-in surplus) to the capital contribution
reserves of the Company.

Art. 3 

septies

 . Contribution in Kind.  In course of the capital increase as of 10 September 2015, the Company acquires

(i) pursuant to a contribution in kind agreement as of 10 September 2015 in exchange for - registered shares of the Company
with a nominal value of CHF 1.50 each - Swedish Depositary Receipts regarding fully paid-in underlying registered shares
in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, without designation of nominal value, (the Oriflame IV SDRs; ISIN-Code:
SE0001174889) from SEB (as defined in Art. 3 

quater

 ) acting as exchange agent, in the name and for the account of the

holders of the Oriflame IV SDRs, who have by 7 September 2015, 17:00 CET, during the third extended acceptance period,
accepted the Exchange Offer (as defined in Art. 3 

quater

 ) and (ii) pursuant to a contribution in kind agreement as of 10

September 2015, from François Brouxel (as defined in Art. 3 

quater

 ), acting as exchange agent in the name and for the

account of the holders of registered and bearer shares in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, who have by 7 September
2015, 17:00 CET, during the third extended acceptance period, accepted the Exchange Offer, - fully paid-in registered and
bearer shares in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, without designation of nominal value, in exchange for - registered
shares of the Company with a nominal value of CHF 1.50 each. The difference in the amount of CHF - between the aggregate
nominal value of the newly issued registered shares and the aggregate valuation of the contribution in kind in the aggregate
amount of CHF - is credited as share premium (paid-in surplus) to the capital contribution reserves of the Company.

Art. 4. Form of Shares, Conversion of Shares.
1 The Company issues its registered shares in the form of single certificates, global certificates or uncertificated secur-

ities. Within the provisions of the law, the Company may at any time and at its own cost convert registered shares issued
in one of the above mentioned forms into another form without the consent of the shareholder.

2 The Company shall keep a register for the issued uncertificated securities (register of uncertificated securities), in

which  the  amount  and  the  denomination  of  the  issued  uncertificated  securities  and  the  name  of  the  creditors  shall  be
registered. The register of uncertificated securities is not public. The uncertificated securities take effect upon entry into
the register of uncertificated securities and exist only to the extent registered.

3  The  shareholder  has  no  entitlement  to  the  converting  of  shares  issued  in  a  specific  form  into  another  form.  The

shareholder may however at any time request the Company to issue a written statement in respect of the shares held by the
shareholder pursuant to the share register.

4 Uncertified securities may only be transferred by assignment. In order to be binding, such assignment must be notified

to the Company. They may be pledged in accordance with the pertinent provisions on the pledging of claims. Book entry
securities based on registered shares of the Company may, however, not be transferred by assignment. Neither can securities
be granted on book entry securities by assignment. Registered shares of the company that are registered in accordance with
art. 5 para. 3 of these Articles of Association in a securities register in accordance with the Swedish Financial Instruments
Accounts Act (1998:1479) or otherwise in accordance with Swedish law shall be transferred in accordance with such Act
and other applicable Swedish laws. Uncertificated registered shares registered in accordance with article 5 para. 3 of these
Articles  of  Association  in  a  securities  register  in  accordance  with  the  Swedish  Financial  Instruments  Accounts  Act
(1998:1479) or otherwise in accordance with Swedish law may be pledged in accordance with such Act and other applicable
Swedish laws.

Art. 5. Share Ledger, Transfer of Shares.
1 The Company shall maintain a share ledger of the registered shares in which the owners and beneficiaries are registered

with their names and addresses. The registration in the share ledger is subject to proof of acquisition of shares or the
entitlement to a right of usufruct to a share. No shareholder or usufructuary shall be recognized as such by the Company

105488

L

U X E M B O U R G

unless it is entered in the share ledger. If a person registered in the share register changes his/her address, he/she shall
inform the Company thereof. As long as such an address change has not been notified, any information by mail shall validly
be notified to the address filed with the share register.

2 Acquirers of registered shares shall be registered upon request as shareholders with the right to vote.
3 Notwithstanding para. 1 and 2 of this article, for as long as the Company is party to an Affiliation Agreement with

Euroclear Sweden AB in Sweden, the Company's shares and the acquirers of those shares may be registered in a securities
register in accordance with the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) and other applicable Swedish
laws.

4 The Board of Directors shall specify the details and give the necessary orders concerning the adherence to the preceding

provisions. It may delegate these duties.

3. Organization

Art. 6. Corporate Bodies of the Company. The corporate bodies of the Company are:
(a) the General Shareholders' Meeting
(b) the Board of Directors
(c) the Auditors
3.1. The General Shareholders' Meeting

Art. 7. Powers. The supreme corporate body of the Company is the General Shareholders' Meeting. It has the following

inalienable powers:

(a) the adoption and the amendment of the Articles of Association;
(b) the individual election of the members of the Board of Directors and the election from among them of the Chairman

of the Board of Directors and the individual election of the members of the Remuneration Committee as well as the election
of the Independent Proxy and the Auditors;

(c) the approval of the management report, the annual financial statements and the consolidated financial statements, as

well as the resolution on the use of the balance sheet profits as shown on the balance sheet, in particular, the declaration
of dividends;

(d) the release of the members of the Board of Directors and the persons entrusted with management (Executive Man-

agement);

(e) The approval of the compensation of the Board of Directors and the Executive Management pursuant to the Articles

of Association;

(f) the passing of resolutions on matters which are by law or by the Articles of Association reserved to the General

Shareholders' Meeting, or those submitted to it by the Board of Directors.

Art. 8. Meetings.
1 The ordinary General Shareholders' Meeting takes place annually within six months after the close of the business

year.

2 Extraordinary General Shareholders' Meetings are called as often as necessary, in particular in all cases required by

law.

3 Furthermore, extraordinary General Shareholders' Meetings shall be convened by the Board of Directors upon reso-

lution  of  a  General  Shareholders'  Meeting  or  at  the  written  request  of  one  or  more  shareholders  with  voting  rights
representing in the aggregate at least 10% of the share capital, specifying the items and proposals to appear on the agenda
and, in case of elections, the names of the candidates.

Art. 9. Notice and Agenda.
1 The Board of Directors, or if necessary, the Auditors shall call the ordinary General Shareholders' Meeting. The

liquidators shall also have the right to call.

2 The General Shareholders' Meeting shall be convened by notice in the official means of publication of the Company

no less than 20 days before the date fixed for the Meeting. Shareholders may also be informed by ordinary mail. The notice
of the General Shareholders' Meeting shall also be made available on the Company's website. As long as the Company's
shares are listed on a Swedish stock exchange, the Company may publish in a daily Swedish newspaper an announcement
with the information that the notice has been issued. The convocation shall be served in English and may be translated into
Swedish.

3 At the latest 20 days prior the General Shareholders' Meeting, the annual management report, the compensation report

and the Auditors' report shall be available for examination by the shareholders at the domicile of the Company. Reference
thereto and the right of the shareholders to request the receipt of these documents must be included in the invitation to the
General Shareholders' Meeting.

4 The invitation to a General Shareholders' Meeting shall state besides day, time and place of the General Meeting of

Shareholders to be held, the items and the proposals of the Board of Directors and the shareholders who demand that the
General Shareholders' Meeting be called or that items be included in the agenda.

105489

L

U X E M B O U R G

5 One or more shareholders with voting rights whose combined holdings represent an aggregate nominal value of at

least CHF 1,000,000 or at least 10% of the share capital may request that an item be included In the agenda of a General
Shareholders' Meeting. Such a request must be made in writing to the Board of Directors at the latest 45 days before the
General Shareholders' Meeting and shall specify the agenda items and the proposals made.

6 No resolution shall be passed on items for which no proper notice has been given; this prohibition does not apply to

proposals made during a General Shareholders' Meeting to call an extraordinary General Shareholders' Meeting or to initiate
a special audit.

7 No prior notice shall be required for proposals concerning items included in the agenda and deliberations that do not

result in the adoption of resolutions.

Art. 10. Chair, Minutes.
1 The General Shareholders' Meeting shall be chaired by the Chairman, or, in his absence, by another member of the

Board of Directors or by another Chairman for the day elected by the General Shareholders' Meeting, who does not have
to be a shareholder.

2 The Chairman designates a Secretary and a voting teller who do not have to be shareholders.
3 The Board of Directors shall arrange for the taking of minutes. These minutes shall be signed by the Chairman and

the Secretary.

Art. 11. Voting Rights, Proxies.
1 Subject to art. 5 of these Articles of Association, each share entitles to one vote.
2 Each shareholder may be represented at the General Shareholders' Meeting by a third person who need not be a

shareholder and who is authorized to vote on behalf of the shareholder by a written power of attorney or by the independent
proxy holder (Independent Proxy). Legal representation is reserved.

3 Shareholders entered in the share ledger as shareholders with voting rights on a specific qualifying date designated

by the Board of Directors shall be entitled to vote at the General Shareholders' Meeting and to exercise their votes at the
General Shareholders' Meeting.

4 The Independent Proxy shall be elected by the General Shareholders' Meeting for a term of office until completion of

the next ordinary General Shareholders' Meeting. The Independent Proxy whose term of office has expired is immediately
eligible for re-election. The duties of the Independent Proxy are determined by applicable laws, rules and regulations. The
General Shareholders' Meeting may remove the Independent Proxy with effect as per the end of the General Shareholders'
Meeting.

5 If the Company does not have an Independent Proxy, the Board of Directors shall appoint the Independent Proxy for

the next General Shareholders' Meeting.

6 The Board of Directors shall set forth the rules regarding the participation and representation in the General Share-

holders' Meeting.

Art. 12. Quorum and Resolutions.
1 The General Shareholders' Meeting shall be duly constituted irrespective of the number of shareholders present or of

shares represented.

2 Elections and votes shall be taken on a show of hands unless a vote by ballot or electronic voting is ordered by the

Chairman of the General Shareholders' Meeting. The Chairman may at any time order that a resolution by show of hands
be repeated by vote by ballot if he believes the result of the vote by show of hands not to be conclusive. In this case, the
previous election or vote by show of hands shall be deemed not to have taken place.

3 The Board of Directors may also make arrangements for electronic voting. Resolutions passed by electronic voting

shall have the same effect as elections and votes by ballot.

4 The General Shareholders' Meeting passesits resolutions and carries out its elections with the absolute majority of the

shares represented, to the extent the mandatory law or the Articles of Association do not provide otherwise.

5 If the first ballot fails to result in an election and more than one candidate is standing for election, the Chairman shall

order a second ballot in which a relative majority shall be decisive.

6 Those matters provided for by law shall require a qualified majority of two thirds of the votes represented and the

absolute majority of the share capital represented.

3.2. The Board of Directors

Art. 13. Election, Constitution.
1 The Board of Directors shall consist of two or several members.
2 The members of the Board of Directors shall be elected individually for a term of one year. A year shall mean the

period running between one ordinary General Shareholders' Meeting and the next. New members elected during the year
shall continue in office until the end of their predecessor's term.

3 The members and the Chairman of the Board of Directors may be re-elected without limitation.

105490

L

U X E M B O U R G

4 Unless provided otherwise in the Articles of Association, the Board of Directors constitutes itself. It shall elect from

amongst its members, if necessary, one or several Vice Chairmen. The Board of Directors shall further appoint a secretary
who need not be a member of the Board of Directors.

5 If the office of the Chairman of the Board of Directors is vacant, the Board of Directors may appoint a new Chairman

from among its members for the remaining term of office.

Art. 14. Ultimate Management, Delegation.
1 The Board of Directors is responsible for the ultimate management of the Company and the supervision of the managing

bodies. The Board of Directors represents the Company towards third parties and is responsible for all matters which are
not allocated to another body of the Company by law, the Articles of Association or regulations.

2 The Board of Directors may appoint from amongst its members standing or ad hoc committees entrusted with the

preparation and execution of its decisions or the supervision of specific parts of the business. The Board of Directors shall
ensure that it is kept properly informed.

3 The Board of Directors may delegate its powers and duties, in part or entirely, except for the non-delegable and

inalienable duties, pursuant to organizational regulations adopted by the Board of Directors (the Organizational Regula-
tions) to one or several members of the Executive Management or representatives of the Company, to members of the
Board of Directors, to committees or third parties, who need not be shareholders.

Art. 15 Duties. The Board of Directors has the following non-transferable and unalienable duties:
(a) the ultimate management of the Company and giving of the necessary directives;
(b) the establishment of the organization;
(c) the organization of the accounting system, the internal financial controls as well as the financial planning;
(d) the appointment and the recall from office of the persons entrusted with the management and the representation of

the Company and the grant of signatory power;

(e) the ultimate supervision of the persons entrusted with the management, in particular, in view of compliance with the

law, the Articles of Association, the regulations and the directives;

(f) the preparation of the annual business report and the compensation report as well as the organization of the General

Shareholders' Meeting and execution of its resolutions;

(g) to inform the judge in the event of overindebtedness;
(h) the passing of resolutions concerning the subsequent payment of capital in respect of non-fully paid-in shares;
(i) the passing of resolutions concerning the assessment of capital increases and amendments to the Articles of Asso-

ciation resulting from it;

(j) the examination of the professional qualifications of the Auditors;
(k) the non-transferable and unalienable duties and powers of the Board of Directors pursuant to laws and ordinances

applicable to the Company.

Art. 16. Organization, Minutes.
1 The organization of the meetings, the quorum and the passing of resolutions of the Board of Directors shall be in

compliance with the Organizational Regulations. Attendance of meetings of the Board of Directors by telephone- or video-
conference shall be permissible.

2 The resolutions of the Board of Directors are made by majority of votes cast. The Chairman has the casting vote.
3 Resolutions to be passed in the form of a notarial deed pursuant to Art. 634a, 651a, Art. 652g, Art. 653g and Art. 653i

CO may be adopted without observing a quorum.

4 Resolutions of the Board of Directors may also be adopted by written consent, by telefax, by e-mail or any other means

enabling the evidence of passing of the resolutions by text, provided that none of the members demands verbal discussion.

5 The discussions and resolutions of the Board of Directors must be recorded by minutes. The minutes have to be signed

by the Chairman and by the Secretary.

6 Subject to the Articles of Association, the Board of Directors shall set forth its organization and the adaption of

resolutions in Organizational Regulations.

Art. 17. Remuneration Committee.
1  The  Remuneration  Committee  consists  of  at  least  two  members  of  the  Board  of  Directors.  Each  member  of  the

Remuneration Committee is elected individually by the General Shareholders' Meeting for a term of office until completion
of the next ordinary General Shareholders' Meeting. Members of the Remuneration Committee whose term of office has
expired are immediately eligible for re-election. If there are vacancies on the Remuneration Committee, the Board of
Directors may appoint the missing members from among its members for the remaining term of office.

2 The Remuneration Committee constitutes itself and elects a Chair from among its members. It appoints its secretary

who need not be a member of the Board of Directors or the Remuneration Committee.

3 The Remuneration Committee supports the Board of Directors in establishing and reviewing the Company's com-

pensation strategy and guidelines and performance criteria as well as in preparing the proposals to the Shareholders' Meeting

105491

L

U X E M B O U R G

regarding the compensation of the Board of Directors and Executive Management. It may submit proposals and recom-
mendations to the Board of Directors in other compensation-related issues. The Board of Directors establishes a charter,
which defines purpose, composition and procedural rules of the Remuneration Committee, including its responsibilities
and authorities for making proposals and decisions related to compensation of the members of the Board of Directors and
Executive Management in line with legal and regulatory requirements, these Articles of Association and the respective
compensation framework approved by the Board of Directors from time to time. The Board of Directors may delegate
further responsibilities and authorities to the Remuneration Committee.

3.3. Auditors

Art. 18. Eligibility, Duties.
1 The General Shareholders' Meeting shall elect every year one or more accountants as its Auditors, which shall be

independent from the Company and meet the special professional standards required by law. The Auditors of the Company
may be reelected.

2 The Auditors shall have the rights and duties according to applicable law. The auditors shall be bound to attend the

ordinary General Shareholders' Meeting, to which they must report.

4. Compensation of the Board of Directors and of the Executive Management

Art. 19. Compensation of the members of the Board of Directors and the Executive Management.
1 The General Shareholders' Meeting shall approve annually and with binding effect the proposals of the Board of

Directors in relation to:

(a) the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors for the following term of office;
(b) the maximum aggregate amount of fixed compensation of the Executive Management for the period between July

1 of the year of the ordinary General Shareholders' Meeting and June 30 of the following year;

(c) the aggregate amount of variable compensation of the Executive Management for the past financial year.
2 The Board of Directors may submit for approval by the General Shareholders' Meeting deviating or additional proposals

relating to the same or different periods.

3 In the event the General Shareholders' Meeting does not approve a proposal of the Board of Directors, the Board of

Directors shall determine in a new proposal, taking into account all relevant factors, the respective (maximum) aggregate
amount(s) or (maximum) partial amount(s), and submit the amount(s) so determined for approval by the same General
Shareholders' Meeting, an extraordinary General Shareholders' Meeting or the following ordinary General Shareholders'
Meeting.

4 The Company or companies controlled by it may pay out or grant compensation prior to approval by the General

Shareholders' Meeting subject to subsequent approval by a General Shareholders' Meeting and applicable claw-back pro-
visions.

Art. 20. Supplementary amount for changes in the Executive Management. If the maximum aggregate amount of com-

pensation already approved by the General Shareholders' Meeting is not sufficient to cover compensation of a person who
becomes a member of the Executive Management or is being promoted within the Executive Management after the General
Shareholders' Meeting has approved the compensation, the Company or companies controlled by it shall be authorized to
grant and pay to each such member a supplementary amount during the compensation period(s) already approved. The
supplementary amount per compensation period and each member shall not exceed 50% of the aggregate amounts of
compensation of the Executive Management last approved by the General Shareholders' Meeting pursuant to Art. 19 of
the Articles of Association.

Art. 21. Principles of compensation of the Board of Directors and of the Executive Management.
1 In addition to a fixed compensation, members of the Board of Directors and of the Executive Management may be

paid a variable compensation, depending on the achievement of certain performance criteria.

2 The performance criteria may include individual targets, targets of the Orilame-Group or parts thereof and targets in

relation to the market, other companies or comparable benchmarks, taking into account position and level of responsibility
of the recipient of the variable compensation. The Board of Directors or, where delegated to it, the Remuneration Committee
shall determine the relative weight of the performance criteria and the respective target values.

3 Compensation may be paid or granted in the form of cash, shares, financial instruments or units, in kind, or in the form

of other types of benefits. The Board of Directors or, where delegated to it, the Remuneration Committee shall determine
grant, vesting, exercise and forfeiture conditions; they may provide for continuation, acceleration or removal of vesting
and exercise conditions, for payment or grant of compensation assuming target achievement or for forfeiture in the event
of  predetermined  events  such  as  a  change-of-control  or  termination  of  an  employment  or  mandate  agreement.  In  this
determination, the Board of Directors or, where delegated to it, the Remuneration Committee may take into account the
Company's ability to recruit new talent and retain employees. The compensation shall be valued in accordance with gen-
erally recognized valuation methods as per the grant date of the respective compensation element. The Company may
procure the shares to be issued or delivered, to the extent available, from conditional share capital, or through use of treasury
shares purchased in the market.

105492

L

U X E M B O U R G

4 Compensation may be paid or granted by the Company or companies controlled by it.

5. Agreements with Members of the Board of Directors and the Executive Management, External Mandates, Credits

and Loans

Art. 22. Agreements with Members of the Board of Directors and the Executive Management.
1 The Company or companies controlled by it may enter into agreements for a fixed term or for an indefinite term with

members of the Board of Directors relating to their compensation. Duration and termination shall comply with the term of
office and the law.

2 The Company or companies controlled by it may enter into employment agreements with members of the Executive

Management for a fixed term or for an indefinite term. Employment agreements for a fixed term may have a maximum
duration of 1 year. Renewal is possible. Employment agreements for an indefinite term may have a termination notice
period of maximum 12 months.

3 Members of Executive Management who are subject to a termination notice may be released from their obligation of

work. The Company or companies controlled by it may enter into termination agreements.

4 Contracts of employment with members of Executive Management may contain a prohibition of competition for the

time after the end of employment for a duration of up to 2 years. The annual consideration for such prohibition shall not
exceed 50% of the total annual compensation last paid to such member of the Executive Management.

Art. 23. External Mandates.
1 No member of the Board of Directors may hold more than ten (10) additional mandates.
2 No member of the Executive Management may hold more than five (5) additional mandates of which no more than

one (1) mandate in listed companies.

3 The following mandates are not subject to the limitations as set out in paras. 1 and 2 above:
(a) mandates in companies which are controlled by the Company or which control the Company;
(b) mandates held at the request of the Company or companies controlled by it. No member of the Board of Directors

or of the Executive Management shall hold more than five (5) such mandates;

(c) mandates in associations, charitable organizations, foundations, trusts, employee welfare foundations, investment

companies, equity partnerships or limited liability partnerships. No member of the Board of Directors or of the Executive
Management shall hold more than fifteen (15) such mandates.

4 Mandates shall mean mandates in the supreme governing body of a legal entity which is required to be registered in

the commercial register or a comparable foreign register. Mandates in different legal entities that are under joint control
are deemed one mandate.

5 The Board of Directors shall in any event ensure that the number of external mandates held by members of the Board

of Directors or the Executive Management does not conflict with their commitment, availability, capacity and independence
required in fulfilling their role as member of the Board of Directors or the Executive Management, respectively.

Art. 24. Credits and Loans. Credits and loans to members of the Executive Management may be granted at employee

conditions applicable for the Oriflame-Group. The total amount of such credits and loans outstanding shall not exceed CHF
500,000 per member of the Executive Management.

6. Fiscal Year and Allocation of Profits

Art. 25. Business Year. The business year shall be determined by the Board of Directors.

Art. 26. Allocation of Profits.
1 Subject to the Articles of Association and the legal provisions about distribution of profits, in particular Article 671

et seq. CO, the balance sheet profit is at the disposal of the General Shareholders' Meeting.

2 The dividend must be fixed only after deducting from the profit the allocations to the statutory reserves according to

the law.

3 All dividends not drawn within five years after the due date shall be forfeited to the benefit of the Company.

7. Termination

Art. 27. Dissolution, Liquidation.
1 Subject to other legal provisions, the General Shareholders' Meeting may at any time resolve on the dissolution and

liquidation of the Company, in accordance with the provisions of the law and the Articles of Association.

2 The liquidation is carried out by the Board of Directors, unless the General Shareholders' Meeting has entrusted it to

other persons.

3  The  liquidation  of  the  Company  shall  take  place  in  accordance  with  Article  742  et  seq.  CO.  The  liquidators  are

authorized to dispose of the assets (including real estate) by way of private contract.

105493

L

U X E M B O U R G

8. Communication

Art. 28. Notices and Announcements. To the extent that personal notification is not required by law, all communications

to the shareholders shall be deemed valid if published in the Swiss Official Gazette of Commerce. Communications by the
Company to its shareholders may also be sent by ordinary mail to the last address of the shareholder entered in the share
register of the Company.

Art. 29 Publications. The official instrument for publication of the Company is the Swiss Commercial Gazette (Schwei-

zerisches Handelsamtsblatt (SHAB)).

Art. 30. Interpretation. Solely the German version of these Articles of Association shall be legally binding. The English

translation shall have no legal effects and may not be used for the construction of the German wording.

Zürich, 25. September 2015.

Gabriel Bennet.

Référence de publication: 2015141670/1740.
(150153859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

Pfizer PFE Luxembourg Holding 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 184.855.

Les comptes annuels au 30 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2015.

Référence de publication: 2015100691/10.
(150110539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Pfizer PFE Luxembourg Holding 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 184.856.

Les comptes annuels au 30 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2015.

Référence de publication: 2015100692/10.
(150110542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Pfizer PFE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, Avenue JF Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 184.851.

Les Comptes annuels au 30 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2015.

Référence de publication: 2015100693/10.
(150110529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Crown Premium GP VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 189.914.

<i>Auszug aus den Beschlüssen der alleinigen Gesellschafterin der Gesellschaft vom 1. Juni 2015

Am 1. Juni 2015 hat die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft folgenden Beschluss gefasst:
- Ernennung von Herrn Claude RADOUX, geboren am 27. August 1963 in Esch-sur-Alzette, Luxemburg, mit beruflicher

Adresse in: 6, Avenue des Archiducs, L-1135 Luxemburg, als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung
und dies für einen unbefristeten Zeitraum.

Demnach setzt sich der Geschäftsführerrat der Gesellschaft wie folgt zusammen:
- Herr Konrad BÄCHINGER
- Herr Maximilian F. BRÖNNER

105494

L

U X E M B O U R G

- Herr Roberto PAGANONI
- Herr Robert SCHLACHTER
- Herr Urs GÄHWILER
- Herr Claude RADOUX
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1 Juli 2015.

Crown Premium GP VI S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2015105643/24.
(150115740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2015.

Private Equity Plus OP, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 127.652.

Der Jahresabschluss vom 30. September 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100702/10.
(150110933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Landmark S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.905.

Bestellung des Wirtschaftsprüfers der Landmark S.A. für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr
In der ordentlichen Generalversammlung der Landmark S.A. am 1. Juni 2015 wurde die Ernst &amp; Young S.A., 7, rue

Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Wirtschaftsprüfer der Landmark S.A. für das am 31. Dezember 2015 endende
Geschäftsjahr bestellt. Die Bestellung endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre
2016.

Wiederwahl des Verwaltungsrates der Landmark S.A.
Die Amtszeit sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder endete mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre

2015. Daher hat die ordentliche Generalversammlung der Landmark S.A. vom 1. Juni 2015 die Wiederwahl des Verwal-
tungsrates beschlossen. Der Verwaltungsrat hat Frau Cathrin Schwartz zu seiner Vorsitzenden gewählt und Herrn Andreas
Katzur zum stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden. Die ordentliche Generalversammlung vom 1. Juni 2015 hat
Frau Maria Löwenbrück zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
- Cathrin Schwartz (Vorsitzende des Verwaltungsrates),
- Andreas Katzur (stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates),
- Maria Löwenbrück (geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied),
- Claudia Pundt (Mitglied des Verwaltungsrates) und
- Petra Hauer (Mitglied des Verwaltungsrates).
Die Amtszeit sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder endet mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre

2021, die über den Jahresabschluss des am 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres beschließt. Die Berufsadressen
von Frau Schwartz und Herrn Katzur lauten Valentinskamp 70 / EMPORIO, D-20355 Hamburg. Die Berufsadressen von
Frau Löwenbrück, Frau Pundt und Frau Hauer lauten 308, route d'Esch, L-1471 Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. Juni 2015.

Immo Steichen Société anonyme
Maria Löwenbrück / Petra Hauer

Référence de publication: 2015104057/32.

(150114382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2015.

105495

L

U X E M B O U R G

Pacific S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 2.817.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2015100705/10.
(150110651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Prevalux Conseil s. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 182, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.218.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 26/06/2015.

Référence de publication: 2015100718/10.
(150110871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Private Equity Global Select II, Sicar S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 112.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100721/10.
(150110506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Private Equity Global Select IV, Sicar S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 124.243.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100722/10.
(150110505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 153.622.

<i>Extrait des résolutions en date du 17 juin 2015:

1. Il est mis fin en date du 17 juin 2015 au mandat de gérant à savoir:
M. Jean-Bernard Zeimet, gérant de classe B
2. Le gérant suivant est nommé en date du 17 juin 2015 et cela pour une durée illimitée;
M. Miroslav Stoev, né le 4 janvier 1976 à Sofia (Bulgarie), de résidence professionnelle: 28, boulevard d'Avranches,

L-1160 Luxembourg;

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:
M. Dominique Prince, gérant de classe A
M. Philippe Van der Beken, gérant de classe A
M. Sansal Ozdemir, gérant de classe B

105496

L

U X E M B O U R G

M. Philip Lance Kianka, gérant de classe B
M. Miroslav Stoev, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Christina Mouradian
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015105830/24.
(150116615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2015.

Ravago Production S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 136.281.

Les comptes statutaires au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100739/9.
(150110725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Ravago S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 76-78, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 88.948.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100740/9.
(150110721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Ravago S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 88.948.

Les comptes statutaires au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100741/9.
(150110723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Ravara S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 76.591.

Les comptes statutaires au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100742/9.
(150110728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

CompAM FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 92.095.

As the quorum of at least one half (50%) of the outstanding shares of the Fund present or represented has not been met

at the first extraordinary general meeting of shareholders of the Fund (the "First EGM) and consequently the meeting could
not validly deliberate on items 1 and 2 of the agenda, you are kindly invited to attend and vote at the Fund's

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders (the "Second EGM") which will be held on <i>25 September 2015 at 11.15 (luxembourg time) at the

registered office of the Fund at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in order to
amend the articles of incorporation of the Fund (the "Articles").

The Second EGM will have the following agenda:

105497

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda:

1. Removal of the possibility for the Fund to issue bearer shares and subsequent amendment of articles 7, 23 and 28 of

the Articles; and

2. Amendment of the ownership restrictions of the Fund in the sense that only FATCA Eligible Investors are entitled

to become Shareholder and/or beneficial owner of the Shares of the Fund and subsequent amendment of articles 5
and 11 of the Articles.

The Second EGM may validly deliberate, regardless of the proportion of the capital present or represented and to be

passed, a resolution must be carried by at least two thirds (2/3) of the votes cast at the meeting.

The First EGM held on 20 August 2015 had been convened with the same agenda as the present Second EGM. Out of

1,277,571 shares in issue as at August 18, 2015, 0 share was present or represented at the First EGM, which therefore could
not validly deliberate on said agenda for lack of quorum.

If you are unable to attend the meeting, you may submit the signed proxy, by mail to the Fund's registered office at State

Street Bank Luxembourg S.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, or by fac-
simile at +0352/464010-413 or by e-mail at Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com. Such proxy must arrive by
mail, facsimile or e-mail not later than 23 September 2015.

Any questions from Shareholders on the contents of this convening notice should be directed to the registered office of

the Fund.

<i>For the Board

Référence de publication: 2015142587/755/32.

REF Eastern European Opportunities Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.506.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100746/9.
(150110277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Alphastock Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.684.

<i>Extrait de cession de parts sociales

Il résulte d'une convention de cession de parts sous seing privé entre Mme Marie-Line PROTIN, et M. Olivier CHAS-

SAGNE, Melle Margaux CHASSAGNE, Camille CHASSAGNE.

Depuis le 15 mai 2015, les associés de la société ALPHASTOCK Sàrl sont composés comme suit:

- PROTIN Marie-Line
Née le 15/10/1964 à St Mard (Belgique)
19 rue Jean-Pierre BIERMAN, L-1268 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts sociales

- CHASSAGNE Olivier
Né le 16/04/1965 à Issy-Les-Moulineaux (France)
19 rue Jean-Pierre BIERMAN, L-1268 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts sociales

- CHASSAGNE Margaux
Née le 26/09/1991 à Nivelles
Triq Nicolo'Isouard
2080 Sliema, Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts sociales

- CHASSAGNE Camille Marie
Née le 09/06/1994 à Namur
19 rue Jean-Pierre BIERMAN, L-1268 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts sociales

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

(100 parts sociales d'une valeur nominale de 125,00€ chacune soit un capital de 12.500,- €.)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015102750/27.
(150112780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

105498

L

U X E M B O U R G

Over the Rainbow A.s.b.l. - International School, Association sans but lucratif,

(anc. OVER THE RAINBOW - Ecole Maternelle &amp; Primaire Multilingue A.s.b.l.).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg F 8.626.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Extraordinaire tenue en date du 24 juin 2015

L'Assemblée a pris les décisions suivantes:
- la dénomination de l'Association est modifiée comme suit:
OVER THE RAINBOW A.s.b.l. - International School
- le siège social de l'Association est transféré à l'adresse suivante:
7, Val Ste. Croix
L-1371 Luxembourg
- L'objet de l'Association est modifié comme suit:
«L'Association a pour objet la création, l'organisation et la gestion d'un centre d'enseignement multilinguistique pour

enfants de l'école maternelle jusqu'au baccalauréat dont les parents ont leur lieu de résidence ou leur centre d'intérêts au
Grand-Duché de Luxembourg.

L'Association  a  encore  pour  objet  la  promotion  de  toutes  activités  scolaires  ou  parascolaires  en  faveur  des  enfants

préqualifiés ainsi que de façon générale, toutes activités se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature
à promouvoir la réalisation.

En générale, l'Association pourra effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant di-

rectement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»

Luxembourg, le 24 juin 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015103264/26.
(150112768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Reservjagd Aktiengesellschaft, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 23.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015100747/10.
(150110227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Roose S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 190.671.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100751/9.
(150110353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Perseus Real Estate Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 541.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 127.199.

<i>Auszug aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juli 2015

Abtretung von Anteilen
Anhand einer Abtretung von Anteilen, die am 23.Juni 2015 mit Wirkung am 2. Juli 2015 unterzeichnet wurde, hat

Löwenfeld Beteiligungen AG mit Gesellschaftssitz in Metzgergasse 8 CH-5000 Aarau (Schweiz) den Besitz von 1.379.550
Anteilen der Kategorie B an ARIGONO LIMITED mit Gesellschaftssitz in Konstantinou Skokou 1 CAPITAL CHAM-

105499

L

U X E M B O U R G

BERS 5 

th

 Floor Agios Antonios - Nicosia CY-1061 Nicosia (Cyprus) eingetragen im Handelsregister Nicosia unter der

Nummer HE341983, abgetreten und übertragen.

Anhand einer Abtretung von Anteilen, die am 23.Juni 2015 mit Wirkung am 2. Juli 2015 unterzeichnet wurde, hat

Lakeward Holding mit Gesellschaftssitz in Grabenstrasse 25 CH-6340 Baar (Schweiz) den Besitz von 1.379.550 Anteilen
der Kategorie B an ARIGONO LIMITED mit Gesellschaftssitz Konstantinou Skokou 1 CAPITAL CHAMBERS 5 

th

 Floor

Agios Antonios -Nicosia CY-1061 Nicosia (Cyprus) eingetragen im Handelsregister Nicosia unter der Nummer HE341983,
abgetreten und übertragen.

Anhand dieser Abtretung von Anteilen, ist das Kapital der Gesellschaft wie folgt aufgeteilt:

Gutburg Immobilien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.050.000 Anteile der Kategorie A
Gutburg Immobilien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.290.900 Anteile der Kategorie B
Arigono Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.759.100 Anteile der Kategorie B

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.100.000 Anteile

<i>Geschäftsführer

Die Hauptversammlung nahm den Rücktritt von den folgenden Kategorie A Geschäftsführern mit sofortiger Wirkung

an:

- Herr Simon KÖNIG, und
- Herr Martin RECHSTEINER,
Die Hauptversammlung ernannte zum Kategorie A Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit:
- Herr Daniel MALKIN, geboren in Tel Aviv (Israel) am 29. Februar 1976 beruflich wohnhaft in 24, Avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg, und

- Frau Simone RUNGE-BRANDNER, geboren in Friedberg/Hessen (Deutschland) am 9. Januar 1976 beruflich wohn-

haft in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Référence de publication: 2015106968/35.
(150117380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.

Société de Radiodiffusion Luxembourgeoise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 38.432.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100761/10.
(150110408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Société Anonyme Paul WURTH, Société Anonyme.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 4.446.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100762/9.
(150111139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Care Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 118.858.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 30 juin 2015 que:
- La démission de la société NUTRILUXE S.à R.L., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois sise 10A

rue Henri M. Schnadt à L-2530 Luxembourg, inscrite et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 193.406, de ses fonctions d'Administrateur unique de la société a été acceptée;

L'Assemblée à décidé de nommer aux fonctions d'Administrateurs:
- Monsieur Vincent TUCCI, né le 26.07.1968 à Moyeuvre Grande (France), résident professionnellement au 10A, rue

Henri M. Schnadt à L-2530 Luxembourg;

105500

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Eriks MARTINOVSKIS, né le 12.09.1980 à Venispils (Letonie) résident professionnellement au 10A, rue

Henri M. Schnadt à L-2530 Luxembourg;

- Madame Filippa INCARDINE-RAULET, née le 12 septembre 1961 à Thionville (France), demeurant professionnel-

lement 10A, rue Henri M. Schnadt à L-2530 Luxembourg.

La durée de leur mandat est fixée pour une période de six ans allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires qui se tiendra en 2021.

L'Assemblée à décidé de nommer aux fonctions de Président du Conseil d'Administration:

- Monsieur Vincent TUCCI, né le 26.07.1968 à Moyeuvre Grande (France), résident professionnellement au 10A, rue

Henri M. Schnadt à L-2530 Luxembourg;

La durée de son mandat est fixée pour une période de six ans allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires qui se tiendra en 2021.

L'Assemblée à décidé de nommer aux fonctions d'Administrateur délégué:

- Monsieur Vincent TUCCI, né le 26.07.1968 à Moyeuvre Grande (France), résident professionnellement au 10A, rue

Henri M. Schnadt à L-2530 Luxembourg;

La durée de son mandat est fixée pour une période de six ans allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires qui se tiendra en 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015109216/35.

(150119430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2015.

Stena Carron Lux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 172.775.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015100769/9.

(150110736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Stena Drillmax Lux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 176.689.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015100771/9.

(150110717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Stena Forth Lux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 165.636.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015100772/9.

(150110751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

105501

L

U X E M B O U R G

Devonport Maritime Inc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.

R.C.S. Luxembourg B 93.710.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg le 4 mai

<i>2015.

<i>Première résolution:

L'Assemblée Générale annuelle décide de renouveler le mandat des membres suivants au conseil d'administration de la

société, dont l'administrateur délégué à la gestion journalière, avec effet immédiat à partir du 4 mai 2015, et pour une durée
maximale de six ans:

- M. Pantelis Elephterios KOLLAKIS, de nationalité hellénique, administrateur de sociétés, résidant professionnellement

à 2, Poseidonos Avenue &amp; Zisimopoulou, GR-16674, Athènes, Grèce.

- Mme. Diane Olive KOLLAKIS, de nationalité britannique, administrateur de sociétés, résidant professionnellement

à 2, Poseidonos Avenue &amp; Zisimopoulou, GR-16674, Athènes, Grèce.

- M. Stefanos Pantelis KOLLAKIS, de nationalité britannique, administrateur de sociétés, résidant professionnellement

à 2, Poseidonos Avenue &amp; Zisimopoulou, GR-16674, Athènes, Grèce et également administrateur délégué à la gestion
journalière.

<i>Deuxième résolution:

L'Assemblée Générale annuelle décide de renouveler le mandat de la personne morale suivante, chargée du contrôle des

comptes, avec effet immédiat à partir du 4 mai 2015 et pour une durée maximale de six ans:

- MORATINA SERVICES LIMITED, n° de registre du commerce, D.R.C. HE 230792, située à 30 Karpenisiou P.C.

1660, Nicosia, Chypre.

Extrait Conforme
<i>Un Administrateur

Référence de publication: 2015103819/27.

(150113945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2015.

Stena Midwater S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 178.589.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100773/9.
(150110759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Savim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1459 Luxembourg, 8, ancienne côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 121.424.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100780/9.
(150111113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Scarabeo Investment S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 48.913.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100782/9.
(150110143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

105502

L

U X E M B O U R G

NGP IX Northern Blizzard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 4.554.870,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 153.608.

<i>Extrait des résolutions des associés datées du 25 juin 2015

En date du 16 juin 2015, les associés de la Société ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Cristina Lara, en tant que gérant ayant le pouvoir de signature B de la Société et ce avec

effet au 25 juin 2015.

- de nommer Sophie Zintzen, née le 2 décembre 1979 à Verviers, Belgique, demeurant professionnellement au 6, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant ayant le pouvoir de signature B de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet au 25 juin 2015.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

<i>Gérant ayant le pouvoir de signature A:

- John Perry

<i>Gérants ayant le pouvoir de signature B:

- Hille-Paul Schut

- Neela Gungapersad

- Sophie Zintzen

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2015.

<i>Pour Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Sophie Zintzen
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015106894/27.

(150117312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.

Ethna - AKTIV, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Ethna-AKTIV modifié au 1 

er

 août 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, août 2015

ETHENEA Independent Investors S.A.

Référence de publication: 2015133724/10.

(150144983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.

Ethna-DYNAMISCH, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Ethna-DYNAMISCH modifié au 1 

er

 août 2015 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, août 2015

ETHENEA Independent Investors S.A.

Référence de publication: 2015133722/10.

(150144981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.

105503

L

U X E M B O U R G

Tishman Speyer 33 Holborn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 240.165,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 181.692.

EXTRAIT

I/ Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 22 mai 2015 que la personne suivante a démissionné,

avec effet au 22 mai 2015, de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Gysbert Van Reenen Muller, né le 28 juillet 1981 à Vredendal, Afrique du Sud, ayant son adresse profes-

sionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

II/ Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommé, avec effet au 22 mai 2015, et pour

une durée indéterminée, en qualité de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Julien Peters, né le 20 août 1984 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

III/ Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommé, avec effet au 15 juin 2015, et pour

une durée indéterminée, en qualité de gérant de catégorie A de la Société:

- Madame Svetlana Krasteva, né le 25 mai 1973 à Burgas, Bulgarie, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue

de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

<i>Gérants de catégorie A

- Madame Joséphine Andonissamy, née le 27 février 1973 à Pondicherry, Inde, ayant son adresse professionnelle au

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Joao Antonio Carocha Rolo, né le 26 mai 1975 à Cascais, Portugal, ayant son adresse professionnelle au

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Pascal Brayeur, né le 10 décembre 1979 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 34-38,

avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Julien Peters, prénommé,

- Madame Svetlana Krasteva, prénommée.

<i>Gérants de catégorie B

- Monsieur Michael Philip Maurice Spies, né le 4 septembre 1957 à Boston, Massachussetts, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 61, Aldwych,

WC2B 4AE Londres, Royaume Uni,

- Monsieur Florian Reiff, né le 27 octobre 1970 à Stuttgart, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à TaunusTurm,

Taunustor 1, D-60311 Frankfurt am Main, Allemagne,

- Monsieur Michael B. Benner, né le 11 mai 1955 au Maryland, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle

au 45, Rockefeller Plaza, NY 10111 New-York, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 25 juin 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2015100835/47.

(150110312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

105504


Document Outline

Alphastock Sàrl

Axa World Funds II

Care Invest S.A.

CompAM FUND

Crown Premium GP VI S.à r.l.

Devonport Maritime Inc S.A.

Ethna - AKTIV

Ethna-DYNAMISCH

Fortuna Select Fund

Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l.

Landmark S.A.

NGP IX Northern Blizzard S.à r.l.

Oriflame Cosmetics S.A.

Oriflame Cosmetics S.A.

Over the Rainbow A.s.b.l. - International School

OVER THE RAINBOW - Ecole Maternelle &amp; Primaire Multilingue A.s.b.l.

Pacific S.A.

Perseus Real Estate Investment S.à r.l.

Pfizer PFE Luxembourg Holding 3 S.à r.l.

Pfizer PFE Luxembourg Holding 4 S.à r.l.

Pfizer PFE Luxembourg S.à r.l.

Prevalux Conseil s. à r.l.

Private Equity Global Select II, Sicar S.C.A.

Private Equity Global Select IV, Sicar S.C.A.

Private Equity Plus OP

Ravago Production S.A.

Ravago S.A.

Ravago S.A.

Ravara S.A.

REF Eastern European Opportunities Luxembourg S.à r.l.

Reservjagd Aktiengesellschaft

Roose S.à r.l.

Savim S.A.

Scarabeo Investment S.A.

Société Anonyme Paul WURTH

Société de Radiodiffusion Luxembourgeoise S.à r.l.

Stena Carron Lux 3 S.à r.l.

Stena Drillmax Lux 3 S.à r.l.

Stena Forth Lux 3 S.à r.l.

Stena Midwater S.à r.l.

Tishman Speyer 33 Holborn S.à r.l.