logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2131

18 août 2015

SOMMAIRE

ACP II S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102243

ACRON Gloria Palace S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

102243

ACRON Wien West A3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

102243

Akuo Investment Management S.A.  . . . . . . . .

102242

Amer-Sil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102243

Bedford Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102266

Consulting Gestion et Assistance  . . . . . . . . . . .

102272

Damea S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102288

D.B. International Finance S.A.  . . . . . . . . . . . .

102265

Doric Capital SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102275

Eagle Capital Logistics No 1  . . . . . . . . . . . . . . .

102268

GL Europe ASRS Investments S.à r.l. . . . . . . .

102252

Hanseatic Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

102249

Heaven Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102249

Helux Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102250

Holz & Dach Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102242

Immobilière Marnach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102242

Immobilière Marnach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102242

International Flooring Systems S.A.  . . . . . . . .

102249

Lancaster Coinvestors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

102288

Pets Angels Luxembourg A.s.b.l.  . . . . . . . . . . .

102287

SES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102262

Shell Treasury Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

102288

Strada Chaussures Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102244

VCM Mezzanine SICAV-FIS III  . . . . . . . . . . .

102245

VCM Venture Capital Europe Plus . . . . . . . . .

102245

VertBois Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102244

Villport Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

102244

Vis Europe Finance S.à r.l. société de gestion de

patrimoine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102244

Vis Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102245

Vis Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102245

Vision Foot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102246

Vuvezela 1 Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102243

Water Cutting Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

102247

Waterton Global Value (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102246

Welington S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102248

WER Luxembourg II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

102247

Western Trade & Commerce (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102248

Westquay Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

102246

Wind Acquisition Holdings Finance S.A.  . . . .

102246

WOOD & Company Group S.A.  . . . . . . . . . . .

102247

WTC Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102247

Xchanging Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

102248

YELLOW T International S.A.  . . . . . . . . . . . .

102248

Zaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102242

102241

L

U X E M B O U R G

Holz & Dach Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 152.865.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015094402/9.
(150104797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

Immobilière Marnach, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.336.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17.6.2015.

Signature.

Référence de publication: 2015094432/10.
(150104854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

Immobilière Marnach, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.336.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.6.2015.

Signature.

Référence de publication: 2015094433/10.
(150104855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

Zaka, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 162.189.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 de la société Zaka ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 18 juin 2015.

<i>Pour Zaka

Référence de publication: 2015097131/12.
(150107045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.

Akuo Investment Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.452.

Société Anonyme fondée le 17 octobre 2008 et publication dans le Mémorial C-N° 2683.

Les comptes annuels de 2014 ont été clôturés au 31 décembre 2014 au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Finexis S.A.

Référence de publication: 2015102747/13.
(150112904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

102242

L

U X E M B O U R G

ACP II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 75.996.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015102737/9.
(150112293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

ACRON Gloria Palace S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 181.205.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015102738/10.
(150112415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

ACRON Wien West A3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 171.484.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015102740/10.
(150112414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Amer-Sil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 8.871.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 Juin 2015.

Référence de publication: 2015102753/11.
(150113151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Vuvezela 1 Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 153.851.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 5 Avril 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 Juin 2015.

Vuvuzela 1 Luxco S.à.r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant

Référence de publication: 2015103529/14.
(150113396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

102243

L

U X E M B O U R G

Strada Chaussures Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7-9, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 81.115.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour STRADA CHAUSSURES Sàrl

Référence de publication: 2015103469/10.
(150112339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Vis Europe Finance S.à r.l. société de gestion de patrimoine familial, Société à responsabilité limitée - Société de

gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 172.872.

Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015103539/13.
(150112958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Villport Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 87.118.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 21 mai 2015

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants

procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammadia
(Algérie), domiciliée professionnellement au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au titre d'administrateur en rempla-
cement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

<i>Pour la société
VILLPORT INVESTISSEMENTS S.A.

Référence de publication: 2015103537/15.
(150113237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

VertBois Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.300.000,00.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 71.973.

L'assemblée générale des associés en date du 29 avril 2015 a pris les résolutions suivantes:
La démission avec effet au 29 avril 2015 de M. Olivier Wigniolle en sa qualité de gérant a été approuvée.
Ont été nommés gérants avec effet au 29 avril 2015 pour une durée de six ans:
Mme Kathleen Van den Eynde, Linthoutstraat 5A, B-1785 Merchtem;
M. Jean-Pascal Vialaron, drève du Caporal, 13, B-1180 Uccle;
M. Alain Schaedgen, rue d'Itzig 43, L5858 Hesperange.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015103526/16.
(150113374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

102244

L

U X E M B O U R G

VCM Mezzanine SICAV-FIS III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 137.911.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015103535/9.
(150112883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

VCM Venture Capital Europe Plus, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 138.706.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015103536/10.
(150112884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Vis Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 154.671.

Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015103541/12.
(150112959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Vis Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 154.671.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 17 juin 2015 au siège social de la société

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour

la période expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

<i>Conseil d'Administration:

- Monsieur Federico FRANZINA, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, admi-

nistrateur;

- Monsieur Massimiliano SELIZIATO, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,

administrateur;

- Madame Marion GERARD, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, adminis-

trateur.

<i>Commissaire aux comptes:

- DIMEST S.A., ayant son siège social au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176.670, commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015103540/23.
(150112957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

102245

L

U X E M B O U R G

Westquay Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 152.789.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015103549/9.
(150112892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Vision Foot, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 164.895.

Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VISION FOOT

Référence de publication: 2015103542/10.
(150113254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Waterton Global Value (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.183.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015103547/12.
(150112403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Wind Acquisition Holdings Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 109.823.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 26 juin 2015

Mme Ingrid Cernicchi a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 26 juin 2015.
L'Assemblée a nommé M. Ludovic Trogliero, né le 8 juin 1979 à Clichy-la-Garenne, France, ayant son adresse profes-

sionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur, avec effet au 26 juin 2015 jusqu'à
l'assemblée générale approuvant les comptes annuels 2014.

L'Assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs actuels de la société jusqu'à l'assemblée générale

approuvant les comptes annuels 2014.

Veuillez prendre note que Messieurs David Catala et Douwe Terpstra, administrateurs, résident désormais profession-

nellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 1 

er

 mars 2014.

La société PricewaterhouseCoopers, société coopérative (R.C.S. Luxembourg: B 65477), ayant son siège social au 2,

rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, a été nommée comme réviseur d' entreprises agréé avec effet au 16 juillet
2014 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels 2014.

Luxembourg, le 30 juin 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Wind Acquisition Holdings Finance S.A.
Mme Nathalie Baloze

Référence de publication: 2015103552/23.
(150113300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

102246

L

U X E M B O U R G

Water Cutting Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-4385 Ehlerange, Zone Industrielle Zare Est.

R.C.S. Luxembourg B 80.921.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015103555/9.
(150112536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

WER Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 35/37, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 181.474.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015103557/11.
(150112655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

WOOD &amp; Company Group S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.088.560,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 83.396.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 juin 2015 que:
- Le mandat de commissaire aux comptes de L'Alliance Révision a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se

tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 30 juin 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015103561/16.
(150113265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

WTC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.001,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 167.787.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des Associés prises en date du 19 juin 2015

L'Associé Unique de WTC Holdings S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Kenneth MacRae en tant que gérant B de la Société à partir du 19 juin 2015;
- De nommer:
* Monsieur Thierry Larroque, né à Haguenau, France, le 14 octobre 1966, demeurant professionnellement à 205, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société à partir du 19 juin 2015, pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2015.

WTC Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2015103563/18.
(150112554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

102247

L

U X E M B O U R G

Xchanging Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.001,00.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 171.504.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015103565/12.
(150113319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

YELLOW T International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 57.498.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandweiler.

<i>Pour YELLOW T INTERNATIONAL S.A.
Gabriel DELLANDREA / Patrick GINDT
<i>Administrateur Technique / <i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2015103570/13.
(150113045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Western Trade &amp; Commerce (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 48.253.

En date du 29 juin 2015 il a été décidé ce qui suit:
le siège social de la société WESTERN TRADE &amp; COMMERCE (Luxembourg) S.A. est transféré au:
70, Grand-Rue
L - 1660 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extraits conformes et sincères
WESTERN TRADE &amp; COMMERCE (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015103558/14.
(150112380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Welington S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 115.713.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 21 mai 2015

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants

procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammadia
(Algérie), domiciliée professionnellement au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au titre d'administrateur en rempla-
cement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

<i>Pour la société
WELINGTON S.A.

Référence de publication: 2015103556/15.
(150113238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

102248

L

U X E M B O U R G

International Flooring Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 157.729.

EXTRAIT

Il a été décidé lors de l'assemblée générale de la Société, en date du 12 juin 2015 et avec effet immédiat:
1 d'accepter la démission de Messieurs Filiep Balcaen et Didier Ysenbaert en tant qu'administrateurs de la Société,
2 de nommer Brooser Be Operations BVBA, ayant son siège social à Koudehaard 1B, 9255 Buggenhout, Belgique,

immatriculée auprès du Register of Legal Entities de Ghent (division Dendermonde) sous le numéro 0830.357.018 et
représenté par son représentant permanent Mr. Bart Van Den Eeede, demeurant professionnellement à Koudehaard 1B,
9255 Buggenhout, Belgique, en tant qu'administrateur de la Société, pour une période prenant fin lors de l'assemblée
générale approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour International Flooring Systems S.A.

Référence de publication: 2015098382/17.
(150108337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.

Heaven Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 166.683.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique du 29 mai 2015

Il résulte des décisions de l'Associé Unique du 29 mai 2015 que:
«L'associé unique décide de ratifier la nomination par cooptation de la société de droit luxembourgeois, SH Services

SA, représentée par Monsieur Eloi Thill, représentant permanent, avec adresse professionnelle sise à L-3782 Tétange, 28
A, rue du Parc, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.369, ayant son
siège social à L-3782 Tétange, 28 A, rue du Parc, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Eloi Thill
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance le 30 janvier 2018.»

<i>Pour l'Actionnaire Unique
Promotion Partners S.A.
Jean-François Leidner / Geert De Bruyne
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015098347/18.
(150108503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.

Hanseatic Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,00.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 8, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 82.746.

EXTRAIT

Démission de gérant:
Veuillez noter que la gérante A Nina Kleinbongartz a démissionné en date du 17 avril 2015.
Transfert de parts sociales:
Il résulte du contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 8 décembre 2014 sous seing privé, que l'associé

Hanseatic Americas LDC a transféré 1799 parts sociales à Hanseatic Americas Ltd ayant son ayant son siège social au c/
o Codan Services Limited, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, et inscrite auprès du Bermuda
Registrar of Companies sous le numéro 30750.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015098343/19.
(150108322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.

102249

L

U X E M B O U R G

Helux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 90.639.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth of June.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Helux Holding S.A., a Luxembourg public limited liability

company (“société anonyme’’), with registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 90639 (the “Company’’),
which has been incorporated by deed of the notary public Maître Joseph Elvinger, then residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, dated December 6 

th

 , 2002, published in the Mémorial C n°155 dated February 14 

th

 , 2003.

The articles of association of the Company have lastly been amended by a deed of Maître Joseph Elvinger dated De-

cember 15 

th

 , 2006, published in the Mémorial C n°486 dated March 29 

th

 , 2007.

The meeting is chaired by Peggy Simon, employee, with professional address at L-6475 Echternach, 9, Rabatt.
The chairman appointed as secretary Claudine Schoellen, employee, with professional address at L-6475 Echternach,

9, Rabatt.

The meeting elected as scrutineer Peggy Simon, prenamed.
The chairman declares and requests the undersigned notary to act that:
I. The sole shareholder represented and the number of its shares are shown on an attendance list, signed by the chairman,

the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered with these
minutes.

II. As appears from the said attendance list, sixteen thousand (16,000) shares, representing the entirety of the Company's

share capital currently set at thirty-two thousand Euros (EUR 32,000.) are represented at the present extraordinary general
meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Anticipated dissolution of the Company;
2. Taking over by the sole shareholder of ail of the Company's assets and close of the Company's liquidation;
3. Wholly and fully discharge granted to the directors and the statutory auditor of the dissolved Company for the exercise

of their mandates; and

4. Decision to keep the accounting books and documents of the dissolved Company during a five years period at the

registered office of the dissolved Company.

The sole shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder expressly declares to proceed with the anticipated dissolution of the Company and to act as liqui-

dator of the Company.

<i>Second resolution

The activity of the Company has ceased, with the exception of a remaining shareholding of a subsidiary; all the outs-

tanding assets and more specifically the shares held in Sulikon Ltd, a Cyprian company with registered office at Miltonos
86A, 3047 Limassol, Cyprus, registered with the Cyprian company registers under number HE196670, and liabilities of
the Company are taken over by the sole shareholder, which declares that all liabilities of the Company have been settled,
and which is now personally liable for all liabilities and commitments of the Company, even those actually unknown;
accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.

<i>Third resolution

The sole shareholder wholly and fully discharges the directors and the statutory auditor of the dissolved Company for

the exercise of their mandates as of the date hereof.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to keep the accounting books and documents of the dissolved Company during a five

years period at the registered office of the dissolved Company.

102250

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present resolutions are estimated at approximately eight hundred Euro (EUR 800.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

company, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing company and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the notary by her Surname,

Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the présent original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le seize juin.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de Helux Holding S.A., une société anonyme de droit lu-

xembourgeois, ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90639 (la «Société»), qui a été constituée par acte reçu par le notaire
Maître Joseph Elvinger, alors résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 décembre 2002, publié
au Mémorial C numéro 155 du 14 février 2003.

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire Maître Joseph Elvinger, en date du 15

décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 486 du 29 mars 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle à L-6475

Echternach, 9, Rabatt.

Le  président  désigne  comme  secrétaire  Claudine  Schoellen,  employée,  ayant  son  adresse  professionnelle  à  L-6475

Echternach, 9, Rabatt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.
La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:
I. L'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, signée

par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il appert de cette liste de présence que la totalité des seize mille (16.000) actions, représentant l'intégralité du capital

social actuellement fixé à trente-deux mille (EUR 32.000,-), sont représentées à la présente assemblée générale extraordi-
naire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Dissolution anticipée de la Société;
2. Transfert de tout l'actif à l'actionnaire unique et clôture de la liquidation de la Société;
3. Décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats; et
4. Décision de conserver durant cinq ans au siège social de la Société tous les documents et pièces relatifs à la Société

dissoute.

L'actionnaire unique décide de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'activité de la Société a cessé, à l'exception d'une détention dans une filiale; l'actionnaire unique déclare que tout le

passif de la Société est réglé et décide que tout l'actif, en particulier les actions détenues dans la société Sulikon Ltd, une
société de droit chypriote, ayant son siège social au Miltonos 86A, 3047 Limassol, Chypre, inscrite au registre des sociétés
de Chypre sous le numéro HE196670, lui est transféré et qu'il répondra personnellement de tous les engagements de la
Société même inconnus à ce jour; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

<i>Troisième résolution

L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice

de leurs mandats jusqu'à ce jour.

102251

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide de conserver les documents et pièces relatifs à la Société dissoute durant cinq ans au siège

social de la Société dissoute.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents Euros (EUR 800.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. SIMON, C. SCHOELLEN, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 juin 2015. Relation: GAC/2015/5179. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 25 juin 2015.

Référence de publication: 2015099589/121.
(150110012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

GL Europe ASRS Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 197.831.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of June.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

GL Europe ASRS Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, in the process of being registered with Luxembourg Trade and Companies Register, having
its registered office at 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

here represented by Ms Kety Tsochas, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company

(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

GL Europe ASRS Investments S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

102252

L

U X E M B O U R G

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the

transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.

102253

L

U X E M B O U R G

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, at which point
decisions shall be validly approved in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the
fraction of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be shareholders of the Company.

If the Company has several managers, the managers form a board of managers composed of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

Art. 15. Convening meetings of the board of managers.
15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication initiated from Luxembourg by a class B Manager, allowing all persons participating at such meeting to

102254

L

U X E M B O U R G

hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting
by these means is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered
office of the Company.

16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers, among which at least one (1) class A manager and one (1) class B
manager must be present or represented.

16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting provided that

at least one (1) class A manager and one (1) class B manager vote in favour of a resolution. The chairman, if any, shall not
have a casting vote.

16.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.

Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by

the chairman pro tempore and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which
may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.

17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 18. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, (i) by the joint signature of one (1) class A manager
and one (1) class B manager, (ii) by the joint signature of two (2) class B managers (excluding, however, for the operation
of the Company’s bank accounts), or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such
signatory power may have been delegated by the Company within the limits of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 19. Auditor(s).
19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

19.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

19.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

19.5.  An  independent  auditor  may  only  be  removed  by  the  general  meeting  of  shareholders  with  cause  or  with  its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 20. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

21.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

21.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

21.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

102255

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.

22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 23. Liquidation.
23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators  shall  have  the  most  extensive  powers  for  the  realisation  of  the  assets  and  payment  of  the  liabilities  of  the
Company.

23.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 24. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by GL Europe ASRS Holdings S.à r.l.,

aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five

hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500,-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating sole shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any con-

vening requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Richard Stabinsky, born in New York, USA on January 28 

th

 1968, professionally residing at 399 Park Avenue, 6

th

 Floor, New York, New York 10022, United States, as class A manager; and

(ii) Thomas M. Larkin, born in New Jersey, USA on February 21 

st

 1964, professionally residing at 399 Park Avenue,

th

 Floor, New York, New York 10022, United States, as class A manager; and

(iii) Henry Saavedra, born in New York, USA on November 17 

th

 1978, professionally residing at 25a, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, as class B manager; and

(iv) Ramon van Heusden, born in Nijmegen, the Netherlands, on May 7 

th

 1967, professionally residing at Carré Bonn,

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as class B manager;

(v) Jorrit Crompvoets, born in Voorst, the Netherlands, on May 16 

th

 1976, professionally residing at Carré Bonn, 20,

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as class B manager.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

102256

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède.

L’an deux mille quinze, le onze juin.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

GL Europe ASRS Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Société de Luxembourg, ayant
son siège social au 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par Mademoiselle Kety Tsochas, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte de constitution d’une société à responsabilité limitée

qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «GL Europe ASRS Invest-

ments S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, le transfert
par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l’administration, le contrôle et la
mise en valeur de ces participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des

sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Sauf par voie d’appel publique à l’épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme

ou en émettant toute sorte d’obligations, de titres obligataires ou d’instrument de dettes, d’obligations garanties ou non
garanties, et d’une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des associés, adoptée

selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4 Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, écono-

mique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité
normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation
complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq

cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

102257

L

U X E M B O U R G

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre

événement similaire d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour

consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession

ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l’acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l’associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous

réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital social. Un
tel agrément n’est cependant pas requis dans l’hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, des-
cendants ou au conjoint survivant.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les

présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il

détient.

8.3 Dans l’hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient d’ordinaire de la compétence de l’assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l’assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l’associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés seront exercés par l’associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l’hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une

assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D’autres assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.

Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent
être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même agenda et les décisions sont vala-
blement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement

unanime des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l’accord d’une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

102258

L

U X E M B O U R G

D. Gérance

Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas être actionnaires de la Société. Si la

Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance, composé au moins d’un (1) gérant de classe A et
d’un (1) gérant de classe B.

13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n’est pas

expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».

13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute

mesure nécessaire ou utile pour l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés.

Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et

la durée de son (leur) mandat.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par

une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au

siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures

à l’avance par rapport à l’heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs d’une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel document signé
constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l’heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.

15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l’hypothèse où les tous les gérants seront présents ou représentés

à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l’hypothèse de décisions écrites et approu-
vées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.

16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,

le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.

16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en
constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l’intégralité des membres du conseil
de gérance.

16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, initié au Luxembourg par un gérant de classe B, permettant à toutes les personnes
y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens
de communication est réputée s’être tenue au siège social de la Société.

16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance, parmi lesquels doivent être présents ou représentés au moins un (1)
gérant de classe A et un (1) gérant de classe B.

16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de

gérance, pourvu qu'au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B ait voté en faveur de la décision. Le
président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d’une voix prépondérante.

16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l’ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions
sera la date de la dernière signature.

102259

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,

en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par
deux (2) gérants.

17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.

Art. 18. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la

signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, (i) par la signature conjointe d’un (1) gérant de classe A
et d’un (1) gérant de classe B, (ii) par la signature conjointe de deux (2) gérants de classe B (à l’exception de la gestion des
comptes bancaires de la Société), ou (iii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/
auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par la Société dans les limites de cette délégation.

E. Audit et surveillance

Art. 19. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.
19.1 Dans l’hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront

surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.

19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif

ou avec son accord.

F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 20. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le

trente et un décembre de la même année.

Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif

et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

21.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

21.5  Sur  proposition  du  conseil  de  gérance,  l'assemblée  générale  des  associés  décide  de  l’affectation  du  solde  des

bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

21.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la

Société.

Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-

formément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 23. Liquidation.
23.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera

102260

L

U X E M B O U R G

les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.

23.2 Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre

de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2015.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

<i>Souscription et paiement

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par GL Europe ASRS Holdings S.à r.l.,

susmentionnée, pour un prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en numéraire, de sorte que le

montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.

L’apport global d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.500,-.

<i>Résolutions de l’associé

L’associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convo-

cation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
(i) Richard Stabinsky, né à New York, Etats-Unis, le 28 janvier 1968, résidant professionnellement à 399 Park Avenue,

th

 Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis, en tant que gérant de classe A; et

(ii) Thomas M. Larkin, né à New Jersey, Etats-Unis, le 21 février 1964, résident professionnellement à 399 Park Avenue,

th

 Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis, en tant que gérant de classe A; et

(iii) Henry Saavedra, né à New York, Etats-Unis, le 17 novembre 1978, résidant professionnellement à 25a, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que gérant de classe B;

(iv) Ramon van Heusden, né à Nijmegen, Pays-Bas, le 7 mai 1967, résidant professionnellement à Carré Bonn, 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérant de classe B; et

(v) Jorrit Crompvoets, né à Voorst, Pays-Bas, le 16 mai 1976, résidant professionnellement à Carré Bonn, 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérant de classe B.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la comparante que le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la comparante et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. TSOCHAS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/18847. Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 juin 2015.

Référence de publication: 2015098320/516.
(150108585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.

102261

L

U X E M B O U R G

SES, Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 81.267.

L’an deux mille quinze, le premier juin.
Pardevant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue

la réunion du Chairman’s Office de la société anonyme «SES», ayant son siège social au Château de Betzdorf, L-6815

Betzdorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.267, constituée suivant
acte notarié du 16 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 591 du 31 juillet 2001
et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 2
avril 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1278 du 18 mai 2015 (la «Société»).

La réunion du Chairman’s Office est ouverte à 13.00 heures sous la présidence de Monsieur Romain BAUSCH, Président

du Conseil d’administration de SES, demeurant à Mamer qui constate la présence de Monsieur François TESCH, Vice-
President du Conseil d'Administration, demeurant à Kockelscheuer et de Monsieur Jean-Paul ZENS, Vice-Président du
Conseil d'Administration, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président constate que le Chairman’s Office a été dûment convoqué et qu'il est valablement constitué et

peut délibérer sur son ordre du jour.

I. Le Chairman’s Office constate que par décision du 2 avril 2015, l’assemblée générale des actionnaires de la Société

a autorisé le Conseil d’Administration à émettre dans le cadre du capital autorisé un maximum de six millions deux cent
mille (6.200.000) nouvelles actions A et de trois millions cent mille (3.100.000) nouvelles actions B avec faculté de sup-
primer  partiellement  ou  totalement  le  droit  de  souscription  préférentiel  des  actionnaires  existants  en  ce  qui  concerne
l’émission des nouvelles actions A.

II. Dans sa réunion du 2 avril 2015, le Conseil d’Administration de la Société a décidé d’émettre six millions (6.000.000)

de nouvelles actions A et trois millions (3.000.000) de nouvelles actions B correspondant au capital autorisé de six cent
quarante-quatre millions deux cent cinquante mille Euros (EUR 644.250.000,-), et a mandaté le Chairman’s Office d’ac-
cepter les souscriptions y relatives. D’autre part, le Conseil d’Administration a totalement supprimé le droit préférentiel
de souscription des actionnaires existants de la catégorie A.

Une copie de l’extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration restera attachée aux présentes pour

être soumise avec elles aux formalités de l’enregistrement.

III. Le Chairman’s Office reconnaît avoir reçu et accepte par les présentes la souscription de:
- Goldman Sachs International, une société de droit anglais et du Pays de Galles, avec siège à Peterborough Court, 133

Fleet Street, London EC4A 2BB et immatriculée sous le numéro 02263951, pour un total de six millions (6.000.000)
d’actions A;

- Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, établissement public, avec siège à L-2954 Luxembourg, 1, Place de Metz, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.775, pour un total de neuf cent soixante-
dix-neuf mille quatre-vingt-cinq (979.085) actions B;

- Société Nationale de Crédit et d’Investissement, établissement public, avec siège à L-1012 Luxembourg, 7, rue du

Saint-Esprit, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J1, pour un total de neuf
cent soixante-dix-huit mille neuf cent soixante (978.960) actions B;

-  l’Etat  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  pour  un  total  de  un  million  quarante-un  mille  neuf  cent  cinquante-cinq

(1.041.955) actions B.

La réalité de ces souscriptions a été prouvée au notaire soussigné par des bulletins de souscription ainsi que par des

lettres qui resteront annexés au présent acte afin d’être enregistrés en même temps.

Les nouvelles actions A mentionnées ci-dessus sont intégralement libérées par un apport en numéraire d’un montant de

cent quatre-vingt-treize millions quatre cent quarante mille Euros (EUR 193.440.000,-), dont un montant de sept millions
cinq cent mille Euros (EUR 7.500.000,-) est affecté au capital social de la Société et un montant de cent quatre-vingt-cinq
millions neuf cent quarante mille Euros (EUR 185.940.000,-) est affecté au compte prime d’émission de la Société.

Les nouvelles actions B mentionnées ci-dessus sont intégralement libérées comme suit:
- pour la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat par un apport en numéraire d’un montant de douze millions six cent

vingt-six mille deux cent quatre-vingt Euros et seize cents (EUR 12.626.280,16), dont un montant de un million deux cent
vingt-trois mille huit cent cinquante-six euros et vingt-cinq cents (EUR 1.223.856,25) est affecté au capital social de la
Société et un montant de onze millions quatre cent deux mille quatre cent vingt-trois Euros et quatre-vingt-onze cents (EUR
11.402.423,91) au compte prime d’émission de la Société;

- pour la Société Nationale de Crédit et d’Investissement par un apport en numéraire d’un montant de douze millions

six cent vingt-quatre mille six cent soixante-huit mille Euros et seize cents (EUR 12.624.668,16), dont un montant de un
million deux cent vingt-trois mille sept cents euros (EUR 1.223.700,-) est affecté au capital social de la Société et un montant

102262

L

U X E M B O U R G

de onze millions quatre cent mille neuf cent soixante-huit Euros et seize cents (EUR 11.400.968,16) au compte prime
d’émission de la Société.

Le montant total de deux cent dix-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quarante-huit Euros et trente-

deux cents (EUR 218.690.948,32) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui
le constate expressément;

- pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par un apport en nature consistant en quatre cent seize mille sept cent

quatre-vingt-deux (416.782) FDRs de la Société.

Le montant total de cet apport en nature est évalué à treize millions quatre cent trente-sept mille cinquante et un Euros

et soixante-huit cents (EUR 13.437.051,68), dont un montant de un million trois cent deux mille quatre cent quarante-trois
Euros et soixante-quinze cents (EUR 1.302.443,75) est affecté au capital social de la Société et un montant de douze millions
cent trente-quatre mille six cent sept Euros et quatre-vingt-treize cents (EUR 12.134.607,93) est affecté au compte prime
d’émission de la Société.

L’existence et l’apport à la Société de ces quatre cent seize mille sept cent quatre-vingt-deux (416.782) FDRs a été

démontré par une attestation de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, qui restera annexée au présent acte.

La réalité de ces apports a fait l’objet d’un rapport établi en date du 1 

er

 juin 2015 par PricewaterhouseCoopers, réviseur

d’entreprises, ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, conformément aux articles 32-1 et
26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La conclusion du rapport est la suivante:

<i>«Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the contribution

in kind does not correspond at least to the number of the shares without indication of par value to be issued in counterpart
and their ascribed value increased by the share premium.”

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
IV. Suite aux résolutions et constatations qui précèdent, et étant entendu que le total du capital autorisé a été utilisé,

l’article 4 des statuts de la Société est modifié comme suit:

« Art. 4. Capital Social. La Société a un capital souscrit de six cent quarante-quatre millions deux cent cinquante mille

d’euros (EUR 644.250.000) représenté par cinq cent quinze millions quatre cent mille (515.400.000) actions sans dési-
gnation de valeur nominale. Le capital est divisé en trois cent quarante-trois millions six cent mille (343.600.000) Actions
A sans désignation de valeur nominale et cent soixante et onze millions huit cent mille (171.800.000) Actions B sans
désignation de valeur nominale.

Les actions des catégories A et B constituent des catégories différentes d’actions mais prenant rang pari passu sauf dans

les cas spécifiquement indiqués ci-après.

A chaque scission d’actions, distribution d'actions, opération de recapitalisation, subdivision, reclassification, combi-

naison ou échange d’actions, émission de droits ou de warrants pour l’acquisition d’actions de la Société ou toute autre
opération similaire influant sur le nombre d’actions d’une catégorie, la même scission d’actions, distribution d'actions,
recapitalisation, subdivision, reclassification, combinaison ou échange d’actions, émission de droits ou de warrants pour
l’acquisition d’actions de la Société ou une opération identique devra avoir lieu pour les autres catégories d’actions.»

Les résolutions ci-avant reproduites ont été prises à l’unanimité des membres du Chairman’s Office présents.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Betzdorf, au siège social de la Société, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé

en langue française suivi d’une traduction en anglais et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du Chairman’s Office ont signé avec le

notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and fifteen, on the first day of June.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held

the meeting of the Chairman’s Office of “SES”, a société anonyme having its registered office at Château de Betzdorf,

L-6815 Betzdorf, registered with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg under number B 81.267, incorporated
pursuant to a notarial deed on 16 March 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
591 of 31 July 2001 and of which the articles of incorporation have been amended several times and for the last time
pursuant  to  a  deed  of  the  undersigned  notary  on  2  April  2015,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations number 1278 of 18 May 2015 (the «Company»).

102263

L

U X E M B O U R G

The meeting of the Chairman’s Office is opened at 1.00 p.m. with Mr Romain BAUSCH, Chairman of the Board of

Directors of SES, residing in Mamer, in the chair, who acknowledges the presence of Mr. François TESCH, Vice-Chairman
of the Board of Directors of SES, residing in Kockelscheuer and Mr. Jean-Paul ZENS, Vice-Chairman of the Board of
Directors of SES, residing in Luxembourg.

The chairman states that the Chairman’s Office has been duly convened and that it is regularly constituted and able to

validly deliberate on the items of the agenda.

I. The Chairman’s Office acknowledges that by decision of 2 April 2015, the general meeting of shareholders of the

Company has authorized the board of directors to issue, within the authorized share capital amounting to six hundred forty
four million two hundred and fifty thousand euros (EUR 644,250,000.-), a maximum of six million two hundred thousand
(6,200,000) new A shares and of three million one hundred thousand (3,100,000) new B shares without reserving to the
existing shareholders any preferential subscription rights when issuing new A shares.

II. In its meeting on 2 April 2015, the board of directors of the Company has decided to issue six million (6,000,000)

new A shares and three million (3,000,000) new B shares, corresponding to the authorized capital of six hundred and forty
four million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 644,250,000.-) and has mandated the Chairman’s Office to accept
the relevant subscriptions. The board of directors has further decided to suppress any preferential subscription rights of the
existing shareholders in relation with the issue of A shares.

A copy of the extract of the minutes of the meeting of the board of directors remains attached to the present deed to be

registered with the registration authorities.

III. The Chairman’s Office acknowledges having received and accepts herewith the following subscriptions:
- Goldman Sachs International, a company incorporated in England and Wales, with registered office at Peterborough

Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB and registered under number 02263951, for a total of six million (6,000,000)
A shares;

- Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, établissement public, with registered office at L-2954 Luxembourg, 1, Place de

Metz, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 30.775, for a total of nine hundred
and seventy nine thousand and eighty five (979,085) B shares;

- Société Nationale de Crédit et d’Investissement, établissement public, with registered office at L-1012 Luxembourg,

7, rue du Saint-Esprit, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number J1, for a total of nine
hundred and seventy eight thousand nine hundred and sixty (978,960) B shares;

- The State of the Grand-Duchy of Luxembourg, for a total of one million forty one thousand nine hundred and fifty

five (1,041,955) B shares.

Proof of the subscriptions has been given to the undersigned notary by subscriptions forms and by letters which will

remain attached to the present deed to be registered.

The new A shares are entirely paid up in cash for an amount of one hundred and ninety three million four hundred and

forty thousand Euro (EUR 193,440,000.-) allocated for an amount of seven million five hundred thousand Euro (EUR
7,500,000.-) to the share capital of the Company and for an amount of one hundred and eighty five million nine hundred
and forty thousand Euro (EUR 185,940,000.-) to the share premium account of the Company.

The new B shares are entirely paid up as follows:
- for Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat in cash for an amount of twelve million six hundred and twenty six thousand

two hundred and eighty Euro and sixteen cents (EUR 12,626,280.16) allocated for an amount of one million two hundred
and twenty three thousand eight hundred and fifty six Euro and twenty five cents (EUR 1.223.856,25) to the share capital
of the Company and for an amount of eleven million four hundred and two thousand four hundred and twenty three Euro
and ninety one cents (EUR 11,402,423.91) to the share premium account of the Company;

- for Société Nationale de Crédit et d’Investissement in cash for an amount of twelve million six hundred and twenty

four thousand six hundred and sixty eight Euro and sixteen cents (EUR 12,624,668.16) allocated for an amount of one
million two hundred and twenty three thousand seven hundred Euro (EUR 1,223,700.-) to the share capital of the Company
and for an amount of eleven million four hundred thousand nine hundred and sixty eight Euro and sixteen cents (EUR
11,400,968.16) to the share premium account of the Company.

A total amount of two hundred and eighteen million six hundred and ninety thousand nine hundred and forty eight Euro

and thirty two cents (EUR 218,690,948.32) is as of now available to the Company as has been proved to the undersigned
notary.

- for the State of the Grand-Duchy of Luxembourg by a contribution in kind, consisting of four hundred and sixteen

thousand seven hundred and eighty two (416,782) FDRs of the Company.

The total value of the contribution in kind amounts to thirteen million four hundred and thirty seven thousand fifty one

Euro and sixty eight cents (EUR 13,437,051.68) allocated for an amount of one million three hundred and two thousand
four hundred and forty three Euro and seventy five cents (EUR 1,302,443.75) to the share capital of the Company and for
an amount of twelve million one hundred and thirty four thousand six hundred and seven Euro and ninety three cents (EUR
12,134,607.93) to the share premium account of the Company.

102264

L

U X E M B O U R G

The existence and the contribution of the four hundred and sixteen thousand seven hundred and eighty two (416,782)

FDRs to the Company is evidenced by an attestation of Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat which will remain attached
to the present deed.

Pursuant to articles 26-1 and 32-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the valuation

of the contribution in kind has been confirmed to the undersigned notary by a report dated June 1 

st

 , 2015 established by

PricewaterhouseCoopers, réviseur d'entreprises, with registered office at L-1014 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator,
which report, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The said report concludes as follows:

<i>“Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the contribution

in kind does not correspond at least to the number of the shares without indication of par value to be issued in counterpart
and their ascribed value increased by the share premium.”

IV. As a consequence of the foregoing resolutions and observations, and being understood that the total of the authorized

capital has been utilized, article 4 of the articles of incorporation of the Company is amended to read as follows:

“ Art. 4. Corporate Capital. The Company has a subscribed share capital of six hundred forty four million two hundred

and  fifty  thousand  Euro  (EUR  644,250,000.-)  represented  by  five  hundred  and  fifteen  million  four  hundred  thousand
(515,400,000) shares without indication of a par value. The share capital is divided in three hundred and forty three million
six hundred thousand (343,600,000) A shares without indication of a par value and one hundred seventy one million eight
hundred thousand (171,800,000) B shares without indication of par value.

The shares of Classes A and B shall constitute separate classes of shares in the Company, but shall rank pari passu in

all respects save as hereinafter specifically provided.

Each time a stock split, stock dividend, recapitalisation, subdivision, reclassification, combination, exchange of shares,

issuance of rights or warrants to acquire shares of the Company or similar transaction occurs with respect to the number
of shares of any class of shares of the Company, a corresponding stock split, stock dividend, recapitalisation, subdivision,
reclassification, combination, exchange of shares, issuance of rights or warrants to acquire shares of the Company or similar
transaction will occur with respect to the number of shares of the other classes of shares of the Company.”

These resolutions have been taken by unanimous vote of the members of the Chairman’s Office present.
There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Betzdorf, at the registered office of the Company, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith on request of the appearing persons that

the present deed is worded in French followed by an English version; and in case of divergences between the French and
the English text, the French version will be prevailing.

The document having been read and interpretation having been given to the persons appearing, the members of the

Chairman’s Office signed together with the notary the present deed.

Signé: R. BAUSCH, F. TESCH, J.-P. ZENS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 4 juin 2015. 1LAC / 2015 / 17234. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

Référence de publication: 2015101732/212.
(150111803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

D.B. International Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 33.911.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2015.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015102896/12.
(150112342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

102265

L

U X E M B O U R G

Bedford Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 185.470.

In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of June,
Before the undersigned, Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Bedford Lux S.à r.l., a Luxembourg société

à responsabilité limitée having its registered office at 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 185.470 and having a
share capital of EUR 12,500 (the Company).

THERE APPEARED:

ALCHEMY SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II L.P., a Guernsey limited partnership registered under number 1316,

having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, acting through its
manager ALCHEMY SEPCIAL OPPORTUNITIES (GUERNSEY) LIMITED, a non-cellular company limited by shares,
incorporated in Guernsey, with registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey,
GY1 3QL Channel Islands and registered with the register of companies of Guernsey under registration number 57506 (the
Sole Shareholder),

here duly represented by Peggy Simon, employee, whose professional address is in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, the

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That it is the Company’s sole shareholder and that the Meeting is thus validly constituted and may deliberate on the

items on the agenda, as set out below;

II. That the Company has been incorporated on 14 March 2014, pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Beck,

notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (the Mémorial) number 1325, page 63583 of 23 May 2014. Since that date, the Company’s articles of association
(the Articles) have been amended several times, most recently on 2 April 2015 pursuant to a deed drawn up by Maître
Henri Beck, aforementioned, not yet published in the Mémorial;

III. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Dissolution of the Company;
2. Appointment of the liquidator;
3. Powers of the liquidator;
4. Instructions to the liquidator.
IV. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation

volontaire).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint ASO Lux 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company having

its registered office at 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154631 and with a share capital of EUR 1,931,885.69
as the Company’s liquidator (the Liquidator). The Liquidator is empowered, by its sole signature, to do whatever is required
for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg

law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of

the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, on its sole responsibility, delegate
some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.

The Liquidator is authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole

Shareholder, subject to the drawing-up of interim accounts.

102266

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise all the Company’s assets on the best possible terms

and to pay all its debts.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Sole Shareholder, this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Echternach, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholders’ authorised representative.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le quinzième jour de juin,
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Bedford Lux S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est établi 6 rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 185.470
et disposant d’un capital social de EUR 12.500 (la Société).

A COMPARU:

ALCHEMY SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II L.P., une société en commandite immatriculée à Guernesey sous

le numéro 1316, dont le siège social se situe à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Îles Anglo-Nor-
mandes, agissant par le biais de son gérant ALCHEMY SEPCIAL OPPORTUNITIES (GUERNSEY) LIMITED, une
société en commandite par actions non-cellulaire (non-cellular company limited by shares) constituée à Guernesey, dont
le siège social se situe au PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey GY1 3QL, Îles Anglo-
Normandes, et immatriculée au registre des sociétés de Guernesey sous le numéro 57506 (l’Associé Unique),

ici dûment représenté par Peggy Simon, employée, avec adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en

vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant, la procuration

restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Qu’il est le seul associé de la Société et que l’Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur

les points de l’ordre du jour reproduits ci-après;

II. Que la Société a été constituée le 14 mars 2014, suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à

Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial)
numéro 1325, page 63583 du 23 mai 2014. Depuis, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises
et le plus récemment le 2 avril 2015, suivant acte reçu par Maître Henri Beck, susmentionné, non encore publié au Mémorial;

III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Dissolution de la Société;
2. Nomination du liquidateur;
3. Pouvoirs du liquidateur;
4. Instructions au liquidateur.
IV. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de nommer ASO Lux 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

dont le siège social se situe à 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 154631 et disposant d’un capital social de EUR 1.931.885,69,
en qualité de liquidateur de la Société (le Liquidateur). Le Liquidateur est autorisé à accomplir, sous sa seule signature,
tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs.

<i>Troisième résolution

L’Associé  Unique  décide  d’attribuer  au  Liquidateur  tous  les  pouvoirs  prévus  aux  articles  144  et  suivants  de  la  loi

luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

102267

L

U X E M B O U R G

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à l’article

145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’Associé Unique. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule responsabilité,
certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques
ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser à l’Associé Unique des acomptes sur le boni de liquidation, à condition que des

comptes intérimaires soient établis.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide d'autoriser le Liquidateur à procéder dans les meilleures conditions à la réalisation de l’actif

et au paiement de toutes les dettes de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de l’Associé Unique, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l’Associé Unique.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 juin 2015. Relation: GAC/2015/5077. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): N. DIEDERICH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 25 juin 2015.

Référence de publication: 2015099243/128.
(150109884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

Eagle Capital Logistics No 1, Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 196.171.

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of June.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary, residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders (the "Shareholders") of Eagle Capital Logistics

No.1  S.A.,  a  public  limited  liability  company  (société  anonyme)  incorporated  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of
Luxembourg by a notarial deed enacted by Maître Pierre PROBST, notary, residing in Ettelbruck, Grand Duchy of Lu-
xembourg, dated 2 April 2015, in the course of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
of 9 June 2015, number 1447, page 69442, with registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 196171 (the "Company"). The articles of association
of the Company have not been amended since the incorporation.

The Meeting was opened by Mr Thierry SOMMA, lawyer, with professional address in Luxembourg, acting as chairman

of the Meeting.

The Chairman appointed as secretary of the Meeting Mrs Joana CARDOSO, jurist, with professional address in Lu-

xembourg.

The Meeting elected as scrutineer of the Meeting Mrs Coralie PAUWELS, lawyer, with professional address in Lu-

xembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares the following:
I. The names of the Shareholders, present or represented, and the number of shares held by each of them are indicated

in an attendance list signed by the Shareholders present or the proxies of the Shareholders represented and by the members
of the bureau of the Meeting; such attendance list and the proxies will remain attached to the original of these minutes.

II. It appears from the said attendance list that all the Shareholders, representing the entire share capital of the Company,

are present or represented at the Meeting. The Shareholders unanimously waive all convening formalities and declare that
they have been duly informed about the agenda before this Meeting.

III. The present meeting is thus duly constituted and can validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. To allocate an amount of thirty-nine thousand and twenty-nine euros (EUR 39,029.-) to the Company's legal reserve.
2. To fix a par value to the shares, so as to set it to a par value of one euro (EUR 1.-) each.

102268

L

U X E M B O U R G

3. To increase the Company's share capital by an amount of three hundred twenty thousand two hundred and fifty-five

euros (EUR 320,255.-), so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) to an amount
of three hundred and fifty-one thousand two hundred and fifty-five euros (EUR 351,255.-), by the issue of three hundred
twenty thousand two hundred and fifty-five (320,255) new shares (the "New Shares") with a par value of one euro (EUR
1.-), having the rights and privileges as set forth in the Company's articles of association and to be paid up in full.

4. To accept the subscription by KOOKMIN REIT A to one hundred and ninety-eight thousand two hundred and thirty-

eight (198,238) ordinary shares with a par value of one euro (EUR 1.-) and fully pay up such new ordinary shares as well
as a share premium amount of twelve million eight hundred and sixty-four thousand six hundred euros and eighty-nine
cents (EUR 12,864,600.089) by a contribution in cash of the same amount.

5. To accept the subscription by KOOKMIN REIT B to one hundred and twenty-two thousand seventeen (122,017)

shares with a par value of one euro (EUR 1.-) and fully pay up such shares as well as a share premium amount of seven
million nine hundred and eighteen thousand two hundred and seventy-five euros and nine hundred eleven cents (EUR
7,918,275.911) by a contribution in cash of the same amount.

6. To amend the article 5.1 of the articles of association of the Company which shall now read as follows:

Art. 5.
(1) The Company's share capital is set at three hundred and fifty-one thousand two hundred and fifty-five euros (EUR

351,255.-) consisting of three hundred and fifty-one thousand two hundred and fifty-five (351,255) shares in registered
form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up."

7. Miscellaneous.
IV. After deliberation, the Meeting then adopted, the following resolutions, each time by unanimous vote:

<i>First resolution

The Meeting resolved to allocate an amount of thirty-nine thousand and twenty-nine euros (EUR 39,029.-) out of the

contribution in cash made by shareholders to the legal reserve of the Company.

<i>Second resolution

The Meeting resolved to fix a par value to the shares, so as to set it to a par value of one euro (EUR 1.-) each.

<i>Third resolution

The Meeting resolved to increase the share capital of the Company for an amount of three hundred and twenty thousand

two hundred and fifty-five euros (EUR 320,255.-), so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand euros
(EUR 31,000.-) to an amount of three hundred and fifty-one thousand two hundred and fifty-five euros (EUR 351,255.-)
by the issue of three hundred twenty thousand two hundred and fifty-five (320,255) new shares, with a par value of one
euro (EUR 1.-), having the rights and privileges as set forth in the Company's articles.

<i>Subscription and Payment

Thereupon, now appears Mr Thierry SOMMA, prenamed, acting in her capacity as duly authorized agent and attorney

in fact of the Shareholders, by virtue of the above mentioned proxies.

1. The person appearing declared, in the name and on behalf of each of the Shareholders to subscribe in the name and

on behalf of KOOKMIN BANK AS TRUSTEE OF SAMSUNG SRA PRIVATE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NO.13A a Korean investment trust registered with the Financial Services Commission in Korea ("KOOKMIN REIT A")
to one hundred and ninety-eight thousand two hundred and thirty-eight (198,238) ordinary shares with a par value of one
euro (EUR 1.-) and fully pay up such new ordinary shares by contribution in cash, so the total amount of thirteen million
sixty two thousand eight hundred thirty eight euros and eighty-nine cents (EUR 13,062,838.089) is allocated as follows:

- ninety-eight thousand two hundred and thirty-eight euros (EUR 198,238) to the share capital, and
- twelve million eight hundred and sixty-four thousand six hundred euros and eighty-nine cents (EUR 12,864,600.089)

to the share premium account.

2. The person appearing declared, in the name and on behalf of each of the Shareholders to subscribe in the name and

on behalf of KOOKMIN BANK AS TRUSTEE OF SAMSUNG SRA PRIVATE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NO.13B Korean investment trust registered with the Financial Services Commission in Korea ("KOOKMIN REIT B") to
one hundred and twenty-two thousand seventeen (122,017) ordinary shares with a par value of one euro (EUR 1.-) and
fully pay up such shares by contribution in cash, so the total amount of eight million forty thousand two hundred ninety-
two euros and nine hundred eleven cents (EUR 8,040,292.911) is allocated as follows:

- one hundred and twenty-two thousand seventeen euros (EUR 122,017) to the share capital, and
- seven million nine hundred and eighteen thousand two hundred and seventy-five euros and nine hundred eleven cents

(EUR 7,918,275.911) to the share premium account.

The total amount of twenty one million one hundred three thousand one hundred thirty one euros (EUR 21,103,131) is

at the disposal of the Company, evidence of the payment of the mentioned contributions of cash has been given to the
notary.

102269

L

U X E M B O U R G

Thereupon the Shareholders resolved to accept the subscriptions and payments of the newly issued shares as well as

their allocation to each one of the Shareholders in accordance with the subscriptions listed above.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolved to amend the article 5.1 of the articles of association of the Company, which shall now read as

follows:

Art. 5.
(1) The Company's share capital is set at three hundred and fifty-one thousand two hundred and fifty-five euros (EUR

351,255.-) consisting of three hundred and fifty-one thousand two hundred and fifty-five (351,255) shares in registered
form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up."

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this deed are estimated at approximately EUR 6,500.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the German
text, the German text shall prevail.

This document was read to the Representative, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and

residence. This original deed was then signed by the Representative together with the notary.

Folgt die Deutsche Fassung des vorstehenden Textes

Im Jahre zweitausend fünfzehn, am siebzehnten Tag des Monats Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH mit dem Amtssitz in Redingen, (Großherzogtum Luxemburg),
eine außerordentliche Hauptversammlung (nachfolgend die „Hauptversammlung“ genannt) der Aktionäre (nachfolgend

die „Aktionäre“ genannt) der Eagle Capital Logistics No.1 S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg gemäß notarieller Urkunde von Pierre Probst, Notar in Ettelbrück, Großherzogtum
Luxemburg, vom 2. April 2015, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 9. Juni 2015 veröffent-
licht wurde, Nummer 1447, Seite 69442, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im luxemburgischen
Handelsregister unter der Nummer B 196171 (nachfolgend die „Gesellschaft“ genannt), abgehalten. Die Satzung der Ge-
sellschaft wurde seit ihrer Gründung nicht geändert.

Die Hauptversammlung wurde von Herr Thierry SOMMA, Rechtsanwalt, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, in seiner

Eigenschaft als Vorsitzender der Hauptversammlung eröffnet.

Der  Vorsitzende  hat  Frau  Joana  CARDOSO,  Juristin,  mit  Geschäftsadresse  in  Luxembourg,  zum  Schriftführer  der

Hauptversammlung ernannt.

Die Hauptversammlung hat Frau Coralie PAUWELS, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in Luxembourg, als Wahl-

prüfer der Hauptversammlung gewählt.

Nach vorgenannter Einsetzung des Verwaltungsorgans der außerordentlichen Hauptversammlung erklärt der Vorsit-

zende wie folgt:

I. Die Namen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von jedem Aktionär gehaltenen Aktien

werden in einer Anwesenheitsliste vermerkt, welche von den anwesenden Aktionären oder von den Stellvertretern der
vertretenen Aktionäre sowie von den Mitgliedern des Verwaltungsorgans der Hauptversammlung unterzeichnet wird. Diese
Anwesenheitsliste sowie die Bevollmächtigungen werden der Urschrift des vorliegenden Protokolls als Anlagen beigefügt.

II. Aus der zuvor erwähnten Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche, das gesamte Grundkapital der Gesellschaft

vertretende Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind. Die Aktionäre verzichten einstimmig auf
sämtliche Einberufungsformalitäten und erklären, im Vorfeld der Hauptversammlung ordnungsgemäß über die Tagesord-
nung in Kenntnis gesetzt worden zu sein.

III. Somit ist diese Hauptversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und hinsichtlich folgender Tagesordnung

beschlussfähig:

<i>Tagesordnung

1. Zuweisung eines Betrags in Höhe von neununddreißigtausendneunundzwanzig Euro (39.029,- EUR) zu der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage der Gesellschaft.

2. Festlegung eines Nennwerts der Aktien auf jeweils einen Euro (1,- EUR).
3.  Erhöhung  des  Grundkapitals  der  Gesellschaft  um  dreihundertzwanzigtausendzweihundertfünfundfünfzig  Euro

(320.255,- EUR) von derzeit einunddreißgtausend Euro (31.000,-EUR) auf dreihunderteinundfünfzigtausendzweihundert-
fünfundfünfzig  Euro  (351.255,-  EUR)  durch  die  Ausgabe  von  dreihundertzwanzigtausendzweihundertfünfundfünfzig
(320.255) neuen, voll einzuzahlenden Aktien (nachfolgend die „Neuen Aktien“ genannt) mit einem Nennwert von einem
Euro (1,- EUR) sowie mit den in der Satzung der Gesellschaft festgelegten Rechten und Privilegien.

102270

L

U X E M B O U R G

4. Annahme der Zeichnung durch KOOKMIN REIT A von einhundertachtundneunzigtausendzweihundertachtundd-

reißig (198.238) Stammaktien mit einem Nennwert von einem Euro (1,-EUR) und der vollständigen Einzahlung dieser
neuen Stammaktien sowie eines Agios in Höhe von zwölf Millionen achthundertvierundsechzigtausendsechshundert Euro
und neunundachtzig Cent (12.864.600,089 EUR) durch eine Bareinlage in selber Höhe.

5. Annahme der Zeichnung durch KOOKMIN REIT B von einhundertzweiundzwanzigtausendsiebzehn (122.017) Ak-

tien mit einem Nennwert von einem Euro (1,- EUR) und der vollständigen Einzahlung dieser Aktien sowie eines Agios in
Höhe  von  sieben  Millionen  neunhundertachtzehntausendzweihundertfünfundsiebzig  Euro  und  neunhundertelf  Cent
(7.918.275,911 EUR) durch eine Bareinlage in selber Höhe.

6. Änderung des Artikels 5.1 der Satzung der Gesellschaft auf folgenden Wortlaut:

„ Art. 5.
(1)  Das  Grundkapital  der  Gesellschaft  wird  auf  dreihunderteinundfünfzigtausendzweihundertfünfundfünfzig  Euro

(351.255,- EUR) festgelegt und setzt sich aus dreihunderteinundfünfzigtausendzweihundertfünfundfünfzig (351.255) ge-
zeichneten und voll eingezahlten Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1,- EUR) zusammen.“

7. Sonstiges.
IV. Nach Beratung wurden durch die Hauptversammlung jeweils einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung hat beschlossen, einen Betrag in Höhe von neununddreißigtausendneunundzwanzig Euro (EUR

39.029,-) aus den Bareinlagen der Aktionäre der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage der Gesellschaft zuzuweisen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung hat beschlossen, einen Nennwert der Aktien auf jeweils einen Euro (1,- EUR) festzulegen.

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um dreihundertzwanzigtausendzweihun-

dertfünfundfünfzig Euro (320.255,- EUR) von derzeit einunddreißgtausend Euro (31.000,- EUR) auf dreihunderteinund-
fünfzigtausendzweihundertfünfundfünfzig Euro (351.255,-EUR) durch die Ausgabe von dreihundertzwanzigtausendzwei-
hundertsechsundfünfzig (320.256) neuen Aktien mit einem Nennwert von einem Euro (1,- EUR) sowie mit den in der
Satzung der Gesellschaft festgelegten Rechten und Privilegien zu erhöhen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Daraufhin erscheint Herr Thierry SOMMA, vorbenannt, durch die vorgenannten Bevollmächtigungen in seiner/ ihrer

Eigenschaft als ordnungsgemäßer Bevollmächtigter und Stellvertreter der Aktionäre.

1. Die erschienene Person erklärte im Namen und im Auftrag jeder der Aktionäre, im Namen und im Auftrag von

KOOKMIN BANK ALS TREUHÄNDER VON SAMSUNG SRA PRIVATE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NO.13A  ein  Koreanischer  Investment  Trust  registriert  bei  der  Financial  Services  Commission  in  Korea  (nachfolgend
„KOOKMIN REIT A“ genannt) einhundertachtundneunzigtausendzweihundertachtunddreißig (198.238) Stammaktien mit
einem Nennwert von einem Euro (1,- EUR) zu zeichnen und diese neuen Stammaktien durch eine Bareinlage einzuzahlen,
so dass der Gesamtbetrag von dreizehn Millionen zweiundsechzigtausendachthundertachtunddreißig Euro neunundachtzig
Cent (13.062.838,089) folgendes verteilt wird:

- als Kapitaleinteil in Höhe von einhundertachtundneunzigtausendzweihundertachtunddreißig Euro (198.238 EUR), und
- als Agio in Höhe von zwölf Millionen achthundertvierundsechzigtausendsechshundert Euro neunundachtzig Cent

(12,864,600.089 EUR).

Die erschienene Person erklärte im Namen und im Auftrag jeder der Aktionäre, im Namen und im Auftrag von KOOK-

MIN BANK ALS TREUHÄNDER VON SAMSUNG SRA PRIVATE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NO.13B
ein Koreanischer Investment Trust registriert bei der Financial Services Commission in Korea (nachfolgend „KOOKMIN
REIT B“ genannt) einhundertzweiundzwanzigtausendsiebzehn (122.017) Stammaktien mit einem Nennwert von einem
Euro (1,- EUR) zu zeichnen und diese Aktien durch eine Bareinlage einzuzahlen, so dass der Gesamtbetrag von acht
Millionen vierzigtausendzweihundertzweiundneunzig Euro neunhundertelf Cent (8.040.292,911 EUR) folgendes verteilt
wird:

- als Kapitaleinteil in Höhe von einhundertzweiundzwanzigtausendsiebzehn Euro (122.017,- EUR), und
- als Agio in Höhe von sieben Millionen neunhundertachtzehntausendzweihundertfünfundsiebzig Euro neunhundertelf

Cent (7.918.275,911 EUR).

Die Gesamtbetrag von einundzwanzig Millionen einhundertunddreitausendeinhunderteinunddreißig Euro (21.103.131,-

EUR) ist zu Verfügung der Gesellschaft, der Notarin wurden die Belege für die Einzahlung der vorgenannten Bareinlagen
vorgelegt.

Daraufhin haben die Aktionäre beschlossen, die Zeichnungen und Einzahlungen der neu ausgegebenen Aktien sowie

ihre Zuweisung zu jedem der Aktionäre in Übereinstimmung mit den oben aufgeführten Zeichnungen anzunehmen.

102271

L

U X E M B O U R G

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung hat beschlossen, Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft auf folgenden Wortlaut zu ändern:

„ Art. 5.
(1)  Das  Grundkapital  der  Gesellschaft  wird  auf  dreihunderteinundfünfzigtausendzweihundertfünfundfünfzig  Euro

(351.255,-EUR) festgelegt und setzt sich aus dreihunderteinundfünfzigtausendzweihundertfünfundfünfzig (351.255) ge-
zeichneten und voll eingezahlten Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1,- EUR) zusammen.“

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR

6.500- abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der

oben genannten erschienenen Personen, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung,
gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen
Textes, wird der English Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen

Parteien in Luxemburg vorgelesen wurde, haben dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.

Signé: T. SOMMA, J. CARDOSO, C. PAUWELS, D. KOLBACH
Enregistré à Diekirch A.C., le 22 juin 2015. Relation: DAC/2015/10539. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Carlo RODENBOUR.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 29 juin 2015.

Référence de publication: 2015102154/220.
(150112292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

Consulting Gestion et Assistance, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 197.954.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le dix juin.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Pierre GOLDZAHL, dirigeant d’entreprise, né le 23 novembre 1960 à Marseille (France), demeurant à L-1327

Luxembourg 2, rue Charles VI,

représenté aux présentes par Monsieur Claude FAVRE, administrateur de sociétés, résidant professionnellement à Lu-

xembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé en date à Luxembourg du 21 mai 2015.

Ladite procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné demeurera annexée aux

présentes pour être soumises avec elles à l’enregistrement.

Lequel comparant, tel que représenté, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité

limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet:
- la prestation de services en matière de direction, de gestion, d'administration, de conseil, d'animation au profit de toutes

sociétés, entreprises ou groupes de sociétés ou groupements d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers;

- le conseil et l’assistance en matière d’ingénierie immobilière, de conception et de conduite de projets de promotion et

d’exploitation d’ensembles immobiliers de toute nature;

- la réalisation de toute opération financière en rapport avec les prestations ci-dessus
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement
à cet objet social et ce, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

102272

L

U X E M B O U R G

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société est constituée sous le nom de «Consulting Gestion et Assistance».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société
peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres
pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à

des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés
que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement

révocables à tout moment et sans cause.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature unique du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants

ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil de gérance.

Art. 12. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir

parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les

associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la
présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de
chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation  spéciale  ne  sera  pas  requise  pour  une  réunion  du  conseil  de  gérance  se  tenant  à  une  heure  et  un  endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier

électronique ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou d'autres

moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les
autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

102273

L

U X E M B O U R G

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,

par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associées

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Art. 18. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés

par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 19. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre

de la même année.

Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un

inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication
au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le conseil
de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont dispo-
nibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

L'intégralité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales est souscrite par Monsieur Pierre GOLDZAHL préqua-

lifié.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de décembre

2015.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000.-).

<i>Résolutions

Et aussitôt Monsieur Pierre GOLDZAHL préqualifié, tel que représenté, représentant l'intégralité du capital social a pris

les résolutions suivantes:

102274

L

U X E M B O U R G

1. Le siège social de la Société est établi à L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.
2. Est nommé en tant que gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Pierre GOLDZAHL, dirigeant d’entreprise, né le 23 novembre 1960 à Marseille (France), demeurant à L-1327

Luxembourg 2, rue Charles VI,

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. FAVRE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 12 juin 2015. 1LAC/2015/18310. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 29 juin 2015.

Référence de publication: 2015102078/146.
(150112256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

Doric Capital SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 197.951.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth of June.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Stichting DAFL (the Shareholder), established under the laws of the Netherlands, with registered office at Barbara

Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam, The Netherlands, duly represented by Mr. Christoph Junk, employee, with profes-
sional address at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, by virtue of a proxy under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its capacity as representative of the Shareholder, has requested the officiating notary to

enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which it declares to establish as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Doric

Capital SA" (the Company) qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the Lu-
xembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended (the Securitisation Act 2004).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be dis-

solved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder or, as the case
may be, of any of the shareholders.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Munsbach, municipality of Schuttrange,

Grand Duchy of Luxembourg (Luxembourg). It may be transferred within the boundaries of the municipality of Schuttrange
by a resolution of the board of directors of the Company (the Board).

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are im-

minent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the

manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 22 below.

Art. 4. Corporate objects. The corporate objects of the Company are to enter into, perform and serve as a vehicle for,

any securitisation transactions as permitted under the Securitisation Act 2004.

The Company may acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks relating to the holding or

ownership of claims, receivables and/or other goods, either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks
relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent to all or part of the activities undertaken by third
parties, by issuing securities (valeurs mobilières) of any kind whose value or return is linked to these risks. The Company
may assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, structured deposits, receivables and/or other goods,
structured products relating to commodities or assets, by guaranteeing the liabilities or commitments of third parties or by

102275

L

U X E M B O U R G

binding itself in any other way. The method that will be used to determine the value of the securitised assets will be set out
in the relevant issue documents entered into by the Company.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004, proceed, so far as they relate to securitisation

transactions, to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of
participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by pur-
chase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds,
debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by
Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings and exchangeable or convertible securities), structured pro-
ducts relating to commodities or assets (including debt or equity securities of any kind), receivables, claims or loans or
other credit facilities (and the agreements relating thereto) as well as all other types of assets, and (iii) the ownership,
administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred
to in (i) and (ii) above) in accordance with the provisions of the relevant issue documentation.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004 and for as long as it is necessary to facilitate the

performance of its corporate objects, borrow in any form and enter into any type of loan agreement. It may issue notes,
bonds (including exchangeable or convertible securities and securities linked to an index or a basket of indices or shares),
debentures, certificates, shares, beneficiary shares or parts, warrants and any kind of debt or equity securities, including
under one or more issue programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or
issues of securities, within the limits of the Securitisation Act 2004 and provided such lending or such borrowing relates
to securitisation transactions, to its subsidiaries or affiliated companies or to any other company.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004, give guarantees and grant security over its assets

in order to secure the obligations it has assumed for the securitisation of those assets or for the benefit of investors (including
their trustee or representative, if any) and/or any issuing entity participating in a securitisation transaction of the Company.
The Company may not pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets or transfer its
assets for guarantee purposes, unless permitted by the Securitisation Act 2004.

The  Company  may  enter  into,  execute  and  deliver  and  perform  any  swaps,  futures,  forwards,  derivatives,  options,

repurchase, stock lending and similar transactions for as long as such agreements and transactions are necessary to facilitate
the performance of the Company's corporate objects. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instru-
ments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004 and in accordance with the provisions of the relevant

issue documentation of the securities, assign or arrange for the assignment of the underlying assets and risks which guarantee
the rights of the relevant investors.

The Board is entitled to create one or more compartments (referencing the assets of the Company relating to an issue

by the Company of securities), in each case, corresponding to a separate part of the Company's estate. The Company may
appoint one or more fiduciary representatives as described in articles 67 to 84 of the Securitisation Act 2004.

The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate

objects of the Company shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided that it
is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction

which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects to the largest extent
permitted under the Securitisation Act 2004.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000 (thirty one thousand euros) consisting of 310

(three hundred and ten) ordinary shares in registered form with a par value of EUR 100 (one hundred euros) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 22 below.

Art. 6. Shares. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be

available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or
elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on each such share, and the transfer of shares and
the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee
or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims
provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The  Company  may  also  accept  as  evidence  of  transfer  other  instruments  of  transfer  evidencing  the  consent  of  the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

102276

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Debt securities. Debt securities issued by the Company in registered form (obligations nominatives) may, under

no circumstances, be converted into debt securities in bearer form (obligations au porteur).

Art. 9. Meetings of the shareholders of the Company. In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes

all powers conferred on the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting
shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one
shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the

General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the

registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in
the convening notice of the meeting, on the third Thursday in April of each year at 11.30 a.m. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional cir-

cumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Art. 10. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices. The notice periods and quorum provided for by law

shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed

by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing. Copies of written

proxies may be transmitted either in original, by telefax, cable, telegram, telex or by e-mail.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being

duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletins) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (i) the name (including the first name), address and the signature of the
relevant shareholder, (ii) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as
set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda.
The original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

Art. 11. Management. The Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need

not be shareholders of the Company. The members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and
shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a member of the Board (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as member of the Board in accor-
dance  with  article  51bis  of  the  Luxembourg  act  dated  10  August  1915  on  commercial  companies,  as  amended  (the
Companies Act 1915).

The directors shall be elected by the General Meeting. The shareholder(s) of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/
or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may

elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting.

Art. 12. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose

a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman
will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other
members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant
meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting

which shall be in Luxembourg.

102277

L

U X E M B O U R G

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if

they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing. Such written consent of each member of the Board may be transmitted either in
original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail. Separate written notice shall not be required for meetings that are held
at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing another director as his or her

proxy. Such appointment may be transmitted in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail.

One member of the Board may represent one prevented member at a meeting of the Board and there must always be at

least two members who are either present in person or who assist at such meeting by way of conference call, video conference
or any means of communication that complies with the requirements set forth in the next following paragraph, participate
in a meeting of the Board.

Any director may participate in a meeting of the Board, and will be considered as having been personally present at

such meeting, by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors
attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii)
the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented

at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such
meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist

of one or more documents containing the resolutions, signed by each director manually. The date of such resolution shall
be the date of the last signature.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman

or a member of the Board who presided at such meeting and shall be held at the Company’s registered office.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman or any two members of the Board.

Art. 14. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts

of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of the assets
of the Company in accordance with the Securitisation Act 2004 and the relevant issue documentation. All powers not
expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the
Board.

Art. 15. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder

or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for

any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative will act
with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member
of the board of directors of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions

at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures.  The  Company  shall  be  bound  towards  third  parties  in  all  matters  (including  the  daily

management) by (i) the joint signatures of any two members of the Board, or (ii) the joint signatures of any persons or sole
signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such
power.

Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which

the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other
company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or
other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote

102278

L

U X E M B O U R G

upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following
annual General Meeting.

The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course

of business of the Company and which are entered into on arm's length terms.

Art. 18. Statutory Auditor(s). The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors

(réviseurs d'entreprises agréés). The statutory auditor(s) shall be appointed by the Board in accordance with the Securiti-
sation Act 2004. The Board will determine their number, their remuneration and the term of their office.

Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall terminate on 31

December of each year.

Art. 20. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may, in its

sole discretion, decide to pay dividends from time to time, as it believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and

times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within
the limits laid down in the Companies Act 1915.

Art. 21. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted  in  the  manner  required  for  amendment  of  these  Articles,  as  prescribed  in  article  22  below.  In  the  event  of  a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 22. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject

to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

Art. 23. Segregation of assets. If as of any payment date of the assets relating to a compartment (including a hedging

agreement entered into by the Company in connection with a compartment) the total amount of monies received under the
assets of that compartment exceeds the payments to be made by the Company under the same compartment, the Board may
use the excess amount to pay off the claims of those creditors of the Company whose claims cannot be allocated to a
particular compartment.

The assets allocated to a compartment are exclusively available to (1) the investors in that compartment (the Investors),

(2) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment
and who are provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the Transaction
Creditors), (3) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that
compartment and who are not provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the
Compartment-Specific Claims Creditors and, together with the Transaction Creditors, the Creditors) and (4), subject to the
provisions of the next following paragraph, the creditors whose claims have not arisen in connection with the creation,
operation or liquidation of a compartment and who have not waived their recourse to the assets of any compartment of the
Company (the Non Compartment-Specific Claims Creditors).

The rights of the Non Compartment-Specific Claims Creditors shall be allocated by the Company, on a half year basis

in arrears, to all the compartments, on an equal basis and pro rata temporis for compartments created within such half year,
where the relevant issue documentation expressly authorises Non Compartment-Specific Claims Creditors to have recourse
against the assets allocated to such compartments. Such right of a Non Compartment-Specific Claims Creditor against a
compartment are hereinafter referred to as the Pro Rata Rights.

The Investors and the Creditors acknowledge and accept that once all the assets allocated to the compartment under

which they have invested or in respect of which their claims have arisen, have been realised, they are not entitled to take
any further steps against the Company to recover any further sums due and the right to receive any such sum shall be
extinguished. Each Non Compartment-Specific Claims Creditor acknowledges and accepts that once all the assets allocated
to a compartment in respect of which it has Pro Rata Rights, have been realised, it is not entitled to take any further steps
against the Company to recover such Pro Rata Rights and the right to receive any sum in respect of the Pro Rata Rights
shall be extinguished.

The Compartment-Specific Claims Creditors and the Non Compartment-Specific Claims Creditors expressly accept,

and shall be deemed to have accepted by entering into contractual obligations with the Company, that priority of payment
and waterfall provisions will be included in the relevant issue documentations and they expressly accept, and shall be
deemed to have accepted the consequences of such priority of payments and waterfall provisions.

The rights of the shareholders of the Company are limited to the assets of the Company which are not allocated to a

compartment.

102279

L

U X E M B O U R G

Art. 24. Prohibition to petition for bankruptcy of the Company or to seize the assets of the Company. In accordance

with article 64 of the Securitisation Act 2004, any Investor in, and any Creditor and shareholder of, the Company and any
person which has entered into a contractual relationship with the Company (the Contracting Party) agrees, unless expressly
otherwise agreed upon in writing between the Company and the Investor, the Creditor or the Contracting Party, not to (1)
petition for bankruptcy of the Company or request the opening of any other collective or reorganisation proceedings against
the  Company  or  (2)  seize  any  assets  of  the  Company,  irrespective  of  whether  the  assets  in  question  belong  to  (i)  the
compartment in respect of which the Investor has invested or in respect of which the Creditor or the Contracting Party have
contractual rights against the Company, (ii) any other compartment or (iii) the assets of the Company which have not been
allocated to a compartment (if any).

Art. 25. Subordination. Any claims which the shareholders of the Company may have against the Company (in such

capacity) are subordinated to the claims which any creditors of the Company (including the Creditors) or any investors in
the Company (including the Investors) may have.

The Investors accept and acknowledge that their rights under a compartment may be subordinated to the rights of other

Investors under, and/or Creditors of, the same compartment.

Art. 26. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act 1915 and the Securitisation Act 2004.

<i>Transitory provisions

The first business year begins today and ends on 31 December 2015.
The first annual General Meeting will be held in 2016.

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to 310

(three hundred and ten) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been paid up by the Shareholder to an extent of 100% (one hundred per cent.) by payment in cash,

so that the sum of EUR 31,000 (thirty one thousand euros) paid by the Shareholder is from now on at the free disposal of
the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by articles 26, 26-3 and 26-5 of the Companies

Act 1915 have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms
that these Articles comply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 3,000.-.

<i>Resolutions of the shareholder

The above named party, representing the whole of the subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. the number of directors is set at three (3) directors;
2. the following persons are appointed as directors:
Mr Marc Kriegsmann, with professional address at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
Mr Horst Baumann, with professional address at 9, place de Clairefontaine, L-1341 Luxembourg; and
Mr Peter Erich Hein, with professional address at 191, Post Road West, USA -CT 06880 Westport, United States of

America;

3. that the terms of office of the members of the Board will expire after the annual General Meeting of the year 2021;

and

4. that the address of the registered office of the Company is at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between English and the German versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and

residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am achtzehnten Juni.
Vor dem Unterzeichneten, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

102280

L

U X E M B O U R G

Stichting  DAFL  (der  Gesellschafter),  eine  Stiftung  niederländischen  Rechtes,  mit  Sitz  in  Barbara  Strozzilaan  101,

1083HN Amsterdam, die Niederlande, ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Christoph Junk, Privatangestellter, beruflich
ansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Die genannte Vollmach bleibt nach ihrer Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Person und den unterzeich-

neten  Notar  zum  Zweck  der  gleichzeitigen  Vorlage  bei  den  Registrierungsbehörden  mit  dieser  notariellen  Urkunde
verbunden.

Die erschienene Partei, als Vertreter des Gesellschafter handelnd, hat den Notar beauftragt, die folgende Gesellschafts-

satzung (die Satzung) eines Unternehmens aufzunehmen, das sie wie folgt zu gründen wünscht:

Art. 1. Rechtsform und Bezeichnung. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Namen "Doric

Capital SA" (das Unternehmen), eine Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) im Sinne des Luxemburger Ver-
briefungsgesetzes vom 22. März 2004 in der jeweils gültigen Fassung (das Verbriefungsgesetz 2004).

Das Unternehmen kann einen (der Alleingesellschafter) oder mehrere Gesellschafter haben. Der Tod, die Aberkennung

der bürgerlichen Ehrenrechte, die Insolvenz, Abwicklung oder der Konkurs des Alleingesellschafters oder gegebenenfalls
eines der Gesellschafter führt nicht zur Auflösung des Unternehmens.

Art. 2. Eingetragener Firmensitz. Der eingetragene Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Munsbach, in der

Gemeinde Schuttrange, im Großherzogtum Luxemburg (Luxemburg). Der Sitz kann innerhalb des Bezirks der Gemeinde
Schuttrange durch einen Beschluss des Verwaltungsrats des Unternehmens (der Verwaltungsrat) verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außerordentliche politische oder militärische Ereignisse aufgetreten sind oder

unmittelbar bevorstehen, die den normalen Geschäftsbetrieb des Unternehmens an seinem Firmensitz oder die Reibungs-
losigkeit der Kommunikation zwischen diesem Firmensitz und Personen im Ausland beeinträchtigen würden, kann der
Geschäftssitz zeitweise ins Ausland verlegt werden, bis diese außergewöhnlichen Umstände vollständig beendet sind.
Derartige vorläufige Maßnahmen wirken sich nicht auf die Nationalität des Unternehmens aus, das trotz zeitweiser Ver-
legung des Firmensitzes, eine in Luxemburg eingetragene Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Dauer. Das Unternehmen wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Das Unternehmen kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung (wie unten dargelegt) aufgelöst werden,

der gemäß den für Satzungsänderungen geltenden Erfordernissen, wie in Artikel 22 unten dargelegt, gefasst wurde.

Art. 4. Unternehmenszweck. Der Zweck des Unternehmens liegt darin Verbriefungstransaktionen im Rahmen des Ver-

briefungsgesetzes 2004 einzugehen, durchzuführen und als Vehikel für Verbriefungstransaktionen zu dienen.

Das Unternehmen kann die mit der Beteiligung oder Ansprüchen, Forderungen und/oder anderen Waren, ob beweglich

oder unbeweglich, materiell oder immateriell, in Verbindung stehenden Risiken, und/oder Risiken, die sich auf Verbind-
lichkeiten oder Verpflichtungen Dritter beziehen, oder Risiken, mit denen Aktivitäten Dritter ganz oder teilweise behaftet
sind, direkt oder über eine andere Körperschaft oder ein anderes Vehikel durch die Ausgabe von Wertpapieren (valeurs
mobilières) jeglicher Art, deren Wert oder Rendite mit diesen Risiken verbunden ist, erwerben oder übernehmen. Das
Unternehmen kann diese Risiken durch den Erwerb von Ansprüchen, strukturierten Einlagen, Forderungen und/oder an-
deren Waren, strukturierte Produkte in Bezug auf Verbrauchsgüter oder Vermögenswerte auf jegliche Weise übernehmen
oder erwerben, indem sie die Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen Dritter verbürgt oder sich auf andere Weise bindend
verpflichtet. Das zur Bestimmung des Werts von verbrieften Vermögenswerten eingesetzte Verfahren wird in den ent-
sprechenden Emissionspapieren des Unternehmens dargelegt.

Im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004 kann das Unternehmen, insofern es sich um Verbriefungstransaktionen

handelt, Anteile, Rechte, Beteiligungen an und Verpflichtungen gegenüber luxemburgischen und ausländischen Unter-
nehmen (i) in jeglicher Form, auf jeglichem Wege, ob direkt oder indirekt, erwerben, verwalten und veräußern, (ii) Aktien,
Anleihen,  Obligationen,  Schuldscheine  und  andere  Wertpapiere  oder  Finanzinstrument  jeglicher  Art  (einschließlich
Schuldscheinen oder Teilen oder Einheiten, die in Luxemburg ausgegeben werden, oder ausländische Investmentfonds,
oder ähnliche Unternehmungen und umtauschbare oder wandelbaren Wertpapiere), strukturierte Produkte, die sich auf
Waren oder Vermögenswerte beziehen (einschließlich Schuld- und Dividendenpapiere jeglicher Art), Forderungen, An-
sprüche oder Darlehens- oder Kreditfazilitäten (und die damit in Zusammenhang stehenden Vereinbarungen), sowie alle
anderen Arten von Vermögenswerten käuflich erwerben, zeichnen oder auf jeglichem anderen Wege erwerben, sowie durch
Verkauf, Austausch oder auf jede andere Art übertragen, und (iii) Anlagenbestände (unter anderem einschließlich der in
(i) und (ii) beschriebenen Vermögenswerte) gemäß der in den entsprechenden Emissionsunterlagen enthaltenen Bestim-
mungen besitzen, entwickeln und verwalten.

Das Unternehmen kann im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004, und solange es für die Erfüllung seiner Unterneh-

menszwecke erforderlich ist, Kredite in jeglicher Form aufnehmen und jegliche Art von Darlehensvereinbarung eingehen.
Es kann Schuldscheine, Anleihen (einschließlich umtauschbarerer oder wandelbarer Wertpapiere und an einen Börsenindex
oder einen Indexkorb oder Aktien gebundene Wertpapiere), Obligationen, Zertifikate, Aktien, Gewinnanteilscheine (parts
bénéficiaires) oder Anteilen, Bürgschaften und jegliche Art von Schuld- oder Dividendenpapieren, einschließlich derer aus
einem oder mehreren Emissionsprogrammen. Das Unternehmen kann im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004, und
unter der Voraussetzung, dass sich diese Kreditgewährung oder Kreditverbindlichkeiten auf Verbriefungstransaktionen

102281

L

U X E M B O U R G

beziehen, Finanzmittel, einschließlich der Erträge aus Kreditverbindlichkeiten und/oder der Emission von Wertpapieren,
an seine Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen oder jegliches andere Unternehmen verleihen.

Das  Unternehmen  kann  im  Rahmen  des  Verbriefungsgesetzes  2004  Garantien  und  Sicherheiten  hinsichtlich  seiner

Vermögenswerte gewähren, um die von ihr für die Sicherung dieser Vermögenswerte oder zu Gunsten der Anleger (ein-
schließlich deren Treuhänder oder Vertreter, falls zutreffend) und/oder jeglicher emittierenden Körperschaft, die an einer
Verbriefungstransaktion des Unternehmens beteiligt ist, eingegangenen Verpflichtungen abzusichern. Das Unternehmen
darf keine Sicherheiten durch Verpfändung, Übertragung, Belastung oder sonstiges im Hinblick auf Teile oder die Ge-
samtheit seiner Vermögenswerte schaffen oder seine Vermögenswerte zu Garantiezwecken übertragen, es sei denn, dies
ist im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004 zulässig.

Das Unternehmen kann jegliche Swap-Geschäfte, Termingeschäfte, Terminkontrakte, Derivate, Optionen, Rückkäufe,

Effektenkredite  und  ähnliche  Rechtsgeschäfte  tätigen,  ausführen  und  andienen,  solange  solche  Vereinbarungen  und
Rechtsgeschäfte für die Erfüllung der Unternehmenszwecke erforderlich sind. Im Allgemeinen kann das Unternehmen
zum Zweck der effizienten Verwaltung jegliche Technik und jegliches Instrument in Bezug auf die Investitionen anwenden,
unter anderem Techniken und Instrumente, deren Beschaffenheit vor Kredit-, Wechselkurs-, Zinssatz- und andere Risiken
schützt.

Das Unternehmen kann im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004, und gemäß der in den entsprechenden Emissions-

unterlagen  enthaltenen  Bestimmungen,  die  zugrunde  liegenden  Vermögenswerte  und  Risiken,  die  die  Rechte  der  ent-
sprechenden Anleger verbürgen, abtreten oder deren Abtretung veranlassen.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, ein oder mehrere Teilvermögen (unter Bezugnahme auf die Vermögenswerte des

Unternehmens, die sich auf eine Wertpapieremission des Unternehmens beziehen) zu bilden, die in jedem Fall einem
gesonderten Teil des Vermögens des Unternehmens entsprechen. Das Unternehmen kann einen oder mehrere treuhänder-
ische Vertreter, wie in den Artikeln 67 bis 84 des Verbriefungsgesetzes 2004 beschrieben, bestellen.

Die obenstehenden Beschreibungen sind in ihrem weitesten Sinne zu verstehen und deren Auflistung ist nicht ein-

schränkend. Die Geschäftszwecke des Unternehmens beinhalten jegliche von dem Unternehmen eingegangenen Rechts-
geschäfte oder Vereinbarungen, vorausgesetzt, dass sie den vorstehend benannten Gegenständen nicht widersprechen.

Im Allgemeinen kann das Unternehmen jegliche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jegliche Ge-

schäfte oder Transaktionen durchführen, die sie für das Erreichen und die Entwicklung ihres Unternehmensgegenstands,
im weitesten Sinne des im Rahmen des Verbriefungsgesetzes 2004 Zulässigen, für erforderlich oder nützlich erachtet.

Art. 5. Aktienkapital. Das gezeichnete Aktienkapital wird auf EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro), bestehend aus

310 (dreihundertzehn) eingetragenen Stammaktien zu einem Nennwert von jeweils EUR 100 (hundert Euro), festgelegt.

Das  gezeichnete  Aktienkapital  des  Unternehmens  kann  durch  einen  Beschluss  der  Gesellschafterversammlung,  der

gemäß den für Satzungsänderungen geltenden Erfordernissen, wie in Artikel 22 unten dargelegt, gefasst wurde, erhöht oder
gesenkt werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien sind und bleiben Namensaktien (actions nominatives).
Am eingetragenen Sitz des Unternehmens wird ein Aktienbuch des Unternehmens geführt, wo es den Gesellschaftern

zur Einsicht zur Verfügung steht. Das Aktienbuch enthält den Namen jedes Gesellschafters, dessen Anschrift oder gewählter
Wohnsitz, die Anzahl der in seinem Besitz befindlichen Aktien, die auf jede dieser Aktien eingezahlten Beträge, sowie die
Übertragung von Aktien und das Übertragungsdatum. Das Eigentum an den Aktien wird durch die Eintragung in das
Aktienbuch begründet.

Das Unternehmen kann seine eigenen Aktien im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften einziehen.

Art. 7. Übertragung von Aktien. Aktien können durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung erfolgen, die in das

Aktienbuch des Unternehmens eingetragen wird; Übertragungserklärungen müssen von dem Übertragenden und dem Er-
werber oder von Personen, die ausreichend bevollmächtigt sind, oder nach Maßgabe der für die Abtretung von Ansprüchen
geltenden Bestimmungen gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuchs unterzeichnet werden.

Zudem kann das Unternehmen, als Nachweis für die Übertragung, andere Abtretungsinstrumente akzeptieren, die das

Einverständnis des Übertragenden und des Erwerbers zur Zufriedenstellung des Unternehmens belegen.

Art. 8. Schuldverschreibungen. Die von dem Unternehmen in registrierter Form emittierten Schuldverschreibungen

(obligations nominatives) dürfen unter keinen Umständen in Inhaberschuldverschreibungen (obligations au porteur) um-
gewandelt werden.

Art. 9. Gesellschafterversammlungen des Unternehmens. Im Fall eines alleinigen Gesellschafters übernimmt der allei-

nige Gesellschafter sämtliche auf Grundlage der Hauptversammlung übertragenen Befugnisse. In diesen Satzungsartikeln
gelten die von der Hauptversammlung beschlossenen Entscheidungen oder vor ihr ausgeübte Befugnisse solange, wie das
Unternehmen nur einen Gesellschafter hat, als Bezugnahme auf von dem alleinigen Gesellschafter getroffene Entschei-
dungen oder von ihm ausgeübte Befugnisse. Die von dem alleinigen Gesellschafter gefassten Entscheidungen sind zu
protokollieren.

Im Fall mehrerer Gesellschafter repräsentiert jede regelmäßig einberufene Versammlung der Gesellschafter des Unter-

nehmens  (die  Hauptversammlung)  die  Gesamtheit  der  Gesellschafter  des  Unternehmens.  Sie  verfügt  über  die  weites-

102282

L

U X E M B O U R G

treichenden Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Ratifizierung von Handlungen, die mit den Tätigkeiten des
Unternehmens in Verbindung stehen.

Die Jahreshauptversammlungen finden nach luxemburgischem Recht, in Luxemburg, an dem eingetragenen Sitz des

Unternehmens oder an einem anderen Ort innerhalb des Bezirks des eingetragenen Firmensitzes statt, der in der Mitteilung
über die Einberufung der Versammlung am dritten Donnerstag im April eines jeden Jahres für 11:30 Uhr genannt ist. Falls
der Termin nicht auf einen Geschäftstag der Banken in Luxemburg fällt, findet die Hauptversammlung an dem nächsten
Geschäftstag statt.

Die Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, wenn der Verwaltungsrat der absoluten und endgültigen Auffas-

sung ist, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die dies erforderlich machen.

Sonstige Versammlungen der Gesellschafter des Unternehmens können an dem Ort und zu der Zeit stattfinden, die in

den entsprechenden Mitteilungen zur Einberufung der Versammlungen angegeben werden.

Alle Gesellschafter können durch Konferenzschaltung, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmedien an den

Hauptversammlungen teilnehmen, wobei (i) die Identifizierung der an Versammlung teilnehmenden Gesellschafter gege-
ben ist, (ii) alle an der Versammlung teilnehmenden Personen sich gegenseitig hören und miteinander sprechen können,
(iii) die Übertragung der Versammlung auf kontinuierlicher Basis erfolgt und (iv) die Gesellschafter sich ordentlich beraten
und so mit allen Mitteln an der Versammlung teilnehmen können, als seien sie persönlich bei einer solchen Versammlung
anwesend.

Art. 10. Mitteilung, Beschlussfähigkeit, Vertretungsvollmachten und Einberufungsmitteilungen. Die gesetzlichen Ein-

berufungsfristen und die gesetzlich festgelegte Beschlussfähigkeit finden auf die Einberufung und die Durchführung der
Hauptversammlungen Anwendung, wenn in dieser Satzung nichts Gegenteiliges festgelegt ist.

Auf jede Aktie entfällt ein Stimmrecht.
Mit Ausnahme anderslautender gesetzlicher Bestimmungen oder der in dieser Satzung festgelegten Bestimmungen,

werden Beschlüsse der ordentlich einberufenen Hauptversammlung auf Grundlage einer einfachen Mehrheit der anwe-
senden oder vertretenen Personen, die von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, angenommen.

Gesellschafter können bei allen Hauptversammlungen durch eine andere, in Schriftform als ihren Vertreter ernannte

Person handeln. Das Schriftstück kann im Original, als Telefax, Depesche, Telegramm, Telex oder Email vorgelegt werden
kann.

Wenn alle Gesellschafter des Unternehmens bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind, sich als ord-

nungsgemäß einberufen betrachten und über die Tagesordnung der Versammlung informiert sind, kann die Versammlung
ohne vorherige Mitteilung einberufen werden.

Die Gesellschafter können schriftlich über Beschlüsse, die der Hauptversammlung vorgelegt werden, abstimmen (mittels

Stimmzetteln), vorausgesetzt, dass die in Schriftform verfassten Stimmzettel (i) den Namen (einschließlich des Vornamens,
die Adresse und die Unterschrift des jeweiligen Gesellschafters, (ii) die Angabe der Aktien hinsichtlich derer der Gesell-
schafter dieses Recht ausüben wird, (iii) die Tagesordnung laut Einberufungsmitteilung und (iv) die Informationen zur
Stimmabgabe  (Genehmigung,  Ablehnung,  Enthaltung)  für  jedem  Tagesordnungspunkt  beinhalten.  Die  Originale  der
Stimmzettel müssen 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor der betreffenden Hauptversammlung bei dem Unternehmen einge-
hen.

Art. 11. Geschäftsführung.  Das  Unternehmen  wird  von  einem  Verwaltungsrat  geführt,  der  aus  mindestens  drei  (3)

Direktoren bestehen muss, die nicht Gesellschafter des Unternehmens sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats
können für maximal für einen Zeitraum von sechs Jahren gewählt werden, und sie können wiedergewählt werden.

Wenn eine Rechtspersönlichkeit zum Mitglied des Verwaltungsrats (die Körperschaft) ernannt wird, dann muss die

Körperschaft einen ständigen Vertreter (représentant permanent) ernennen, der die Körperschaft als Verwaltungsratsmit-
glied  nach  Maßgabe  der  in  Artikel  51bis  des  luxemburgischen  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  kommerzielle
Gesellschaften, in der jeweils gültigen Fassung (das Unternehmensgesetz 1915) vertritt.

Die Verwaltungsräte werden durch die Hauptversammlung gewählt. Der Gesellschafter/ Die Gesellschafter des Unter-

nehmens bestimmen auch die Anzahl der Verwaltungsräte, deren Vergütung und Amtszeit. Verwaltungsräte können mit
oder ohne Angabe eines Grunds jederzeit durch einen von der Hauptversammlung angenommenen Beschluss abgesetzt
und/oder ersetzt werden.

Sollte die Position eines Verwaltungsrats wegen Ableben, Ausscheiden oder aus einem anderen Grund frei werden,

können  die  übrigen  Verwaltungsräte  durch  Mehrheitsbeschluss  einen  Verwaltungsrat  wählen,  der  die  Position  bis  zur
nächsten Hauptversammlung füllt.

Art. 12. Versammlungen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ernennt aus der Reihe seiner Mitglieder einen Vor-

sitzenden (der Vorsitzende) und er kann einen Schriftführer auswählen, bei dem es sich nicht um einen Verwaltungsrat
handeln muss, der für das Führen der Protokolle über die Versammlungen des Verwaltungsrats und die in den Hauptver-
sammlungen von den Gesellschaftern angenommenen Beschlüsse oder die von dem alleinigen Gesellschafter angenom-
menen Beschlüsse verantwortlich ist. Der Vorsitzende führt den Vorsitz bei allen Versammlungen des Verwaltungsrats
und Hauptversammlungen. In seiner/ihrer Abwesenheit ernennt die Hauptversammlung oder ernennen die anderen Mit-
glieder des Verwaltungsrats (je nach Lage des Falls) durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden Verwaltungsräte,

102283

L

U X E M B O U R G

oder durch deren bei den Versammlungen anwesenden Vertreter, einen anderen vorläufigen Vorsitzenden, der den Vorsitz
bei der entsprechenden Versammlung führt.

Auf Anweisung des Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsräte versammelt sich der Verwaltungsrat an dem in der

Einberufung angegebenen Ort, der in Luxemburg liegen muss.

Alle Verwaltungsräte sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Versammlung anberaumten Termin

schriftlich über die Versammlung des Verwaltungsrats zu benachrichtigen, außer bei Notfällen, in welchem Fall die Art
solcher Umstände in der Benachrichtigung über die Einberufung einer Versammlung des Verwaltungsrats kurz zu be-
schreiben ist.

Das Erfordernis der schriftlichen Benachrichtigung entfällt bei Anwesenheit oder Vertretung aller Mitglieder des Ver-

waltungsrats  bei  Versammlungen,  und  wenn  sie  dabei  angeben,  dass  sie  ordnungsgemäß  informiert  worden  sind  und
vollständige Kenntnis der Tagesordnung der Versammlung besitzen. Auf schriftliche Benachrichtigung kann durch schrift-
liches Einverständnis verzichtet werden. Das Schriftstück kann im Original, als Telefax, Depesche, Telegramm, Telex oder
Email  vorgelegt  werden  kann.  Gesonderte  schriftliche  Benachrichtigungen  sind  nicht  für  die  Anberaumung  von  Ver-
sammlungen erforderlich, die an Orten und Terminen stattfinden, die auf Grundlage eines im Voraus durch Beschluss des
Verwaltungsrats angenommenen Terminplans festgelegt sind.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats können bei den Versammlungen des Verwaltungsrats durch schriftliche Ernennung

eines anderen Verwaltungsrats als ihren Vertreter handeln. Das Schriftstück kann im Original, als Telefax, Depesche,
Telegramm, Telex oder Email vorgelegt werden kann.

Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann ein an der Teilnahme an einer Versammlung des Verwaltungsrats verhindertes

Mitglied  vertreten,  und  es  muss  immer  mindestens  zwei  Mitglieder  geben,  die  entweder  persönlich  bei  einer  solchen
Versammlung anwesend sind oder einer solchen Versammlung auf dem Wege einer Konferenzschaltung, Videokonferenz
oder eines Kommunikationsmittels, das den in dem folgenden Absatz, Teilnahme an Verwaltungsratsversammlungen,
dargelegten Erfordernissen entspricht, beiwohnen.

Die Verwaltungsräte können auf dem Wege einer Konferenzschaltung, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikati-

onsmitteln an Versammlungen des Verwaltungsrats teilnehmen, und sie werden so gestellt, als wären sie persönlich bei
einer Versammlung anwesend, wobei (i) die Identifizierung der an Versammlung teilnehmenden Verwaltungsräte gegeben
ist, (ii) alle an der Versammlung teilnehmenden Personen sich gegenseitig hören und miteinander sprechen können, (iii)
die Übertragung der Versammlung auf kontinuierlicher Basis erfolgt und (iv) die Verwaltungsräte sich ordentlich beraten
und so mit allen Mitteln an der Versammlung teilnehmen können, als seien sie persönlich bei einer solchen Versammlung
anwesend.

Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam beraten und handeln, wenn mindestens die Mehrheit der Verwaltungsräte

des Unternehmens bei den Versammlungen des Verwaltungsrats anwesend ist oder vertreten wird. Entscheidungen erfolgen
nach Mehrheitsbeschluss der bei solchen Versammlungen anwesenden oder vertretenen Verwaltungsräte. Im Fall einer
unentschiedenen Abstimmung hat der Vorsitzende der Versammlung eine entscheidende Stimme.

Unbeschadet des Vorstehenden können Beschlüsse des Verwaltungsrats auch schriftlich angenommen werden. Solche

Beschlüsse müssen ein oder mehrere Dokumente umfassen, die die Beschlüsse enthalten, und handschriftlich von jedem
der Verwaltungsräte unterzeichnet sind. Das Datum eines solchen Beschlusses ist das Datum der zuletzt geleisteten Un-
terschrift.

Art. 13. Protokoll über die Verwaltungsratsversammlungen. Die Protokolle der Verwaltungsratsversammlungen sind

von dem Vorsitzenden oder dem Mitglied des Verwaltungsrats zu unterzeichnen, der oder das bei der Versammlung den
Vorsitz geführt hat und werden am eingetragenen Firmensitz des Unternehmens hinterlegt.

Kopien oder Auszüge aus den Protokollen, die bei Gerichtsverfahren oder zu sonstigen Anlässen vorgelegt werden, sind

von dem Vorsitzenden oder zwei beliebigen Mitgliedern des Verwaltungsrats zu unterzeichnen.

Art. 14. Vollmachten des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehende Vollmacht zur Durchführung

oder Veranlassung der Durchführung sämtlicher Handlungen hinsichtlich der Verfügung und Verwaltung im Interesse des
Unternehmens, einschließlich der Vollmacht zur Übertragung, Abtretung oder Veräußerung der Vermögenswerte des Un-
ternehmens gemäß dem Verbriefungsgesetz 2004 und der einschlägigen Emissionsunterlagen. Alle Vollmachten, die nicht
ausdrücklich durch das Unternehmensgesetz 1915 oder die Artikel über die Hauptversammlungen vorbehalten sind, fallen
in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

Art. 15. Übertragung der Vollmacht. Der Verwaltungsrat kann eine Person ernennen (délégué à la gestion journalière),

bei der es sich um einen Gesellschafter oder ein Mitglied des Verwaltungsrats handeln kann oder nicht, die mit der unein-
geschränkten Vollmacht ausgestattet ist, im Namen des Unternehmens in allen Belangen der alltäglichen Geschäftsführung
und Angelegenheiten des Unternehmens zu handeln.

Der Verwaltungsrat kann eine Person, bei der es sich um einen Gesellschafter oder ein Mitglied des Verwaltungsrats

handeln kann oder nicht, als ständigen Vertreter einer Körperschaft ernennen, bei der das Unternehmen als Mitglied des
Verwaltungsrats ernannt ist. Dieser ständige Vertreter handelt nach vollem Ermessen, aber im Namen und auf Rechnung
des Unternehmens, und kann das Unternehmen in seiner Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrats einer solchen Kör-
perschaft verpflichten.

102284

L

U X E M B O U R G

Der Verwaltungsrat ist zudem bevollmächtigt, eine Person, bei der es sich um ein Mitglied des Verwaltungsrats handeln

kann oder nicht, zum Zweck der Wahrnehmung bestimmter Funktionen auf jeder Ebene des Unternehmens zu ernennen.

Art. 16. Verbindliche Unterschriften. Das Unternehmen ist gegenüber Dritten in allen Belangen (einschließlich der

alltäglichen Geschäftsführung, durch (i) die gemeinsamen Unterschriften von zwei beliebigen Mitgliedern des Verwal-
tungsrats, oder (ii) die gemeinsamen Unterschriften von zwei Personen oder die Einzelunterschrift der Person, der eine
solche Unterschriftsvollmacht durch den Verwaltungsrat wurde, jedoch nur innerhalb der Grenzen einer solchen Bevoll-
mächtigung, bindend verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikt. Kein Vertrag oder sonstige Rechtsgeschäfte zwischen dem Unternehmen und anderen Un-

ternehmen  oder  Firmen  soll  von  der  Tatsache,  dass  einer  oder  mehrere  der  Verwaltungsräte  oder  Führungskräfte  des
Unternehmens an einem solchen anderen Unternehmen oder einer solchen anderen Firma beteiligt, oder ein Verwaltungsrat,
ein Teilhaber, eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter dieses anderen Unternehmens oder dieser anderen Firma ist, berührt
oder entkräftet wird.

Die Verwaltungsräte oder Führungskräfte des Unternehmens, die als Verwaltungsrat, Führungskraft oder Mitarbeiter

eines Unternehmens oder einer Firma tätig sind, mit denen das Unternehmen Verträge abschließt oder anderweitig ge-
schäftlich tätig wird, darf nicht einzig auf Grund einer solchen Verbundenheit mit einem anderen Unternehmen oder einer
anderen Firma an der Betrachtung und Stimmabgabe oder dem Befassen mit jeglichen Angelegenheiten in Bezug auf solche
Verträge oder andere Geschäfte gehindert werden.

Falls einer der Verwaltungsräte des Unternehmens eine direktes persönliches und gegenteiliges Interesse an den Rechts-

geschäften des Unternehmens haben sollte, muss dieser Verwaltungsrat den Verwaltungsrat des Unternehmens über dieses
persönliche und gegenteilige Interesse in Kenntnis setzen, und er darf nicht an der Betrachtung oder Stimmabgabe hin-
sichtlich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen, und die betreffenden Rechtsgeschäfte und das Interesse des Verwaltungsrats
daran ist bei der nächsten folgenden Jahreshauptversammlung zu berichten.

Der vorstehende Absatz gilt nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrats, die sich auf Rechtsgeschäfte beziehen, die im

gewöhnlichen Betriebsablauf des Unternehmens getätigt und unabhängig eingegangen werden.

Art. 18. Wirtschaftsprüfer. Die Tätigkeiten des Unternehmens werden von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern

(réviseurs d'entreprises agréés) überwacht. Der/Die Wirtschaftsprüfer werden von dem Verwaltungsrat gemäß dem Ver-
briefungsgesetz 2004 ernannt. Der Verwaltungsrat legt ihre Anzahl, ihre Vergütung und ihre Amtszeit fest.

Art. 19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr des Unternehmens beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines

jeden Jahres

Art. 20. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Nettogewinn des Unternehmens werden 5% (fünf Prozent) der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Zuteilung ist nicht länger erforderlich, sobald die gesetzlich vorgeschriebene
Rücklage 10% (zehn Prozent) des wie in Artikel 5 oben angegebenen oder mitunter erhöhten oder gesenkten Kapitals des
Unternehmens beträgt.

Die  Hauptversammlung  bestimmt,  wie  über  den  übrigen  Jahresnettogewinn  verfügt  werden  soll  und  sie  kann  nach

eigenem Ermessen entscheiden, mitunter Dividenden auszuschütten, und zwar so wie sie es für den Geschäftszweck und
die Geschäftspolitik als am besten angemessen erachtet.

Die Dividenden können in Euro oder jeder von dem Verwaltungsrat gewählten anderen Währung ausgeschüttet werden,

und sie werden an den von dem Verwaltungsrat festgelegten Orten und Terminen ausgezahlt. Der Verwaltungsrat kann
sich für die Auszahlung von Zwischendividenden nach Maßgabe und im Rahmen der in dem Unternehmensgesetz 1915
festgelegten Bestimmungen entscheiden.

Art. 21. Auflösung und Abwicklung. Das Unternehmen kann jederzeit durch einen nach Maßgabe der Bestimmungen

für Änderungen an dieser Satzung, wie in Artikel 22 unten dargelegt, gefassten Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst
werden. Im Fall der Auflösung des Unternehmens wird die Abwicklung von einem oder mehreren Abwicklern (bei denen
es sich um natürliche Personen oder Körperschaften handeln kann) durchgeführt, die von der Hauptversammlung ernannt
werden, die über die Abwicklung entscheidet. Diese Hauptversammlung bestimmt ebenso die Befugnisse und Vergütung
des Abwicklers oder der Abwickler.

Art. 22. Änderungen. Unter der Voraussetzung der Beschlussfähigkeit und des Erfordernisses einer Mehrheit laut Un-

ternehmensgesetz 1915, kann diese Satzung mitunter durch eine außerordentliche Hauptversammlung geändert werden.

Art. 23. Trennung der Vermögenswerte. Wenn ab einem der Zahlungstermine von Anlagevermögen, die sich auf ein

Teilvermögen (einschließlich Deckungsgeschäften, die das Unternehmen in Verbindung mit einem Teilvermögen einge-
gangen ist) beziehen, die Gesamtsumme der Gelder, die in das Anlagevermögen dieses Teilvermögens eingezahlt wurden,
die Zahlungen übersteigt, die von der Gesellschaft in dieses Teilvermögen eingezahlt werden müssen, kann der Verwal-
tungsrat den überschüssigen Betrag zur Begleichung von Forderungen von Gläubigern des Unternehmens, deren Forde-
rungen keinem bestimmten Teilvermögen zugeordnet werden können, einsetzen.

Die einem Teilvermögen zugeordneten Anlagevermögen stehen ausschließlich den (1) Anlegern in dieses Teilvermögen

(die  Anleger),  (2)  den  Gläubigern,  deren  Ansprüche  in  Verbindung  mit  der  Bildung,  Verwaltung  oder  Auflösung  des
Teilvermögens entstanden sind, und die in den Bestimmungen für die Rangfolge von Zahlungen der entsprechenden Emis-

102285

L

U X E M B O U R G

sionsunterlagen vorgesehen sind (die Transaktionsgläubiger), (3) den Gläubigern, deren Ansprüche in Verbindung mit der
Bildung, Verwaltung oder Auflösung des Teilvermögens entstanden sind, und die nicht in den Bestimmungen für die
Rangfolge von Zahlungen der entsprechenden Emissionsunterlagen vorgesehen sind (die Gläubiger, deren Ansprüche aus
einem bestimmten Teilvermögen entstehen/ Compartment-Specific Claims Creditors und, gemeinsam mit den Transakti-
onsgläubigern,  die  Gläubiger)  und  (4),  den  Bestimmungen  des  nächsten  Absatzes  unterliegend,  die  Gläubiger,  deren
Ansprüche nicht in Verbindung mit der Bildung, Verwaltung oder Auflösung eines Teilvermögens entstanden sind und die
nicht auf ihr Rückgriffsrecht auf die Vermögenswerte eines Teilvermögens des Unternehmens verzichtet haben (die Gläu-
biger, deren Ansprüche nicht aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen/ Non Compartment-Specific Claims Credi-
tors) zur Verfügung.

Die Rechte der Gläubiger, deren Ansprüche nicht aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen (Non Compartment-

Specific Claims Creditors), werden allen Teilvermögen von dem Unternehmen halbjährlich im Nachhinein zugeteilt, auf
gleicher Basis und zeitanteilig (pro rata temporis) hinsichtlich der Teilvermögen, die innerhalb des Halbjahres gebildet
wurden, und in deren Emissionsunterlagen die Gläubiger, deren Ansprüche nicht aus einem bestimmten Teilvermögen
entstehen (Non Compartment-Specific Claims Creditors), ausdrücklich zur Ausübung des Rückgriffrechts auf die einem
solchen Teilvermögen zugeordneten Vermögenswerte bevollmächtigt. Dieses Recht der Gläubiger, deren Ansprüche nicht
aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen, gegenüber einem Teilvermögen werden im Folgenden als Pro-rata-Rechte
bezeichnet.

Die Anleger und die Gläubiger erkennen an und akzeptieren, dass sie, sobald alle Vermögenswerte, die dem Teilver-

mögen zugeordnet worden sind, in das sie investiert haben oder auf Grundlage derer ihre Ansprüche entstanden sind,
realisiert sind, keine Berechtigung haben, jegliche weiteren Schritte gegen das Unternehmen einzuleiten, um weitere fäl-
ligen Beträge zurückzuerlangen und das Recht auf den Erhalt solcher Beträge erlischt. Alle Gläubiger, deren Ansprüche
nicht aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen (Non-Compartment-Specific Claims Creditor) erkennen an und ak-
zeptieren, dass sie, sobald alle Vermögenswerte, die einem Teilvermögen zugeordnet sind, an dem sie Pro-rata-Rechte
haben, realisiert sind, keine Berechtigung haben, jegliche weiteren Schritte gegen das Unternehmen einzuleiten, um diese
Pro-rata-Rechte zurückzuerlangen, und das Recht auf die Auszahlung von Beträgen in Zusammenhang mit den Pro-rata-
Rechten erlischt.

Die Gläubiger, deren Ansprüche aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen (Compartment-Specific Claims Cre-

ditors) und die Gläubiger, deren Ansprüche nicht aus einem bestimmten Teilvermögen entstehen (Non Compartment-
Specific Claims Creditors) akzeptieren ausdrücklich, und werden bei dem Eingehen von Vertragspflichten gegenüber dem
Unternehmen so gestellt, als hätten sie dies akzeptiert, dass die Rangfolge der Zahlungen und die Bedingungen des Was-
serfall-Prinzips Teil der Emissionsunterlagen bilden, und sie akzeptieren die Folgen der Rangfolge der Zahlungen und der
Bedingungen des Wasserfall-Prinzips ausdrücklich und werden so gestellt, als hätten sie diese akzeptiert.

Die Rechte der Gesellschafter des Unternehmens sind auf die Vermögenswerte beschränkt, die nicht einem Teilver-

mögen zugeteilt sind.

Art. 24. Verbot des Konkursantrags für das Unternehmen und der Pfändung der Vermögenswerte des Unternehmens.

Gemäß Artikel 64 des Verbriefungsgesetzes 2004, verpflichten sich sämtliche Anleger, Gläubiger und Gesellschafter des
Unternehmens, sowie sämtliche Personen, die ein Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen eingegangen sind (der Ver-
tragspartner) (1) keinen Konkursantrag für das Unternehmen zu stellen oder die Eröffnung eines anderen Sammel- oder
Sanierungsverfahrens gegen das Unternehmen zu beantragen und (2) keine Vermögenswerte des Unternehmens zu pfänden,
und zwar ungeachtet der Tatsache, ob die betreffenden Vermögenswerte (i) zu dem Teilvermögen, in das der Anleger
investiert hat, gehören oder ob die Gläubiger oder die Vertragspartei dem Unternehmen gegenüber Vertragsrechte über die
Vermögenswerte hat, (ii) oder zu anderen Teilvermögen oder (iii) den Vermögenswerten des Unternehmens gehören, die
noch keinem Teilvermögen zugeordnet worden sind (wenn überhaupt) gehören, es sei denn, Gegenteiliges wird ausdrück-
lich in Schriftform zwischen dem Unternehmen und dem Anleger, Gläubiger oder Vertragspartner vereinbart.

Art. 25. Unterordnung. Ansprüche, die die Gesellschafter des Unternehmens ggf. gegenüber dem Unternehmen (in dieser

Eigenschaft) haben, werden den Ansprüchen von jeglichen Gläubigern des Unternehmens (einschließlich der Gläubiger)
oder Anleger des Unternehmens (einschließlich der Anleger) untergeordnet.

Die Anleger akzeptieren und erkennen an, dass ihre Rechte an einem Teilvermögen den Rechten anderer Anleger und/

oder Gläubiger an demselben Teilvermögen untergeordnet werden können.

Art. 26. Geltendes Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch die hierin enthaltenen Artikel ge-

regelt  werden,  unterliegen  der  Maßgabe  der  in  dem  Unternehmensgesetz  1915  und  dem  Verbriefungsgesetz  2004
festgelegten Bestimmungen.

<i>Übergangsregelungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2015.
Die erste Jahreshauptversammlung findet 2016 statt.

<i>Zeichnung

Nach Festlegung der Satzung des Unternehmens erklärt die erschienene Partei hiermit, dass sie 310 (dreihundertzehn)

Anteile zeichnet, die das gesamte Aktienkapital des Unternehmens repräsentieren.

102286

L

U X E M B O U R G

Sämtliche dieser Anteile sind von dem Gesellschafter zu 100% (einhundert Prozent) durch Barzahlung voll einbezahlt

worden, so dass die von dem Gesellschafter geleistete Summe in Höhe von EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro) dem
Unternehmen von nun an frei zur Verfügung steht, was dem Notar gegenüber durch Nachweise belegt wurde.

<i>Abrechnung - Kosten

Der diese Urkunde errichtende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Unternehmensgesetzes 1915

vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind und er deren Erfüllung ausdrücklich bezeugt. Weiter bestätigt der diese Urkunde
errichtende Notar, dass die hierin enthaltenen Artikel im Einklang mit den Vorschriften laut Artikel 27 des Unterneh-
mensgesetzes 1915 stehen.

Die Höhe des, zumindest überschlagenen, Betrags an Kosten, Ausgaben, Gehältern oder Gebühren, die dem Unterneh-

men infolge seiner Gründung auf irgendeine Weise entstanden sind oder in Rechnung gestellt werden, werden auf circa
EUR 3.000.-geschätzt.

<i>Gesellschafterbeschlüsse

Die obengenannte Partei, die das gesamte gezeichnete Kapital repräsentiert, hat die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. die Anzahl der Verwaltungsräte wird auf drei (3) Verwaltungsräte festgelegt;
2. die folgenden Personen werden zu Verwaltungsräten ernannt:
(a) Herr Marc Kriegsmann, mit beruflicher Anschrift in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
(b) Herr Horst Baumann, mit beruflicher Anschrift in 9, place de Clairefontaine, L-1341 Luxemburg; und
(c) Herr Peter Erich Hein, mit beruflicher Anschrift in 191, Post Road West, USA -CT 06880 Westport, Vereinigte

Staaten von Amerika;

3. dass die Amtszeiten der Verwaltungsratsmitglieder nach der Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 ablaufen; und
4. dass die Adresse des eingetragenen Firmensitzes des Unternehmens 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,

ist.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen

der obengenannten, erschienenen Partei, in englischer Fassung errichtet wurde, gefolgt von einer deutschen Version. Auf
Verlangen der erschienenen Person und für den Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Ver-
sion, soll die englische Fassung Vorrang haben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, an dem zu Beginn dieses Dokuments genannten Datum, errichtet.
Das Dokument wurde der erschienenen Person, die dem Notar mit Namen, Familienstand und Wohnanschriften bekannt

ist, vorgelesen, die benannte Person unterzeichnete die vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar.

Gezeichnet: C. JUNK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 24 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/19654. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 29. Juni 2015.

Référence de publication: 2015102135/700.
(150112199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

Pets Angels Luxembourg A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3583 Dudelange, 7, rue des Forgerons.

R.C.S. Luxembourg F 8.807.

Art. 21. L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3) membres au moins et de

onze (11) membres au plus.

Les membres du Conseil d'Administration seront élus par l'assemblée générale à la majorité simple des voix parmi les

membres actifs ayant une ancienneté ininterrompue d'au moins un (1) an au sein de l'Association.

Art. 22. Les administrateurs sont élus pour une durée de trois ans. Ils désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui

exerceront les fonctions de président/e, secrétaire et trésorier/ère.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultants de la loi et des présents statuts. Les membres du Conseil d'Ad-

ministration sont rééligibles.

Fait et passé à Dudelange, le 1 

er

 juin 2015.

Pierrette GREIVELDINGER / Sandra BACK / Magali FUNEZ.

Référence de publication: 2015104209/16.

(150114186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2015.

102287

L

U X E M B O U R G

Shell Treasury Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 97.745.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 29 juin 2015.

Laurence Macors
<i>Gérante

Référence de publication: 2015103446/12.
(150112677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2015.

Lancaster Coinvestors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 141.095.

Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 2008, acte publié au

Mémorial C no 2235

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Lancaster Coinvestors S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Gérant

Référence de publication: 2015102371/14.
(150112171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

Damea S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 181.696.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «DAMEA

S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 9 juin 2015, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 juin 2015. Relation: EAC/2015/13193.

- que la société «DAMEA S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
181696,

Constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 3317 du 30 décembre 2013. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 21 février 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1231 du 14 mai 2014,

se trouve à partir de la date du 9 juin 2015 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 12 mai 2015 aux termes de laquelle la Société

a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les article 141
et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des
sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social

de la Société dissoute, en l’occurrence au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 17 juin 2015.

Référence de publication: 2015094233/28.
(150104873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

102288


Document Outline

ACP II S.C.A.

ACRON Gloria Palace S.A.

ACRON Wien West A3 S.A.

Akuo Investment Management S.A.

Amer-Sil S.A.

Bedford Lux S.à r.l.

Consulting Gestion et Assistance

Damea S.A.

D.B. International Finance S.A.

Doric Capital SA

Eagle Capital Logistics No 1

GL Europe ASRS Investments S.à r.l.

Hanseatic Europe S.à r.l.

Heaven Services S.A.

Helux Holding S.A.

Holz &amp; Dach Lux S.à r.l.

Immobilière Marnach

Immobilière Marnach

International Flooring Systems S.A.

Lancaster Coinvestors S.à r.l.

Pets Angels Luxembourg A.s.b.l.

SES

Shell Treasury Luxembourg

Strada Chaussures Sàrl

VCM Mezzanine SICAV-FIS III

VCM Venture Capital Europe Plus

VertBois Sàrl

Villport Investissements S.A.

Vis Europe Finance S.à r.l. société de gestion de patrimoine familial

Vis Europe S.A.

Vis Europe S.A.

Vision Foot

Vuvezela 1 Luxco S.à r.l.

Water Cutting Luxembourg

Waterton Global Value (Luxembourg) S.à r.l.

Welington S.A.

WER Luxembourg II S.à r.l.

Western Trade &amp; Commerce (Luxembourg) S.A.

Westquay Investments S.à r.l.

Wind Acquisition Holdings Finance S.A.

WOOD &amp; Company Group S.A.

WTC Holdings S.à r.l.

Xchanging Finance S.à r.l.

YELLOW T International S.A.

Zaka