This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2112
17 août 2015
SOMMAIRE
ACF I Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
101334
Adainvest S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101334
Ad Valorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101333
Advent OT (Luxembourg) Holding S.à r.l. . . .
101333
Al Masaryk (Luxembourg) S.à.r.l. . . . . . . . . . .
101335
Ambrosia CEE Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101333
Ana Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101330
Aria Structured Investments S.à r.l. . . . . . . . .
101335
Artemide S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101335
A.S. Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101354
A Table S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101333
Balkinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101334
Digital Services XXXIV S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
101357
Finpadana International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
101352
GL Europe Luxembourg III (US) Investments
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101342
Globant S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101339
Horus SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101338
Lux Cogeba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101332
Lux Gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101332
Mafrem Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101332
Magellan Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
101331
Maragole S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101331
Mary H S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101331
Parc Helfent Participations S.A. . . . . . . . . . . .
101331
Phoenix B2 - Glatzerstrasse . . . . . . . . . . . . . . .
101332
Play Holdings 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101331
Polygonetic S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101332
Qatar Airways Luxembourg s.à.r.l. . . . . . . . . .
101334
Real Estate Engineering and Development S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101333
Scorlux SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101337
SLP III Investment Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
101336
SMC Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
101336
Solumo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101336
South Real Estate Investment S.A. . . . . . . . . .
101337
SPRT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101376
Stereolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101356
Stingray S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101337
Stone Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101336
SynerTrade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101337
Theta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101356
Thomas Becker - Architekturbüro S.à r.l. . . .
101330
Tiafy SPF, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101376
TMRD Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
101330
Topsin Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101330
Tremalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101330
Valindus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101352
101329
L
U X E M B O U R G
Thomas Becker - Architekturbüro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5444 Schengen, 10, Wengertswee.
R.C.S. Luxembourg B 121.647.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015092665/9.
(150103221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
TMRD Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 234, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 120.453.
Le bilan approuvé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2015.
Référence de publication: 2015092672/10.
(150103197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Tremalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 5, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 105.592.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15/6/2015.
Référence de publication: 2015092679/10.
(150103265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Topsin Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 64.405.
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015092675/11.
(150103429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Ana Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 107.682.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2015.
<i>Pour ANA INVESTMENTS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015100192/14.
(150110644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
101330
L
U X E M B O U R G
Mary H S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 182, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 120.653.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015095414/9.
(150105266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Magellan Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 125.038.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015095406/10.
(150105884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Maragole S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8385 Koerich, 28, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 136.824.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015095413/10.
(150106036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Play Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 183.894.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2014 de sa société
mère, Olympia Development ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2015.
Référence de publication: 2015095502/12.
(150106175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Parc Helfent Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 81.575.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nebst den gesetzlich vorgeschriebenen Anhängen für das Ge-
schäftsjahr endend zum 31. Dezember 2014 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 15. Juni 2015.
<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2015095482/13.
(150106040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
101331
L
U X E M B O U R G
Mafrem Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 187.698.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015095405/9.
(150105723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Lux Cogeba S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 9, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 85.819.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Helmsange, le 17 juin 2015.
Référence de publication: 2015095380/10.
(150105335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Lux Gare, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 435.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 167.678.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2015.
Référence de publication: 2015095381/10.
(150105438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Polygonetic S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6582 Rosport, 6, rue de la Montagne.
R.C.S. Luxembourg B 194.048.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2015.
Pour statuts coordonnés
Référence de publication: 2015099148/11.
(150110110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Phoenix B2 - Glatzerstrasse, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 108.718.
Il est à noter que l'adresse des gérants Pamela Valasuo, Miranda Lansdowne et Arndt Nicolaus se trouve désormais au
68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2015.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015095490/14.
(150105763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
101332
L
U X E M B O U R G
Real Estate Engineering and Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 97.857.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015099144/9.
(150108879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.
Ambrosia CEE Holding, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 192.664.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2015.
Référence de publication: 2015099165/10.
(150109623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Advent OT (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 164.594.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2015.
Référence de publication: 2015099153/10.
(150109381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
A Table S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-6446 Echternach, 2, rue du Haut-Ruisseau.
R.C.S. Luxembourg B 164.919.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/06/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015099149/12.
(150109513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Ad Valorem, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5410 Beyren, 12, rue Langheck.
R.C.S. Luxembourg B 178.095.
Société à Responsabilité Limitée constituée le 21 juin 2013.
Les comptes annuels de 2014 ont été clôturés au 31 décembre 2014 au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié conforme et sincère
Paddock Fund Administration S.A.
Référence de publication: 2015099151/13.
(150109193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
101333
L
U X E M B O U R G
Balkinvest S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 56.239.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015099258/9.
(150110014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Adainvest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 150.277.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015099191/9.
(150109829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Qatar Airways Luxembourg s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.510,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 192.727.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2015.
Référence de publication: 2015099143/10.
(150108875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.
ACF I Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.000.000,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 139.901.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique de la Société en date du 18 juin 2015i>
L’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- M. Ian Kent a démissionné de ses fonctions en tant que gérant de la Société avec effet immédiat;
A. Nomination de Mme. Kathryn O’Sullivan, employé privé, née le 28 juin 1963, à San Jose, États-Unis, résidant
professionnellement à 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que gérant avec effet immédiat et pour
une période de temps illimitée;
- M. Alain Nicolai a démissionné de ses fonctions en tant que gérant de la Société avec effet immédiat;
B. Nomination de Mme. Joan-Sophie Kiener-Wegmann, employé privé, née le 5 octobre 1984 à Sarreguemines, France,
résidant professionnellement au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et
pour une période de temps illimitée.
Le conseil de gérance se compose dorénavant comme il suit:
- Mme. Kathryn O’Sullivan, Gérant
- Mme. Joan-Sophie Kiener-Wegmann, Gérant
- M. Dominique Gaillard, Gérant
- M. Yann Chareton, Gérant
- Mme. Jennifer Ferrand, Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015099187/26.
(150109165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
101334
L
U X E M B O U R G
Al Masaryk (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 193.752.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 25 juin 2015.
Référence de publication: 2015099200/10.
(150109630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Aria Structured Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 130.148.
Société anonyme constituée le 16 Juillet 2007, enregistrée auprès du RCSL le 3 Août 2007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié conforme et sincère
FINEXIS S.A.
Référence de publication: 2015099175/12.
(150109832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Artemide S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.857.050,00.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 108.756.
1. L'assemblé a décidé du transfert du siège social de la Société au 1 rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg le 17
juin 2015.
2. A la suite de la démission de Mr Thomas DEWE et Mme Manuela D'AMORE en date du 24 mars 2015, et confor-
mément à l'Article 8 des statuts si deux (2) membres du conseil de gérance cessent leurs fonctions pour quelque raison que
ce soit, l'ensemble des autres membres du conseil devront être considérés comme étant démissionnaires et leurs démissions
seront effectives immédiatement.
L'assemblée en date du 17 juin 2015 a donc procédé à la nomination du nouveau conseil de gérance comme suit:
- Mr. Alain TIRCHER, expert-comptable, né le 13 mars 1959 à Watermael-Boitsfort, Belgique, résidant profession-
nellement à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer, Gérant;
- Mr. Jean-Michel HAMELLE, expert-comptable, né le 13 septembre 1962 à Reims, France, résidant professionnelle-
ment à L-2538 Luxembourg, 1 , rue Nicolas Simmer, Gérant;
- Mr. Charles EMOND, conseiller fiscal, né le 28 mars 1955 à Arlon, Belgique résidant professionnellement à L-2538
Luxembourg, 1 , rue Nicolas Simmer, Gérant;
- Mr. Ralph BOURGNON, expert-comptable, né le 23 juin 1975 à Bâle, Suisse résidant professionnellement à L-1445
Strassen, 7A, rue Thomas Edison, Gérant;
- Mr. Christophe ROEDER, expert-comptable, né le 14 août 1975 à Algrange, France, résidant professionnellement à
L-1445 Strassen, 7A, rue Thomas Edison, Gérant;
- Mr. Gianpaolo BIANCHI, né le 23 janvier 1979 à Cernusco sul Naviglio, Italie et résidant professionnellement à
Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, Pays-Bas, Gérant.
3. Le siège social de l'associé PRELIOS SPA se situe au 27 Viale Piero e Alberto Pirelli, I-20126 Milan, Italie et non
au 25 Viale Piero e Alberto Pirelli, I-20126 Milan, Italie comme actuellement renseigné auprès du Registre du commerce
et des sociétés et son numéro d'immatriculation auprès du registre de Milan est le 02473170153 et non le 02473131701453
comme actuellement renseigné auprès du Registre du commerce et des sociétés.
<i>Pour ARTEMIDE S.à r.li>
Référence de publication: 2015099218/32.
(150108932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
101335
L
U X E M B O U R G
Solumo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 47.851.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015096330/9.
(150106700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
SLP III Investment Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 162.420.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015096323/10.
(150106747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Stone Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 197.413.
<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique en date du 17 juin 2015i>
1. Le nombre de gérant a été augmenté de 2 à 3.
2. Monsieur Alain ROULEAU, né à Montauban (France), le 10 janvier 1946, demeurant à 40000 Marrakech (Maroc),
26, rue de la Koutoubia, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée,
Luxembourg, le 17 juin 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Stone Holding S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015096340/16.
(150106177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
SMC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 162.872.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 15 juin 2015i>
En date du 15 juin 2015, l’associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de prendre connaissance de la démission de Monsieur Giuseppe Di Modica en tant que gérant B de la Société et ce
avec effet immédiat;
- de nommer Madame Laetitia Brion, née le 10 août 1984 à Woippy, France, ayant son adresse professionnelle au 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société, pour une durée indéterminée, et ce avec effet
immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015096326/19.
(150106171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
101336
L
U X E M B O U R G
Stingray S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 178.451.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015096304/9.
(150106588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
South Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 20, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 163.453.
Les comptes annuels rectificatifs au 31.12.2012 (rectificatif du dépôt de comptes annuels au 31.12.2012 déposé le
26.07.2013, L130128734) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015096302/10.
(150106194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
SynerTrade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 114.106.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 juin 2015 que le mandat de Certifica Luxembourg S.à
r.l. en tant que Commissaire de la Société a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2015.
Référence de publication: 2015096309/12.
(150106718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Scorlux SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 174.442.
<i>Extrait des Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2015i>
Composition du Conseil d'Administration:
- L'Assemblée Générale a décidé le renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs DE VARENNE Fran-
çois, ROSSARY Fabrice et ANDRIANNE Benoît.
- L'Assemblée Générale a décidé le renouvellement du mandat de Deloitte Audit en tant que réviseur d'entreprises.
- Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises ainsi élus viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2015.
Au 4 juin 2015, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Mr. DE VARENNE François (Président du Conseil d'Administration)
- Mr. ROSSARY Fabrice
- Mr. ANDRIANNE Benoît
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2015.
SCORLUX SICAV-SIF
Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2015096313/23.
(150106364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
101337
L
U X E M B O U R G
Horus SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de fer.
R.C.S. Luxembourg B 165.714.
L'an deux mille quinze, le quatre juin.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
S'est réunit
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HORUS SA, ayant son siège social au 9bis
rue Basse, L-4963 Clemency, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section
B numéro 165.714, constituée suivant acte reçu par Me Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 21 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 299 du 3 février 2012
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 13 décembre 2013, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 508 du 25 février 2014.
L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier Verhaeghe de Naeyer, employé, demeurant à L - 2560 Luxembourg, 16
rue de Strasbourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à
Senningerberg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Verhaeghe de Naeyer, précité.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
2. Transfert du siège du siège social de la Société au 13-15 rue du Chemin de fer, L - 8057 Bertrange et modification
du premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la Société.
3. Adoption de la seule forme nominative des actions et modification subséquente du deuxième paragraphe de l’article
5 des statuts qui se lira comme suit: «Les actions sont et resteront nominatives.»
4. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Resteront annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“
par les comparants et le notaire soussigné aux fins d’enregistrement.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée à savoir 51.033 actions
nominatives, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires renoncent à leurs droits de convocation, reconnaissent avoir été suffisamment informés au préalable
sur les points portés à l'ordre du jour, considèrent avoir été valablement convoqués et acceptent dès lors de délibérer et de
voter les points portés à l'ordre du jour. Les Actionnaires confirment ensuite que toute la documentation présentée lors de
l'assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour leur permettre d'examiner attentivement chaque
document.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 9bis rue Basse, L-4963 Clemency au 13-15 rue du
Chemin de fer, L - 8057 Bertrange.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la Société qui aura
la teneur suivante:
Art. 2. Premier paragraphe. «Le siège social est établi dans la commune de Bertrange.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide que les actions auront la seule forme nominative et en conséquence de modifier le deuxième para-
graphe de l’article 5 des statuts qui se lira comme suit:
Art. 5. Deuxième paragraphe. «Les actions sont et resteront nominatives.»
101338
L
U X E M B O U R G
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent euros (1.100,- EUR).
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude
du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.
DONT ACTE, passé à Senningerberg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont
signé avec le Notaire, la présente minute.
Signé: Olivier Verhaeghe de Naeyer, Sophie Mathot, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 8 juin 2015. 1LAC / 2015 / 17645. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 juin 2015.
Référence de publication: 2015098352/72.
(150108626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.
Globant S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 173.727.
In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of June,
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
Mr. Alexandre Gobert, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting as the duly, legally
and validly appointed representative (the "Representative") of the duly authorized delegate (the “Authorized Officer”) of
the board of directors of Globant S.A. (the "Board of Directors"), a public limited liability company (société anonyme)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 173 727 (the “Company”), duly authorized to represent the Authorized Officer pursuant to the resolutions
adopted by the Authorized Officer on respectively 13 May 2015, 28 May 2015 and 2 June 2015 (the “Resolutions”).
A copy of the Resolutions, initialled "ne varietur" by the Representative and the undersigned notary will remain attached
to the present deed in order to be filed with the same.
The Representative has requested the notary to record that:
1. The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,
Grand Duchy of Luxembourg, on 10 December 2012, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 258 dated 2 February 2013. The articles of association have been amended for the last time by a deed of the same
notary on 4 May 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2. The share capital of the Company currently amounts to forty million nine hundred fifty-nine thousand eight hundred
fourteen US dollars and eighty cents (USD 40,959,814.80), represented by thirty-four million one hundred thirty-three
thousand one hundred seventy-nine (34,133,179) common shares having a nominal value of one US dollar and twenty cents
(USD 1.20) per common share.
3. Pursuant to article 6.1 of the articles of association of the Company (the "Articles"), the Company’s authorized capital,
excluding the issued share capital, is set at five million one hundred nine thousand three hundred eighty US dollars and
forty cents (USD 5,109,380.40) consisting in four million two hundred fifty-seven thousand eight hundred seventeen
(4,257,817) common shares having a nominal value of one US dollar and twenty cents (USD 1.20) per common share.
Article 6.2 of the Articles further states that:
"The board of directors is authorized to issue common shares, to grant options to subscribe for common shares and to
issue any other instruments convertible into, or giving rights to, common shares within the limit of the authorized share
capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving a
pre-emptive subscription right for the existing shareholders during a period ending on the fifth (5
th
) anniversary of the
date of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the minutes of the extraordinary general
meeting of shareholders held on 4 May 2015. Such common shares may be issued above, at or below market value, above
101339
L
U X E M B O U R G
or at nominal value as well as by way of incorporation of available reserves (including premium). The general meeting has
waived and suppressed and has authorized the board of directors to waive, suppress or limit any preemptive subscription
rights of shareholders to the extent the board deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues
of common shares within the scope of the Company’s authorized (un-issued) share capital. This authorization may be
renewed, amended or extended once or several times by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the
manner required for an amendment of these articles of association. Upon an issue of shares within the authorized share
capital the board shall have the present articles of association amended accordingly.”
4. Through the adoption of the Resolutions, the Authorized Officer has decided to increase the share capital of the
Company, without reserving to the existing shareholders any pre-emptive subscription right, according to the terms of
article 6.2 of the Articles, by an amount of eighty-five thousand seven hundred sixty thousand US dollars and forty cents
(USD 85,760.40) (the "Capital Increase Amount”) in order to increase the share capital of the Company from its current
amount of forty million nine hundred fifty-nine thousand eight hundred fourteen US dollars and eighty cents (USD
40,959,814.80) to forty-one million forty-five thousand five hundred seventy-five US dollars and twenty cents (USD
41,045,575.20) through the issuance (and to issue) of seventy-one thousand four hundred sixty-seven (71,467) fully-paid
common shares of the Company, with a nominal value of one US dollar and twenty cents (USD 1.20) each (each a "New
Common Share" and together the "New Common Shares"), for an issue price of eight hundred seven thousand two hundred
ninety-eight US dollars (USD 807,298) (the “Issue Price”) consisting of the Capital Increase Amount and seven hundred
twenty-one thousand five hundred thirty-seven US dollars and sixty cents (USD 721,537.60) attributed to the share premium
account of the Company (the "Share Premium Amount").
5. The New Common Shares have been entirely subscribed for by the subscriber, as referred to in the Resolutions
(respectively the "Subscription" and the "Subscriber") at the Issue Price.
The New Common Shares have been fully paid up by the Subscriber to the benefit of the Company by a contribution
in cash (the "Contribution") in an aggregate amount of eight hundred seven thousand two hundred ninety-eight US dollars
(USD 807,298) consisting of (i) the Capital Increase Amount and of (ii) the Share Premium Amount.
Evidence of the completion of both the Subscription and the Contribution has been provided to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.
As a consequence of the share capital increase, with effect as of the date of the Resolutions, (i) the share capital of the
Company amounts to forty-one million forty-five thousand five hundred seventy-five US dollars and twenty cents (USD
41,045,575.20) and is divided into thirty-four million two hundred four thousand six hundred forty-six (34,204,646) com-
mon shares having a nominal value of one US dollar and twenty cents (USD 1.20) per common share and (ii) the authorized
capital of the Company, excluding the issued share capital of the same, is set at five million twenty-three thousand six
hundred twenty US dollars (USD 5,023,620.-) consisting in four million one hundred eighty-six thousand three hundred
fifty (4,186,350) common shares having a nominal value of one US dollar and twenty cents (USD 1.20) per common share.
6. Therefore the following articles of the Articles are amended accordingly and now read as follows:
" 5.1. The Company has a share capital of forty-one million forty-five thousand five hundred seventy-five US dollars
and twenty cents (USD 41,045,575.20) and is divided into thirty-four million two hundred four thousand six hundred forty-
six (34,204,646) common shares having a nominal value of one US dollar and twenty cents (USD 1.20) per common share.".
“ 6.1. The Company’s authorized capital, excluding the Company's share capital, is set at five million twenty-three
thousand six hundred twenty US dollars (USD 5,023,620.-) consisting in four million one hundred eighty-six thousand
three hundred fifty (4,186,350) common shares having a nominal value of one US dollar and twenty cents (USD 1.20) per
common share.”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present stated increase of capital, are estimated at two thousand five hundred.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, at the date named at the beginning
of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le douze juin.
Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu
101340
L
U X E M B O U R G
Maître Alexandre Gobert, maître en droit, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg agissant en sa qualité
de représentant, dûment, légalement et valablement nommé (le «Représentant») du délégué dûment autorisé (le «Délégué»)
du conseil d’administration de la société Globant S.A. (le «Conseil d’Administration»), une société anonyme constituée et
existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 173 727 (la «Société»), dûment autorisé à représenter le Délégué suivant les résolutions adoptées par le Délégué
respectivement en date du 13 mai 2015, 28 mai 2015 et 2 juin 2015 (le «Délégué»).
Une copie des résolutions du Délégué, après avoir été paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire, restera
annexée aux présentes pour être enregistrée avec celles-ci (les «Résolutions»).
Le Représentant a requis le notaire d’acter que:
1. La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 10 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
258 du 2 février 2013. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 04 mai 2015,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2. Le capital social de la Société est actuellement de quarante millions neuf cent cinquante-neuf mille huit cent quatorze
US dollars et quatre-vingt cents (USD 40.959.814,80) représenté par trente-quatre millions cent trente-trois mille cent
soixante-dix-neuf (34.133.179) actions ordinaires ayant une valeur nominale d’un US dollar et vingt cents (USD 1,20)
chacune.
3. Au terme de l’article 6.1 des statuts de la Société (les «Statuts»), le capital autorisé de la Société, excluant le capital
social émis, est fixé à un montant de cinq millions cent neuf mille trois cent quatre-vingt US dollars et quarante cents (USD
5.109.380,40) divisé en quatre millions deux cent cinquante-sept mille huit cent dix-sept (4.257.817) actions ordinaires
ayant une valeur nominale d’un US dollar et vingt cents (USD 1,20) chacune. L’article 6.2 des Statuts indique par ailleurs
que:
"Le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions ordinaires, à accorder des options de souscription d’actions
ordinaires et à émettre tous autres instruments convertibles en, ou donnant des droits à des, actions ordinaires dans la limite
du capital social autorisé au profit de personnes et dans les conditions qu’il jugera opportunes, et plus précisément de
procéder à une telle émission sans qu’un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ne soit réservé aux ac-
tionnaires existants pour une période se terminant au cinquième (5
ème
) anniversaire de la date de la publication dans le
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue le 4 mai 2015. Ces actions peuvent être émises à une valeur excédant ou en-deçà de la valeur du marché, au-dessus
de ou à la valeur nominale ainsi que par incorporation de réserves disponibles (y compris la prime d’émission). L’assemblée
générale a renoncé et supprimé et a autorisé le conseil d’administration à renoncer, supprimer ou limiter tous droits pré-
férentiels de souscription d’actionnaires dans la mesure où ce dernier jugera cette renonciation, suppression ou limitation
opportune pour toute émission ou émissions d’actions ordinaires dans la limite du capital social autorisé (non-émis) de la
Société. Cette autorisation pourra être renouvelée, modifiée ou prolongée une ou plusieurs fois par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires adoptée aux conditions requises pour la modification des statuts. Après une émission
d’actions dans le cadre du capital social autorisé, le conseil d’administration veillera à ce que les présents statuts soient
modifiés en conséquence."
4. Par les Résolutions, le Délégué a décidé d’augmenter le capital social de la Société, sans réserver aux actionnaires
existant leur droit de souscription préférentiel, conformément aux termes de l’article 6.2 des Statuts, d’un montant de quatre-
vingt-cinq mille sept cent soixante US dollars et quarante cents (USD 85.760,40) (le «Montant de l’Augmentation du
Capital») pour le porter de son montant actuel de quarante millions neuf cent cinquante-neuf mille huit cent quatorze US
dollars et quatre-vingt cents (USD 40.959.814,80) au montant de quarante-et-un million quarante-cinq mille cinq cent
soixante-quinze US dollars et vingt cents (USD 41.045.575,20) par l’émission de (et d’émettre) soixante-et-onze mille
quatre cent soixante-sept (71.467) actions ordinaires entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un US dollar et vingt
cents (USD 1,20) chacune (chacune une «Nouvelle Action Ordinaire» et ensemble les "Nouvelles Actions Ordinaires"),
pour un prix d’émission de huit cent sept mille deux cent quatre-vingt-dix-huit US dollars (USD 807.298,-) (le «Prix
d’Emission») représentant le Montant de l’Augmentation du Capital et un montant de sept cent vingt-et-un mille cinq cent
trente-sept US dollars et soixante cents (USD 721.537,60) alloué au compte de prime d’émission de la Société (le «Montant
de la Prime d’Emission»).
5. Les Nouvelles Actions Ordinaires ont été entièrement souscrites et payées par le souscripteur dont il est fait référence
dans les Résolutions (respectivement la «Souscription» et le «Souscripteur») au Prix d’Emission.
Les Nouvelles Actions Ordinaires ont été entièrement payées par le Souscripteur par un paiement en numéraire (le
«Paiement») de huit cent sept mille deux cent quatre-vingt-dix-huit US dollars (USD 807.298,-) consistant dans (i) le
Montant de l’Augmentation de Capital et dans (ii) le Montant de la Prime d’Emission.
Une preuve de la réalisation, à la fois, de la Souscription et du Paiement a été donnée au notaire instrumentant, qui le
reconnaît expressément.
En conséquence de l’augmentation du capital social, avec effet en date des Résolutions, (i) le capital social de la Société
s’élève à quarante-et-un million quarante-cinq mille cinq cent soixante-quinze US dollars et vingt cents (USD
41.045.575,20) et est représenté par trente-quatre millions deux cent quatre mille six cent quarante-six (34.204.646) actions
101341
L
U X E M B O U R G
ordinaires d’une valeur nominale d’un US dollar et vingt cents (USD 1,20) chacune et (ii) le capital autorisé de la Société,
excluant le capital social de celle-ci, est fixé à un montant de cinq millions vingt-trois mille six cent vingt US dollars (USD
5.023.620,-) divisé en quatre millions cent quatre-vingt-six mille trois cent cinquante (4.186.350) actions ordinaires ayant
une valeur nominale d’un US dollar et vingt cents (USD 1,20) chacune.
6. De ce fait, les articles suivants des Statuts sont modifiés en conséquence et ont désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé quarante-et-un million quarante-cinq mille cinq cent soixante-quinze US dollars et vingt
cents (USD 41.045.575,20) et est représenté par trente-quatre millions deux cent quatre mille six cent quarante-six
(34.204.646) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un US dollar et vingt cents (USD 1,20) chacune.».
« 6.1. Le capital autorisé de la Société, excluant le capital social émis, est fixé à un montant de cinq millions vingt-trois
mille six cent vingt US dollars (USD 5.023.620,-) divisé en quatre millions cent quatre-vingt-six mille trois cent cinquante
(4.186.350) actions ordinaires ayant une valeur nominale d’un US dollar et vingt cents (USD 1,20) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de deux
mille cinq cents euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état
et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. GOBERT, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 juin 2015. Relation: EAC/2015/13785. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015098324/178.
(150108576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.
GL Europe Luxembourg III (US) Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 197.820.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of June.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
GL Europe Luxembourg III (US) Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies
of Luxembourg, having its registered office at 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Ms Kety Tsochas, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
GL Europe Luxembourg III (US) Investments S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of
10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of asso-
ciation.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
101342
L
U X E M B O U R G
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
101343
L
U X E M B O U R G
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, at which point
decisions shall be validly approved in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the
fraction of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be shareholders of the Company.
If the Company has several managers, the managers form a board of managers composed of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
Art. 15. Convening meetings of the board of managers.
15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
101344
L
U X E M B O U R G
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication initiated from Luxembourg by a class B Manager, allowing all persons participating at such meeting to
hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting
by these means is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered
office of the Company.
16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers, among which at least one (1) class A manager and one (1) class B
manager must be present or represented.
16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting provided that
at least one (1) class A manager and one (1) class B manager vote in favour of a resolution. The chairman, if any, shall not
have a casting vote.
16.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by
the chairman pro tempore and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which
may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.
17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 18. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, (i) by the joint signature of one (1) class A manager
and one (1) class B manager, (ii) by the joint signature of two (2) class B managers (excluding, however, for the operation
of the Company’s bank accounts), or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such
signatory power may have been delegated by the Company within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 19. Auditor(s).
19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
19.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
19.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
19.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 20. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
101345
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
21.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
21.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
21.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
23.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 24 Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by GL Europe Luxembourg III (US)
Holdings S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1.500,-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating sole shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any con-
vening requirements, has passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
101346
L
U X E M B O U R G
(i) Richard Stabinsky, born in New York, USA on January 28
th
1968, professionally residing at 399 Park Avenue, 6
th
Floor, New York, New York 10022, United States, as class A manager; and
(ii) Thomas M. Larkin, born in New Jersey, USA on February 21
st
1964, professionally residing at 399 Park Avenue,
6
th
Floor, New York, New York 10022, United States, as class A manager; and
(iii) Henry Saavedra, born in New York, USA on November 17
th
1978, professionally residing at 25a, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, as class B manager; and
(iv) Ramon van Heusden, born in Nijmegen, the Netherlands, on May 7
th
1967, professionally residing at Carré Bonn,
20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as class B manager;
(v) Jorrit Crompvoets, born in Voorst, the Netherlands, on May 16
th
1976, professionally residing at Carré Bonn, 20,
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as class B manager.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède.
L’an deux mille quinze, le onze juin.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
GL Europe Luxembourg III (US) Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée existant sous les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commence et des Sociétés du Luxem-
bourg, ayant son siège social au 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
dûment représentée par Mademoiselle Kety Tsochas, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte de constitution d’une société à responsabilité limitée
qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «GL Europe Luxembourg
III (US) Investments S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises
et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, le transfert
par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l’administration, le contrôle et la
mise en valeur de ces participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Sauf par voie d’appel publique à l’épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme
ou en émettant toute sorte d’obligations, de titres obligataires ou d’instrument de dettes, d’obligations garanties ou non
garanties, et d’une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
101347
L
U X E M B O U R G
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, écono-
mique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité
normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation
complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre
événement similaire d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera visà-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l’acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l’associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous
réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital social. Un
tel agrément n’est cependant pas requis dans l’hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, des-
cendants ou au conjoint survivant.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l’hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d’ordinaire de la compétence de l’assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l’assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l’associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés seront exercés par l’associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l’hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une
assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
101348
L
U X E M B O U R G
générale. D’autres assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent
être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même agenda et les décisions sont vala-
blement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement
unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l’accord d’une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas être actionnaires de la Société. Si la
Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance, composé au moins d’un (1) gérant de classe A et
d’un (1) gérant de classe B.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n’est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et
la durée de son (leur) mandat.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par
une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l’avance par rapport à l’heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs d’une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel document signé
constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l’heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l’hypothèse où les tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l’hypothèse de décisions écrites et approu-
vées par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en
constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l’intégralité des membres du conseil
de gérance.
101349
L
U X E M B O U R G
16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, initié au Luxembourg par un gérant de classe B, permettant à toutes les personnes
y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens
de communication est réputée s’être tenue au siège social de la Société.
16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance, parmi lesquels doivent être présents ou représentés au moins un (1)
gérant de classe A et un (1) gérant de classe B.
16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance, pourvu qu'au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B ait voté en faveur de la décision. Le
président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d’une voix prépondérante.
16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l’ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions
sera la date de la dernière signature.
Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par
deux (2) gérants.
17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
Art. 18. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la
signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, (i) par la signature conjointe d’un (1) gérant de classe A
et d’un (1) gérant de classe B, (ii) par la signature conjointe de deux (2) gérants de classe B (à l’exception de la gestion des
comptes bancaires de la Société), ou (iii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/
auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par la Société dans les limites de cette délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 19. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.
19.1 Dans l’hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 20. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
21.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l’affectation du solde des
bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
101350
L
U X E M B O U R G
21.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la
Société.
Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.
23.2 Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre
de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 24. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2015.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par GL Europe Luxembourg III (US)
Holdings S.à r.l., susmentionnée, pour un prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en numéraire, de sorte que le
montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.
L’apport global d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.500,-.
<i>Résolutions de l’associéi>
L’associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convo-
cation, a adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
(i) Richard Stabinsky, né à New York, Etats-Unis, le 28 janvier 1968, résidant professionnellement à 399 Park Avenue,
6
th
Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis, en tant que gérant de classe A; et
(ii) Thomas M. Larkin, né à New Jersey, Etats-Unis, le 21 février 1964, résident professionnellement à 399 Park Avenue,
6
th
Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis, en tant que gérant de classe A; et
(iii) Henry Saavedra, né à New York, Etats-Unis, le 17 novembre 1978, résidant professionnellement à 25a, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que gérant de classe B;
(iv) Ramon van Heusden, né à Nijmegen, Pays-Bas, le 7 mai 1967, résidant professionnellement à Carré Bonn, 20, rue
de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérant de classe B; et
(v) Jorrit Crompvoets, né à Voorst, Pays-Bas, le 16 mai 1976, résidant professionnellement à Carré Bonn, 20, rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérant de classe B.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la comparante que le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la comparante et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
101351
L
U X E M B O U R G
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. TSOCHAS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/18845. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 juin 2015.
Référence de publication: 2015098323/517.
(150108269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.
Valindus S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 52.813.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 21 mai 2015i>
Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants
procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammadia
(Algérie), domiciliée professionnellement au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au titre d'administrateur en rempla-
cement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
<i>Pour la société
i>VALINDUS S.A.
Référence de publication: 2015100057/15.
(150109160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Finpadana International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 47.468.
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée FINPADANA INTER-
NATIONAL S.A., avec siège social au 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47468, constituée suivant acte notarié reçu par Maître Georges d’Huart,
alors notaire de résidence à Pétange, le 5 avril 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous le
numéro C 330 de l’année 1994.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire
en date du 10 octobre 2014 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro C 3510 du 22 novembre
2014.
La société a un capital social actuel d’un million cinq cent soixante et un mille sept cent vingt-neuf euros et vingt et un
cents (EUR 1.561.729,21) composé de cinq cent quatre mille (504.000) actions sans désignation de valeur nominale.
L'assemblée est présidée par Monsieur Denis BREVER, demeurant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, demeurant profession-
nellement au L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo
L'assemblée désigne comme scrutatrice Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à la
même adresse.
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés
sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste
de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence,
après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel
elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.
101352
L
U X E M B O U R G
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Conformément aux articles 261 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la Loi sur les Sociétés), le conseil d'administration de la société CASALGRANDE PADANA S.P.A., une société de droit
italien, ayant son siège social à Casalgrande (RE), Strada Statale n.467, italie, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Reggio Emilia sous le numéro REA 178600 (la Société Absorbante ou la Société), précitée,
et le conseil d’administration de la société «FINPADANA INTERNATIONAL S.A.», ayant son siège social à 18, rue
de l’Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47468
(la Société Absorbée et conjointement avec la Société, les Sociétés Fusionnantes)
ont établi le 16 avril 2015 sous seing privé un projet commun de fusion, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, Mémorial C n° 1086 du 25 avril 2015 pour la partie luxembourgeoise,
et publié au Registre de commerce de Reggio Emilia, Italie le 24 avril 2015 et publié au journal officiel italien le 28
avril 2014 selon les références «foglio inserzioni n. 48, aviso n.T15AAB6464», pour la partie italienne (le Projet de Fusion).
La Société Absorbante détient la totalité des cinq cent quatre mille (504.000) actions émises par la Société Absorbée.
II. Conformément à l’article 265 de la Loi sur les Sociétés, un rapport a été établi par le conseil d’administration de
FINPADANA INTERNATIONAL S.A. en date du 16 avril 2015.
III. Le Projet de Fusion et les documents requis conformément aux dispositions de l'article 267 (1) a), b) c) et d) de la
Loi sur les Sociétés (ensemble les Documents) ont été mis à la disposition des actionnaires un mois avant la date des
présentes résolutions.
IV. Aucun créancier de la société n’a fait usage du droit qui lui est accordé par l’article 268 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée sur les sociétés commerciales.
V. Que FINPADANA INTERNATIONAL S.A. a émis un emprunt obligataire non convertible au porteur de EUR
9.296.224,18 (neuf millions deux cent quatre-vingt-seize mille deux cent vingt-quatre euros et dix-huit cents) émis en date
du 19 septembre 1994 et que l’assemblée générale des obligataires tenue en date de 29 mai 2015 ne s’est pas opposée à la
fusion envisagée. Une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des obligataires restera annexée au présent acte.
VI. L'Assemblée des Actionnaires est appelée à prendre des résolutions sur les points de l’agenda suivants:
(a) renonciation aux formalités de convocation;
(b) prise de connaissance du rapport du conseil d’administration en vue de la fusion entre les sociétés CASALGRANDE
PADANA S.P.A., ayant son siège social en Italie et la société FINPADANA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège
social à Luxembourg
(c) constatation de la disponibilité des documents requis conformément aux dispositions de l'article 267 (1) a), b), c) et
d) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;
(d) approbation de la fusion par absorption de «FINPADANA INTERNATIONAL S.A.» par la Société «CASAL-
GRANDE PADANA S.P.A.» (la Fusion) telle qu'envisagée par le projet commun de fusion du 16 avril 2015, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C n° 1086 du 25 avril 2015;
(f) divers.
VII. L'Assemblée, après délibération, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Représentant l'intégralité du capital social de la Société, les Actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire,
renoncent aux formalités de convocation, se considèrent dûment convoqué et déclarent avoir pleine connaissance de l'objet
des présentes résolutions qui leur ont été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale prend connaissance du rapport du conseil d’administration de la société FINPADANA INTER-
NATIONAL S.A. préqualifiée, relatif à la justification du point de vue juridique et économique de la fusion tel que prescrit
par l’article 265 de la Loi sur les Sociétés.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée constate que les Documents dont questions au point c) de l’ordre du jour sont disponibles.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d'approuver la Fusion sous les clauses et conditions telles que fixées par le Projet de Fusion sous
seing privé du 16 avril 2015, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C n° 1086 du 25 avril
2015.
L'Assemblée constate que, conformément au susdit projet de fusion, la Fusion est considérée comme effective d’un
point de vue compte et considérée comme réalisée:
«La fusion prendra effet à l’égard des tiers (effets réels) à compter de la date de l’inscription de l’acte de fusion au
Registre du Commerce où est sise la Société Absorbante (Reggio Emilia, Italie).
101353
L
U X E M B O U R G
Aux fins fiscales et de l’imputation comptable des opérations de la société Absorbée dans les comptes de la société
absorbante, et conformément à ce qui est prévu par la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, transposée au Luxembourg
dans les articles 17 bis et 170 (2) LITL (Luxembourg Income Tax Law) et en Italie dans les articles 172, alinéa 9, 178 et
179 du Décret Présidentiel 917/1986 et de l’article 2504-bis, alinéa 3, du Code Civil italien, à compter du jour où la fusion
produira ses propres effets réels.»
<i>Déclarationi>
Conformément à l'article 271 (2) de la Loi sur les Sociétés, le notaire instrumentant avoir vérifié et attesté l’existence
et la légalité des actes et formalités ayant incombé à la société absorbée en vue de la fusion opérée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, ledit mandataire a signé ensemble avec la notaire, l'original du
présent acte.
Signé: D. Brever, M. Krecké, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 2 juin 2015. 2LAC/2015/12051. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): André Muller.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2015.
Référence de publication: 2015096025/104.
(150106864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
A.S. Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 197.780.
STATUTS
L’an deux mil quinze, le vingt-deux mai
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Madame Angélique BOURGRAFF, épouse Grandjean, employée, née à Bastogne (B) le 21 mai 1975, demeurant à
B-6640 Vaux-sur-Sûre, 51H, Rosière la Grande;
2. Madame Sonia DEWALQUE, épouse Stordeur, sans profession, née à Bastogne (B) le 13 août 1975, demeurant à
B-6640 Vaux-sur-Sûre, 33, rue du Manège.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte d’une société à responsabilité limitée,
qu'elles déclarent constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «A.S. Services».
La société sera régie par les dispositions légales en vigueur, et notamment celles de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Le siège social de la société est établi sur le territoire de la commune de Winseler.
Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du où des associés.
La société pourra ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. La durée de la société est illimitée. Elle pourra être dissoute conformément à la loi.
Art. 4. La société a pour objet l’organisation et la réalisation de tous travaux administratifs et de secrétariat pour compte
de tiers.
En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières
qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le
développement.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.-EUR) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-quatre euros (124.-EUR) chacune.
La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,
sans qu'il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.
101354
L
U X E M B O U R G
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi que
des bénéfices.
Art. 6. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que du
consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans le même cas, elles ne
peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales
représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés
réunis en assemblée générale, qui fixent leurs pouvoirs.
Art. 8. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que
de l’exécution de leur mandat.
Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de
l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, sont consignées dans un registre tenu au
siège social.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix
proportionnellement au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant
qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant pour
objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant est à libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur participation
au capital social.
Art. 13. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou d’un associé n’entraîneront pas la
dissolution de la société.
Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,
nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif
après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils son propriétaires.
Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Mesure transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Madame Angélique BOURGRAFF prénommée:
50 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Madame Sonia DEWALQUE prénommée:
50 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros
(12.400 EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, tel qu’il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
101355
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000.-EUR
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant les personnes comparantes, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi à L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne,
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Bernard RISACK, comptable-fiscaliste, né à Montegnée (B) le 22 février 1969, demeurant professionnelle-
ment à L-4384 Ehlerange, 30 ZARE Ilot Ouest.
Vis-à-vis des tiers, la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la partie constituante sur la nécessité d'obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social
à l'article 4 des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Bourgraff, S. Dewalque, Anja Holtz.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mai 2015. EAC/2015/11684. Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 3 juin 2015.
Référence de publication: 2015096439/108.
(150107349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.
Stereolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 42.722.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015092603/10.
(150103334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Theta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 142.044.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 Juin 2015i>
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats de gérants de Mme Agnès LARUELLE, M. Garvan Rory
PIETERS et M. Martin VOGEL résidant professionnellement au 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, pour une nou-
velle période se terminant lors l’Assemblée Générale des Actionnaires qui se déroulera en 2016.
L’Assemblée Générale a également décidé d’élire Ernst & Young S.A., dont le siège social se situe Rue Gabriel Lipp-
mann, n° 7, L-5365 Munsbach, Luxembourg, en qualité de réviseur d’entreprise pour une nouvelle période se terminant
lors l’Assemblée Générale des Actionnaires qui se déroulera en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Société et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2015.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015092624/18.
(150103507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
101356
L
U X E M B O U R G
Digital Services XXXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 193.945.
In the year two thousand and fifteen, on the third day of June,
before us, Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG), a Societas Europaea existing under the laws of Germany, registered
with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 165662 B, having its registered
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (“Rocket”),
being the holder of twenty-five thousand (25,000) shares, and becoming the holder of one thousand two hundred (1,200)
series A1 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Berlin, Germany, on 1
st
June 2015; and
2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 191.426 (hereinafter “Holtzbrinck”),
becoming the holder of three thousand six hundred two (3,602) series A1 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 1
st
June 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Rocket is the sole shareholder of Digital Services XXXIV S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 193.945 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 7 January 2015, published in
the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 551 dated 27 February 2015. The articles of association were
amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 4 May 2015, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
Rocket representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general meeting of the
shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda whereby Holtz-
brinck participates and votes for purpose of agenda points 4 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Decision to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, so that the Company will hence have
two (2) classes of shares, represented by common shares (hereinafter “Common Shares”) and series A1 shares (hereinafter
“Series A1 Shares”).
2. Decision to convert the existing twenty-five thousand (25,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1)
each, into twenty-five thousand (25,000) Common Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, without can-
cellation of shares.
Acceptance of HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des
Sociétés) under number B 191.426, as new shareholder of the Company.
3. Increase of the Company’s share capital by an amount of four thousand eight hundred two euro (EUR 4,802) so as
to raise it from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) up to twenty-nine thousand eight hundred
two euro (EUR 29,802) by issuing four thousand eight hundred two (4,802) Series A1 Shares with a nominal value of one
euro (EUR 1) each.
4. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read
as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-nine thousand eight hundred two euros (EUR 29,802.00), represented
by:
5.1.1 twenty-five thousand (25,000) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
101357
L
U X E M B O U R G
5.1.2 four thousand eight hundred two (4,802) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
5. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services
XXXIV S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may
be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-nine thousand eight hundred two euros (EUR 29,802.00), represented
by
5.1.1 twenty-five thousand (25,000) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.2 four thousand eight hundred two (4,802) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
101358
L
U X E M B O U R G
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet SE (“Roc-
ket”) and the shareholder HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtzbrinck”, jointly with Rocket the “Investors” and
each also an “Investor”) to a company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock
Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is
directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct
or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Controlled” or
“Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing
shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a con-
tractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies
of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one
or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified
employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;
7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation proce-
dures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company,
if the shareholders of the Company hold more than 50% in any surviving legal entity after such transformation procedure.
7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of
first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased
shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is
rejected for lack of assets;
8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such
enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration of
redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its share
register and to proceed with the relevant filings required by law.
101359
L
U X E M B O U R G
8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one person;
independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way through
one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.
8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).
Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date
is the date before the redemption resolution.
9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding amounts
including interest.
9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert arbitrator
shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the Company. The
decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company and the
requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the redemption price and
the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption
price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a person
named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or partial
assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
11.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also
be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a
shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of
managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
11.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must
state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must
be sent to each shareholder in writing without undue delay.
11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be
specified in the respective convening notices of meeting.
101360
L
U X E M B O U R G
12.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or regis-
tered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of
notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary share-
holders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’ meeting
is not counted in the calculation of the period of notice.
12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another shareholder
authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.
12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders’
resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’ meeting (for
purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.
Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s shareholders are
only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is no
quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with Article
12.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this was
pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.
Art. 16. Shareholders’ resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders’ Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-
holders (ii) who also constitute a Super Majority:
16.1.1 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company; and
16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq. German
Stock Corporation Act (AktG));
16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of
any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation in
the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners;
16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases; and
16.2.4 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and
transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.
16.3 Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold all
the issued shares of that class.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or
by these articles of association to the general meeting of shareholders.
101361
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-
ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
21.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board (as defined below) for the legal transactions and
measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and
have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board (as defined below):
21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros
(EUR 200,000.00) in aggregate;
21.8.2 future transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other trans-
actions with derivative financial instruments;
21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
101362
L
U X E M B O U R G
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;
21.8.6 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party, excluding,
however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;
21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such
shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or
indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent
requirement pursuant to this Article
21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business of the Company and is at arm’s length;
21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options) outside
the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders’ agreement, if
any.
21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also required
for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further transactions
and measures requiring the consent of the Advisory Board (as defined below). The Advisory Board (as defined below) may
give its consent also in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
21.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in the
future.
Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and
class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board (“Advisory Board”). It shall consist of three (3) voting members. The
shareholders may by way of unanimous shareholders’ consent increase or decrease the number of voting members of the
Advisory Board.
24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous
shareholders’ consent.
24.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s respective
appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
24.3.1 two (2) voting members of the Advisory Board, each having two (2) votes, shall be nominated by Rocket in its
sole discretion; and
24.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by Holtzbrinck in its sole
discretion.
24.4 Each member of the Advisory Board may be represented by another member of the Advisory Board or any other
representative of the respective party. In this case a written proxy must be presented at the respective Advisory Board
meeting. For this purpose, Rocket and Holtzbrinck are entitled to appoint one substitute member for each Advisory Board
member.
101363
L
U X E M B O U R G
24.5 The Advisory Board may have non-voting members of the Advisory Board as observers.
24.6 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall
be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board, if any, may provide for further
provisions in particular on the selforganization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with
the simple majority of votes cast. The Advisory Board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar
quarter.
24.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
E. Audit and Supervision
Art. 25 Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
27.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities
of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with the
101364
L
U X E M B O U R G
provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent per-
mitted by Luxembourg law.
30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
6. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, as well as Mr Ruediger Trox, regardless of his
category, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders’ register of the
Company.
7. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, so
that the Company will hence have two (2) classes of shares, represented by common shares (hereinafter “Common Shares”)
and series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”).
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to convert the existing twenty-five thousand (25,000) shares, with a nominal
value of one euro (EUR 1) each, into twenty-five thousand (25,000) Common Shares, with a nominal value of one euro
(EUR 1) each, without cancellation of shares.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, aforementioned, as new share-
holder of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four thousand
eight hundred two euro (EUR 4,802) so as to raise it from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000)
up to twenty-nine thousand eight hundred two euro (EUR 29,802) by issuing four thousand eight hundred two (4,802)
Series A1 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
Four thousand eight hundred two (4,802) Series A1 Shares have been duly subscribed as follow:
- one thousand two hundred (1,200) Series A1 Shares have been subscribed by Rocket, aforementioned, for the price
of one thousand two hundred euro (EUR 1,200);
- three thousand six hundred two (3,602) Series A1 Shares have been subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, for
the price of three thousand six hundred two euro (EUR 3,602);
<i>Paymenti>
The four thousand eight hundred two (4,802) Series A1 Shares subscribed by Rocket and Holtzbrinck, have been entirely
paid up through a contribution in cash in an amount of four thousand eight hundred two euro (EUR 4,802).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of four thousand eight hundred two euro (EUR 4,802) is entirely allocated to the share
capital of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article five (5) of the articles of association of the Company so
that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-nine thousand eight hundred two euros (EUR 29,802.00), represented
by:
5.1.1 twenty-five thousand (25,000) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.2 four thousand eight hundred two (4,802) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
101365
L
U X E M B O U R G
<i>Sixth resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders decide to fully restate the articles of association
of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well
as Mr Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders register
of the Company.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 2,000.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am vierten Juni,
vor uns, Maître Cosita DELVAUX, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) bestehend
nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 165662 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),
Inhaberin von fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteilen und zukünftige Inhaberin von eintausendzweihundert (1.200)
Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 1. Juni 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland; und
2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend
unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter
der Nummer B 191.426 („Holtzbrinck“),
zukünftige Inhaberin von dreitausendsechshundertzwei (3.602) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 1. Juni 2015, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Rocket ist der alleinige Gesellschafter der Digital Services XXXIV S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 193.945, gegründet am 7. Januar 2015 gemäß einer Urkunde der
unterzeichnenden Notarin, welche am 27. Februar 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
551, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 4. Mai 2015 gemäß einer Urkunde der unter-
zeichnenden Notarin geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde.
Da Rocket das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und erklärt, auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet zu haben,
ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über jeden Punkt der folgen-
den Tagesordnung verhandeln, wobei Holtzbrinck ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und
stimmberechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung von zwei (2) Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, sodass die
Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen (die „Stammanteile“) und Anteilen der
Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“).
101366
L
U X E M B O U R G
2. Beschluss bezüglich der Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden fünfundzwanzigtausend
(25.000) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in fünfundzwanzigtausend (25.000) Stammanteile
mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
3. Aufnahme der HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, einer Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groß-
herzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés) unter der Nummer B 191.426, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro
(EUR 25.000) um einen Betrag von viertausendachthundertzwei Euro (EUR 4.802) auf einen Betrag von neunundzwan-
zigtausendachthundertzwei Euro (EUR 29.802) durch die Ausgabe von viertausendachthundertzwei (4.802) Anteilen der
Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
5. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunundzwanzigtausendachthundertzwei Euro (EUR 29.802,00),
bestehend aus
5.1.1 fünfundzwanzigtausend (25.000) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.2 viertausendachthundertzwei (4.802) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Digital Services XXXIV S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sons-
tige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
101367
L
U X E M B O U R G
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunundzwanzigtausendachthundertzwei Euro (EUR 29.802,00),
bestehend aus
5.1.1 fünfundzwanzigtausend (25.000) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.2 viertausendachthundertzwei (4.802) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-
gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechtenoder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern
übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung von An-
teilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter
Rocket Internet SE („Rocket“) und den Gesellschafter HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS („Holtzbrinck“, gemein-
schaftlich mit Rocket die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit einem solchen Investor verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen
Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder
indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von diesem
Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert
Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a) die Leitung der
Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten
der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder
indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberech-
tigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere
Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
101368
L
U X E M B O U R G
7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten, welcher
Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen
Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;
7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Umwand-
lungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmel-
zung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als
fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.
7.5 In den in Artikeln 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten
gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters
für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an
Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen
Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile ent-
spricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
101369
L
U X E M B O U R G
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.
10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschrif-
ten des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschaf-
terversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der
entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
12.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mit
einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals
vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
101370
L
U X E M B O U R G
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
12.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 15. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.
Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit
der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:
16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-
gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft; und
16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-
teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;
16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen; und
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.
16.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.
17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
19.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
101371
L
U X E M B O U R G
Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
20.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der
Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der für die
Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (wie unten definiert) für die unten genannten Rechts-
geschäfte und Maßnahmen im Einklang mit Artikel 24.5. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechts-
geschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des
Beirats (wie unten definiert) genehmigt wurden:
21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-
hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;
21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transak-
tionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streitwert
von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;
21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft
an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
101372
L
U X E M B O U R G
21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen. Als
solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt 15
der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheitsbe-
teiligung halten. Die Zustimmung gemäß diesem Artikel
21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und
marktüblichen Bedingungen unterliegt;
21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung
jeglicher Anteils- oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.
21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,
so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beirats (wie unten definiert) erfordern. Der Beirat (wie unten definiert) kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen
und Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Ver-
treter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine
Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat („Beirat“). Dieser besteht aus drei (3) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-
sellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Beirats erhöhen oder herabsetzen.
24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-
schafter festlegen und/oder verändern.
24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
24.3.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats mit je zwei (2) Stimmen werden von Rocket nach eigenem
Ermessen ernannt; und
24.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von Holtzbrinck nach eigenem Ermessen
ernannt.
101373
L
U X E M B O U R G
24.4 Jedes Mitglied des Beirats kann von jedem anderen Mitglieds des Beirats oder einem Vertreter der jeweiligen Partei
vertreten werden. In diesem Fall muss bei der jeweiligen Sitzung des Beirats eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden.
Zu diesem Zweck sind Rocket und Holtzbrinck berechtigt, ein Ersatzmitglied für jedes Beiratsmitglied zu ernennen.
24.5 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimmbe-
rechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.
24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der
Gesellschaft.
25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
27.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die
Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
101374
L
U X E M B O U R G
Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Andwendbares Recht
Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
7. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie
Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit unein-
geschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.
8. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, zwei (2) Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft zu schaf-
fen, sodass die Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen (die „Stammanteile“) und
Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“).
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt die Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden fünfund-
zwanzigtausend (25.000) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in fünfundzwanzigtausend (25.000)
Stammanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, vorbenannt, als neue Gesellschafterin
der Gesellschaft an.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) um einen Betrag von viertausendachthundertzwei Euro (EUR 4.802) auf
einen Betrag von neunundzwanzigtausendachthundertzwei Euro (EUR 29.802) durch die Ausgabe von viertausendach-
thundertzwei (4.802) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Viertausendachthundertzwei (4.802) Anteile der Serie A1 wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:
- eintausendzweihundert (1.200) Anteile der Serie A1 wurden ordnungsgemäß von Rocket, vorbenannt, zum Preis von
eintausendzweihundert Euro (1.200) gezeichnet;
- dreitausendsechshundertzwei (3.602) Anteile der Serie A1 wurden ordnungsgemäß von Holtzbrinck, vorbenannt, zum
Preis von dreitausendsechshundertzwei Euro (EUR 3.602) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Rocket und Holtzbrinck gezeichneten viertausendachthundertzwei (4.802) Anteile der Serie A1 wurden voll-
ständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von viertausendachthundertzwei Euro (EUR 4.802).
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde der unterzeichnenden Notarin
erbracht.
Die Einlage in Höhe von viertausendachthundertzwei Euro (EUR 4.802) wird vollständig dem Gesellschaftskapital der
Gesellschaft zugeführt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr
wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunundzwanzigtausendachthundertzwei Euro (EUR 29.802,00),
bestehend aus
101375
L
U X E M B O U R G
5.1.1 fünfundzwanzigtausend (25.000) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.2 viertausendachthundertzwei (4.802) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“ Sechster Beschluss
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Herrn Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.
Gezeichnet J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/17865. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. Juni 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015095086/1085.
(150105406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Tiafy SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 166.878.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015092666/9.
(150103600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
SPRT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 141.901.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015092601/10.
(150103951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
101376
ACF I Investment S.à r.l.
Adainvest S.A., SPF
Ad Valorem
Advent OT (Luxembourg) Holding S.à r.l.
Al Masaryk (Luxembourg) S.à.r.l.
Ambrosia CEE Holding
Ana Investments S.A.
Aria Structured Investments S.à r.l.
Artemide S. à r.l.
A.S. Services
A Table S.à r.l.
Balkinvest S.A.
Digital Services XXXIV S.à r.l.
Finpadana International S.A.
GL Europe Luxembourg III (US) Investments S.à r.l.
Globant S.A.
Horus SA
Lux Cogeba S.A.
Lux Gare
Mafrem Holding S.A.
Magellan Investment S.A.
Maragole S.A.
Mary H S.A.
Parc Helfent Participations S.A.
Phoenix B2 - Glatzerstrasse
Play Holdings 3 S.à r.l.
Polygonetic S.à.r.l.
Qatar Airways Luxembourg s.à.r.l.
Real Estate Engineering and Development S.A.
Scorlux SICAV-SIF
SLP III Investment Holding S.à r.l.
SMC Luxembourg S.à r.l.
Solumo S.A.
South Real Estate Investment S.A.
SPRT S.A.
Stereolux S.A.
Stingray S.à r.l.
Stone Holding S.à r.l.
SynerTrade S.A.
Theta S.à r.l.
Thomas Becker - Architekturbüro S.à r.l.
Tiafy SPF, S.A.
TMRD Luxembourg S.à.r.l.
Topsin Investments S.A.
Tremalux S.A.
Valindus S.A.