This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2091
14 août 2015
SOMMAIRE
Allianz Global Investors Renewables Invest-
ment Holding, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100330
Brelus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100322
Buongiorno S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100322
Centre de Recherche Public de la Santé . . . . .
100330
Dictame II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100365
Eltyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100323
Epicerie Blobierg S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100327
ESJ S.C.A. SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100326
Ets. Paul Vrehen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100327
Eurogroup S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100365
European Art Tour S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100326
European Jewellers I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
100325
Eurostone Srio S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100326
Evercare Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100326
Fermat 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100327
Field Point I-A RE 7 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
100328
F.L.D. Hygiène S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100327
I.C.I. S.A. (Immo Consult International) . . . .
100322
IMJA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100323
International Fashion Trading S.à r.l. . . . . . . .
100329
Invacare Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
100323
Iolita Corp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100323
Kensington UK Logistics (Bristol) S.à r.l. . . . .
100324
Kensington UK Office (Chester) S.à r.l. . . . . .
100325
Kensington UK Office (Crewe) S.à r.l. . . . . . .
100324
Kensington UK Office (Working) S.à r.l. . . . .
100332
Kings Falls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100322
L-21 General Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
100328
La Cantina Del Gusto SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
100328
LCO1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100325
Lealex Consult S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100325
Loula S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100330
LSF 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100366
LSREF4 Falcon Investments S.à r.l. . . . . . . . .
100366
Lune Holdings SPF SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100331
Lupercus Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100329
Minhal France S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100323
MML Capital Europe VI S.à r.l. . . . . . . . . . . .
100324
Nis Ganesha S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100340
Pacific Drillship Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100330
R. Linse Holding B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100341
Sienna Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100322
Somuchmore Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
100344
Trinter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100368
TSM Services (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . .
100329
UV S.A. S.P.F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100364
V.D.M. Evenements S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100329
Voltaire Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . .
100330
100321
L
U X E M B O U R G
Kings Falls, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 130.582.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015099667/9.
(150109778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Brelus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 171.741.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015091862/10.
(150103359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Buongiorno S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 147.939.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015091871/10.
(150103110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Sienna Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 178.406.
Les statuts coordonnés à la date du 17 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Paul MEYERS
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015094717/11.
(150104786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.
I.C.I. S.A. (Immo Consult International), Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 25, rue Pierre Federspiel.
R.C.S. Luxembourg B 107.210.
<i>Extrait de l'assemblée générale en date du 31 mars 2015i>
Le siège social de la société sera transféré du 7, Val Sainte Croix L - 1371 Luxembourg au 25, rue Pierre Federspiel L
- 1512 Luxembourg à compter de ce jour.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Pour extrait conforme
I.C.I. S.A. (Immo Consult International)
Signature
Référence de publication: 2015096081/14.
(150106699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
100322
L
U X E M B O U R G
IMJA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8325 Capellen, 98, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 134.798.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015096094/9.
(150106523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Eltyser, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 161.187.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015099429/9.
(150110040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Iolita Corp, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 182.642.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015096101/10.
(150106780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Invacare Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 12.501,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 169.438.
Les comptes annuels au 30 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2015.
Carsten SÖNS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015096088/12.
(150106870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Minhal France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 154.766.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2015.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015096166/13.
(150106226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
100323
L
U X E M B O U R G
MML Capital Europe VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 192.251.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société MML Capital Europe VI S.A. du 10 juin 2015i>
1. Acceptation de la démission de Madame Dalia Bleyer, née le 17 juin 1983 à Alytus, Lituanie, résidant profession-
nellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que administrateur
de la Société avec effet au 10 juin 2015.
2. Acceptation de la nomination de Madame Elke Leenders, née le 2 août 1980 à Maaseik, Belgique, résidant profes-
sionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que adminis-
trateur de la Société avec effet au 10 juin 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2015.
Référence de publication: 2015096183/17.
(150106924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Kensington UK Office (Crewe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 182.217.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 8 juin 2015, que l'associé unique de la Société, BREDS
Europe 1NQ S.à r.l. a transféré la totalité de 750 parts sociales qu'il détenait à:
(1) Kensington UK Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg,
ayant son siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 197.598;
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
1. Kensington UK Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015096116/18.
(150106540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Kensington UK Logistics (Bristol) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 184.155.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 8 juin 2015, que l'associé unique de la Société, BRE/Europe
7Q S.à r.l. a transféré la totalité de 750 parts sociales qu'il détenait à:
(1) Kensington UK Logistics Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Lu-
xembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 197.633;
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
1, Kensington UK Logistics Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015096114/19.
(150106542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
100324
L
U X E M B O U R G
Lealex Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 148.504.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015096144/9.
(150106260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
LCO1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 187.622.
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg en date du 28 mai 2015i>
- en vertu de l'article 12.1 des statuts, Monsieur Hervé MOTTE est nommé Président du Conseil d'Administration. Son
mandat suivra son mandat d'Administrateur et viendra donc à échéance en 2020;
Référence de publication: 2015096142/10.
(150106762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
European Jewellers I S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 139.072.666,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 155.031.
EXTRAIT
En date du 17 décembre 2014, les actionnaires de la société ont pris la résolution de nommer Ernst & Young S.A. en
tant que réviseur d'entreprise agréé domicilié au 7 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach jusqu'à l'Assemblée Générale
qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EUROPEAN JEWELLERS I S.A.
Christophe Gammal / Michael Goosse
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2015100386/16.
(150110781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Kensington UK Office (Chester) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 185.944.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 8 juin 2015, que l'associé unique de la Société, BRE/Europe
7NQ S.à r.l, a transféré la totalité de 750 parts sociales qu'il détenait à:
(1) Kensington UK Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg,
ayant son siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 197.598;
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
1. Kensington UK Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015096115/19.
(150106541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
100325
L
U X E M B O U R G
European Art Tour S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 5, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 148.903.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100385/9.
(150110295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Eurostone Srio S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3a, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 183.026.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2015.
<i>Pour EUROSTONE SRIO S.C.A.i>
Référence de publication: 2015100388/11.
(150110608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
ESJ S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à
Risque.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 169.860.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ESJ S.C.A. SICAR
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2015100377/12.
(150110980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Evercare Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 138.057.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 3 juin 2015:i>
L'assemblée générale ordinaire décide:
- de renouveler, pour une période d'un an se terminant avec l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra
en 2016, les Administrateurs suivants:
* Monsieur Antoine Böhler, Administrateur de type A
* Monsieur Franck Payrar, Administrateur de type A
* Monsieur Didier Bensadoun, Administrateur de type B
- de renouveler PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé, pour une
période d'un an se terminant avec l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016.
A l'issue de l'assemblée, le Conseil d'Administration est composé comme suit:
- Monsieur Antoine Böhler, Administrateur de type A, 7, rue des Battoirs, CH-1211, Genève 4 Plainpalais, Suisse.
- Monsieur Franck Payrar, Administrateur de type A, 37 A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Monsieur Didier Bensadoun, Administrateur de type B, 37 A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2015.
Référence de publication: 2015100389/22.
(150110329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
100326
L
U X E M B O U R G
Ets. Paul Vrehen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7475 Schoos, 28, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 68.290.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100380/9.
(150110201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
F.L.D. Hygiène S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 124, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 55.954.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015100395/9.
(150110894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Fermat 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 169.330.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 26 juin 2015.
Référence de publication: 2015100397/11.
(150110622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
Epicerie Blobierg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4818 Rodange, 16, avenue Dr. Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 149.477.
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date
du 15 juin 2015, numéro 2015/1338 de son répertoire, enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 juin 2015, relation:
1LAC/2015/19165 de la société à responsabilité limitée "EPICERIE BLOBIERG S.à r.l.", avec siège social à L-4818
Rodange, 16, avenue Dr. Gaasch, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 149 477, constituée suivant acte reçu
par le notaire Georges d'HUART, alors de résidence à Pétange, en date du 16 novembre 2009, publié au Mémorial C numéro
2465 du 18 décembre 2009, ce qui suit:
- Monsieur Antonio DE SOUSA NEVES et Madame Maria Adilia MACHADO DE SOUSA, seuls associés, ont déclaré
procéder à la dissolution et à la liquidation de la société prédite, avec effet au 15 juin 2015,
- la société dissoute n'a plus d'activités.
- les associés ont déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'ils assument tous les éléments
actifs et passifs éventuels de la société dissoute.
- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l'adresse suivante:
L-4831 Rodange, 63, route de Longwy.
Bascharage, le 26 juin 2015.
Pour extrait conforme
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2015100375/25.
(150110772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
100327
L
U X E M B O U R G
L-21 General Investments S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.070.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 102.400.
Le bilan du 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015096841/10.
(150107839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.
La Cantina Del Gusto SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3212 Bettembourg, 3, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 132.186.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015096842/10.
(150107813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.
Field Point I-A RE 7 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 122.587.
Il résulte que la Société a pris acte en date du 17 juin 2015:
- de la démission de Monsieur TSCHEPE Christoph en tant que gérant B de la Société avec effet au 17 juin 2015;
- de la démission de Monsieur DOUGHERTY James en tant que gérant A de la Société avec effet au 17 juin 2015;
- de la démission de Monsieur GOFFIN Julien en tant que gérant B de la Société avec effet au 17 juin 2015;
- de la démission de Monsieur BUTT Nicholas Alec Geoffrey en tant que gérant A de la Société avec effet au 17 juin
2015;
- de la démission de Monsieur BEISSEL Pierre en tant que gérant B de la Société avec effet au 17 juin 2015;
La Société a décidé également de nommer comme conseil de gérance:
- la Société Exequtive Partners S.A., une société anonyme de droit luxembourgeoise, ayant son siège social au 48,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et enregistrée au Registre de
Commerce et Société du Luxembourg sous numéro B 174367, en tant que gérant unique de la Société avec effet au 17 juin
2015 et pour une durée indéterminée.
Résultant des décisions susmentionnées, le gérant unique de la Société est:
- Exequtive Partners S.A.
Il est aussi notifié que:
Suite à la cession de parts sociales intervenue en date du 17 juin 2015 entre Field Point I-A S. à r.l. une société à
responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et Société du Luxembourg sous numéro B121088, et
Exequtive Partners S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société
du Luxembourg sous numéro B 174367, les 500 parts sociales de la de la Société sont désormais détenues comme suit:
- Exequtive Partners S.A. est l'associé unique de la Société à compter du 17 juin 2015 et détient les 500 parts sociales
de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Exequtive Partners S.A.
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2015100402/34.
(150110804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.
100328
L
U X E M B O U R G
V.D.M. Evenements S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 4-6, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 162.771.
Les comptes annuels abrégés au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015094820/9.
(150104258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.
TSM Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 152.398.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015094804/10.
(150104957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.
Lupercus Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 161.803.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 mai 2015.
Pour statuts coordonnés
Référence de publication: 2015096153/11.
(150106790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
International Fashion Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 245.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 51.129.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des associés tenue le 29 mai 2015 au siège social de la sociétéi>
Les mandats des gérants et du réviseur d'entreprises agréé venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la
période expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016 pour statuer sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015,
comme suit:
<i>Conseil de gérance:i>
- Monsieur Guido RAMI, demeurant au 165, viale Provinciale, I-40056 Valsamoggia - Località Crespellano (BO), gérant
et président;
- Madame Vania BARAVINI, demeurant au 89, rue Clair-Chêne, L-4062 Esch-sur-Alzette, gérant;
- Monsieur Federico FRANZINA, demeurant professionnellement au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, gérant.
<i>Personne chargée du contrôle des comptes:i>
- BDO Audit S.A., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.570, réviseur d'entreprises agréé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015096813/23.
(150107608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.
100329
L
U X E M B O U R G
Loula S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.
R.C.S. Luxembourg B 124.630.
Der Jahresabschluss auf den 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015095368/9.
(150105679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Pacific Drillship Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 162.253.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015094627/9.
(150104751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.
Centre de Recherche Public de la Santé, Etablissement d'Utilité Publique.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 84, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg J 34.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015095348/9.
(150105891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Allianz Global Investors Renewables Investment Holding, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 180.573.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015091733/9.
(150103309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Voltaire Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 10, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 97.692.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 12 février 2015i>
L'assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur la société Kingsbridge Square S.A. (RC Luxembourg:
B 162 847) ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 10 Avenue de la Porte Neuve, représentée par son Administrateur
Délégué Madame Khansa Sbouai, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2017.
L'assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur Madame SBOUAI Khansa, née à Tunis (Tunisie) le
10 septembre 1968 et demeurant à L-8328 Capellen, 61 rue du Kiem, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en l'an 2017.
L'assemblée générale décide de nommer administrateur-délégué Madame SBOUAI Khansa, née à Tunis (Tunisie) le 10
septembre 1968 et demeurant à L-8328 Capellen, 61 rue du Kiem, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
l'an 2017.
Madame SBOUAI Khansa peut représenter la société par sa signature unique.
L'assemblée générale décide de nommer administrateur-délégué Monsieur Gilles CHAVANAC , né le 6 avril 1964 à
bort les Orgues (France) , et demeurant à L-8328 Capellen, 61 rue du Kiem, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en l'an 2017.
Monsieur CHAVANAC Gilles peut représenter la société par sa signature unique.
Référence de publication: 2015097117/22.
(150107037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.
100330
L
U X E M B O U R G
Lune Holdings SPF SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 161.964.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of the month of June
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Clarmond Investment Solutions AG, , a corporation organised under the laws of Switzerland, having its registered office
at Bannhaldenstrasse 32a, CH-8500 Frauenfeld, Switzerland, and registered with the commercial register of the canton of
Thurgau under CH-440.3.028.151-8 (the “Principal”),
represented by its director with sole power of signature, Mr Gerald Carl GONZENBACH.
The appearing party declared the following and requested the notary to act:
I. Lune Holdings SPF SA (the "Company"), having its registered office at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, under number B
161.964, has been incorporated by deed of the undersigned notary on 1 July 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations on 16 September 2011, number 2190.
II. That the subscribed capital of the Company is presently set at forty-eight thousand US Dollars (USD 48,000) repre-
sented by forty-eight thousand (48,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1).
III. The Principal is the owner of all outstanding registered shares of the Company with a par value of one US Dollar
(USD 1), representing the entire outstanding share capital of the Company;
IV. The Principal declares that he has full knowledge of the financial standing and position of the Company;
V. The Principal, as the sole shareholder, makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company
and assumes the function of liquidator;
VI. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive
all assets of the Company and acknowledges that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution;
VII. The Principal gives discharge to all directors in office and to the statutory auditor of the Company in office in
respect of their mandate up to this date;
VIII. The shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled; and
IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered
office of the Company at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
After reading the present deed to the representative of the appearing party, known to the notary by his name, first name,
civil status and residence, the said representative has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le cinquième jour du mois de juin.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé.
A COMPARU:
Clarmond Investment Solutions AG, une société de droit suisse, ayant son siège social à Bannhaldenstrasse 32a,
CH-8500 Frauenfeld, Suisse et inscrite au registre commercial du canton de Thurgovie sous le numéro CH-440.3.028.151-8
(la «Comparante»),
représentée par son administrateur avec pouvoir de signature individuel, Monsieur Gerald Carl GONZENBACH.
La Comparante a déclaré et a requis le notaire d'acter:
I. Que Lune Holdings SPF SA ("la Société"), ayant son siège social à 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro B
161.964, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1
er
juillet 2011, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations le 16 septembre 2011, numéro 2190.
100331
L
U X E M B O U R G
II. Que le capital souscrit de la Société est actuellement de quarante-huit mille dollars des Etats-Unis (USD 48.000)
représenté par quarante-huit mille (48.000) actions ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1).
III. Que la Comparante est le propriétaire de toutes les actions nominatives de la Société ayant une valeur nominale d'un
dollar des Etats-Unis (1 USD) en circulation représentant l'entièreté du capital en émission de la Société.
III. Que la Comparante déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l'état financier de la susdite
Société.
IV. Que la Comparante, en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société et
assume la fonction de liquidateur.
V. Que la Comparante déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société
et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (s'il y en a) de la Société après sa dissolution.
VI. Que décharge pleine et entière est accordée par la Comparante aux administrateurs et au commissaire aux comptes
en fonction jusqu'à ce jour.
VII. Qu'il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.
VIII. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social 291, Route
d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
<i>Déclarationi>
A la demande de la partie comparante, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et
sur décision de la partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait
foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au représentant de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit représentant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. C. GONZENBACH, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 juin 2015. 2LAC/2015/12770. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 16 juin 2015.
Référence de publication: 2015092280/83.
(150103748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Kensington UK Office (Working) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.669.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of the month of June.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Kensington UK Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000) and in the process of being registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,
represented by Maître Ségolène Le Marec, maître en droit professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy
which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company “Kensington UK Office (Woking) S.à r.l.” (société à responsabilité limitée)
which is hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Kensington UK
Office (Woking) S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become
shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
100332
L
U X E M B O U R G
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream guarantees), grant security interests,
grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the
same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000)
represented by seven hundred fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pounds Sterling (GBP 20) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
100333
L
U X E M B O U R G
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability”
and “expenses” shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.
100334
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:
100335
L
U X E M B O U R G
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price
Kensington UK Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15,000
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles
of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 8 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under number B 195.140.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English
language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünften Tag des Monats Juni,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen,
Kensington UK Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxem-
burgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital fünfzehntausend
Pfund Sterling (GBP 15.000) beträgt, und die dabei ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg eingetragen
zu werden,
hier vertreten durch Maître Ségolène Le Marec, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer
privatschriftlichen Vollmacht welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde
eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) “Kensington UK Office (Woking) S.à r.l.”
wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
“Kensington UK Office (Woking) S.à r.l.” (die “Gesellschaft”) wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen,
die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream als auch side-stream Bürgschaften), Sicherheiten
leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt
oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
100336
L
U X E M B O U R G
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-
denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die
Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfzehntausend
Pfund Sterling (GBP 15.000), eingeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je
zwanzig Pfund Sterling (GBP 20).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht
anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die
keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
100337
L
U X E M B O U R G
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage”, „Streitsache”, „Prozess” oder
„Verfahren” finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit”
und „Ausgaben” beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
100338
L
U X E M B O U R G
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-
schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich
nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
100339
L
U X E M B O U R G
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2015 enden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
in bar eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
Kensington UK Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15.000
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15.000
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 8 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue
Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer
B 195.140.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen
Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: S. LE MAREC, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/17892. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 16. Juni 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015092244/451.
(150103831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Nis Ganesha S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 28.735.139,88.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 156.279.
Les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2014 de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walferdange.
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2015096943/12.
(150107156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.
100340
L
U X E M B O U R G
R. Linse Holding B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.160,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 158.772.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of May, before Maître Jacques Kesseler, notary, residing
in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
Is held
an extraordinary general meeting of the sole shareholder of R. Linse Holding B.V./ S.à r.l., a Luxembourg private limited
liability company (Société à responsabilité limitée), having its principal establishment and central administration at 6, rue
Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg and its registered office at Vrouwe Meilendislaan 16, 2553 EX, the Hague, the
Netherlands, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 158.772 (the “Com-
pany”). The principal establishment and central administration of the Company was migrated from the Netherlands to
Luxembourg on 31 December 2010 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, C - N° 950 of 10 May 2011. The articles of association of the Company (the “Articles”) have
never been amended since.
There appears:
Mr. Rodger Linse, an individual born on 19 October 1969 in Gravenhage, The Netherlands, and residing at Gravin
Machteldlaan 24, 2553 EV The Hague, the Netherlands, being the sole shareholder of the Company (the “Sole Shareholder”)
here represented by MRS Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally at Pétange, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
The proxyholder, acting on behalf of the Sole Shareholder, requests the notary to record the following:
I. that all the 400 (four hundred) shares with a par value of EUR 45.40 (forty five euros and forty euro cents) each,
representing the entire subscribed share capital of the Company are duly represented at the meeting, which is thus regularly
constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda; and
II. that the agenda is worded as follows:
1. waiver of the convening notice;
2. approval of the Company's interim accounts for the current financial year dated 29 May 2015, such interim accounts,
being the final accounts of the Company as of the migration date and that will be used in Luxembourg for income tax
purposes;
3. transfer of the Company's principal establishment and central administration from the Grand Duchy of Luxembourg
to the Netherlands (the “Migration”) and a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aans-
prakelijkheid) under the name "R. Linse Holding B.V." and amendment and full restatement of the Company's articles of
association (the “Articles”) for the purpose of its transfer and continuation in the Netherlands;
4. termination of the mandate of and granting of discharge (quitus) to the sole manager of the Company and statutory
appointment of the new directors of Company effective as of the migration date;
5. approval of further actions and formalities linked to the Migration; and
6. miscellaneous.
These facts exposed and recognised accurate by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder passes the following reso-
lutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital being represented at the present meeting, the Sole Shareholder waives the convening
notice, the Sole Shareholder represented considers itself as duly convened and declares having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve the Company's interim accounts (balance sheet and profit
and loss account) for the current financial year (i.e, from 1 January 2015 to 29 May 2015, attached hereto as a schedule)
(the “Interim Accounts”). Such Interim Accounts, being the final accounts of the Company as of the Migration Date (as
defined here-below) and that will be used in Luxembourg for income tax purposes.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the Company's principal establishment and central administration from Lu-
xembourg to the Netherlands. The decisions of control with respect to the Company will be made in the Netherlands, and
100341
L
U X E M B O U R G
the direction, operation and administration of the Company will be effected and executed in the Netherlands. Accordingly,
the Sole Shareholder resolves to apply for registration by way of continuation as a private limited liability company (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) pursuant to the Article 2:175 of the Dutch Civil Code of the Netherlands.
The Sole Shareholder resolves to transfer the principal establishment and central administration of the Company to
Vrouwe Meilendislaan 16, 2553 EX, The Hague, the Netherlands, effective as of the date on which all the formalities under
both the laws of the Netherlands and the laws of Luxembourg which are required to give effect to the Migration are fulfilled
(the “Migration Date”).
The Sole Shareholder acknowledges that, as a consequence of the Migration (i) the Company will cease to be a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by Luxembourg law without being dissolved, and
subsequently (ii) the Company, keeping its legal personality, will be governed by the laws of the Netherlands as a private
limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), as from the Migration Date.
The Sole Shareholder resolves to restate the Articles in their entirety in order to adopt the articles of association of a
private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), governed by the laws of the
Netherlands, substantially in the form of the draft articles of association presented to the Sole Shareholder, effective as of
the Migration Date, attached hereto as a schedule.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to terminate the mandate of sole manager of the Company with effect on or immediately
after the Migration Date.
The Sole Shareholder also resolves to grant it discharge (quitus) for the performance of its mandate.
The Sole Shareholder resolves to appoint the following individual as member of the board of director of the Company,
effective as of the Migration Date:
- Mr. Rodger Linse, born on October 19, 1969 in Gravenhage, the Netherlands, having its address at Gravin Machteldlaan
24, 2553 EV The Hague, the Netherlands.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve and hereby approves any and all further actions necessary or useful to the
implementation of the Migration.
In this respect, the Sole Shareholder resolves that the Company will be struck off from the Luxembourg Trade and
Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) conditional upon completion of all the formalities with respect
to the Migration and the registration of the Company, as a private limited liability company (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid), in the Register of Companies of the Netherlands.
The Sole Shareholder furthermore resolves to authorise and empower any of any employee Intertrust Luxembourg S.à
r.l., 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, acting individually and severally under his/her sole signature, on behalf
of the Company, to perform any and all actions which are necessary or useful to the implementation of the Migration in
Luxembourg, and in particular to execute, deliver and perform under any and all documents, certificates, instruments,
notices and agreements in relation to the Migration.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the proxyholder of
the Sole Shareholder, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version
shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this deed.
The deed having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, who is known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de mai, par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence
à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg.
Se tient
l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») de l'associé unique de R. Linse Holding B.V./S.à r.l., une société
à responsabilité limitée ayant son principal établissement et l'administration centrale au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, et son siège social au Vrouwe Meilendislaan 16, 2553 EX, la Haye, les Pays-Bas, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.772 (la «Société»). Le principal établissement
et l'administration centrale de la Société a été migré des Pays-Bas au Luxembourg en date du 31 Décembre 2010 en vertu
d'un acte du notaire Maître Francis Kesseler, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association, C-N °950 du 10 mai
2011. Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont jamais été modifiés.
Comparait:
100342
L
U X E M B O U R G
M. Rodger Linse, une personne physique, né le 19 octobre 1969 à Gravenhage, Pays-Bas, et résidant à Gravin Mach-
teldlaan 24, 2553 EV la Haye, Pays-Bas, étant l'associé unique de la Société (l'«Associé Unique»)
ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pé-
tange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumen-
taire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités compétentes.
Le mandataire, agissant au nom de l'Associé Unique, demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Que toutes les 400 (quatre-cent) part sociales ayant une valeur nominale de EUR 45,40 (quarante cinq euros et quarante
centimes) chacune, représentant la totalité du capital social souscrit de la Société, étant dûment représentées à la présente
Assemblée, celle-ci est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre
du jour; et
II. Que l'ordre du jour est libellé comme suit:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. constatation et approbation des comptes intérimaires de l'exercice en cours de la Société en date du 29 mai 2015, ces
comptes intérimaires, étant les derniers comptes de la Société à la date de la redomiciliation et seront utilisés au Luxembourg
aux fins de l'impôts sur le revenu.
3. transfert du principal établissement et l'administration centrale du Grand-Duché du Luxembourg aux Pays-Bas (la
«Redomiciliation») et continuité de la Société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid) sous la dénomination “R. Linse Holding B.V.” et modification et refonte des statuts de la
Société (les “Statuts”) dans le but de sa redomiciliation et de sa continuité aux Pays-Bas.
4. fin des mandats de et décharge (quitus) donnée aux membres du conseil de gérance et nomination des nouveaux
gérants de la Société avec effet à la date de la redomiciliation.
5. approbation d'autres démarches et formalités liées à la Redomiciliation; et
6. divers.
Ces faits étant exposés et reconnus exacts par l'Associé Unique, celui-ci a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Associé Unique renonce aux formalités de
convocation, l'Associé Unique se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de prendre acte et, pour autant que de besoin, d'approuver et par la présente prend acte et,
autant que de besoin, approuve les comptes intérimaires (le bilan et le compte de profits et pertes) de la Société pour l'année
sociale en cours (c'est à dire du 1 janvier 2015 au 29 mai 2015, annexés au présent acte) (les “Comptes Intérimaires”). Ces
Comptes Intérimaires étant les derniers comptes de la Société à la Date de la Redomiciliation (telle que définie ci-dessous)
et seront utilisés au Luxembourg aux fins de l'impôts sur le revenu.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le principal établissement et l'administration centrale de la Société du Luxembourg
aux Pays-Bas. Les décisions d'administration liées à la Sociétés seront prises aux Pays-Bas, et la direction, la gestion et
l'administration de la Société auront lieu et seront exécutées aux Pays-Bas. Il s'ensuit que l'Associé Unique décide de
demander l'enregistrement par voie de continuité de la Société sous forme d'une société à responsabilité limitée (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) conformément à l'Article 2:175 du Code Civil Néerlandais des Pays-Bas.
L'Associé Unique décide de transférer le principal établissement et l'administration centrale au Vrouwe Meilendislaan
16, 2553 EX, la Haye, les Pays-Bas, avec effet à la date à laquelle toutes les formalités requises à la fois en droit des Pays-
Bas et en droit luxembourgeois pour rendre la Redomiciliation effective auront été accomplies (la «Date de la Redomici-
liation»).
L'Associé Unique constate que, suite à la Redomiciliation, (i) la Société cessera d'être une société à responsabilité limitée
régie par le droit luxembourgeois sans pour autant être dissoute, et par conséquent (ii) la Société conservant sa personnalité
juridique, sera régie par les droit des Pays-Bas sous forme d'une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid), à compter de la Date de la Redomiciliation.
L'Associé Unique décide de refondre les Statuts dans leur intégralité afin de prendre la forme de statuts d'une société à
responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), régie par les lois des Pays-Bas, principa-
lement sous la forme de projets de statuts présenté à l'Associé Unique, avec effet à la Date de la Redomiciliation, annexé
à la présente.
100343
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de mettre fin aux mandats des membres du conseil de gérance avec effet à la Date de la
Redomiciliation ou immédiatement après.
L'Associé Unique décide également de leur donner décharge (quitus) pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs.
L'Associé Unique décide de nommer la personne suivante en tant que membre du conseil d'administration de la Société,
avec effet à la Date de la Redomiciliation.
- M. Rodger Linse, né le 19 octobre 1969 à Gravenhage, Pays-Bas, et résidant à Gravin Machteldlaan 24, 2553 EV la
Haye, Pays-Bas.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver et approuve par la présente toute démarche ainsi que toutes les démarches néces-
saires ou utiles à la réalisation de la Redomiciliation.
A ce sujet, l'Associé Unique décide que la Société sera radiée du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg sous réserve que toutes les formalités relatives à la Redomiciliation et l'enregistrement de la Société sous forme de
société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) aient été effectuées auprès du
registre de commerce des Pays-Bas.
L'Associé Unique décide en outre d'autoriser et de donner pouvoir à tout employé de Intertrust Luxembourg S.à r.l., 6,
rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, agissant individuellement et séparément en vertu de sa seule signature, au nom
de la Société, pour entreprendre toutes les démarches qui seront nécessaires ou utiles à la réalisation de la Redomiciliation
de Luxembourg, et plus spécifiquement exécuter, remettre et donner effet à tous les documents, certificats, instruments,
notices et contrats en rapport avec la Redomiciliation.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande du mandataire de l'Associé Unique, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la requête du mandataire de l'Associé Unique, il
est précisé qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date des présentes, à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel,
état et demeure, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 juin 2015. Relation: EAC/2015/12350. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015094671/196.
(150104317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.
Somuchmore Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.874,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 194.134.
In the year two thousand and fifteen, on the third day of June,
before us, Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG), a Societas Europaea existing under the laws of Germany, registered
with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 165662 B, having its registered
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (“Rocket”),
being the holder of fifteen thousand (15,000) shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Berlin, Germany, on 1
st
June 2015; and
2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 191.426 (hereinafter “Holtzbrinck”),
becoming the holder of two thousand eight hundred seventy-four (2,874) series A1 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 2
nd
June 2015.
100344
L
U X E M B O U R G
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Rocket is the sole shareholder of Somuchmore Global S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée in-
corporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 194.134 and incorporated under the name of “Digital Services XXXVIII S.à r.l.” pursuant to a deed of the
undersigned notary, on 7 January 2015, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 669
dated 11 March 2015. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary on 23 April 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Rocket representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general meeting of the
shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda whereby Holtz-
brinck participates and votes for purpose of agenda points 4 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Decision to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, so that the Company will hence have
two (2) classes of shares, represented by common shares (hereinafter “Common Shares”) and series A1 shares (hereinafter
“Series A1 Shares”).
2. Decision to convert (i) the existing fourteen thousand forty-two (14,042) shares, with a nominal value of one euro
(EUR 1) each, into fourteen thousand forty-two (14,042) Common Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
and (ii) the existing nine hundred fifty-eight (958) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, into nine hundred
fifty-eight (958) Series A1 Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, without cancellation of shares.
3. Acceptance of HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et
des Sociétés) under number B 191.426, as new shareholder of the Company.
4. Increase of the Company's share capital by an amount of two thousand eight hundred seventy-four euro (EUR 2,874)
so as to raise it from its current amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) up to seventeen thousand eight hundred
seventy-four euro (EUR 17,874) by issuing two thousand eight hundred seventy-four (2,874) Series A1 Shares with a
nominal value of one euro (EUR 1) each.
5. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read
as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at seventeen thousand eight hundred and seventy-four euros (EUR 17,874.00),
represented by:
5.1.1 fourteen thousand and forty-two (14,042) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.2 three thousand eight hundred thirty-two (3,832) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00)
each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
6. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Somuchmore
Global S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
100345
L
U X E M B O U R G
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may
be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at seventeen thousand eight hundred and seventy-four euros (EUR 17,874.00),
represented by
5.1.1 fourteen thousand and forty-two (14,042) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.2 three thousand eight hundred thirty-two (3,832) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00)
each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet SE (“Roc-
ket”) and the shareholder HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtzbrinck”, jointly with Rocket the “Investors” and
100346
L
U X E M B O U R G
each also an “Investor”) to a company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock
Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is
directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct
or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Controlled” or
“Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing
shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a con-
tractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies
of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one
or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified
employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;
7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation proce-
dures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company,
if the shareholders of the Company hold more than 50% in any surviving legal entity after such transformation procedure.
7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of
first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased
shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is
rejected for lack of assets;
8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such
enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration of
redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its share
register and to proceed with the relevant filings required by law.
8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one person;
independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way through
one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.
8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).
Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date
is the date before the redemption resolution.
9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding amounts
including interest.
9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert arbitrator
shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the Company. The
decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company and the
requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the redemption price and
the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption
price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
100347
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a person
named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or partial
assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
11.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also
be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a
shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of
managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
11.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must
state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must
be sent to each shareholder in writing without undue delay.
11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be
specified in the respective convening notices of meeting.
12.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or registered
letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of notice of
at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary shareholders'
meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders' meeting is not
counted in the calculation of the period of notice.
12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another shareholder
authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.
12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders'
resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders' meeting (for
purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.
Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders are
only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is no
quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with Article
100348
L
U X E M B O U R G
12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this was
pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.
Art. 16. Shareholders' resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders' Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of shareholders
(ii) who also constitute a Super Majority:
16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company; and
16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq. German
Stock Corporation Act (AktG));
16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of
any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation in
the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners;
16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases; and
16.2.4 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and
transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.
16.3 Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold all
the issued shares of that class.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to ful-fill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or
by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
100349
L
U X E M B O U R G
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-
ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
21.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board (as defined below) for the legal transactions and
measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and
have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board (as defined below):
21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros
(EUR 200,000.00) in aggregate;
21.8.2 future transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other trans-
actions with derivative financial instruments;
21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;
21.8.6 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party, excluding,
however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;
21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such
shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or
indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent
requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business of
the Company and is at arm's length;
21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options) outside
the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders' agreement, if
any.
21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also required
for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further transactions
and measures requiring the consent of the Advisory Board (as defined below). The Advisory Board (as defined below) may
give its consent also in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
100350
L
U X E M B O U R G
21.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in the
future.
Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and
class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board (“Advisory Board”). It shall consist of three (3) voting members. The
shareholders may by way of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members of the
Advisory Board.
24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous
shareholders' consent.
24.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's respective
appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
24.3.1 two (2) voting members of the Advisory Board, each having two (2) votes, shall be nominated by Rocket in its
sole discretion; and
24.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by Holtzbrinck in its sole
discretion.
24.4 Each member of the Advisory Board may be represented by another member of the Advisory Board or any other
representative of the respective party. In this case a written proxy must be presented at the respective Advisory Board
meeting. For this purpose, Rocket and Holtzbrinck are entitled to appoint one substitute member for each Advisory Board
member.
24.5 The Advisory Board may have non-voting members of the Advisory Board as observers.
24.6 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall
be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board, if any, may provide for further
provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with
the simple majority of votes cast. The Advisory Board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar
quarter.
24.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
E. Audit and supervision
Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
100351
L
U X E M B O U R G
25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
27.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities
of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with the
provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted
by Luxembourg law.
30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
7. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, as well as Mr Ruediger Trox, regardless of his
category, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders' register of the
Company.
8. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, so
that the Company will hence have two (2) classes of shares, represented by common shares (hereinafter “Common Shares”)
and series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”).
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to convert (i) the existing fourteen thousand forty-two (14,042) shares,
with a nominal value of one euro (EUR 1) each, into fourteen thousand forty-two (14,042) Common Shares, with a nominal
value of one euro (EUR 1) each; and (ii) the existing nine hundred fifty-eight (958) shares, with a nominal value of one
100352
L
U X E M B O U R G
euro (EUR 1) each, into nine hundred fifty-eight (958) Series A1 Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each,
without cancellation of shares.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, aforementioned, as new share-
holder of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand
eight hundred seventy-four euro (EUR 2,874) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000)
up to seventeen thousand eight hundred seventy-four euro (EUR 17,874) by issuing two thousand eight hundred seventy-
four (2,874) Series A1 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
Two thousand eight hundred seventy-four (2,874) Series A1 Shares have been duly subscribed by Holtzbrinck, for the
price of two thousand eight hundred seventy-four euro (EUR 2,874).
<i>Paymenti>
The two thousand eight hundred seventy-four (2,874) Series A1 Shares subscribed by Holtzbrinck, have been entirely
paid up through a contribution in cash in an amount of two thousand eight hundred seventy-four euro (EUR 2,874).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of two thousand eight hundred seventy-four euro (EUR 2,874) is entirely allocated to
the share capital of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article five (5) of the articles of association of the Company so
that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at seventeen thousand eight hundred and seventy-four euros (EUR 17,874.00),
represented by:
5.1.1 fourteen thousand and forty-two (14,042) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.2 three thousand eight hundred thirty-two (3,832) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00)
each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
<i>Sixth resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders decide to fully restate the articles of association
of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well
as Mr Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders register
of the Company.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 2,000.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
100353
L
U X E M B O U R G
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dritten Juni,
vor uns, Maître Cosita DELVAUX, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) bestehend
nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 165662 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),
Inhaberin von fünfzehntausend (15.000) Anteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 1. Juni 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland; und
2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend
unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter
der Nummer B 191.426 („Holtzbrinck“),
zukünftige Inhaberin von zweitausendachthundertvierundsiebzig (2.874) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 2. Juni 2015, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Rocket ist der alleinige Gesellschafter der Somuchmore Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 194.134, gegründet am 7. Januar 2015 unter dem Namen „Digital
Services XXXVIII S.à r.l.“ gemäß einer Urkunde der unterzeichnenden Notarin, welche am 11. März 2015 im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 669, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt
am 23. April 2015 gemäß einer Urkunde der unterzeichnenden Notarin geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.
Da Rocket das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und erklärt, auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet zu haben,
ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über jeden Punkt der folgen-
den Tagesordnung verhandeln, wobei Holtzbrinck ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und
stimmberechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung von zwei (2) Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, sodass die
Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen (die „Stammanteile“) und Anteilen der
Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“).
2. Beschluss bezüglich der Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen (i) der bestehenden vierzehntausendzweiund-
vierzig (14.042) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in vierzehntausendzweiundvierzig (14.042)
Stammanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1); und (ii) der bestehenden neunhundertachtundfünfzig
(958) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in neunhundertachtundfünfzig (958) Anteile der Serie
A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
3. Aufnahme der HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, einer Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groß-
herzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés) unter der Nummer B 191.426, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfzehntausend Euro (EUR
15.000) um einen Betrag von zweitausendachthundertvierundsiebzig Euro (EUR 2.874) auf einen Betrag von siebzehn-
tausendachthundertvierundsiebzig Euro (EUR 17.874) durch die Ausgabe von zweitausendachthundertvierundsiebzig
(2.874) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
5. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt siebzehntausendachthundertvierundsiebzig Euro (EUR 17.874,00),
bestehend aus
5.1.1 vierzehntausendzweiundvierzig (14.042) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
und
5.1.2 dreitausendachthundertzweiunddreißig (3.832) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00).
100354
L
U X E M B O U R G
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Somuchmore Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sons-
tige Artikel
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt siebzehntausendachthundertvierundsiebzig Euro (EUR 17.874,00),
bestehend aus
5.1.1 vierzehntausendzweiundvierzig (14.042) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
und
5.1.2 dreitausendachthundertzweiunddreißig (3.832) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
100355
L
U X E M B O U R G
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-
gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen.
Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den)
Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berücksichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechtenoder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern
übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung von An-
teilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter
Rocket Internet SE („Rocket“) und den Gesellschafter HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS („Holtzbrinck“, gemein-
schaftlich mit Rocket die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit einem solchen Investor verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen
Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder
indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von diesem
Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert
Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a) die Leitung der
Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten
der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder
indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberech-
tigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere
Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten, welcher
Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen
Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;
7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Umwand-
lungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmel-
zung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als
fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.
7.5 In den in Artikeln 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten
gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters
für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an
100356
L
U X E M B O U R G
Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen
Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile ent-
spricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.
10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
100357
L
U X E M B O U R G
11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschrif-
ten des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschaf-
terversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der
entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
12.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mit
einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals
vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
12.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 15. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.
Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit
der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:
16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-
gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft; und 16.1.2 Beschluss hinsichtlich der
Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
100358
L
U X E M B O U R G
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-
teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;
16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen; und 16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesell-
schaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.
16.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.
17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
19.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
20.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der
Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der für die
Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
100359
L
U X E M B O U R G
21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (wie unten definiert) für die unten genannten Rechts-
geschäfte und Maßnahmen im Einklang mit Artikel 24.5. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechts-
geschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des
Beirats (wie unten definiert) genehmigt wurden:
21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-
hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;
21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transak-
tionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streitwert
von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;
21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft
an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen. Als
solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt 15
der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheitsbe-
teiligung halten. Die Zustimmung gemäß diesem Artikel 21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;
21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung
jeglicher Anteils- oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.
21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,
so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beirats (wie unten definiert) erfordern. Der Beirat (wie unten definiert) kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen
und Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
100360
L
U X E M B O U R G
21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Ver-
treter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine
Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat („Beirat“). Dieser besteht aus drei (3) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-
sellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Beirats erhöhen oder herabsetzen.
24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-
schafter festlegen und/oder verändern.
24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
24.3.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats mit je zwei (2) Stimmen werden von Rocket nach eigenem
Ermessen ernannt; und 24.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von Holtzbrinck
nach eigenem Ermessen ernannt.
24.4 Jedes Mitglied des Beirats kann von jedem anderen Mitglieds des Beirats oder einem Vertreter der jeweiligen Partei
vertreten werden. In diesem Fall muss bei der jeweiligen Sitzung des Beirats eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden.
Zu diesem Zweck sind Rocket und Holtzbrinck berechtigt, ein Ersatzmitglied für jedes Beiratsmitglied zu ernennen.
24.5 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimmbe-
rechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.
24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft
Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der
Gesellschaft.
25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
100361
L
U X E M B O U R G
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
27.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die
Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Andwendbares recht
Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
7. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie
Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit unein-
geschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.
8. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
100362
L
U X E M B O U R G
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, zwei (2) Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft zu schaf-
fen, sodass die Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen (die „Stammanteile“) und
Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“).
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt die Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen (i) der bestehenden vier-
zehntausendzweiundvierzig (14.042) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in vierzehntausend-
zweiundvierzig (14.042) Stammanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1); und (ii) der bestehenden
neunhundertachtundfünfzig (958) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in neunhundertachtund-
fünfzig (958) Anteile der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, vorbenannt, als neue Gesellschafterin
der Gesellschaft an.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) um einen Betrag von zweitausendachthundertvierundsiebzig Euro (EUR 2.874)
auf einen Betrag von siebzehntausendachthundertvierundsiebzig Euro (EUR 17.874) durch die Ausgabe von zweitausen-
dachthundertvierundsiebzig (2.874) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Zweitausendachthundertvierundsiebzig (2.874) Anteile der Serie A1 wurden ordnungsgemäß von Holtzbrinck zum Preis
von zweitausendachthundertvierundsiebzig Euro (EUR 2.874) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Holtzbrinck gezeichneten zweitausendachthundertvierundsiebzig (2.874) Anteile der Serie A1 wurden voll-
ständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von zweitausendachthundertvierundsiebzig Euro (EUR 2.874).
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde der unterzeichnenden Notarin
erbracht.
Die Einlage in Höhe von zweitausendachthundertvierundsiebzig Euro (EUR 2.874) wird vollständig dem Gesellschafts-
kapital der Gesellschaft zugeführt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr
wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt siebzehntausendachthundertvierundsiebzig Euro (EUR 17.874,00),
bestehend aus
5.1.1 vierzehntausendzweiundvierzig (14.042) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
und
5.1.2 dreitausendachthundertzweiunddreißig (3.832) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Herrn Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
100363
L
U X E M B O U R G
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.
Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/17863. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. Juni 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015094703/1091.
(150104867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.
UV S.A. S.P.F, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 137.182.
DISSOLUTION
L'an deux mil quinze, le vingt-neuf mai.
Pardevant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur François Charles Jean ANDRE, né le 16 avril 1978 à Montélimar (France) résidant en Suisse, 3, Chemin de
Bram Van Velde, CH 1206 Genève, (ci-après «l'Actionnaire Unique»),
ici représenté par Madame Sandrine ANTONELLI, employée privée, demeurant professionnellement à L- 2420 Lu-
xembourg, 11 avenue Emile Reuter, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter:
1- que la société anonyme - société de gestion de patrimoine familial UV S.A. S.P.F., immatriculée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 137182 ayant son siège social à L - 1724 Luxembourg,
11A, Boulevard Prince Henri a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mars 2008 publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 933 du 15 avril 2008 (la «Société»).
2- que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310
(trois cent dix) actions de EUR 100 (cent euros) chacune entièrement libérées.
3- que l'Actionnaire Unique, étant le seul propriétaire des actions dont s'agit, prononce par la présente la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation, désigne en qualité de liquidateur de la Société,
CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S. à r.l., avec siège social au 2 avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg, imma-
triculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30467 et donne décharge pleine
et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.
4- que l'Actionnaire Unique déclare fixer à tout de suite les deuxième et troisième assemblées conformément à l'article
151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.
5- que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et
requiert du notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en
relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels passifs
de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, l'Actionnaire Unique assume irrévocablement l'obli-
gation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé et que l'actif restant éventuel
est réparti à l'Actionnaire Unique.
100364
L
U X E M B O U R G
6- que l'Actionnaire Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation AUDIEX S.A., avec siège social au 9
rue du Laboratoire, L -1911 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 65469 et lui confie la mission de faire le rapport sur la gestion.
7- qu'après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Actionnaire Unique en adopte les
conclusions, approuve les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans
réserve ni restriction à AUDIEX S.A., prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.
Le rapport du commissaire à la liquidation et le rapport du liquidateur après avoir été signés «ne varietur» par le man-
dataire de la partie comparante et le notaire soussigné sont annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.
8- que l'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière au liquidateur en ce qui concerne l'exécution de son mandat.
9- que l'Actionnaire Unique, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la
Société a définitivement cessé d'exister.
10- que les livres et documents de la Société seront déposés pendant cinq ans auprès de Société Générale Bank & Trust,
11 avenue Emile Reuter, L - 2420 Luxembourg.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Sandrine Antonelli, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 08 juin 2015. 1LAC / 2015 / 17633. Reçu 75.-€
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 juin 2015.
Référence de publication: 2015095712/58.
(150105538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Eurogroup S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 40.515.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015092057/10.
(150103368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Dictame II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 142.768.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 juin 2015i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2015:
- Monsieur Benoît JACQUES, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 15, boulevard Joseph II,
L - 1840 Luxembourg, Président.
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg;
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2015:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2015.
Référence de publication: 2015092004/21.
(150103123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
100365
L
U X E M B O U R G
LSREF4 Falcon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LSF 2 S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 196.199.
In the year two thousand and fifteen, on the tenth day of June,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits
Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the “RCS”) under number B 91796 (the Sole Share-
holder),
hereby represented by Valérie Fagnant, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, on 9 June 2015,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and by the
undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary
to act that it represents the entire share capital of LSF 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société
à responsabilité limitée) registered with the RCS under number B 196199, with a share capital of EUR 12,500.-, having its
registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg
and incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg dated 10 April 2015 (the “Articles”), not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the “Mémorial”). The articles of incorporation have not been amended since.
The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:
1. The entire issued share capital represented by 100 (one hundred) shares is held by the Sole Shareholder.
2. The Sole Shareholder is represented by a proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this
extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below
agenda.
3. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
a) Change of the name of the Company to "LSREF4 Falcon Investments S.à r.l." (the “Name Change”);
b) Subsequent amendment of article 4 (Name) of the Articles to reflect such Name Change;
c) Amendment of article 8 of the Articles relating to the shares so as to read as follows:
“ Art. 8. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence and entitles to one vote at the general meetings of shareholders, as the case may be.
As far as the Company is concerned, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
The transfer of the Company's shares inter vivos to third parties must be authorised in accordance with Article 189 of
the Companies Act. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders of the Company."
d) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the change proposed above with power and
authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole
signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the Name Change in the share register of the Company and
(ii) to the performance of any formalities in connection therewith.
The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record their resolutions as
follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the Company’s name into “LSREF4 Falcon Investments S.à r.l.”.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to subsequently amend article 4 (Name) of the Articles so as to read it as follows in the
English version of the Articles:
" Art. 4. Name. The corporate name of the Company is "LSREF4 Falcon Investments S.à r.l.".
100366
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 8 of the Articles relating to the shares as set forth in the agenda.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the change resolved above
and hereby empower and authorise any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed,
under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the Name Change in the share register of
the Company and (ii) to any formalities in connection therewith.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the proxyholder of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder appearing signed,
together with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix juin,
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à l’Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B 91796 (l’Associé
Unique),
ici représentée par Valérie Fagnant, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 9 juin 2015.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l’Associé Unique de LSF 2 S.à r.l., société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 196199, ayant un capital
social de EUR 12.500,-, ayant son siège social à l’Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,
Grand- Duché de Luxembourg, et constituée suivant un acte Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg daté du 10 avril 2015 (les “Statuts”) non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le “Mémorial”). Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis.
La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. La totalité du capital social, représentée par 100 (cent) parts sociales, est détenu par l’Associé Unique.
2. L’Associé Unique est représenté en vertu d’une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société
sont représentées à cette décision extraordinaire de l’Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises
sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.
3. L’ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
a) Changement de nom de la Société en «LSREF4 Falcon Investments S.à r.l."» (le «Changement de Dénomination»);
b) Par conséquent, modification de l'article 4 (Dénomination) des Statuts afin d’y refléter ce Changement de Dénomi-
nation;
c) Modification de l'article 8 des Statuts relatif aux parts sociales de sorte qu'il ait la teneur suivante:
« Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes,
de l'actif social ainsi que des bénéfices de la Société et donne droit à une voix dans les assemblées générales d’associés, le
cas échéant.
A l'égard de la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour
chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des tiers doit être autorisé conformément à l’article 189 de la Loi de 1915. Cette
autorisation n'est pas requise en cas de transfert de parts sociales à des associés de la Société.»
100367
L
U X E M B O U R G
d) Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter le changement proposé ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de l’ Associé Unique, afin d’effectuer, par sa
seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription du Changement de Dénomination dans le registre de parts
sociales de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte des résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de changer le nom de la Société en «LSREF4 Falcon Investments S.à r.l.».
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide en conséquence de modifier l'article 4 (Dénomination) des Statuts, de sorte qu'il ait la teneur
suivante dans la version française des Statuts:
« Art. 4. Dénomination. La société est dénommée «LSREF4 Falcon Investments S.à r.l.».
<i>Troisième résolutioni>
L'Associe Unique décide de modifier en conséquence l"article 8 des Statuts relatif aux parts sociales tel que défini dans
l'ordre du jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués
ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de l’Associé Unique, afin
d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription du Changement de Dénomination dans le
registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante ci-
dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction en langue française. A la requête de ce même mandataire
et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au bureau du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du document faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire comparant et le notaire ont
signé le présent acte original.
Signé: V. Fagnant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 11 juin 2015. 2LAC/2015/13023. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): André Muller.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2015.
Référence de publication: 2015094533/141.
(150104901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.
Trinter S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 127.176.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue Extraordinairementi>
L'Assemblée Générale décide, à compter du 15 juin 2015, de renouveler le mandat de d'un administrateur et du com-
missaire aux comptes, à savoir:
- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur et président du conseil, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, domicilié
professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
- ZIMMER & PARTNERS S.A., commissaire aux comptes, domiciliée professionnellement au 50, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés Luxembourg sous le numéro B 151.507.
Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015100029/17.
(150109856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
100368
Allianz Global Investors Renewables Investment Holding, S.à r.l.
Brelus S.A.
Buongiorno S.à r.l.
Centre de Recherche Public de la Santé
Dictame II S.A.
Eltyser
Epicerie Blobierg S.àr.l.
ESJ S.C.A. SICAR
Ets. Paul Vrehen S.à r.l.
Eurogroup S.A.
European Art Tour S.A.
European Jewellers I S.A.
Eurostone Srio S.C.A.
Evercare Fund
Fermat 1 S.à r.l.
Field Point I-A RE 7 S. à r.l.
F.L.D. Hygiène S.A.
I.C.I. S.A. (Immo Consult International)
IMJA S.A.
International Fashion Trading S.à r.l.
Invacare Holdings S.à r.l.
Iolita Corp
Kensington UK Logistics (Bristol) S.à r.l.
Kensington UK Office (Chester) S.à r.l.
Kensington UK Office (Crewe) S.à r.l.
Kensington UK Office (Working) S.à r.l.
Kings Falls
L-21 General Investments S.A.
La Cantina Del Gusto SA
LCO1 S.A.
Lealex Consult S.à r.l.
Loula S.A.
LSF 2 S.à r.l.
LSREF4 Falcon Investments S.à r.l.
Lune Holdings SPF SA
Lupercus Partners S.A.
Minhal France S.à r.l.
MML Capital Europe VI S.à r.l.
Nis Ganesha S.A.
Pacific Drillship Sàrl
R. Linse Holding B.V.
Sienna Capital S.à r.l.
Somuchmore Global S.à r.l.
Trinter S.A.
TSM Services (Luxembourg) S.à r.l.
UV S.A. S.P.F
V.D.M. Evenements S.A.
Voltaire Investissements S.A.