This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2064
13 août 2015
SOMMAIRE
Bugaboo Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99041
Comgest Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99034
Global Funds Management S.A. . . . . . . . . . . .
99054
JV Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99036
Kensington UK Industrial (Huncoat) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99041
Kensington UK Retail (Scarborough AW) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99052
Links Bidco S.à r.l. Propco 9 . . . . . . . . . . . . . .
99072
M3 Architectes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99066
P3M Prestige S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99026
Patrizia Bastite Holdco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
99049
Pro Clean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99027
Pro Clean S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99027
PSB Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99029
Puck International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99027
Quo Vadis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99026
Rain Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99026
Ram (Lux) Tactical Funds II . . . . . . . . . . . . . .
99031
Randstad Holding Luxembourg S.à r.l. . . . . .
99067
RDF Investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99028
Reacomex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99033
Real Estate Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
99026
Red Lion Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99027
Reinet Fund S.C.A., F.I.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
99070
Renaissance Enterprises S.A. . . . . . . . . . . . . . .
99029
RESOLUTION London W1 S.à r.l. . . . . . . . . .
99028
Restaurant-Auberge Albergo Da Marco S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99028
Rhododendron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99032
Rhombus Bidco S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99029
Ribble Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
99052
Ribeiro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99032
Richmond Hill Capital Management S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99027
Robertshaw Group Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
99029
Romain Allard s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99028
Rubicon Venture Partners S.A. . . . . . . . . . . . .
99032
S.A. Enemge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99026
Scientist of Fortune S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99031
SDV Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99031
SGBT Asset Based Funding S.A. . . . . . . . . . . .
99031
SIEBLAN S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99033
Silicon Motion Technology (Luxembourg) Li-
mited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99030
SINEK Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99033
Sinotrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99033
Smart Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99030
Sorgelux 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99032
Stratus Asset Management SA . . . . . . . . . . . . .
99030
Symbol Holdco B-T Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99055
Tenaris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99034
Westra Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99041
99025
L
U X E M B O U R G
Real Estate Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 160.861.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015096279/9.
(150106904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Quo Vadis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 25, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 22.275.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PINHEIRO Samantha.
Référence de publication: 2015096266/10.
(150106522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Rain Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 166.456.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015096267/10.
(150106681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
P3M Prestige S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3348 Leudelange, 3, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 96.761.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015096264/11.
(150106624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
S.A. Enemge, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 30.673.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 juin 2015i>
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels
au 31 décembre 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L- 1653 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2015.
Référence de publication: 2015096292/14.
(150106241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
99026
L
U X E M B O U R G
Puck International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8325 Capellen, 98, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 144.656.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015096263/9.
(150106288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Pro Clean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8059 Bertrange, 3, rue Grevelsbarrière.
R.C.S. Luxembourg B 94.194.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Helmsange, le 18 juin 2015.
Référence de publication: 2015096258/10.
(150106707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Pro Clean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8059 Bertrange, 3, rue Grevelsbarrière.
R.C.S. Luxembourg B 94.194.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Helmsange, le 18 juin 2015.
Référence de publication: 2015096259/10.
(150106708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Red Lion Group S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 160.830.
Madame Nadine Riedel a démissionné en date du 14 mai 2013 avec effet immédiat de son mandat d'administrateur à la
gestion journalière de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015096268/12.
(150106473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Richmond Hill Capital Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 91, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 165.226.
<i>Extrait de la décision des associés en date du 19 juin 2015i>
Le siège social de la société est transféré de son adresse actuelle sise au 87, rue de Merl in L-2146 Luxembourg à sa
nouvelle adresse au 91, rue de Merl in L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Richmond Hill Capital Management S.à.r.l.
Référence de publication: 2015096287/13.
(150106592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
99027
L
U X E M B O U R G
RESOLUTION London W1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: GBP 60.830,51.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 136.566.
Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015096282/9.
(150106682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Romain Allard s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9654 Grumelscheid, 53, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 100.869.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ARBO SA
Signature
Référence de publication: 2015096274/11.
(150106670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Restaurant-Auberge Albergo Da Marco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 3, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 150.319.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/06/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015096283/12.
(150106910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
RDF Investissement, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 150.560.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 mai 2015i>
<i>Résolution:i>
L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs sont échus et décide d'élire pour la période expirant à
l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 comme suit:
<i>Conseil d'Administrationi>
- Monsieur Antonio Quaratino, employé privé, demeurant professionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg, Administrateur;
- Monsieur Giorgio Bianchi, employé privé, demeurant professionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Administrateur;
- Madame Christine Picco, employée privée, demeurant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,
Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RDF INVESTISSEMENT S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2015096277/22.
(150106512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
99028
L
U X E M B O U R G
PSB Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 141.427.
Les comptes annuels au 30/11/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PSB INVESTMENTS S.A.
Référence de publication: 2015096262/10.
(150106930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Renaissance Enterprises S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 170.168.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2015.
Pour statuts coordonnés
Référence de publication: 2015096269/11.
(150106775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Robertshaw Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.555,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 186.240.
Par résolutions signées en date du 5 juin 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Stéphane Gatto, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2015.
Référence de publication: 2015096272/15.
(150106270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Rhombus Bidco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 166.522.
EXTRAIT
En date du 12 juin 2015, l'associé unique de la Société, Rhombus Holdco S.à r.l. a transféré l'intégralité des 750 parts
sociales émises par la Société à UK Logistics Holdco I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ayant un capital
social de GBP 15.000 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B
196.717. UK Logistics Holdco I S.à r.l. devient de ce fait l'associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015096271/18.
(150106348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
99029
L
U X E M B O U R G
Stratus Asset Management SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 195.405.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l'actionnaire unique de la Société en date du 18 juin 2015 de rayer Monsieur Stéphane BIVER
en tant que gérant de classe A et de nommer Monsieur Jean-Pierre HIGUET, né le 23 novembre 1960, à Couvin, Belgique,
résidant professionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, en tant que gérant de classe A de la
société avec effet au 18 juin 2015 et ce pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2015.
Référence de publication: 2015096305/14.
(150106489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Silicon Motion Technology (Luxembourg) Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 179.305.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 15 juin 2015 que:
- A été nommé en tant que gérant de classe B, avec effet au 15 juin 2015, et ce pour une durée illimitée:
* Monsieur Fabrice HABLOT, né le 23 mars 1978 à Brest, France, demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2015.
Référence de publication: 2015096296/15.
(150106281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Smart Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 127.182.
EXTRAIT
Il résulte d’une réunion de l’assemblée générale ordinaire de la Société qui s’est tenue en date du 18 juin 2015, que:
- Madame Nora Festl a été révoquée de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 4 avril 2013;
- La société AMG G.m.b.H, Allgemeine Management Gesellschaft G.m.b.H, ayant adresse au 24, rue de la Fontaine,
L-1532 Luxembourg et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B145.584 a été nommée
à la fonction de commissaire aux comptes avec effet au 4 avril 2013 jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires ap-
prouvant les comptes annuels pour l’année 2018;
et
- Monsieur Michel Leitz à été renommé à la fonction d’administrateur de la Société jusqu’à l’assemblée générale des
actionnaires approuvant les comptes annuels pour l’année 2018;
- Monsieur Rémi Chevalier, ayant sa nouvelle adresse professionnelle au 51, Route de Thionville, L-2611 Luxembourg,
à été renommé à la fonction d’administrateur de la Société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires approuvant les
comptes annuels pour l’année 2018; et
- Monsieur Olivier Sciales, ayant sa nouvelle adresse professionnelle au 51, Route de Thionville, L-2611 Luxembourg,
à été renommé à la fonction d’administrateur de la Société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires approuvant les
comptes annuels pour l’année 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2015.
Référence de publication: 2015096298/25.
(150106172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
99030
L
U X E M B O U R G
SDV Holding, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 171.813.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015096314/9.
(150106888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Scientist of Fortune S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 161.657.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015096312/10.
(150106419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
SGBT Asset Based Funding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 144.079.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en date du 15 juin 2015 que:
(i) le mandat de la société Deloitte Audit Sàrl, Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société, n'a pas été renouvelé;
(ii) la société Ernst & Young, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann à L-5365 Munsbach, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B47771, a été nommée Réviseur d'Entreprises
Agrée de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31
décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2015.
Référence de publication: 2015096315/16.
(150106813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Ram (Lux) Tactical Funds II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 178.133.
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2015i>
L’Assemblée Générale renomme:
- Thomas DE SAINT-SEINE, Président;
- Philippe WAGENER, Administrateur;
- Roberto ZITO, Administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2015.
L’Assemblée appelle aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé ERNST & YOUNG, 7, rue Gabriel Lippmann,
L-5365, Munsbach en remplacement de PricewaterhouseCoopers. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2015.
Référence de publication: 2015096276/19.
(150106827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
99031
L
U X E M B O U R G
Rhododendron S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 13.173.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015096285/9.
(150106413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Ribeiro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 37, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 145.186.
Le bilan au 31 décembre 2013 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2015.
Référence de publication: 2015096286/10.
(150106703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Sorgelux 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 187.827.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1
er
avril 2015 que le siège social
de la société a été transféré du 26-28 rives de Clausen, L-2165 Luxembourg au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2015.
Référence de publication: 2015096300/12.
(150106911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Rubicon Venture Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1568 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 146.405.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 mai 2015i>
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date
du 26 mai 2015 que:
1. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires accepte la démission de Madame Mayra Romero Torres de ses
fonctions d'administrateur avec effet à ce jour.
2. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires accepte la démission de Monsieur Pierre Petit de ses fonctions
d'administrateur avec effet à ce jour.
3. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires accepte la démission de Monsieur Sébastien Fève de ses fonctions
de commissaire aux comptes avec effet à ce jour.
4. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes
Madame Ana De Oliveira, domiciliée professionnellement au 8A boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet
rétroactif à ce jour. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
Luxembourg, le 26 mai 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015096291/23.
(150106235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
99032
L
U X E M B O U R G
Sinotrade, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 89 e, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 190.077.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015096319/9.
(150106887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Reacomex, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 47.825.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société REACOMEX
i>AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2015096278/11.
(150106885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
SIEBLAN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3514 Dudelange, 128, route de Kayl.
R.C.S. Luxembourg B 191.428.
EXTRAIT
Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2015 les décisions suivantes:
- d’accepter, à compter du 18 mai 2015, la cession de 25 parts sociales détenues par Monsieur SIEBENALER Joé,
demeurant 2, Am Welschbaendchen à L-5842 HESPERANGE, à Monsieur BLANDIN Norbert, domicilié 2, Clos Epona
à F-57300 MONDELANGE pour le prix convenu entre parties.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 18 juin 2015.
PINHEIRO Samantha.
Référence de publication: 2015096317/14.
(150106219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
SINEK Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 109.016.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 juin 2015i>
Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 2 juin 2015
que:
1. Monsieur Marco CASAGRANDE, ayant comme adresse professionnelle, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Lu-
xembourg, a démissionné de son poste de administrateur classe B, avec effet au 27 avril 2015;
2. Monsieur Michal KOWAL, ayant comme adresse professionnelle, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
a été nommé comme administrateur classe B, avec effet au 2 juin 2015, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en
2017;
3. Le mandat de KPMG AUDIT, ayant son siège social à 39, Avenue John F. Kennedy, L-1856 Luxembourg, enregistré
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B103.590, a été renouvelé, avec effet au 2 juin 2015, jusqu’à
l’assemblée générale qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS ATO
Référence de publication: 2015096318/20.
(150106189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.
99033
L
U X E M B O U R G
Tenaris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 85.203.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2015.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Tenaris S.A.
i>Adélia Soares
Référence de publication: 2015089244/13.
(150101348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.
Comgest Europe, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 40.576.
L'an deux mille quinze, le huitième jour de juin.
Par-devant, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand- Duché de Luxembourg).
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de Comgest Europe (la «Société Absorbée»), une
société anonyme, sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 5, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B 40.576), constituée suivant acte reçu par
Maître Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 24 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 323 du 28 juillet 1992. Les statuts de la Société Absorbée ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du notaire soussigné en date du 17 mars 2014, publié au Mémorial numéro
1623 du 25 juin 2014.
L'Assemblée est ouverte au 8, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, à 14h00 (heure luxembourgeoise) sous la
présidence de Madame Michèle Kemp, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg (le «Président»),
qui nomme comme secrétaire Madame Camille Delacoute, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur William Simpson, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte que:
I. Les actions étant toutes nominatives, la présente Assemblée a été convoquée conformément à une convocation adressée
le 7 mai 2015 par lettre recommandée à chacun des actionnaires.
II. Les noms des actionnaires présents ou représentés par une procuration, des mandataires des actionnaires représentés,
ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir
été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau
et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront
pareillement annexés au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés,
après avoir été paraphées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. La présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
I. Approbation de la fusion de la Société Absorbée avec COMGEST GROWTH EUROPE (le «Compartiment Absor-
bant»), compartiment de COMGEST GROWTH PLC, société anonyme ayant le statut de société d'investissement à capital
variable et structurée sous forme de fonds à compartiments multiples, constituée conformément au droit irlandais et enre-
gistrée sous le numéro 323577 (la «Société Absorbante») (la présente opération étant dénommée la «Fusion»), après avoir
pris connaissance des documents suivants:
i. l'avis aux actionnaires de la Société Absorbée (l'«Avis de Fusion»);
ii. un rapport du Conseil d'Administration et du conseil d'administration de la Société Absorbante expliquant et justifiant
la proposition de Fusion (le «Projet Commun de Fusion»);
iii. le rapport audité prescrit par Deloitte Audit S.à.r.l. (Luxembourg).
II. Fixation de la date du 16 juin 2015 comme date de prise d'effet de la Fusion, conformément aux indications détaillées
figurant dans le Projet Commun de Fusion (la «Date de Prise d'Effet»).
III. Approbation du fait qu'à la Date de Prise d'Effet, l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée seront
automatiquement transférés au Compartiment Absorbant.
99034
L
U X E M B O U R G
IV. Approbation du fait qu'à la Date de Prise d'Effet, le Compartiment Absorbant émettra, en faveur des actionnaires
nominatifs de la Société Absorbée, des actions nominatives du Compartiment Absorbant, conformément aux modalités
stipulées dans l'Avis de Fusion, lequel a été envoyé aux actionnaires de la Société Absorbée, avec le présent avis, le 7 mai
2015.
V. Déclaration à l'effet que, du fait de la Fusion, après le transfert de l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée
au Compartiment Absorbant, la Société Absorbée sera liquidée en temps voulu et une demande sera déposée auprès de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (la «CSSF») en vue de la radiation de la Société Absorbée de la liste des
OPCVM agréés par la CSSF.
VI. Sous réserve des termes des résolutions qui précèdent, et sauf stipulation contraire de celles-ci, proposition de
conférer à deux membres du Conseil d'Administration le pouvoir:
- de prendre ou de veiller à ce que soit prise toute mesure et de signer ou faire signer les résolutions ci-dessus ainsi que
tous autres accords, certificats, actes et documents, selon ce qui est jugé utile, et d'engager et de payer tous les frais et
dépenses nécessaires ou utiles afin d'accomplir l'objet et l'intention des résolutions qui précèdent, la signature de deux
membres du Conseil d'Administration constituant à toutes fins utiles une preuve valable de l'approbation des termes des
présentes par la Société Absorbée et en son nom;
- de signer tous les documents sociaux nécessaires aux fins des résolutions ci-dessus;
- de déléguer tout ou partie des pouvoirs (y compris les pouvoirs discrétionnaires) qui leur sont conférés en vertu des
résolutions qui précèdent au moyen d'une ou de plusieurs procurations délivrées aux personnes et selon les modalités qu'ils
pourront déterminer à leur entière discrétion, l'exercice de cette discrétion étant attestée de manière irréfutable par leur
signature conjointe de cette (ces) procuration(s), au nom et pour le compte de la Société Absorbée.
VII. Examen de toute autre question dûment soumise à l'Assemblée.
IV. Suivant l'article 8 des statuts de la Société Absorbée, les résolutions sur chaque point porté à l'ordre du jour doivent
être adoptées par le vote affirmatif de la majorité simple des voix valablement exprimées à l'Assemblée sans condition de
quorum particulière.
V. Qu'il apparaît de la liste de présence de la Société Absorbée que 3.690,729 (21,48%) du capital émis est présent ou
représenté.
VI. Qu'en conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
portés à l'ordre du jour.
Puis l'Assemblée, après délibération, a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée avec 99 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
décide d'approuver la Fusion après avoir pris connaissance de l'Avis de Fusion, du Projet Commun de Fusion, et du
rapport audité prescrit par Deloitte Audit S.à.r.l. (Luxembourg).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée avec 99 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
décide de fixer le 16 juin 2015 comme Date de Prise d'Effet de la Fusion, telle que détaillée avec plus de précisions dans
le Projet Commun de Fusion, et conformément à l'article 66 (4) de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les
organismes de placement collectif.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée avec 99 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
décide d'approuver qu'à la Date de Prise d'Effet, l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée seront automa-
tiquement transférés au Compartiment Absorbant.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée avec 99 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
décide d'approuver qu'à la Date de Prise d'Effet, le Compartiment Absorbant émettra, en faveur des actionnaires nomi-
natifs de la Société Absorbée, des actions nominatives du Compartiment Absorbant, conformément aux modalités stipulées
dans l'Avis de Fusion.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée avec 99 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
décide de prendre note que, du fait de la Fusion, après le transfert de l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée
au Compartiment Absorbant, la Société Absorbée sera liquidée en date du 16 juin 2015 et une demande sera déposée auprès
de la CSSF en vue de la radiation de la Société Absorbée de la liste des OPCVM agréés par la CSSF.
Les registres, livres et pièces comptables de la Société Absorbée seront conservés pendant une période de cinq années
à l'ancien siège social de la Société Absorbée au L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
99035
L
U X E M B O U R G
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée avec 99 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
décide, sous réserve des termes des résolutions qui précèdent et sauf stipulation contraire de celles-ci, de conférer à deux
membres du conseil d'administration de la Société Absorbée (le «Conseil d'Administration») le pouvoir:
- de prendre ou de veiller à ce que soit prise toute mesure et de signer ou faire signer les résolutions ci-dessus ainsi que
tous autres accords, certificats, actes et documents, selon ce qui est jugé utile, et d'engager et de payer tous les frais et
dépenses nécessaires ou utiles afin d'accomplir l'objet et l'intention des résolutions qui précèdent, la signature de deux
membres du Conseil d'Administration constituant à toutes fins utiles une preuve valable de l'approbation des termes des
présentes par la Société Absorbée et en son nom;
- de signer tous les documents sociaux nécessaires aux fins des résolutions ci-dessus;
- de déléguer tout ou partie des pouvoirs (y compris les pouvoirs discrétionnaires) qui leur sont conférés en vertu des
résolutions qui précèdent au moyen d'une ou de plusieurs procurations délivrées aux personnes et selon les modalités qu'ils
pourront déterminer à leur entière discrétion, l'exercice de cette discrétion étant attestée de manière irréfutable par leur
signature conjointe de cette (ces) procuration(s), au nom et pour le compte de la Société Absorbée.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture donnée à l'Assemblée, les membres du bureau de l'Assemblée, tous connus du notaire instrumentant
respectivement par, leur nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte, aucun actionnaire
n'ayant exprimé son désir de signer le présent acte.
Signé: M. Kemp, C. Delacoute, W. Simpson et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 10 juin 2015. Relation: 2LAC/2015/12932. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 15 juin 2015.
Référence de publication: 2015094212/125.
(150104906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.
JV Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 195.728.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of May.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr Alan Lawrence Lee, private employee, born on September 4
th
, 1957 in London, United Kingdom, residing at Flat
16, Connaught House, Mount Street 1-3, London W1K 3NB,
hereby represented by Mrs Céline Haeck residing professionally in Schuttrange, by virtue of a proxy given on the the
28
th
day of May, 2015.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:
- that Mr Alan Lee is the sole shareholder of “JV Holdings S.à r.l.”, a company incorporated by a notarial deed on the
17
th
day of March 2015, published on the 18
th
day of May, 2015 in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
number 1281;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to create two different classes of shares namely the class A shares and the class B shares.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to convert the TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) shares with a nominal
value of ONE EURO (1.- EUR) each, issued by the Company, into TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500)
Class A Shares with a nominal value of ONE EURO (1.- EUR)each.
99036
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the Company’s share capital by an amount of SEVEN MILLION FIVE HUN-
DRED FIFTY THREE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (7,553,500.- EUR) in order to raise it from its present
amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) to SEVEN MILLION FIVE HUNDRED
SIXTY SIX THOUSAND EURO (7,566,000.-EUR) by creation and issuance of:
- SEVEN MILLION FIVE HUNDRED FIFTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED (7,552,500) new Class A Shares
with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
- ONE THOUSAND new Class B Shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each, having the same rights and
obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared:
- Mr Alan Lawrence Lee, prequalified,
hereby represented by Mrs Céline Haeck, by virtue of the aforesaid proxy dated May 28
th
, 2015, who declares to
subscribe ONE MILLION SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED (1,007,500) new Class A Shares and to pay them up
in full by a contribution in kind consisting of a real, due and payable (in French: créance, certaine, liquide et exigible) claim
amounting to ONE MILLION SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (1,007,500.- EUR);
- Mr Edward Michael Lee, private employee, born on May 5
th
, 1959 in London, United Kingdom, residing at Flat 5,
74 Portland Place, London W1B 1NR,
hereby represented by Mrs Céline Haeck, by virtue of the proxy dated May 25
th
, 2015, 2015 who declares to subscribe
FOUR HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED (467,500) new Class A Shares and to pay them up
in full by a contribution in kind consisting of a real, due and payable (in French: créance, certaine, liquide et exigible) claim
amounting to FOUR HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (467,500.- EUR);
- Falcon Capital Group S.A., a company governed by the laws of Panama, incorporated on February 20
th
, 2014, having
its registered office at Beatriz M. de Cabal Street, P.H. Proconsa II Building, 8
th
Floor, Panama, registered with the Public
Registry of Panama under the number 826861,
hereby represented by Mrs Céline Haeck, by virtue of the proxy dated May 26
th
, 2015, who declares to subscribe ONE
MILLION FOUR HUNDRED TWO THOUSAND FIVE HUNDRED (1,402,500) new Class A Shares and to pay them
up in full by a contribution in kind consisting of a real, due and payable (in French: créance, certaine, liquide et exigible)
claim amounting to ONE MILLION FOUR HUNDRED TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (1,402,500.- EUR);
- Mr Daniel Martin Green, private employee, born on October 29
th
, 1966 in London, United Kingdom, residing at 14
Downage, Henden, London NW4 1AH,
hereby represented by Mrs Céline Haeck, by virtue of the aforesaid proxy dated 28
th
May, 2015 who declares to subscribe
ONE MILLION FOUR HUNDRED TWO THOUSAND FIVE HUNDRED (1,402,500) new Class A Shares and to pay
them up in full by a contribution in kind consisting of a real, due and payable (in French: créance, certaine, liquide et
exigible) claim amounting to ONE MILLION FOUR HUNDRED TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EURO
(1,402,500.- EUR);
- Cumberland Arms Ltd, a company governed by the laws of Israel, incorporated on March 20
th
, 2014, having its
registered office at 16 Wet, Beit Shemesh, Israel, registered with the Registrar of Companies and Partnerships of Israel
under the number l514995315,
hereby represented by Mrs Céline Haeck, by virtue of the proxy dated May 27
th
, 2015 who declares to subscribe SIX
HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED (637,500) new Class A Shares and to pay them up in full
by a contribution in kind consisting of a real, due and payable (in French: créance, certaine, liquide et exigible) claim
amounting to SIX HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (637,500.- EUR);
- Summer Hill Investments Ltd, a company governed by the laws of Israel, incorporated on March 19
th
, 2014, having
its registered office at 16 Industry, Beit Shemesh, Israel, registered with the Registrar of Companies and Partnerships of
Israel under the number 514995224,
hereby represented by Mrs Céline Haeck, by virtue of the proxy dated may 26
th
, 2015 who declares to subscribe SEVEN
HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND (765,000) new Class A Shares and to pay them up in full by a contribution in kind
consisting of a real, due and payable (in French: créance, certaine, liquide et exigible) claim amounting to SEVEN HUN-
DRED SIXTY FIVE THOUSAND EURO (765,000.-EUR);
- Mr Michael Gutman, a private employee, born on December 16
th
, 1955 in Sydney, Australia, residing at Flat 8, 30
Portman Close, London Q1H 6DB,
hereby represented by Mrs Céline Haeck, by virtue of the proxy dated May 22
nd
, 2015 who declares to subscribe FOUR
HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED (467,500) new Class A Shares and to pay them up in full
99037
L
U X E M B O U R G
by a contribution in kind consisting of a real, due and payable (in French: créance, certaine, liquide et exigible) claim
amounting to FOUR HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (467,500.- EUR);
- Mr Daniel Peltz, a private employee, born on March 3
rd
, 1961 in Beckenham, United Kingdom, residing at 9 Cavendish
Avenue, London NW8 9JD,
hereby represented by Mrs Céline Haeck, by virtue of the proxy dated May 27
th
, 2015 who declares to subscribe SIX
HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED (637,500) new Class A Shares and to pay them up in full
by a contribution in kind consisting of a real, due and payable (in French: créance, certaine, liquide et exigible) claim
amounting to SIX HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (637,500.- EUR);
- Dobbin Street Limited, a company governed by the laws of Gibraltar, incorporated on January 29
th
, 2014, having its
registered office at Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of Gibraltar
under the number 111039,
hereby represented by Mrs Céline Haeck, by virtue of the proxy dated May 21
st
, 2015 who declares to subscribe SEVEN
HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND (765,000) new Class A Shares and to pay them up in full by a contribution in kind
consisting of a real, due and payable (in French: créance, certaine, liquide et exigible) claim amounting to SEVEN HUN-
DRED SIXTY FIVE THOUSAND EURO (765,000.-EUR);
- Stamford New Dawn Holdings Limited, a company governed by the laws of the British Virgin Islands, having its
registered office at Jayla Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 1110, registered with the
Registrar of the British Virgin Islands under the number 1873134,
hereby represented by Mrs Céline Haeck, by virtue of the proxy dated May 27
th
, 2015 who declares to subscribe ONE
THOUSAND (1,000) new Class B Shares and to pay them up in full by a contribution in kind consisting of a real, due and
payable (in French: créance, certaine, liquide et exigible) claim amounting to ONE THOUSAND EURO (1,000.- EUR);
The foregoing due and payables are evidenced in the interim balance sheet of the Company as at May 28
th
, 2015, that,
after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the meeting resolves to amend article 6 paragraph 1 of the articles of
incorporation, which will henceforth have the following wording:
" Art .6. The Company’s capital is set at SEVEN MILLION FIVE HUNDRED SIXTY SIX THOUSAND EURO
(7,566,000.- EUR) represented by SEVEN MILLION FIVE HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND (7,565,000) Class A
Shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each and ONE THOUSAND (1,000) Class B Shares with a par value of
ONE EURO (1.- EUR).”
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately four thousand two hundred euros (4,200.-EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le vingt-huit mai.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
Monsieur Alan Lawrence Lee, employé privé, né le 4 septembre 1957 à Londres, Angleterre, demeurant à Apt. 16,
Connaught House, Mount Street 1-3, Londres W1K 3NB,
ici représenté par Madame Céline Haeck, employée privée, demeurant professionnellement à Schuttrange,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 28 mai 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que Monsieur Alan Lee est le seul associé de la société «JV Holdings S.à r.l.», une société, constituée suivant acte
notarié en date du 17 mars 2015, publié le 18 mai 2015 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1281.
99038
L
U X E M B O U R G
- Que le seul associé a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de procéder à la création de deux classes différentes de parts sociales dénommées les parts
sociales de classe A et les parts sociales de classe B.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de convertir les DOUZE MILLE CINQ CENTS (12,500) parts sociales d'une valeur nominale
d'UN EURO (1.- EUR) chacune, émises par la Société, en DOUZE MILLE CINQ CENTS (12,500) nouvelles parts sociales
de Classe A d'une valeur nominale d'UN EURO (1.- EUR)) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de SEPT MILLIONS CINQ CENTS
CINQUANTE TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (7,553,500.-EUR) afin de le porter de son montant actuel de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (12,500.- EUR) à un montant de SEPT MILLIONS CINQ CENTS SOIXANTE SIX MILLE
EUROS (7,566,000.- EUR) par la création et l'émission de:
- SEPT MILLIONS CINQ CENTS CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENTS (7,552,500) nouvelles parts sociales
de Classe A d’un valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) chacune, ayant les même droits et obligations que les parts
sociales existantes;
- MILLE (1,000) nouvelles parts sociales de Classe B d’un valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) chacune, ayant
les même droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Sont intervenus alors aux présentes:
- Mr Alan Lawrence Lee, préqualifié,
ici représenté par Madame Céline Haeck, prénommée, en vertu de la pré-mentionnée procuration sous seing privée du
28 mai 2015,
lequel déclare souscrire UN MILLION SEPT MILLE CINQ CENTS (1,007,500) nouvelles parts sociales de Classe A
et les libérer intégralement par capitalisation d’une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la société au
montant d’UN MILLION SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (1,007,500.- EUR);
- Mr Edward Michael Lee, employé privé, né le 5 mai 1959 à Londres, Angleterres, demeurent à Flat 5, 74 Portland
Place, London W1B 1NR,
ici représentée par Madame Céline Haeck, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 25 mai 2015 lequel
déclare souscrire QUATRE CENTS SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENTS (467,500) nouvelles parts sociales de Classe
A et les libérer intégralement par capitalisation d’une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la société
au montant d’UN MILLION SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (467,500.- EUR);
- Falcon Capital Group S.A., une société de droit Panaméen, constituée le 17 février 2014ayant son siège social à Beatriz
M. de Cabal Street, P.H. Proconsa II Building, 8
th
Floor, Panama, enregistré au «Public Registry of Panama» sous le
numéro 826861,
ici représentée par Madame Céline Haeck, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 26 mai 2015 lequel
déclare souscrire UN MILLION QUATRE CENTS DEUX MILLE CINQ CENTS (1,402,500) nouvelles parts sociales de
Classe A et les libérer intégralement par capitalisation d’une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la
société au montant d’UN MILLION QUATRE CENTS DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (1,402,500.- EUR);
- Mr Daniel Martin Green, employé privé, né le 29 octobre 1966 à Londres, Angleterres, demeurent à 14 Downage,
Henden, London NW4 1AH,
ici représentée par Madame Céline Haeck, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 28 mai 2015 lequel
déclare souscrire UN MILLION QUATRE CENTS DEUX MILLE CINQ CENTS (1,402,500) nouvelles parts sociales de
Classe A et les libérer intégralement par capitalisation d’une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la
société au montant d’UN MILLION QUATRE CENTS DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (1,402,500.- EUR);
- Cumberland Arms Ltd, une société de droit Israélien, constituée le 20 mars 2014, ayant son siège social à 16 Wet, Beit
Shemesh, Israel, enregistré au «Registrar of Companies and Partnerships of Israel» sous le numéro l514995315,
ici représentée par Madame Céline Haeck, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 mai 2015, lequel
déclare souscrire SIX CENTS TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS (637,500) nouvelles parts sociales de Classe A et
les libérer intégralement par capitalisation d’une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la société au
montant de SIX CENTS TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (637,500.- EUR);
- Summer Hill Investments Ltd, une société de droit Israélien, constituée le 19 mars 2014, ayant son siège social à 16
Industry, Beit Shemesh, Israel, enregistré au «Registrar of Companies and Partnerships of Israel» sous le numéro
514995224,
99039
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Madame Céline Haeck, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 26 mai 2015, lequel
déclare souscrire SEPT CENTS SOIXANTE CINQ MILLE (765,000) nouvelles parts sociales de Classe A et les libérer
intégralement par capitalisation d’une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la société au montant de
SEPT CENTS SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (765,000.- EUR);
- Mr Michael Gutman, employé privé, né le 16 décembre 1955 à Sydney, Australie, demeurent à Flat 8, 30 Portman
Close, London Q1H 6DB,
ici représentée par Madame Céline Haeck, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 22 mai 2015 lequel
déclare souscrire QUATRE CENTS SOIXANTE SEPT MILLE CINQ cents (467,500) nouvelles parts sociales de Classe
A et les libérer intégralement par capitalisation d’une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la société
au montant de QUATRE CENTS SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (467,500.- EUR);
- Mr Daniel Peltz, employé privé, né le 3 mars 1961 à Beckenham, Angleterres, demeurent à 9 Cavendish Avenue,
London NW8 9JD,
ici représentée par Madame Céline Haeck, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 mai 2015 lequel
déclare souscrire SIX CENTS TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS (637,500) nouvelles parts sociales de Classe A et
les libérer intégralement par capitalisation d’une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la société au
montant de SIX CENTS TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (637,500.- EUR);
- Dobbin Street Limited, une société de droit du Gibraltar, constituée le 29 janvier 2014, ayant son siège social à Suites
7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar, enregistré au «Registrar of Companies of Gibraltar» sous le numéro 111039,
ici représentée par Madame Céline Haeck, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 21 mai 2015 lequel
déclare souscrire SEPT CENTS SOIXANTE CINQ MILLE (765,000) nouvelles parts sociales de Classe A et les libérer
intégralement par capitalisation d’une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la société au montant de
SEPT CENTS SOIXANTE CINQ MILLE EUROS(765,000.- EUR);
- Stamford New Dawn Holdings Limited, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à Jayla
Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 1110, enregistré au «Registrar of the British Virgin
Islands» sous le numéro 1873134,
ici représentée par Madame Céline Haeck, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 mai 2015, lequel
déclare souscrire MILLE (1,000) nouvelles parts sociales de Classe B et les libérer intégralement par capitalisation d’une
créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la société au montant de MILLE EUROS (1,000.- EUR);
La preuve de l’existence des créances certaines liquides et exigibles préqualifiées a été donnée au notaire instrumentant
par un bilan intérimaire de la société émis en date du 28 mai 2015, lequel après avoir été signée “ne varietur” par la
mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l'article 6 paragraphe 1 des statuts comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à SEPT MILLIONS CINQ CENTS SOIXANTE SIX MILLE EUROS (7,566,000-
EUR) représenté par SEPT MILLIONS CINQ CENTS SOIXANTE CINQ MILLE (7,565,000) parts sociales de classe A
d’une valeur nominale d’un euro(1,- Eur) chacune et de MILLE (1,000) parts sociales de classe B d’une valeur nominale
d’UN EURO(1,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ quatre mille deux cents euros (4.200.-
EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue française, suivi d'une version anglaise, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par son
nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. HAECK, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 1
er
juin 2015. Relation: 1LAC/2015/16829. Reçu soixante-quinze euros
75,00 EUR.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2015.
Référence de publication: 2015092236/242.
(150103867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
99040
L
U X E M B O U R G
Westra Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 61.769.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2014 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2015089272/11.
(150101200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.
Bugaboo Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 146.379.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 16 juin 2015.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015094981/12.
(150105728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.
Kensington UK Industrial (Huncoat) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.647.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of the month of June.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Kensington UK Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000) and in the process of being registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,
represented by Maître Ségolène Le Marec, maître en droit professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy
which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company “Kensington UK Industrial (Huncoat) S.à r.l.” (société à responsabilité
limitée) which is hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Kensington UK
Industrial (Huncoat) S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become
shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream guarantees), grant security interests,
grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the
same group of companies as the Company.
99041
L
U X E M B O U R G
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000)
represented by seven hundred fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pounds Sterling (GBP 20) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
99042
L
U X E M B O U R G
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability”
and “expenses” shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
99043
L
U X E M B O U R G
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price
Kensington UK Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15,000
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
99044
L
U X E M B O U R G
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles
of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 8 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under number B 195.140.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English
language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünften Tag des Monats Juni,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen,
Kensington UK Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxem-
burgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital fünfzehntausend
Pfund Sterling (GBP 15.000) beträgt, und die dabei ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg eingetragen
zu werden,
hier vertreten durch Maître Ségolène Le Marec, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer
privatschriftlichen Vollmacht welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde
eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) “Kensington UK Industrial (Huncoat) S.à
r.l.” wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
“Kensington UK Industrial (Huncoat) S.à r.l.” (die “Gesellschaft”) wird hiermit von der erschienenen Partei und allen
Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende
Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream als auch side-stream Bürgschaften), Sicherheiten
leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt
oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
99045
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-
denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfzehntausend
Pfund Sterling (GBP 15.000), eingeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je
zwanzig Pfund Sterling (GBP 20).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht
anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die
keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
99046
L
U X E M B O U R G
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage”, „Streitsache”, „Prozess” oder
„Verfahren” finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit”
und „Ausgaben” beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
99047
L
U X E M B O U R G
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-
schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich
nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2015 enden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
in bar eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
Kensington UK Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15.000
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15.000
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
99048
L
U X E M B O U R G
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 8 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue
Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer
B 195.140.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen
Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: S. LE MAREC, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/17897. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 16. Juni 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015092237/451.
(150103483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Patrizia Bastite Holdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 197.654.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünfzehn,
am neunten Tag des Monats Juni.
Vor Uns Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
PATRIZIA Wohnmodul I Zwischenholding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) mit Sitz in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B 163.333,
hier vertreten durch Herrn Peter AUDESIRK, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in 10, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxemburg,
aufgrund einer am 5. Juni 2015 in Luxemburg erteilten Vollmacht.
Die von dem Bevollmächtigten der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichnete Vollmacht
bleibt dieser Urkunde beigefügt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.
Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienene hat den amtierenden Notar gebeten, die nachstehende Satzung
einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.
Satzung
Titel I. Name, Sitz, Geschäftzweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgischen
Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden
Fassung (im Folgenden das „Gesetz von 1915“) sowie dieser Satzung (im Folgenden die „Satzung“) unterliegt.
99049
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Die Gesellschaft führt den Namen PATRIZIA Bastide Holdco 1 S.à r.l. (im Folgenden die „Gesellschaft“).
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.
Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen
oder eingetreten sind, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen
diesem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen, kann die Gesellschaft ihren Sitz nach Maßgabe der in Luxemburg
geltenden Rechtsvorschriften vorübergehend bis zum Ende dieser Ereignisse in einen anderen Staat verlegen.
Eine solche Sitzverlegung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche Luxemburgisch bleibt. Die
Erklärung der Sitzverlegung soll Dritten durch jenes Organ der Gesellschaft bekannt gemacht werden, welches angesichts
der herrschenden Umstände am besten dazu in der Lage ist.
Art. 4. Der Geschäftszweck der Gesellschaft ist
- das Kaufen oder Halten von Anteilen an einer oder mehreren Immobiliengesellschaften;
- die Gewährung von Finanzierungen an Immobiliengesellschaften, vorausgesetzt, dass sie direkt oder indirekt an der
finanzierten Immobiliengesellschaften beteiligt ist; und/oder
- das Kaufen von Immobilien und die Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf (einschließlich Priva-
tisierung) von durch die Gesellschaft gehaltenen Immobilien.
Für Zwecke dieser Klausel umfasst der Begriff "Immobilien" das Eigentum an Grundstücken (bestehend aus dem Grund
und Boden sowie dem Gebäude) und grundstücksgleiche Rechte, wie z.B. Erbbaurechte. Für die Zwecke dieser Klausel
bezeichnet "Immobiliengesellschaft" jede Kapitaloder Personengesellschaft, deren Ziel (gemäß ihrer Satzung oder ihres
Gesellschaftsvertrags) der Kauf von Immobilien und die Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf
(einschließlich der Privatisierung) von durch diese Gesellschaft gehaltenen Immobilien (direkt oder indirekt durch eine
oder mehrere Immobiliengesellschaften mit entsprechender Zielsetzung), der Kauf oder das Halten von Anteilen an einer
oder mehreren solchen Immobiliengesellschaften mit entsprechender satzungs- oder gesellschaftsvertraglicher Zweckse-
tzung und/oder die Gewährung von Darlehen an solche Immobiliengesellschaften ist, vorausgesetzt, dass sie direkt oder
indirekt an der finanzierten Immobiliengesellschaft beteiligt ist.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten und Transaktionen durchführen, die sie für notwendig erachtet, um den Ge-
schäftszweck zu erfüllen, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt der Erreichung des Geschäftszwecks dienen,
einschließlich Transaktionen zur Absicherung von Zinssatz- und/oder Wechselkursrisiken.
Die Gesellschaft kann sich durch Eigen- oder Fremdkapital finanzieren.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines
Gesellschafters aufgelöst.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert-
fünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (EUR 100,-).
Art. 8. Solange nur ein Anteilsinhaber besteht, kann dieser die Anteile frei übertragen.
Für den Fall mehrerer Anteilinhaber sind die Anteile unter den Anteilinhabern frei übertragbar. Eine Abtretung von
Anteilen unter Lebenden an Nicht-Anteilinhabern kann nur nach vorheriger Zustimmung von Anteilinhabern, welche
mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.
Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handels-
gesellschaften verwiesen.
Art. 9. Ein Anteilinhaber, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Siege-
lanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang der
Gesellschaft beeinträchtigen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Hauptversammlung der Anteilin-
haber beziehen.
Titel III. Geschäftsführung
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die Anteilinhaber sein können. Der
(die) Geschäftsführer werden von dem alleinigen Anteilinhaber oder der Hauptversammlung der Anteilinhaber bestellt,
die sie auch jederzeit wieder abberufen können. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, Teilbefugnisse einem oder mehreren
Bevollmächtigten zu übertragen.
Art. 11. Die Anzahl, die Amtszeit und die jeweilige Entschädigung der Geschäftsführer werden von dem alleinigen
Anteilinhaber oder der Hauptversammlung der Anteilinhaber festgelegt.
Der Posten eines Geschäftsführers gilt als zu besetzen, wenn:
- der Geschäftsführer von seinem Posten durch schriftliche Anzeige gegenüber der Gesellschaft zurücktritt, oder
99050
L
U X E M B O U R G
- der Geschäftsführer seinen Posten kraft Gesetzes aufgeben muss oder wenn er aufgrund Gesetzes von der Eigenschaft
als Geschäftsführer ausgeschlossen wird,
- der Geschäftsführer insolvent wird, oder
- der Geschäftsführer durch den alleinigen Anteilinhaber oder die Hauptversammlung der Anteilinhaber abgewählt wird.
Art. 12. Jeder Geschäftsführer ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung
und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Geschäftszweck durchführen zu können. Alle Befugnisse,
die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Hauptversammlung der Anteilinhaber zugeschrieben wer-
den, fallen in den Aufgabenbereich des/der Geschäftsführer(s). Der/die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft in ihrem
eigenen Namen gegenüber Dritten in jeder Rechtsstreitigkeit entweder als Klägerin oder Beklagte.
Art. 13. Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden. Dies
gilt auch für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer bestellt sind. Darüber hinaus kann eine gesonderte Entscheidung
getroffen werden, durch die die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entscheidung
des/der Geschäftsführer(s) an andere Personen delegiert wird. Eine solche Delegation lässt die Einzelzeichnungsbefugnis
der Geschäftsführer unberührt.
Titel IV. Hauptversammlung der Anteilinhaber
Art. 14. Jeder Anteilinhaber darf an gemeinsamen Entscheidungen unabhängig von der von ihm gehaltenen Anzahl von
Anteilen teilnehmen. Jeder Anteilsinhaber hat Stimmrecht entsprechend der von ihm gehaltenen Anteile.
Solange die Gesellschaft nur einen Anteilinhaber hat, übt dieser die Rechte der Hauptversammlung der Anteilinhaber
gemäß Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 aus.
Alle Entscheidungen, die die Kompetenzen der/des Geschäftsführer(s) überschreiten, werden von dem alleinigen An-
teilinhaber oder der Hauptversammlung der Anteilinhaber getroffen. Solche Beschlüsse müssen schriftlich gefasst werden
und werden in einem speziellen Register der Gesellschaft eingetragen.
Für den Fall mehrerer Anteilinhaber, werden die Beschlüsse in der Hauptversammlung der Anteilinhaber gefasst oder
durch schriftliche Beratung auf Initiative der/des Geschäftsführer(s). Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn An-
teilinhaber, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.
Die Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Titel V. Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven
Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezembertag eines jeden
Jahres.
Art. 16. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der
Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.
Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und
der Provisionen, stellen den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-
ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und aus
welchem Grund auch immer, vermindert wurde.
Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht dem alleinigen Anteilinhaber oder der Hauptversammlung der Antei-
linhaber zur Verfügung.
Art. 17. Die Hauptversammlung der Anteilinhaber verabschiedet jedes Jahr einen Geschäftsplan, einschließlich eines
Haushaltsplans, mit Blick auf das darauffolgende Jahr oder die darauf folgenden Jahre.
Titel VI. Liquidation, Auflösung
Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,
welche keine Anteilinhaber sein müssen und welche von der Hauptversammlung der Anteilinhaber, mit der in Artikel 142
des Gesetzes von 1915 bestimmten Mehrheit, ernannt werden. Der (die) Liquidator(en) verfügt/verfügen über die weitest
gehenden Befugnisse zur Veräußerung der Aktiva und Begleichung der Verpflichtungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sollen alle Auszahlungen, die nach dem Gesetz vorgeschrieben sind, in der Art
und Weise erfolgen, wie sie von den Anteilinhabern vereinbart ist.
Titel VII. Verschiedenes
Art. 19. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen, insbesondere die Regelungen des Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.
99051
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:
Die oben genannte PATRIZIA Wohnmodul I Zwischenholding S.à r.l. zeichnet einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile
gegen Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).
Der Nachweis über diese Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) wurde gegenüber dem
unterzeichneten Notar erbracht.
<i>Kosteni>
Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf neunhundert
Euro.
<i>Beschlüsse der Alleinigen Anteilinhaberini>
Sodann fasst die Erschienene, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:
(i) Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Dauer als Geschäftsführer bestellt:
- Herr Arwed Fischer, geboren am 02. November 1952 in Kemnath, Deutschland, geschäftlich ansässig in Fuggerstraße
26, D-86150 Augsburg, Deutschland; und
- Herr Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren am 21. Dezember 1967 in München, Deutschland, geschäftlich ansässig in
2-4, Rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
(ii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den vorgenannten Bevollmächtigten der Erschienenen, hat
letzterer mit Uns, dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. AUDESIRK, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., le 10 juin 2015. Relation: EAC/2015/13204. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-
EUR).
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2015092456/159.
(150103562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Kensington UK Retail (Scarborough AW) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Ribble Investment S.à r.l.).
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 184.152.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of the month of May.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 7NQ S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 180.314 (the “Sole
Shareholder”),
here represented by Maître Ségolène Le Marec, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a
proxy given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 28
th
May 2015.
Said power of attorney, after having been initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and by the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
being the Sole Shareholder of Ribble Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability
company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under
number B184.152 (the “Company”), incorporated by a deed before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Lu-
xembourg, Grand- Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in
Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg, dated 9 January 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the "Mémorial") on 1 April 2014 number 832.
The appearing party, represented as stated above, declared and the notary recorded as follows:
99052
L
U X E M B O U R G
I. That the appearing party is the Sole Shareholder of the Company and holds the seven hundred fifty (750) shares with
a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20) each in issue in the Company so that the entire share capital is represented
and decisions can be validly taken by the Sole Shareholder.
II. That the Sole Shareholder wishes to take a decision on the following item of the agenda:
- Change of the name of the Company into “Kensington UK Retail (Scarborough AW) S.à r.l.” and consequential
amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
“ Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Kensington UK
Retail (Scarborough AW) S.à r.l." (the "Company") is existing among the subscribers and all persons who will become
shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.”
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, it took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company into “Kensington UK Retail (Scarborough AW) S.à
r.l.” and to consequentially amend Article 1 of the articles of the Company as follows:
“ Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Kensington UK
Retail (Scarborough AW) S.à r.l." (the "Company") is existing among the subscribers and all persons who will become
shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation”.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this amendment to the articles of association are estimated at approximately EUR 1100.
The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above
appearing party the present deed is worded in English followed by and German translation. On request of the same appearing
party and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its name, first name,
civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten Mai.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg.
Ist erschienen:
BRE/Europe 7NQ S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen
Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, und eingetragen ist im Registre de Commerce et des
Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B 180.314 (der „Alleinige Gesellschafter“),
hier vertreten durch Me Ségolène Le Marec, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg am 28. Mai 2015.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung „ne varietur“ durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
als Alleiniger Gesellschafter der Ribble Investment S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, und
eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B184.152 (die „Gesellschaft“),
gegründet am 9. Januar 2014 durch Urkunde des Notars Maître Martine SCHAEFFER, mit dem Amtssitz in Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, handelnd in Ersetzung von Maître Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg, veröffentlicht am 1. April 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das
„Mémorial“), unter Nummer 832.
Die erschienene Partei, wie oben dargestellt vertreten, erklärte und ersuchte den Notar folgendes zu beurkunden:
I. Die erschienene Partei ist der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft und hält siebenhundert fünfzig (750) ausge-
gebenen Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Pfund Sterling (GBP 20), so dass das gesamte Gesellschaftskapital
vertreten ist, und rechtsgültig über alle Punkte der Tagessordnung entschieden werden kann:
II. Der Punkt über den ein Beschluss getroffen werden soll ist der folgende:
- Änderung des Namens der Gesellschaft in „Kensington UK Retail (Scarborough AW) S.à r.l.“ und folgliche Änderung
des Artikels 1 der Satzung der Gesellschaft, welches wie folgt lauten soll:
„ Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem
Namen „Kensington UK Retail (Scarborough AW) S.à r.l." (die „Gesellschaft") besteht zwischen den Ausstellern und allen
99053
L
U X E M B O U R G
Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende Gesetzgebung geregelt.“
Danach wurde der folgende Beschluss vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:
<i>Alleiniger Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschloss, den Namen der Gesellschaft in „Kensington UK Retail (Scarborough AW) S.à
r.l.“ abzuändern und den Artikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern:
„ Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem
Namen „Kensington UK Retail (Scarborough AW) S.à r.l." (die „Gesellschaft") besteht zwischen den Ausstellern und allen
Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende Gesetzgebung geregelt.“
<i>Kosten, Schätzungi>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Satzungsänderung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1100 geschätzt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit dass auf Anfrage der erschienenen
Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im
Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei der dem
amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat derselbe zusammen mit dem Notar die
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: S. Le Marec et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 juin 2015. 2LAC/2015/12469. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): André Muller.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2015.
Référence de publication: 2015092492/107.
(150103961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Global Funds Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 37.359.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 9 juin 2015
que Messieurs Takayuki Nakano, Shinichi Masuda, Alan F. Crutchett et Jean-François Caprasse ont été réélus adminis-
trateurs pour une durée se terminant à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en 2016 et que Madame Virginie
Lagrange a été élue administratrice de façon définitive pour une durée se terminant à l'assemblée générale de la Société
qui se tiendra en 2016.
Le conseil d'administration de la Société se compose comme suit pour une durée se terminant à l'assemblée générale de
la Société qui se tiendra en 2016:
- Takayuki NAKANO;
- Shinichi MASUDA;
- Alan F. CRUTCHETT;
- Jean-François CAPRASSE;
- Virginie LAGRANGE.
Il résulte également du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 9
juin 2015 que la société Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-
Duché du Luxembourg, a été reconduite dans ses fonctions de réviseur d'entreprises agréé pour une durée se terminant à
l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2015.
Référence de publication: 2015088901/26.
(150101750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.
99054
L
U X E M B O U R G
Symbol Holdco B-T Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 197.652.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of June.
Before us Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Symbol Holdco A-T S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Luxembourg, in process to be registered with the Luxembourg register of commerce and companies, the
corporate capital of which is fixed at EUR 12,500.
Such appearing party is here represented by Mr. Manuel Gavin, private employee, residing professionally in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. Legal Form. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of
Symbol Holdco B-T S.à r.l. (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
2.2. The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment to the articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
99055
L
U X E M B O U R G
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these
articles of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the general meeting of shareholders shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on
the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders.
9.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall
be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or
at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
9.2 Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening
notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
10.3 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.
10.4 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of
communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
99056
L
U X E M B O U R G
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.
Art. 11. Change of nationality.
11.1 The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association.
12.1 Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
three quarters of the share capital at least.
Art. 13. Shareholder reserved matters.
13.1 Notwithstanding anything to the contrary in these articles of association, decisions to be taken by the general
meeting of shareholders or the board of managers, as the case may be, concerning Shareholders’ Reserved Matters (as
defined below) may only be taken:
(i) by the general meeting of shareholders or with its prior consent, as the case may be, in accordance with the quorum
and majority rules required to amend the articles of association; and
(ii) with the prior written consent (in respect of each resolution passed concerning Shareholder Reserved Matters (as
defined below)) of the secured finance parties in respect of any loan facility agreement entered into inter alia between (i)
the Company and/or its subsidiaries and (ii) such secured finance parties. For the avoidance of doubt, such prior written
consent will be required only (a) in case a pledge has been granted to such secured finance parties over (i) the shares of the
Company and/or (ii) over the shares of the Company’s direct or indirect subsidiary(ies), (b) during the period that all such
pledges are effective (and shall therefore no longer be required once any such pledge is released or terminated); and (c) to
the extent required by any such pledge.
13.2 For the sake of understanding of the preceding article 13.1, “Shareholders’ Reserved Matters” shall mean any action
or decision of any kind:
(i) relating to any change to the corporate form of the Company or its subsidiaries or nationality of the Company or its
subsidiaries or any transfer of the registered office of the Company or its subsidiaries to a place outside of their jurisdiction
of incorporation; or
(ii) relating to any merger (or similar restructuring), dissolution, winding-up or liquidation on a voluntary basis of the
Company or its subsidiaries; or
(iii) relating to any amendment to these articles of association relating to the appointment and revocation of the Manager
(s) or any other managers; or
(iv) relating to the appointment and revocation of the Manager(s) or the replacement of the Manager(s); or
(v) relating to any amendment to these articles of association or its subsidiaries which has the effect of adversely affecting
the rights of any beneficiary of security over the shares of the Company or its subsidiaries, including for the avoidance of
doubt any rules applicable to the appointment, the revocation or the powers of the management of the Company or its
subsidiaries; or
(vi) whose direct or indirect purpose or effect is to establish that the “centre of main interest” (within the meaning of
the Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as amended) of the Company or
its subsidiaries ceases to be in the Grand Duchy of Luxembourg.
A reference to a subsidiary in this Article 13 is a reference to any direct or indirect subsidiaries in which the Company
holds shares.
D. Management
Art. 14. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
14.1 The Company is managed by one or several Managers, who need not be Shareholder(s). If several Managers have
been appointed, the Managers will constitute the Board of Managers.
14.2 The Manager(s) shall be appointed by the Shareholder(s) or, as the case may be, by the General Meeting, which
will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate. The Manager(s)
will hold office until its (their) successor(s) is (are) elected. It (They) may be re-elected at the end of its (their) term and
he (they) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the Shareholder(s) or, as the case may
be, of the General Meeting.
14.3 In case there is more than one Manager, the Shareholder(s) or, as the case may be, the General Meeting may decide
to qualify the appointed Managers as "Class A Managers" and" Class B Managers".
The Manager(s) may be dismissed freely at any time, with or without cause, by a decision of the shareholders representing
more than half of the Company's share capital.
14.4 In dealing with third parties, the Manager, or in case of several Managers, the Board of Managers has the most
extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent
with the Company's purpose.
99057
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Convening meetings of the board of managers.
15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event
of a tie, the chairman shall have a casting vote.
16.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 18. Dealing with third parties.
18.1 The Company shall be bound towards third parties by the individual signature of the sole manager or of any manager.
18.2 However, if the shareholders have qualified the managers as Class A Managers or as Class B Managers, the
Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Manager and one (1) Class B
Manager.
18.3 The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature or any person
to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the board of managers, within
the limits of such special power.
E. Audit and supervision
Art. 19. Auditor(s).
19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
19.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
19.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
99058
L
U X E M B O U R G
19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
19.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 20. Financial year.
20.1 The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first
of December of the same year.
Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
21.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
21.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
21.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
23.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 24. Governing law.
24.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.
I. Interpretation and Luxembourg law
Art. 25. Interpretation and Luxembourg Law.
25.1 In these Articles:
25.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications)
thereof.
99059
L
U X E M B O U R G
25.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general
words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular
class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;
25.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
25.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Subscription and paymenti>
All the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by Symbol Holdco A-T S.à r.l. aforemen-
tioned, for the subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-). All these shares have been fully
paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) which is entirely allocated to the
share capital of the Company, is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Transitional dispositionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2016.
3. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, representing the entirety of the subscribed
share capital adopted through its proxyholder, the following resolutions:
1) The address of the registered office of the Company is set at L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2) The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined period and with immediate
effect:
(i) Steven Kauff, born in New York, United States of America, on 27 April 1962, professionally residing at 6
th
floor,
6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
(ii) Jonathan Farkas, born in New York, United States of America, on 5 June 1980, professionally residing at 6
th
floor,
6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg; and
(iii) David Fallick, born in New York, United States of America, on 16 August 1963, residing at 6
th
floor, 6A route de
Trèves, L-2633 Senningerberg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le quatrième jour de juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
A comparu:
Symbol Holdco A - T S.à r.l, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, en cours d’enregistrement auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le capital social de laquelle est fixé à EUR 12.500,00.
Laquelle partie comparante est ici représentée par Monsieur Manuel Gavin, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de la
constitution d’une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Symbol Holdco B-T S.à
r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
99060
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Objet.
2.1. La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3. Excepté par voie d’appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non garanties,
et d’une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l’accomplissement de ses objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège Social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique
ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B- Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq
cent (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d’inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
99061
L
U X E M B O U R G
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d’ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés.
9.1 Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale des associés devra
être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au Luxembourg au siège social de la Société
ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée générale.
9.2 D’autres assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent
être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même agenda et les décisions sont vala-
blement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
10.3 Tout associé pourra prendre part aux assemblées des associés en désignant par écrit, ou par télécopie, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication, une autre personne comme son mandataire.
10.4 Les associés prenant part à une assemblée par visioconférence ou tout autre moyen de communication permettant
leur identification sont censés être présents pour le calcul des quorums et des votes. Les moyens de communication utilisés
doivent permettre à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre les uns les autres de façon continue et doivent
permettre une participation effective de toutes ces personnes à la réunion.
Art. 11. Changement de nationalité.
11.1 Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts.
12.1 Toute modification des statuts requiert l'accord d’une (i) majorité des associés (ii) représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Art. 13. Matières réservées aux associés.
Art. 13.1. Nonobstant toute disposition contraire dans les présents statuts, les décisions devant être prises par l'assemblée
générale des associés ou le conseil de gérance, selon le cas, relatives aux Matières Réservées aux Associés (telles que
définies ci-dessous) ne peuvent être prises que:
(i) par l'assemblée générale des associés ou avec son consentement préalable, selon le cas, conformément aux règles de
quorum et de majorité requises pour modifier les statuts; et
(ii) avec le consentement écrit préalable (en ce qui concerne chaque résolution passée relative aux Matières Réservées
aux Associés (telles que définies ci-dessous)) des parties financières garanties en ce qui concerne tout contrat de prêt conclu
inter alia entre (i) la Société et/ou ses filiales et
(ii) ces parties financières garanties. Afin d'éviter tout doute, ce consentement écrit préalable ne sera requis que (a) en
cas de nantissement donné à ces parties financières garanties sur (i) les parts sociales de la Société et/ou (ii) sur les parts
sociales/actions de filiale(s) directe(s) ou indirecte(s) de la Société, (b) durant la période au cours de laquelle tous ces
nantissements sont effectifs (et ne seront pour cela plus requis une fois qu'un tel nantissement est levé ou terminé); et (c)
dans la mesure requise par tel nantissement.
13.2 Dans l'intérêt de la compréhension de l'article 13.1 précédent, "Matières Réservées aux Associés" désigne toute
action ou décision de toute nature:
99062
L
U X E M B O U R G
(i) relative à tout changement de forme sociale de la Société ou de ses filiales ou de nationalité de la Société ou de ses
filiales ou tout transfert de siège social de la Société ou de ses filiales en un lieu hors de leur juridiction de constitution; ou
(ii) relative à toute fusion (ou restructuration similaire), dissolution, faillite ou liquidation sur base volontaire de la
Société ou de ses filiales; ou
(iii) relative à toute modification des présents statuts relative à la nomination ou révocation de Gérant(s) ou autre gérants;
ou
(iv) relative à la nomination ou révocation du/des Gérant(s) ou le remplacement du/des Gérant(s); ou
(v) relative à toute modification des présents statuts ou de ceux de ses filiales qui a pour effet d'affecter défavorablement
les droits de tout bénéficiaire de garantie sur les parts sociales de la Société ou de ses filiales, y compris, afin d'éviter tout
doute, toute règle applicable à la nomination, la révocation ou les pouvoirs de gestion de la Société ou de ses filiales; ou
(vi) dont le but direct ou indirect ou l'effet est d'établir que le "centre d'intérêt principal" (au sens du règlement du Conseil
(EC) No 1346/2000 du 29 mai 2000 sur les procédures d'insolvabilité, tel que modifié) de la Société ou de ses filiales cesse
d'être au Grand-Duché de Luxembourg.
Une référence à une filiale dans cet Article 13 est une référence à toute filiale directe ou indirecte dans laquelle la Société
détient des parts sociales/actions.
D. Gérance
Art. 14. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
14.1 La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, qui n'ont pas besoin d'être Associés. Si plusieurs Gérants sont
nommés, les Gérants constituent un conseil de gérance.
14.2 Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) par le (les) Associé(s), ou le cas échéant, par l'Assemblée Générale, qui
détermine leur nombre, leur rémunération et la durée limitée ou illimitée de leur mandat. Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé
(s) jusqu'à la nomination de leur(s) successeur(s): il(s) peut (peuvent) être réélu(s) au terme de leur mandat et il(s) peut
(peuvent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de(s) Associé(s), ou le cas échéant par une
Assemblée Générale.
14.3 Dans le cas d'une pluralité de Gérants, l'(les) Associé(s) ou le cas échéant, l'Assemblée Générale peut décider de
nommer des Gérants de classe A et des Gérants de classe B.
Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une
décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
14.4 Vis-à-vis des tiers, le Gérant ou, dans le cas ou il y a plusieurs Gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à
son objet.
Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs d’une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel document signé
constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en
constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil
de gérance.
16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
99063
L
U X E M B O U R G
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s’être tenue
au siège social de la Société.
16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. En cas de partage des voix, le président du conseil de gérance dispose d’une voix prépondérante.
16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.
Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par
deux (2) gérants.
17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
Art. 18. Rapports avec les tiers.
18.1 La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique ou la signature
individuelle de l'un des gérants.
18.2 Toutefois, si les associés ont qualifié les gérants de Gérants de Catégorie A ou de Gérants de Catégorie B, la Société
ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Catégorie A et d'un (1) Gérant de
Catégorie B.
18.3 La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle
de toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué
par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
E. Audit et surveillance
Art. 19. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
19.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 20. Exercice social.
20.1 L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre
de la même année.
Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
21.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
99064
L
U X E M B O U R G
21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-
néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
21.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la
Société.
Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
23.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre
de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 24 Loi applicable.
24.1 Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
I. Interprétation et loi luxembourgeoise
Art. 25. Interprétation et Loi Luxembourgeoise.
25.1 Dans les présents Statuts:
25.1.1 Une référence à:
(a) un genre devra inclure chaque genre;
(b) à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;
(c) une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouvernement,
état ou agence d'un état ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des
employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
(d) une disposition légale ou statutaire inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec
ou sans modifications);
25.1.2 les mots "inclure" et "incluant" seront censé être suivis par les mots "sans limitation" et on ne donnera pas aux
mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis d'un mot indiquant un terme
particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;
25.1.3 Les en-têtes de ces Statuts ne doivent pas affecter leur interprétation.
25.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxem-
bourgeoise.
<i>Dispositions transitoirei>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale des associés sera tenue en 2016.
3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par Symbol Holdco A-T S.à r.l., susmen-
tionnée, pour le prix de souscription de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-).
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) qui est entièrement allouée au capital social de la Société, se trouve dès à présent à
la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
99065
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.200.-.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la partie comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
a adopté, au travers de son mandataire, les résolutions suivantes:
1) L'adresse du siège social de la Société est établie à L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2) Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée et avec effet
immédiat:
- M. Steven Kauff, né à New York, Etats-Unis d’Amérique, le 27 avril 1962, résidant professionnellement au 6
ème
étage, 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
- M. Jonathan Farkas, né à New York, Etats-Unis d’Amérique, le 5 juin 1980, résidant professionnellement au 6
ème
étage, 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, et
- M. David Fallick, né à New York, Etats-Unis d’Amérique, le 16 août 1963, résidant au 6
ème
étage, 6A route de Trèves,
L-2633 Senningerberg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l’a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. GAVIN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 9 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/17807. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 16 juin 2015.
Référence de publication: 2015092547/624.
(150103560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
M3 Architectes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.
R.C.S. Luxembourg B 58.144.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 6i>
<i>mai 2015 à 16.00 heuresi>
L'assemblée renouvelle jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2021 les mandats des administrateurs
suivants:
Monsieur Joseph DELL, administrateur et administrateur-délégué, né à Luxembourg (L) le 19.10.1957, demeurant à L
- 1316 Luxembourg, 34, Rue des Carrières
Madame Marie-Hélène LUCAS, administrateur et administrateur-délégué, née à Verviers (B) le 27.04.1960, demeurant
à L - 7475 Schoos, 1, Rue du Puits
Monsieur Luc SCHROEDER, administrateur, né à Verviers (B) le 25.02.1968, demeurant à L -5942 Itzig, 3, Rue Désiré
Zahlen
Monsieur Jürgen SIMON, administrateur, né à Neunkirchen/Saar (D) le 12.01.1971, demeurant à D - 54298 Aach, 50,
Auf der Wiese
Madame Françoise HALSDORF, épouse DELL, administrateur, née à Luxembourg (L) le 07.02.1961, demeurant à L
- 1316 Luxembourg, 34, Rue des Carrières
Le mandat du commissaire aux comptes la société FIRELUX S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés Luxembourg sous le numéro B 84 589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy, est également
renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2021.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2015089016/26.
(150101659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.
99066
L
U X E M B O U R G
Randstad Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 691.119.350,00.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 138.753.
In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of June.
In front of Maître Martine SCHAEFFER, notary established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Randstad Holding Luxembourg S.à r.l.” a "société à
responsabilité limitée", having its registered office at 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, incorporated by deed of
Me Joseph ELVINGER, then notary residing in Luxembourg on May 16, 2008, published in the “Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations” (“Mémorial C”), number 1463 dated June 13, 2008 and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under the number B 138753 (the “Company”).
The articles of association of the Company have last been lastly amended by a notarial deed of Me Martine SCHAEFFER,
notary residing in Luxembourg, enacted on December 18, 2014, published in the “Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations” (“Mémorial C”), number 714 dated March 14, 2015.
The meeting is presided by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo.
The chairman appoints as secretary Mrs Marilyn KRECKÉ, private employee, residing professionally at the same ad-
dress.
The meeting elects as scrutineer Mrs Isabel DIAS, prenamed.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That
list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 27,644,773 (twenty-seven million six hundred and forty-four thousand seven
hundred and seventy-three) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each, representing the whole capital of
the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole
shareholder has been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1-. Increase of the share capital by an amount of EUR 25 (twenty-five euro) so as to raise it from its present amount of
EUR 691,119,325 (six hundred and ninety-one million one hundred and nineteen thousand three hundred and twenty-five
euro) to EUR 691,119,350 (six hundred and ninety-one million one hundred and nineteen thousand three hundred and fifty
euro) by the issue of 1 (one) new share with a par value of EUR 25 (twenty-five euro), together with a share premium
amounting to EUR 229,999,975 (two hundred and twenty-nine million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred
and seventy-five euro), by contribution in kind.
2. - Subscription and payment by Randstad Group Luxembourg S.à r.l. of EUR 230,000,000 by way of a contribution
in kind.
3. - Amendment of the Article 8 of the Company’s articles of association in order to give it the following content:
“ Art. 8. The Company’s share capital is EUR 691,119,350 (six hundred and ninety-one million one hundred and nineteen
thousand three hundred and fifty euro) represented by 27,644,774 (twenty-seven million six hundred and forty-four thou-
sand seven hundred and seventy-four) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each”.
4. - Miscellaneous
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:
<i>First resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 25 (twenty-five euro) so as to raise it
from its present amount of EUR 691,119,325 (six hundred and ninety-one million one hundred and nineteen thousand three
hundred and twenty-five euro) to EUR 691,119,350 (six hundred and ninety-one million one hundred and nineteen thousand
three hundred and fifty euro) by the issue of 1 (one) new share with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) (the “New
Share”), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 229,999,975 (two hundred and twenty-nine
million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and seventy-five euro) payable on the share premium account
of the Company (the “Share Premium”), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in the claim
amounting to EUR 230,000,000 (two hundred and thirty million) held by Randstad Group Luxembourg S.à r.l., a “société
à responsabilité limitée”, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, place
de la Gare, L-1616 Luxembourg, with share capital amounting to EUR 3,639,204,500, and registered with the Luxembourg
99067
L
U X E M B O U R G
Trade and Companies Register under number B 138754 (“RGL”), towards Randstad Finance GmbH, a company incorpo-
rated and existing under Swiss laws, with registered office at 45, Leutschenbachstrasse, 8050 Zürich, Switzerland and
registered with the Trade Register of the canton of Zurich under number CH-020.4.025.879-0 (“RF GmbH”).
<i>Second resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment of the New Share and the payment of the Share Premium through
the contribution of the claim as described above by RGL.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes RGL, prenamed, here represented by Mrs Isabel Dias, prenamed, by virtue of a proxy given under
private seal and declares to subscribe to the New Share. The issue of the New Shares is also subject to the payment of the
Share Premium. The New Share as well as the Share Premium have been fully paid up by RGL through a contribution in
kind as described above.
<i>Valuationi>
The net value of the contribution amounts to EUR 230,000,000 (two hundred and thirty million).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated
June 2015, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Managers’ interventioni>
Thereupon intervene the current managers of the Company all of them here represented by Mrs Isabel Dias, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility legally bound as managers of the
Company by reason of the contribution, they expressly agree with the description of this contribution, with its valuation
and confirm the validity of the subscription payment.
<i>Third resolution:i>
Pursuant to the above increase capital, the sole shareholder resolves to amend Article 8 of the articles of association of
the Company, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 8. The Company’s share capital is EUR 691,119,350 (six hundred and ninety-one million one hundred and nineteen
thousand three hundred and fifty euro) represented by 27,644,774 (twenty-seven million six hundred and forty-four thou-
sand seven hundred and seventy-four) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each”.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand Euro (EUR 7,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le huit juin.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée "Randstad Holding Lu-
xembourg S.à r.l.” ayant son siège social à 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître
Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, reçu le 16 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 1463 du 13 juin 2008 et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 138753 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Me Martine SCHAEFFER, notaire de
résidence à Luxembourg, du 18 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
(«Mémorial C») numéro 714 du 14 mars 2015.
L'assemblée est présidée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Lu-
xembourg, 74, avenue Victor Hugo.
Le président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, demeurant professionnellement
à la même adresse.
99068
L
U X E M B O U R G
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabel DIAS, prénommée.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 27.644.773 (vingt-sept millions six cent quarante-quatre mille sept cent
soixante-treize) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l’associé unique a été préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. - Augmentation du capital social pour un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros), afin de le porter de son montant
actuel de EUR 691.119.325 (six cent quatre-vingt-onze millions cent dix-neuf mille trois cent vingt-cinq euros) à EUR
691.119.350 (six cent quatre-vingt-onze millions cent dix-neuf mille trois cent cinquante euros) par l’émission de 1 (une)
nouvelle part sociale ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros), avec une prime d’émission d’un montant
de EUR 229.999.975 (deux cent vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-quinze euros)
par voie d’apport en nature;
2. - Souscription et paiement par Randstad Group Luxembourg S.à r.l. de EUR 230.000.000 par un apport en nature;
3. - Modification de l'article 8 des statuts, pour lui donner le contenu suivant:
« Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 691.119.350 (six cent quatre-vingt-onze millions cent dix-neuf mille trois cent
cinquante euros) représenté par 27.644.774 (vingt-sept millions six cent quarante-quatre mille sept cent soixante-quatorze)
parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»
4. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l’associé décide ce qui suit:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé d’augmenter le capital social pour un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros), afin de le porter de son montant
actuel de EUR 691.119.325 (six cent quatre-vingt-onze millions cent dix-neuf mille trois cent vingt-cinq euros) à EUR
691.119.350 (six cent quatre-vingt-onze millions cent dix-neuf mille trois cent cinquante euros) par l’émission de 1 (une)
nouvelle part sociale ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) (la «Nouvelle Part»), moyennant le paiement
d’une prime d’émission globale d’un montant de EUR 229.999.975 (deux cent vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf mille neuf cent soixante-quinze euros) payable sur le compte de prime d’émission de la Société (la «Prime
d’Emission»), la totalité devant être libérée par un apport en nature consistant au transfert d’une créance d’un montant de
EUR 230.000.000 (deux cent trente millions) détenue par Randstad Group Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité
limitée, constituée et existant sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, place de la Gare,
L-1616 Luxembourg, avec un capital social de EUR 3.639.204.500, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 138754 (“RGL”), envers Randstad Finance GmbH, une société constituée et existant
sous le droit Suisse, ayant son siège social au 45, Leutschenbachstrasse, 8050 Zürich, Switzerland et inscrite au Registre
de Commerce du canton de Zurich sous le numéro CH-020.4.025.879-0 (“RF GmbH”).
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement de la Nouvelle Part et le paiement de la Prime d’Emission par voie
d’apport en nature tel que décrit ci-dessus par RGL.
<i>Intervention de l’Apporteur - Souscription - Paiementi>
Ensuite intervient RGL, ici représenté par Mme Isabel Dias, prénommée, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé et qui déclare souscrire la Nouvelle Part. La Nouvelle Part a été entièrement payée par RGL par voie d’apport en
nature tel que décrit ci-dessous.
<i>Évaluationi>
La valeur nette de l’apport s’élève à EUR 230.000.000 (deux cent trente millions).
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l’apport en
date de juin 2015, qui sera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire soussigné.
99069
L
U X E M B O U R G
<i>Intervention des gérantsi>
Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés par Mme Isabel Dias, prénommée, en vertu d’une procu-
ration donnée sous seing privé. Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité,
légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison de l’apport, acceptent expressément la description de cet apport,
avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.
<i>Troisième résolution:i>
Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’associé décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société, qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 691.119.350 (six cent quatre-vingt-onze millions cent dix-neuf mille trois cent
cinquante euros) représenté par 27.644.774 (vingt-sept millions six cent quarante-quatre mille sept cent soixante-quatorze)
parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cette augmentation de prime d’émission, ont été estimés à sept mille Euros (EUR 7.000.-).
Aucun autre point n’ayant à être traité, l’assemblée a été ajournée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au jour qu'en tête.
Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l’original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l’assemblée, le
présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: I. Dias, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 10 juin 2015. 2LAC/2015/12937. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): André Muller.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2015.
Référence de publication: 2015092489/188.
(150103178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Reinet Fund S.C.A., F.I.S., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 141.613.
In the year two thousand fifteen, on the eighteenth day of May.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of “Reinet Fund S.C.A., F.I.S.” (hereafter referred to
as the "Company"), a société en commandite par actions qualifying as fonds d’investissement spécialisé having its registered
office at 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 141 613.
The Company was incorporated under Luxembourg law by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Lu-
xembourg, on 27 August 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number
2436 on 6 October 2008.
The articles of incorporation of the Company were last amended by a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 29
January 2010 and published in the Mémorial number 950 on 6 May 2010.
The Meeting was presided by Me Laetitia Servais, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg as chairman
of the Meeting.
The chairman appointed as secretary Mrs Debbie Johnstone, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Christine Burgard, employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the Meeting (hereafter referred to as the “Bureau”) having thus been constituted, the chairman declared
and requested the notary to state:
99070
L
U X E M B O U R G
I. All the registered shares of the Company outstanding as shown on the attendance list attached to these minutes were
represented so that the Meeting could be held without prior notice.
II. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the
proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the proxies,
will remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.
III. The Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:
<i>Agendai>
1. Change of date of the Annual General Meeting of shareholders: Amendment of the first paragraph of article 18 of the
articles of incorporation of the Company in order to change the date of the annual general meeting of shareholders from
the second Tuesday of the month of September each year at 11.00 am Central European Time to the last Tuesday of the
month of August each year at 11.00 am Central European Time.
2. Authorised share capital: Decision on the renewal of the authorised share capital of the Company and related autho-
risations and waivers by:
a. the acknowledgement of the report of Reinet Fund Manager S.A., being the general partner of the Company (the
“General Partner” or the “Manager”) in relation to the authorised share capital and the proposed authorisation to be granted
to the Manager of the Company to issue ordinary shares (actions de commanditaire) held by the limited shareholders
(“Ordinary Shares”) (and/or instruments convertible into Ordinary Shares or giving rights to subscribe for Ordinary Shares)
within the limits of the authorised share capital and to waive, suppress or limit preferential subscription rights of share-
holders in relation to such issuances;
b. the renewal of the validity period of the Company’s authorised unissued share capital for a period starting on the date
of the Meeting and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the
minutes of the Meeting;
c. the renewal of the authorisation of the Manager, for a period starting on the date of the Meeting and ending on the
fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of the Meeting, to issue
further Ordinary Shares (and/or instruments convertible into Ordinary Shares or giving rights to subscribe for Ordinary
Shares) up to the total authorised capital in whole or in part from time to time and disapply preferential subscription rights
for existing shareholders as the Manager may in its discretion, but subject to the corporate interest, determine; and
d. the subsequent amendment of paragraphs 7 to 10 of article 5 of the articles of incorporation of the Company to reflect
the resolutions taken in relation to items 2.b and 2.c of this agenda.
3. Translation of the articles of incorporation of the Company:
Removal of the French translation of the articles of incorporation of the Company.
Thereafter, the following resolutions were unanimously adopted:
<i>First resolutioni>
The Meeting unanimously resolves to amend the first paragraph of article 18 of the articles of incorporation of the
Company so as to read as follows:
“ Art. 18. The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at any other place in Luxembourg as specified in the convening notices on the last Tuesday of the month of August each
year at 11.00 am Central European Time. If such a day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on
the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of
the Manager, exceptional circumstances so require.”
<i>Second resolutioni>
The Meeting acknowledges the report of the Manager presented pursuant to article 32-3(5) of the law of 10
th
August
1915 on commercial companies, as amended, in relation to the authorised share capital and the proposed authorisation to
be granted to the Manager of the Company to issue Ordinary Shares (and/or instruments convertible into Ordinary Shares
or giving rights to subscribe for Ordinary Shares) within the limits of the authorised share capital and to waive, suppress
or limit preferential subscription rights of shareholders in relation to such issuances.
The Meeting unanimously resolves to renew the authorised unissued share capital of two billion Euro (EUR
2,000,000,000) for a period of five years starting on the date of the publication in the Memorial of the minutes of the
extraordinary general meeting of 18 May 2015.
The Meeting unanimously resolves to renew the authorisation of the Manager, for a period starting on the date of this
Meeting and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes
of such meeting, to issue new Ordinary Shares (and/or instruments convertible into Ordinary Shares or giving rights to
subscribe for Ordinary Shares), up to the total authorised share capital.
The Meeting further unanimously resolves to authorise the Manager to issue Ordinary Shares against contributions in
cash, in kind or by the incorporation of reserves, issues premiums or retained earnings in accordance with Luxembourg
law and the prospectus.
99071
L
U X E M B O U R G
The Meeting unanimously resolves to authorise the Manager to set the subscription price, with or without issue premium
and the date from which the relevant Ordinary Shares will carry beneficial rights.
The Meeting then unanimously resolves to renew the authorisation to the Manager to disapply preferential subscription
rights for existing shareholders as the Manager may in its discretion, but subject to the corporate interest, determine.
Consequently, the Meeting unanimously resolves to amend paragraphs 7 to 10 of article 5 of the articles of incorporation
of the Company so as to read as follows:
“ Art. 5. The authorised unissued share capital of the Company is set at two billion Euro (EUR 2,000,000,000).
Any authorised but unissued share capital shall lapse five (5) years after the publication of the decision providing for
such authorised but unissued share capital in the Mémorial.
Out of the authorised share capital, the Manager is authorised to issue further Ordinary Shares (and/or instruments
convertible into Ordinary Shares or giving rights to subscribe for Ordinary Shares) up to the total authorised capital in
whole or in part from time to time subject to the terms and conditions determined by the Manager and disclosed in the
prospectus of the Company.
The Manager may, when issuing authorised Shares, disapply preferential subscription rights for existing shareholders
as it may in its discretion, but subject to the corporate interest, determine.”
<i>Third resolutioni>
The Meeting unanimously resolves to remove the French translation in the articles of incorporation of the Company,
such translation not being required pursuant to article 26(2) of the law of 13 February 2007 on specialised investment funds,
as amended.
There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, civil
status and residences, signed together with Us, the Notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English only, in accordance with article 26 of the Luxembourg law of 13 February
2007 relating to specialised investment funds, as amended.
Signé: L. SERVAIS, D. JOHNSTONE, C. BURGARD et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15746. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 juin 2015.
Référence de publication: 2015092501/114.
(150104045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.
Links Bidco S.à r.l. Propco 9, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.497.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2015:i>
- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mons. Kailash Ramassur, employée privée, résidant
professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire
Mme. Marion Fritz, avec effet au 29 mai 2015.
- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mme. Laurie Domecq, employée privée, résidant
professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire
Mons. Daniel Bley, avec effet au 29 mai 2015.
Luxembourg, le 3 juin 2015.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015088984/18.
(150101284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
99072
Bugaboo Holdings
Comgest Europe
Global Funds Management S.A.
JV Holdings S.à.r.l.
Kensington UK Industrial (Huncoat) S.à r.l.
Kensington UK Retail (Scarborough AW) S.à r.l.
Links Bidco S.à r.l. Propco 9
M3 Architectes S.A.
P3M Prestige S.A.
Patrizia Bastite Holdco 1 S.à r.l.
Pro Clean S.à r.l.
Pro Clean S.à r.l.
PSB Investments S.A.
Puck International S.A.
Quo Vadis S.à r.l.
Rain Luxembourg S.A.
Ram (Lux) Tactical Funds II
Randstad Holding Luxembourg S.à r.l.
RDF Investissement
Reacomex
Real Estate Luxembourg S.A.
Red Lion Group S.A.
Reinet Fund S.C.A., F.I.S.
Renaissance Enterprises S.A.
RESOLUTION London W1 S.à r.l.
Restaurant-Auberge Albergo Da Marco S.à r.l.
Rhododendron S.A.
Rhombus Bidco S. à r.l.
Ribble Investment S.à r.l.
Ribeiro S.à r.l.
Richmond Hill Capital Management S.à r.l.
Robertshaw Group Holdings S.à r.l.
Romain Allard s.à.r.l.
Rubicon Venture Partners S.A.
S.A. Enemge
Scientist of Fortune S.A.
SDV Holding
SGBT Asset Based Funding S.A.
SIEBLAN S.à r.l.
Silicon Motion Technology (Luxembourg) Limited
SINEK Capital S.A.
Sinotrade
Smart Immo S.A.
Sorgelux 1 S.A.
Stratus Asset Management SA
Symbol Holdco B-T Sàrl
Tenaris S.A.
Westra Investments S.A.