logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2008

7 août 2015

SOMMAIRE

Agriland Fund S.C.A., SICAV-FIS  . . . . . . . . .

96342

Amlelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96342

BJR International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96341

Business Angel Venture Management S.A. . . .

96342

BYOB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96342

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) . . . . . .

96343

Dania Presents S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96343

Deltainvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96343

Desmag S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96343

Diaverum S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96373

Disar S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96344

Dream Island S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96382

ERF Enschede S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96374

Gero S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96346

InterV Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

96338

INVESCO Paris CDG Airport Hotel Invest-

ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96338

Jeantet Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96345

Kensington UK Pledgeco S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

96358

Kern Tech 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96341

KMU/PME S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96339

L'Air Liquide Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . .

96340

Landlake Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96340

Legal & General Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96366

Links Bidco S.à r.l. Propco 1  . . . . . . . . . . . . . .

96345

Lion Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96341

Lux-Immo-Containers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

96341

Lux Rent Office S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96340

Maple Bidco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96344

MarketPrizm Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

96345

MBERP II (Luxembourg) 26 S.à r.l.  . . . . . . . .

96367

MFB International Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

96339

Monocle Fund SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96340

MyBioBox S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96384

N1ghtfor S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96344

NBIM Otto NKE S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96338

NBIM Otto W1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96338

NBIM Otto W3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96339

NBIM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96339

Olky Payment Service Provider S.A. . . . . . . . .

96384

OT Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96344

OT Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96345

OT Luxco 3 & Cy S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

96339

Riward S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96348

Robec SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96338

Robec SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96344

Robec SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96346

Sautel Investissements Industriels S.A.  . . . . . .

96384

96337

L

U X E M B O U R G

INVESCO Paris CDG Airport Hotel Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.193.

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015086404/9.
(150098313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

NBIM Otto NKE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 171.594.

Les statuts coordonnés au 27 mai 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 09 juin 2015.

Référence de publication: 2015086552/10.
(150098566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

NBIM Otto W1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 171.609.

Les statuts coordonnés au 27 mai 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 09 juin 2015.

Référence de publication: 2015086553/10.
(150098598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

Robec SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 148.610.

Les comptes annuels au 31.03.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ROBEC S.A.
Société Anonyme en cours de liquidation

Référence de publication: 2015086668/11.
(150098661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

InterV Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 10, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 171.844.

<i>Extrait rectificatif sur le dépôt L150093677 du 02 juin 2015

Le dépôt L150093677 du 02 juin 2015 mentionne que, V2 Investment S.à r.l., associé unique de la Société, a transféré

son siège social au 37, rue des Romains, L-2444 Luxembourg.

Or, il convient de modifier l'adresse comme suit: 10, rue des Romains, L-2444 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2015.

Référence de publication: 2015094425/14.
(150104538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

96338

L

U X E M B O U R G

KMU/PME S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6636 Wasserbillig, 7, rue de Mertert.

R.C.S. Luxembourg B 74.665.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2006 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015086442/9.
(150098567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

OT Luxco 3 &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.949.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 juin 2015.

Référence de publication: 2015086583/10.
(150099037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

NBIM Otto W3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 171.592.

Les statuts coordonnés au 27 mai 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 09 juin 2015.

Référence de publication: 2015086554/10.
(150098616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

NBIM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 160.744.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NBIM Sàrl
Per Arne Eriksen
<i>Managing Director

Référence de publication: 2015088265/12.
(150100370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

MFB International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 182.082.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 14 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Beringen, le 11 juin 2015.

Maître Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015088224/13.
(150100757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

96339

L

U X E M B O U R G

L'Air Liquide Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4801 Rodange, Zone du P.E.D.

R.C.S. Luxembourg B 9.958.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015086447/9.
(150098675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

Landlake Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 115.094.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un gérant

Référence de publication: 2015087311/11.
(150099253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2015.

Lux Rent Office S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 159.394.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2014.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015087351/12.
(150100037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2015.

Monocle Fund SICAV, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 189.329.

L'assemblée annuelle des actionnaires du 10 juin 2015 a renouvelé les mandats des membres du conseil d'administration

jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Par conséquent, le conseil d'administration se compose désormais comme suit et ce jusqu'à la fin de l'assemblée générale

ordinaire des actionnaires qui devra se tenir en 2016:

M. Eric Bonnet, Membre du conseil d'administration
22, rue de la Paix, F-75002 Paris
M. Jean-Bernard Quillon, Membre du conseil d'administration
14-16, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
M. Charles Monot, Membre du conseil d'administration
33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
PricewaterhouseCoopers, a été réélu comme commissaire aux comptes, et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée

générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2015088234/22.
(150100820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

96340

L

U X E M B O U R G

Lion Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 151.653.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015086475/9.
(150098229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

Lux-Immo-Containers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.718.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015086485/9.
(150098200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

BJR International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 134.743.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2015

Démission du mandat de commissaire aux comptes:
Fiduciaire et Expertises (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 70.909, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer.
Nomination du mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
FGA (Luxembourg) S.A., RC Luxembourg B 61.096, 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015091851/13.
(150103659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

Kern Tech 1, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 184.360.

<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du 3 juin 2015

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires en date du 3 juin 2015 que:
- les mandats des membres du conseil d'administration suivants, sont renouvelés pour une période de six ans qui arrivera

à échéance lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2020:

* M. Thierry Timsit, ayant son adresse professionnelle au 68, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France;
* Mme Bénédicte Moens-Colleux, ayant son adresse professionnelle au 37A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg;

* M. Pascal Leclerc, ayant son adresse au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
* M. Charles Meyer, ayant son adresse au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
- le mandat de Ernst &amp; Young S.A., réviseur d'entreprises agrée, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771,
est renouvelé pour une période d'un an qui arrivera à échéance lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui
approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Kern Tech 1
Un mandataire

Référence de publication: 2015087287/23.
(150099554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2015.

96341

L

U X E M B O U R G

Business Angel Venture Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 78.001.

Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015091872/10.
(150103026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

BYOB, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 142.060.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 18 mai 2015

L'assemblée générale a décidé de réélire comme commissaire aux comptes de la société, FASCOLUX S.A., enregistrée

au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 168121, dont le siège est situé au 15, rue Astrid, L-1143
Luxembourg. Son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

<i>Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2015091873/13.
(150103430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

Amlelux S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 142.084.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, à la date du 15 juin 2015 à 15.00 heures

1. L'assemblée prend connaissance de la démission de l'administrateur unique Monsieur Marc VOGEL.
2. L'assemblée nomme comme nouvel administrateur unique, Monsieur Gilles Vogel, né le 31 janvier 1976 à Luxem-

bourg, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents et ceci jusqu'à l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2015.

<i>L'administrateur unique

Référence de publication: 2015094062/15.
(150104519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

Agriland Fund S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 168.088.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 9 juin 2015

En date du 9 juin 2015, l'Assemblée Générale Annuelle a décidé:
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, en tant que Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire en 2016.

Luxembourg, le 15 juin 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AGRILAND FUND S.C.A., SICAV-FIS
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2015094056/16.
(150104394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

96342

L

U X E M B O U R G

Dania Presents S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6623 Wasserbillig, 2, Am Haerewengert.

R.C.S. Luxembourg B 91.588.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2015088803/10.
(150101886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.

Deltainvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 169.573.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015088807/10.
(150101435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 69.054.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2015.

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Référence de publication: 2015088793/11.
(150101898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.

Desmag S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 36.625.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 03.04.2015

<i>Quatrième résolution:

Le mandat d'Administrateur de Monsieur Paolo PERINO et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la

présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur de Mon-
sieur Paolo PERINO, dirigeant d'entreprises, né le 27/02/1954 à Milan, résidant professionnellement à Via Messina n°38,
I 20154 Milan, ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, Rue du Laboratoire,
L-1911 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
65.469, pour une nouvelle période de deux ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra
en 2017.

<i>Cinquième résolution:

L'Assemblée Générale prend note de la démission de Monsieur Frank LEMERY de ses fonctions d'Administrateurs à

compter du 19 mai 2014.

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Monsieur David BEUGIN à compter du 19 mai 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DESMAG S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015088811/23.
(150101617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.

96343

L

U X E M B O U R G

Maple Bidco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 197.045.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 673 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015086493/9.
(150098173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

N1ghtfor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 89A, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 189.255.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2015.

Référence de publication: 2015086561/10.
(150098881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

OT Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.931.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 juin 2015.

Référence de publication: 2015086581/10.
(150099040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

Robec SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 148.610.

Les comptes annuels au 31.03.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ROBEC S.A.
Société Anonyme en cours de liquidation

Référence de publication: 2015086669/11.
(150098677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

Disar S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 18.145.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DISAR S.A. - SPF
Société anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015088813/14.
(150101507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.

96344

L

U X E M B O U R G

MarketPrizm Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 160.294.

Les Comptes Annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015086494/9.
(150098751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

OT Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.941.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 juin 2015.

Référence de publication: 2015086582/10.
(150099036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

Jeantet Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 196.196.

<i>Cession de part

En date du 31 mai 2015, JeantetAssociés AARPI a cédé l'intégralité des paris qu'elle détenait dans la Société (à savoir

12.498 paris) à Maître Philippe Portier.

A la suite de cette cession, la répartition des parts sociales est la suivantes:

Philippe PORTIER détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.499 parts

Frédéric DUPONT détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

<i>Pour la Société
Philippe Portier
<i>Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2015087281/17.
(150099220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2015.

Links Bidco S.à r.l. Propco 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 175.441.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 Juin 2015:

- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mons. Kailash Ramassur, employée privée, résidant

professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire
Mme. Marion Fritz, avec effet au 29 mai 2015.

-  Est  nommé  gérant  de  la  société  pour  une  période  indéterminée  Mme.  Laurie  Domecq,  employée  privée,  résidant

professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire
Mons. Daniel Bley, avec effet au 29 mai 2015.

Luxembourg, le 3 juin 2015.

Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015087315/18.
(150099308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2015.

96345

L

U X E M B O U R G

Robec SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 148.610.

Les comptes annuels au 31.03.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ROBEC S.A.
Société Anonyme en cours de liquidation

Référence de publication: 2015086670/11.
(150098680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

Gero S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, an de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 197.556.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.
Den achten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Herr Werner Jürgen CYGANEK, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-15378 Herzfelde, Möllenstrasse, 50,
hier vertreten durch Frau Heike Bretz-Schmitz, Steuerfachwirtin, beruflich ansässig in L-6776 Grevenmacher 10, an de

Längten, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 26. Mai 2015,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Bevollmächtigte des Komparenten und dem

amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung

zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie

durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "GERO S.à r.l.".

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Eigenentwicklung und der Entwurf von Design-Kostümen für Karneval, Trachten-

Kleidung als Vorführmodelle, sowie der Vertrieb der Designer-Lizenzen zur Vervielfältigung.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls das Anmieten und/oder Kauf von Modellen/Lizenzen zum Zwecke der Weiterver-

gabe gegen Gebühr.

Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-

Transaktionen  zu  tätigen,  welche  mit  dem  Gesellschaftszweck  verbunden  werden  können  und  der  Entwicklung  der
Gesellschaft förderlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in ein

hundert (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), alle zugeteilt Herrn Jürgen Werner
CYGANEK, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-15378 Herzfelde, Möllenstrasse, 50.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690

des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

96346

L

U X E M B O U R G

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht wor-
den,  so  werden  die  Gesellschafter  ein  zweites  Mal  durch  Einschreibebrief  zusammengerufen  oder  befragt  und  die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesell-

schaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschaf-

terversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen

bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates
verantwortlich.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der

Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.

Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit

beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

<i>Einzahlung des Gesellschaftskapitals

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€

12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten

Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2015.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).

96347

L

U X E M B O U R G

<i>Erklärung

Der Komparent, vertreten wie vorerwähnt, erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass

die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Werner Jürgen CYGANEK, Diplom-Kaufmann, geboren in Berlin-Weißensee (Deutschland), am 11. Oktober

1956, wohnhaft in D-15378 Herzfelde, Möllenstrasse, 50.

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und

verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6776 Grevenmacher, 10, an de Längten.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.

Signé: H. BRETZ-SCHMITZ, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 juin 2015. Relation: GAC/2015/4849. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G.SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, le 11 juin 2015.

Référence de publication: 2015088899/116.
(150101248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.

Riward S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 238.884.179,78.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 194.133.

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of May,
Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. Hakogel S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office

at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxem-
bourg under number B 39.959 (“Hakogel S.A.”),

2. Weco Comm. V., a limited liability company (“gewone commanditaire vennootschap” / “société en commandite

simple”), governed by the laws of Belgium, with registered office at 2, Tinnenpotstraat, 8850 Ardooie, and registered with
the Register of Legal Entities of Brugge under number 0822.054.511 (“Weco Comm. V.”),

here duly represented, in accordance with clause 6 of the articles of association of this company, by Mr. Jan HASPES-

LAGH, born on 22 May 1961 in Roeselare (Belgium) and residing at Tinnepotstraat, 8850 Ardooie, Belgium, in his capacity
of manager of this company,

3. Ter Heyde Comm. V., a limited liability company (“gewone commanditaire vennootschap” / “société en commandite

simple”), governed by the laws of Belgium, with registered office at 620 Torhoutse Steenweg, 8200 Sint-Andries, and
registered with the Register of Legal Entities of Brugge under number 0822.051.739 (“Ter Heyde Comm. V.”),

4. Cerfima Comm. V., a limited liability company (“gewone commanditaire vennootschap” / “société en commandite

simple”), governed by the laws of Belgium, with registered office at 18, Box A, Wezestraat, 8850 Ardooie, and registered
with the Register of Legal Entities of Brugge under number 0822.059.261 (“Cerfima Comm. V.”),

5. C.V. XAVIER HASPESLAGH Comm. V., a limited liability company (“gewone commanditaire vennootschap” /

“société en commandite simple”), governed by the laws of Belgium, with registered office at 57, Wezestraat, 8850 Ardooie,
and registered with the Register of Legal Entities of Brugge under number 0822.058.865 (“C.V. XAVIER HASPESLAGH
Comm. V.”),

hereinafter collectively referred to as the “Shareholders”.
Hakogel S.A., Ter Heyde Comm. V., Cerfima Comm. V. and C.V. XAVIER HASPESLAGH Comm. V. are represented

by Me Laurence Ouverleaux, residing professionally in Luxembourg,

96348

L

U X E M B O U R G

by virtue of four (4) proxies under private seal given on May 8, 11 and 12 2015; such proxies, signed by the proxyholders

and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing persons, represented as stated above, have requested the notary to record that:
I. The Shareholders are the only shareholders of Riward S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws

of Luxembourg, having a share capital of EUR 49,999.50, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1822 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the “Company”), incorporated following a deed of the undersigned notary dated
16 January 2015, published in the Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations number 648 of 10 March 2015 and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 194133. The articles of
incorporation have not been amended since the incorporation of the Company.

II. The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To appoint Ms. Mélanie Wilkin as new Class B manager of the Company for an unlimited duration and with immediate

effect.

2. To increase the share capital of the Company by an amount of two hundred thirty-eight million eight hundred thirty-

four thousand one hundred eighty euro and twenty-eight eurocent (EUR 238,834,180.28), so as to raise it from its current
amount of forty-nine thousand nine hundred ninety-nine euro and fifty eurocent (EUR 49,999.50) to an amount of two
hundred thirty-eight million eight hundred eighty-four thousand one hundred seventy-nine euro and seventy-eight eurocent
(EUR 238,884,179.78).

3. To issue two hundred thirty-seven million eight hundred eighty-four thousand one hundred seventy-six (237,884,176)

new shares without nominal value, having the same rights and privileges as the existing shares.

4.  To  accept  subscription  for  (i)  forty-eight  million  five  hundred  twenty-one  thousand  four  hundred  sixty-three

(48,521,463) new shares by Hakogel S.A., (ii) fifty three million eight hundred twenty-five thousand six hundred sixty-
seven (53,825,667) new shares by Weco Comm. V., (iii) fifty three million eight hundred twenty-five thousand six hundred
sixty-seven (53,825,667) new shares by Ter Heyde Comm. V., (iv) forty-six million nine hundred sixty-four thousand five
hundred ninety-three (46,964,593) new shares by Cerfima Comm. V., (v) thirty-four million six hundred eighty-two thou-
sand  six  hundred  thirty-six  (34,682,636)  new  shares  by  C.V.  XAVIER  HASPELSLAGH  Comm.  V.,  (vi)  twenty-five
thousand one hundred ninety-eight (25,198) new shares by H.D.K. N.V., (vii) nineteen thousand four hundred seventy-
five (19,475) new shares by Euro Invest Management N.V., (viii) nineteen thousand four hundred seventy-six (19,476)
new shares by Catamar N.V., (ix) one (1) new share by Biostar N.V., without payment of share premium, and to accept
payment in full for such new shares by contributions in kind and in cash.

5. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing

proposed resolutions.

6. To delegate special powers in relation to the foregoing proposed resolutions.
7. Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to appoint Ms. Mélanie Wilkin, born on 12 January 1982

in Liège (Belgium), with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, as new Class B manager of the Company for an unlimited duration and with immediate effect.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount

of two hundred thirty-eight million eight hundred thirty-four thousand one hundred eighty euro and twenty-eight eurocent
(EUR 238,834,180.28), so as to raise it from its current amount of forty-nine thousand nine hundred ninety-nine euro and
fifty eurocent (EUR 49,999.50) to an amount of two hundred thirty-eight million eight hundred eighty-four thousand one
hundred seventy-nine euro and seventy-eight eurocent (EUR 238,884,179.78).

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to issue two hundred thirty-seven million eight hundred

eighty-four thousand one hundred seventy-six (237,884,176) new shares without nominal value, having the same rights
and privileges as the existing shares.

<i>Fourth resolution

<i>Subscription - Payment - Contributions in kind and in cash

Thereupon have appeared:
1. Hakogel S.A., represented as above stated, (the “Subscriber 1”).

96349

L

U X E M B O U R G

The Subscriber 1, acting through its duly appointed attorney in fact, declared to subscribe for forty-eight million five

hundred twenty-one thousand four hundred sixty-three (48,521,463) new shares without a nominal value of the Company,
without payment of a share premium, and to make payment in full for such new share by a contribution in kind consisting
of:

- the forty-nine million one hundred seventy thousand five hundred twenty-four (49,170,524) shares it owns in Dujardin

Foods Group N.V., a limited liability company (“naamloze vennootschap”/ “société anonyme”) governed by the laws of
Belgium, with registered office at Zwevezeelsestraat 142, 8851 Koolskamp, and registered with the Register of Legal
Entities of Brugge under number 0471.413.763 (“Dujardin Foods Group”); and

- the two million six hundred thirty-one thousand seventy-six (2,631,076) shares it owns in ImmoHako Holding NV, a

limited liability company (“naamloze vennootschap”/ “société anonyme”) governed by the laws of Belgium, with registered
office at Zwevezeelsestraat 142, 8851 Koolskamp, and registered with the Register of Legal Entities of Brugge under
number 0555.644.506 (“ImmoHako Holding”);

(hereinafter collectively referred to as the “Contribution in Kind 1”).
The Contribution in Kind 1 represents a value in aggregate amount of forty-eight million seven hundred fifteen thousand

three hundred forty-one euro and forty-three eurocent (EUR 48,715,341.43).

Proof of the ownership by the Subscriber 1 of the Contribution in Kind 1 has been given to the undersigned notary.
The Subscriber 1, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that the Contribution in Kind 1 is free of

any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contri-
bution in Kind 1 to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake
all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind 1 to the
Company.

2. Weco Comm. V., represented as above stated, (the “Subscriber 2”).
The Subscriber 2, acting through its duly appointed attorney in fact, declared to subscribe for fifty-three million eight

hundred twenty-five thousand six hundred sixty-seven (53,825,667) new shares without a nominal value of the Company,
without payment of a share premium, and to make payment in full for such new share by a contribution in kind consisting
of:

- the eight thousand three hundred and six (8,306) shares it owns in Ardo Holding NV, a limited liability company

(“naamloze vennootschap”/ “société anonyme”) governed by the laws of Belgium, with registered office at Wezestraat 61,
8850 Ardooie and registered with the Register of Legal Entities of Brugge under number 0859.755.144 (“Ardo Holding”);

- the seven thousand nine hundred seventy-five (7,975) shares it owns in Digrom Immo NV, a limited liability company

(“naamloze vennootschap”/ “société anonyme”) governed by the laws of Belgium, with registered office at Leenbosstraat
1, 8850 Ardooie and registered with the Register of Legal Entities of Brugge under number 0859.751.184 (“Digrom Immo”);
and

- the seven thousand nine hundred seventy-five (7,975) shares it owns in Digrom Industries NV, a limited liability

company  (“naamloze  vennootschap”/  “société  anonyme”)  governed  by  the  laws  of  Belgium,  with  registered  office  at
Leenbosstraat 1, 8850 Ardooie and registered with the Register of Legal Entities of Brugge under number 0859.750.194
(“Digrom Industries”);

(hereinafter collectively referred to as the “Contribution in Kind 2”).
The Contribution in Kind 2 represents a value in aggregate amount of fifty-four million forty thousand seven hundred

sixty euro and thirty-three eurocent (EUR 54,040,760.33).

Proof of the ownership by the Subscriber 2 of the Contribution in Kind 2 has been given to the undersigned notary.
The Subscriber 2, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that the Contribution in Kind 2 is free of

any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contri-
bution in Kind 2 to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake
all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind 2 to the
Company.

3. Ter Heyde Comm. V., represented as above stated, (the “Subscriber 3”).
The Subscriber 3, acting through its duly appointed attorney in fact, declared to subscribe for fifty-three million eight

hundred twenty-five thousand six hundred sixty-seven (53,825,667) new shares without a nominal value of the Company,
without payment of a share premium, and to make payment in full for such new share by a contribution in kind consisting
of:

- the eight thousand three hundred and six (8,306) shares it owns in Ardo Holding;
- the seven thousand nine hundred seventy-five (7,975) shares it owns in Digrom Immo; and
- the seven thousand nine hundred seventy-five (7,975) shares it owns in Digrom Industries NV;
(hereinafter collectively referred to as the “Contribution in Kind 3”).
The Contribution in Kind 3 represents a value in aggregate amount of fifty-four million forty thousand seven hundred

sixty euro and thirty-three eurocent (EUR 54,040,760.33).

Proof of the ownership by the Subscriber 3 of the Contribution in Kind 3 has been given to the undersigned notary.

96350

L

U X E M B O U R G

The Subscriber 3, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that the Contribution in Kind 3 is free of

any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contri-
bution in Kind 3 to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake
all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind 3 to the
Company.

4. Cerfima Comm. V., represented as above stated, (the “Subscriber 4”).
The Subscriber 4, acting through its duly appointed attorney in fact, declared to subscribe for forty-six million nine

hundred sixty-four thousand five hundred ninety-three (46,964,593) new shares without a nominal value of the Company,
without payment of a share premium, and to make payment in full for such new share by a contribution in kind consisting
of:

- the seven thousand one hundred fifteen (7,115) shares it owns in Ardo Holding;
- the seven thousand nine hundred seventy-five (7,975) shares it owns in Digrom Immo; and
- the seven thousand nine hundred seventy-five (7,975) shares it owns in Digrom Industries NV;
(hereinafter collectively referred to as the “Contribution in Kind 4”).
The Contribution in Kind 4 represents a value in aggregate amount of forty-seven million one hundred fifty-two thousand

one hundred eighty euro and thirty-two eurocent (EUR 47,152,180.32).

Proof of the ownership by the Subscriber 4 of the Contribution in Kind 4 has been given to the undersigned notary.
The Subscriber 4, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that the Contribution in Kind 4 is free of

any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contri-
bution in Kind 4 to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake
all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind 4 to the
Company.

5. C.V. XAVIER HASPESLAGH Comm. V., represented as above stated, (the “Subscriber 5”).
The Subscriber 5, acting through its duly appointed attorney in fact, declared to subscribe for thirty-four million six

hundred eighty-two thousand six hundred thirty-six (34,682,636) new shares without a nominal value of the Company,
without payment of a share premium, and to make payment in full for such new share by a contribution in kind consisting
of:

- the four thousand nine hundred eighty-three (4,983) shares it owns in Ardo Holding;
- the seven thousand nine hundred seventy-five (7,975) shares it owns in Digrom Immo; and
- the seven thousand nine hundred seventy-five (7,975) shares it owns in Digrom Industries NV;
(hereinafter collectively referred to as the “Contribution in Kind 5”).
The Contribution in Kind 5 represents a value in aggregate amount of thirty-four million eight hundred twenty thousand

nine hundred eighty-five euro and eighty-seven eurocent (EUR 34,820,985.87).

Proof of the ownership by the Subscriber 5 of the Contribution in Kind 5 has been given to the undersigned notary.
The Subscriber 5, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that the Contribution in Kind 5 is free of

any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contri-
bution in Kind 5 to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake
all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind 5 to the
Company.

6. H.D.K. N.V., a limited liability company (“naamloze vennootschap”/ “société anonyme”) governed by the laws of

Belgium,  with  registered  office  at  Zwevezeelsestraat  161,  8851  Koolskamp  and  registered  with  the  Register  of  Legal
Entities of Brugge under number 0461.788.690,

hereby represented by Maître Laurence Ouverleaux, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on May 7, 2015; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration (the “Subscriber 6” or “H.D.K. N.V.”).

The Subscriber 6, acting through its duly appointed attorney in fact, declared to subscribe for twenty-five thousand one

hundred ninety-eight (25,198) new shares without a nominal value of the Company, without payment of a share premium,
and to make payment in full for such new share by a contribution in kind consisting of:

- one (1) share it owns in Dujardin Foods Group; and
- the three thousand nine hundred twenty-eight (3,928) shares it owns in ImmoHako Holding;
(hereinafter collectively referred to as the “Contribution in Kind 6”).
The Contribution in Kind 6 represents a value in aggregate amount of twenty-five thousand one hundred ninety-eight

euro and sixty eurocent (EUR 25,198.60).

Proof of the ownership by the Subscriber 6 of the Contribution in Kind 6 has been given to the undersigned notary.
The Subscriber 6, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that the Contribution in Kind 6 is free of

any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contri-
bution in Kind 6 to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake

96351

L

U X E M B O U R G

all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind 6 to the
Company.

7. Euro Invest Management N.V., a limited liability company (“naamloze vennootschap”/ “société anonyme”) governed

by the laws of Belgium, with registered office at Molierelaan 164, 1050 Brussels, and registered with the Register of Legal
Entities of Brussels under number 0463.587.150,

hereby represented by Maître Laurence Ouverleaux, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on May 8, 2015; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration (the “Subscriber 7” or “Euro Invest Mana-
gement N.V.”).

The Subscriber 7, acting through its duly appointed attorney in fact, declared to subscribe nineteen thousand four hundred

seventy-five (19,475) new shares without a nominal value of the Company, without payment of a share premium, and to
make payment in full for such new share by a contribution in kind consisting of the three thousand thirty-six (3,036) shares
it owns in ImmoHako Holding (hereinafter referred to as the “Contribution in Kind 7”).

The Contribution in Kind 7 represents a value in aggregate amount of nineteen thousand four hundred seventy-five euro

and ninety-eight eurocent (EUR 19,475.98).

Proof of the ownership by the Subscriber 7 of the Contribution in Kind 7 has been given to the undersigned notary.
The Subscriber 7, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that the Contribution in Kind 7 is free of

any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contri-
bution in Kind 7 to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake
all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind 7 to the
Company.

8. Catamar N.V., a limited liability company (“naamloze vennootschap”/ “société anonyme”) governed by the laws of

Belgium, with registered office at Veldstraat 27, 8800 Roeselare and registered with the Register of Legal Entities of
Kortrijk under number 0466.202.388,

hereby represented by Maître Laurence Ouverleaux, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on May 8, 2015; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration (the “Subscriber 8” or “Catamar N.V.”).

The Subscriber 8, acting through its duly appointed attorney in fact, declared to subscribe for nineteen thousand four

hundred seventy-six (19,476) new shares without a nominal value of the Company, without payment of a share premium,
and to make payment in full for such new share by a contribution in kind consisting of:

- one (1) share it owns in Dujardin Foods Group; and
- the three thousand thirty-six (3,036) shares it owns in ImmoHako Holding;
(hereinafter collectively referred to as the “Contribution in Kind 8”).
The Contribution in Kind 8 represents a value in aggregate amount of nineteen thousand four hundred seventy-six euro

and forty-two eurocent (EUR 19,476.42).

Proof of the ownership by the Subscriber 8 of the Contribution in Kind 8 has been given to the undersigned notary.
The Subscriber 8, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that the Contribution in Kind 8 is free of

any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contri-
bution in Kind 8 to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake
all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind 8 to the
Company.

9. Biostar N.V., a limited liability company (“naamloze vennootschap”/ “société anonyme”) governed by the laws of

Belgium, with registered office at Molierelaan 164, 1050 Brussels, and registered with the Register of Legal Entities of
Brussels under number 0473.193.615,

hereby represented by Maître Laurence Ouverleaux, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on May 8, 2015; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration (the “Subscriber 9” or “Biostar”, together
with Subscriber 1, Subscriber 2, Subscriber 3, Subscriber 4, Subscriber 5, Subscriber 6, Subscriber 7, Subscriber 8 herei-
nafter collectively referred to as the “Subscribers”).

The Subscriber 9 declared to subscribe for one (1) new share without a nominal value of the Company, without payment

of a share premium, and to make payment in full for such new share by:

- a contribution in kind consisting of one (1) share it owns in Dujardin Foods Group representing a value of forty-four

eurocent (EUR 0.44) (“Contribution in Kind 9” together with Contribution in Kind 1, Contribution in Kind 2, Contribution
in Kind 3, Contribution in Kind 4, Contribution in Kind 5, Contribution in Kind 6, Contribution in Kind 7 and Contribution
in Kind 8 hereinafter collectively referred to as the “Contributions in Kind”); and

- a contribution in cash of an amount of fifty-six eurocent (EUR 0.56) (“Contribution in Cash”).
Proof of the ownership by the Subscriber 9 of the Contribution in Kind 9 and of the payment by the Subscriber 9 of the

Contribution in Cash have been given to the undersigned notary.

96352

L

U X E M B O U R G

The Subscriber 9 declared that the Contribution in Kind 9 is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that

there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind 9 to the Company without restriction
or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind 9 to the Company.

The Subscribers acting through their duly appointed attorney in fact further stated that a report has been drawn up by

the board of managers of the Company wherein the Contributions in Kind are described and valued, which report has been
presented to the extraordinary general meeting of the shareholders and to the undersigned notary.

Thereupon, the extraordinary general meeting of shareholders resolved (i) to accept the said subscriptions and payments

by the Subscribers and (ii) and to allot the two hundred thirty-seven million eight hundred eighty-four thousand one hundred
seventy-six (237,884,176) new shares according to the above mentioned subscriptions.

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of

incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

“The issued capital of the Company is set at two hundred thirty-eight million eight hundred eighty-four thousand one

hundred seventy-nine euro and seventy-eight eurocent (EUR 238,884,179.78)

divided into two hundred thirty-eight million eight hundred eighty-four thousand one hundred seventy-six (238,884,176)

shares without nominal value, all of which are fully paid up.”

<i>Sixth resolution

The extraordinary general meeting resolves to confer all and any powers to any manager of the Company, each of them

acting individually, with full power of substitution, in order to implement the above resolutions.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the proxyholders of the appearing

parties, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholders
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, who are known to the undersigned notary

by their surname, first name, civil status and residence, such proxyholders signed together with the undersigned notary,
this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1. Hakogel S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.959
(“Hakogel S.A.”),

2. Weco Comm. V., une société en commandite simple de droit belge, ayant son siège social au 2, Tinnenpotstraat, 8850

Ardooie, et immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruges sous le numéro 0822.054.511 (“Weco Comm. V.”),

ici représentée conformément à l’article 6 des statuts de cette société par Monsieur Jan HASPESLAGH, né le 22 mai

1961 à Roeselare (Belgique) et résidant à Tinnepotstraat, 8850 Ardooie, Belgique, en tant que gérant de cette société,

3. Ter Heyde Comm. V., une société en commandite simple de droit belge, ayant son siège social au 620, Torhoutse

Steenweg, 8200 Sint-Andries, et immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruges sous le numéro 0822.051.739
(“Ter Heyde Comm. V.”),

4. Cerfima Comm. V., une société en commandite simple de droit belge, ayant son siège social 18, boîte A, Wezestraat,

8850 Ardooie, et immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruges sous le numéro 0822.059.261 (“Cerfima
Comm. V.”),

5. C.V. XAVIER HASPESLAGH Comm. V., une société en commandite simple de droit belge, ayant son siège social

au  57,  Wezestraat,  8850  Ardooie,  et  immatriculée  au  Registre  des  Personnes  Morales  de  Bruges  sous  le  numéro
0822.058.865 (“C.V. XAVIER HASPESLAGH Comm. V.”),

ensemble les «Associés».
Hakogel S.A., Ter Heyde Comm. V., Cerfima Comm. V. et C.V. XAVIER HASPESLAGH Comm. V. sont représentés

par Maître Laurene Ouverleaux, demeurant professionnellement à Luxembourg,

96353

L

U X E M B O U R G

aux termes de quatre (4) procurations sous seing privé données en date des 8, 11 et 12 mai 2015; lesquelles procurations,

chacune signée par le mandataire concerné et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte aux fins d’enregis-
trement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les Associés sont les seuls et uniques associés de Riward S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit

luxembourgeois, ayant un capital social de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante centimes
d’euro (EUR 49.999,50), dont le siège social est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1822 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 16 janvier 2015, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 648 du 10 mars 2015 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 194133 (la «Société»). Les statuts n’ont pas été modifiés depuis la création de la Société.

II. Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informés des dé-

cisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Nomination de Mme Mélanie Wilkin en qualité de nouveau gérant de Catégorie B de la Société pour une durée illimitée

et avec effet immédiat.

2 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux cent trente-huit millions huit cent trente-quatre

mille cent quatre-vingt euros et vingt-huit centimes d’euro (EUR 238.834.180,28) pour le porter de son montant actuel de
quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante centimes d’euro (EUR 49.999,50) à deux cent trente-
huit millions huit cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-dix-neuf euros et soixante-dix-huit centimes d’euro (EUR
238.884.179,78).

3 Émission de deux cent trente-sept millions huit cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-seize (237.884.176) parts

sociales nouvelles sans valeur nominale, chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

4 Acceptation de la souscription (i) de quarante-huit millions cinq cent vingt-et-un mille quatre cent soixante-trois

(48,521,463) nouvelles parts par Hakogel S.A. (ii) de cinquante-trois millions huit cent vingt-cinq mille six cent soixante-
sept (53.825.667) nouvelles parts par Weco Comm. V., (iii) cinquante-trois millions huit cent vingt-cinq mille six cent
soixante-sept (53.825.667) nouvelles parts par Ter Heyde Comm. V., (iv) quarante-six millions neuf cent soixante-quatre
mille cinq cent quatre-vingt-treize (46,964,593) nouvelles parts par Cerfima Comm. V., (v) trente-quatre millions six cent
quatre-vingt-deux mille six cent trente-six (34.682.636) nouvelles parts par C.V. XAVIER HASPELSLAGH Comm. V.,
(vi) vingt-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit (25.198) nouvelles parts par H.D.K. N.V., (vii) dix-neuf mille quatre cent
soixante-quinze (19.475) nouvelles parts par Euro Invest N.V., (viii) dix-neuf mille quatre cent soixante-seize (19.476)
nouvelles parts par Catamar N.V., (ix) une (1) nouvelle part par Biostar N.V., sans paiement d’une prime d’émission et
acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par des apports en nature et en numéraire.

5 Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions mentionnées ci-

dessus.

6 Délégation de pouvoirs spéciaux en rapport avec les résolutions précédentes.
7 Divers.
ont requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé de nommer Madame Mélanie Wilkin, née le 12 janvier 1982 à Liège (Belgique), résidant

professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en qualité de nouveau
gérant de Catégorie B de la Société pour une durée illimitée et avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent trente-huit millions

huit cent trente-quatre mille cent quatre-vingt euros et vingt-huit centimes d’euro (EUR 238.834.180,28) pour le porter de
son  montant  actuel  de  quarante-neuf  mille  neuf  cent  quatre-vingt-dix-neuf  euros  et  cinquante  centimes  d’euro  (EUR
49.999,50) à deux cent trente-huit millions huit cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-dix-neuf euros et soixante-dix-
huit centimes d’euro (EUR 238.884.179,78).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé d’émettre deux cent trente-sept millions huit cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-

seize (237.884.176) nouvelles parts sociales sans valeur nominale, chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les
parts sociales existantes.

<i>Quatrième résolution

<i>Souscription - Paiement - Apports en numéraire et en nature

Ont ensuite comparu:
1. Hakogel S.A., représentée comme mentionné ci-dessus, (le «Souscripteur 1»),

96354

L

U X E M B O U R G

Le Souscripteur 1, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré souscrire quarante-huit millions

cinq cent vingt et un mille quatre cent soixante-trois (48.521.463) parts sociales nouvelles de la Société sans valeur nominale
sans paiement d’une prime d’émission et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant
en:

- les quarante-neuf millions cent soixante-dix mille cinq cent vingt-quatre (49.170.524) actions qu'elle détient dans

Dujardin Foods Groupe N.V., une société anonyme (“naamloze vennootschap”) de droit belge, ayant son siège social à
Zwevezeelsestraat 142, 8851 Koolskamp, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruges sous le numéro
0471.413.763 («Dujardin Foods Group»); et

- les deux millions six cent trente et un mille soixante-seize (2.631.076) actions qu'elle détient dans ImmoHako Holding

NV, une société anonyme («naamloze vennootschap») de droit belge, ayant son siège social à Zwevezeelsestraat 142, 8851
Koolskamp, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruges sous le numéro 0555.644.506 («ImmoHako Hold-
ing»);

(ensemble l’«Apport en Nature 1»).
L’Apport en Nature 1 représente une valeur totale de quarante-huit millions sept cent quinze mille trois cent quarante

et un euros et quarante-trois centimes d’euro (EUR 48.715.341,43).

La preuve par le Souscripteur 1 de la propriété de l’Apport en Nature 1 a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur 1, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré ensuite que l’Apport en Nature 1

est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l’Apport en Nature 1 à la Société
et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’Apport en Nature 1 à la Société.

2. Weco Comm. V., représentée comme mentionné ci-dessus, (le «Souscripteur 2»)
Le Souscripteur 2, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré souscrire cinquante-trois millions

huit cent vingt-cinq mille six cent soixante-sept (53.825.667) parts sociales nouvelles de la Société sans valeur nominale
sans paiement d’une prime d’émission et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant
en:

- les huit mille trois cent six (8.306) actions qu'elle détient dans Ardo Holding N.V., une société anonyme (“naamloze

vennootschap”) de droit belge, ayant son siège social à Wezestraat 61, 8850 Ardooie, immatriculée au Registre des Per-
sonnes Morales de Bruges sous le numéro 0859.755.144 («Ardo Holding»);

- les sept mille neuf cent soixante-quinze (7.975) actions qu'elle détient dans Digrom Immo N.V., une société anonyme

(“naamloze vennootschap”) de droit belge, ayant son siège social à Leenbosstraat 1, 8850 Ardooie, immatriculée au Registre
des Personnes Morales de Bruges sous le numéro 0859.751.184 («Digrom Immo»); et

-  les  sept  mille  neuf  cent  soixante-quinze  (7.975)  actions  qu'elle  détient  dans  Digrom  Industries  N.V.,  une  société

anonyme (“naamloze vennootschap”) de droit belge, ayant son siège social à Leenbosstraat 1, 8850 Ardooie, immatriculée
au Registre des Personnes Morales de Bruges sous le numéro 0859.750.194 («Digrom Industries»);

(ensemble l’ «Apport en Nature 2»).
L’Apport en Nature 2 représente une valeur totale de cinquante-quatre millions quarante mille sept cent soixante euros

et trente-trois centimes d’euro (EUR 54.040.760,33).

La preuve par le Souscripteur 2 de la propriété de l’Apport en Nature 2 a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur 2, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré ensuite que l’Apport en Nature 2

est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l’Apport en Nature 2 à la Société
et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’Apport en Nature 2 à la Société.

3. Ter Heyde Comm. V., représentée comme mentionné ci-dessus, (le «Souscripteur 3»).
Le Souscripteur 3, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré souscrire cinquante-trois millions

huit cent vingt-cinq mille six cent soixante-sept (53.825.667) parts sociales nouvelles de la Société sans valeur nominale
sans paiement d’une prime d’émission et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant
en:

- les huit mille trois cent six (8.306) actions qu'elle détient dans Ardo Holding;
- les sept mille neuf cent soixante-quinze (7.975) actions qu'elle détient dans Digrom Immo; et
- les sept mille neuf cent soixante-quinze (7.975) actions qu'elle détient dans Digrom Industries;
(ensemble l’«Apport en Nature 3»).
L’Apport en Nature 3 représente une valeur totale de cinquante-quatre millions quarante mille sept cent soixante euros

et trente-trois centimes (EUR 54.040.760,33).

La preuve par le Souscripteur 3 de la propriété de l’Apport en Nature 3 a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur 3, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré encore que l’Apport en Nature 3

est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l’Apport en Nature 3 à la Société
et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’Apport en Nature 3 à la Société.

96355

L

U X E M B O U R G

4. Cerfima Comm. V., représentée comme mentionné ci-dessus, (le «Souscripteur 4»).
Le Souscripteur 4, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré souscrire quarante-six millions

neuf cent soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize (46.964.593) parts sociales nouvelles de la Société sans valeur
nominale sans paiement d’une prime d’émission et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature
consistant en:

- les sept mille cent quinze (7.115) actions qu'elle détient dans Ardo Holding;
- les sept mille neuf cent soixante-quinze (7.975) actions qu'elle détient dans Digrom Immo; et
- les sept mille neuf cent soixante-quinze (7.975) actions qu'elle détient dans Digrom Industries;
(ensemble l’«Apport en Nature 4»).
L’Apport en Nature 4 représente une valeur totale de quarante-sept millions cent cinquante-deux mille cent quatre-vingt

euros et trente-deux centimes d’euro (EUR 47.152.180,32).

La preuve par le Souscripteur 4 de la propriété de l’Apport en Nature 4 a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur 4, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré encore que l’Apport en Nature 4

est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l’Apport en Nature 4 à la Société
et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’Apport en Nature 4 à la Société.

5. C.V. XAVIER HASPESLAGH Comm. V., représentée comme mentionné ci-dessus, (le «Souscripteur 5»).
Le Souscripteur 5, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré souscrire trente-quatre millions

six cent quatre-vingt-deux mille six cent trente-six (34.682.636) parts sociales nouvelles de la Société sans valeur nominale
sans paiement d’une prime d’émission et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant
en:

- les quatre mille neuf cent quatre-vingt-trois (4.983) actions qu'elle détient dans Ardo Holding;
- les sept mille neuf cent soixante-quinze (7.975) actions qu'elle détient dans Digrom Immo; et
- les sept mille neuf cent soixante-quinze (7.975) actions qu'elle détient dans Digrom Industries;
(ensemble l’«Apport en Nature 5»).
L’Apport en Nature 5 représente une valeur totale de trente-quatre millions huit cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-

cinq euros et quatre-vingt-sept centimes d’euro (EUR 34.820.985,87).

La preuve par le Souscripteur 5 de la propriété de l’Apport en Nature 5 a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur 5, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré encore que l’Apport en Nature 5

est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l’Apport en Nature 5 à la Société
et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’Apport en Nature 5 à la Société.

6. H.D.K. N.V., une société anonyme (“naamloze vennootschap”) de droit belge, ayant son siège social à Zwevezeel-

sestraat 161, 8851 Koolskamp, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruges sous le numéro 0461.788.690,

ici représentée par Maître Laurene Ouverleaux, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 7 mai 2015; laquelle procuration, signée par le mandataire

et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement (le «Souscripteur 6» ou «H.D.N. N.V.»).

Le Souscripteur 6, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré souscrire vingt-cinq mille cent

quatre-vingt-dix-huit  (25.198)  parts  sociales  nouvelles  de  la  Société  sans  valeur  nominale  sans  paiement  d’une  prime
d’émission et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant en:

- une (1) action qu’elle détient dans Dujardin Foods Group; et
- les trois mille neuf cent vingt-huit (3.928) actions qu'elle détient dans ImmoHako Holding;
(ensemble l’«Apport en Nature 6»).
L’Apport en Nature 6 représente une valeur totale de vingt-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante cen-

times d’euro (EUR 25.198,60).

La preuve par le Souscripteur 6 de la propriété de l’Apport en Nature 6 a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur 6, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré encore que l’Apport en Nature 6

est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l’Apport en Nature 6 à la Société
et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’Apport en Nature 6 à la Société.

7. Euro Invest Management N.V., une société anonyme (“naamloze vennootschap”) de droit belge, ayant son siège social

à  Molierelaan  164,  1050  Bruxelles,  immatriculée  au  Registre  des  Personnes  Morales  de  Bruxelles  sous  le  numéro
0463.587.150,

ici représentée par Maître Laurene Ouverleaux, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 8 mai 2015; laquelle procuration, signée par le mandataire

et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement (le «Souscripteur 7» ou «Euro Invest
Management N.V.»).

96356

L

U X E M B O U R G

Le Souscripteur 7, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré souscrire dix-neuf mille quatre

cent  soixante-quinze  (19.475)  parts  sociales  nouvelles  de  la  Société  sans  valeur  nominale  sans  paiement  d’une  prime
d’émission et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant en trois mille trente-six
(3.036) actions qu'elle détient dans ImmoHako Holding (ci-après l’«Apport en Nature 7»).

L’Apport en Nature 7 représente une valeur totale de dix-neuf mille quatre cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-

dix-huit centimes d’euro (EUR 19.475,98).

La preuve par le Souscripteur 7 de la propriété de l’Apport en Nature 7 a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur 7, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré encore que l’Apport en Nature 7

est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l’Apport en Nature 7 à la Société
et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’Apport en Nature 7 à la Société.

8. Catamar N.V., une société anonyme (“naamloze vennootschap”) de droit belge, ayant son siège social à Veldstraat

27, 8800 Roeselare, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Courtrai sous le numéro 0466.202.388,

ici représentée par Maître Laurene Ouverleaux, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 8 mai 2015; laquelle procuration, signée par le mandataire

et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement (le «Souscripteur 8» ou «Euro Invest
Management N.V.»).

Le Souscripteur 8, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré souscrire dix-neuf mille quatre

cent soixante-seize (19.476) parts sociales nouvelles de la Société sans valeur nominale sans paiement d’une prime d’émis-
sion et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant en:

- une (1) action qu'elle détient dans Dujardin Foods Group; et
- les trois-mille trente-six (3.036) actions qu'elle détient dans ImmoHako Holding;
(ensemble l’«Apport en Nature 8»).
L’Apport en Nature 8 représente une valeur totale de dix-neuf mille quatre cent soixante-seize euros et quarante-deux

centimes d’euro (EUR 19.476,42).

La preuve par le Souscripteur 8 de la propriété de l’Apport en Nature 8 a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur 8, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré encore que l’Apport en Nature 8

est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l’Apport en Nature 8 à la Société
et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’Apport en Nature 8 à la Société.

9. Biostar N.V., une société anonyme (“naamloze vennootschap”) de droit belge, ayant son siège social à Molierelaan

164, 1050 Bruxelles, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0473.193.615,

ici représentée par Maître Laurene Ouverleaux, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 8 mai 2015; laquelle procuration, signée par le mandataire

et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement (le «Souscripteur 9» ou «Biostar N.V.»,
ensemble avec le Souscripteur 1, le Souscripteur 2, le Souscripteur 3, le Souscripteur 4, le Souscripteur 5, le Souscripteur
6, le Souscripteur 7 et le Souscripteur 8, les «Souscripteurs»).

Le Souscripteur 9, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré souscrire une (1) part sociale

nouvelle de la Société sans valeur nominale sans paiement d’une prime d’émission et libérer intégralement cette part sociale
souscrite par:

- un apport en nature consistant en une (1) action qu'elle détient dans Dujardin Foods Group, représentant une valeur de

quarante-quatre centimes d’euro (EUR 0.44) («l’Apport en Nature 9», ensemble avec l’Apport en Nature 1, l’Apport en
Nature 2, l’Apport en Nature 3, l’Apport en Nature 4, l’Apport en Nature 5, l’Apport en Nature 6, l’Apport en Nature 7 et
l’Apport en Nature 8 les «Apports en Nature»); et

- un apport en numéraire d’un montant de cinquante-six centimes d’euro (EUR 0.56) (l’«Apport en Numéraire»).
La preuve par le Souscripteur 9 de la propriété de l’Apport en Nature 9, ainsi que du paiement par le Souscripteur 9 de

l’Apport en Numéraire a été rapportée au notaire soussigné.

Le Souscripteur 9, agissant par le biais de son représentant dûment nommé, a déclaré ensuite que l’Apport en Nature 9

est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l’Apport en Nature 9 à la Société
et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer un transfert valable de l’Apport en Nature 9 à la Société.

Les Souscripteurs, représentés tel que décrit ci-haut, ont déclaré qu'un rapport a été établi par le conseil de gérance de

la Société dans lequel chacun des Apports en Nature est décrit et évalué (le “Rapport”), lequel rapport a été présenté à
l’assemblée générale des associés et au notaire soussigné.

L’assemblée générale des associés a ensuite décidé (i) d’accepter lesdites souscriptions et paiements par les Souscripteurs

et (ii) d’allouer les deux cent trente-sept millions huit cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-seize (237.884.176) parts
sociales nouvelles selon les souscriptions mentionnées ci-dessus.

96357

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des associés a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société afin de

refléter les résolutions prises ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme tel:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à deux cent trente-huit millions huit cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-

dix-neuf euros et soixante-dix-huit centimes d’euro (EUR 238.884.179,78) divisé en deux cent trente-huit millions huit
cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-seize (238.884.176) parts sociales sans valeur nominale, celles-ci étant entiè-
rement libérées.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale des associés décide de conférer les pouvoirs nécessaires à chacun des gérants de la Société, chacun

d’entre eux agissant séparément, avec pouvoir de substitution, pour mettre en oeuvre les résolutions proposées ci-dessus.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux fondés de pouvoirs des comparants connus du notaire soussigné

par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné.

Signé: L. Ouverleaux, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 22 mai 2015. GAC/2015/4377. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 9 juin 2015.

Référence de publication: 2015086651/564.
(150098690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

Kensington UK Pledgeco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 197.431.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the third day of the month of June.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Kensington UK Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000) and in the process of being registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,

represented by Maître Ségolène Le Marec, maître en droit, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy

which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company “Kensington UK Pledgeco S.à r.l.” (société à responsabilité limitée) which
is hereby established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Kensington UK

Pledgeco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.

96358

L

U X E M B O U R G

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream guarantees), grant security interests,

grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the
same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance

money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case

may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000)

represented by seven hundred fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pounds Sterling (GBP 20) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business

of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to

act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

96359

L

U X E M B O U R G

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,

by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability”
and “expenses” shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the

board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal

to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

96360

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in

the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in  the  register  of  shareholders  held  by  the  Company  at  least  eight  (8)  days  before  the  proposed  effective  date  of  the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions  (or  subject  to  the  satisfaction  of  the  majority  requirements,  on  the  date  set  out  therein).  Unanimous  written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies;

in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December 2015.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:

Subscriber

Number

of shares

Subscription

price (GBP)

Kensington UK Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 GBP 15,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 GBP 15,000

96361

L

U X E M B O U R G

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles

of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:

- BRE/Management 8 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at

35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under number B 195.140.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,

the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English
language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dritten Tag des Monats Juni,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen,

Kensington UK Topco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxembur-

gischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital fünfzehntausend Pfund
Sterling (GBP 15.000) beträgt, und die dabei ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg eingetragen zu
werden,

hier vertreten durch Maître Ségolène Le Marec, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer

privatschriftlichen Vollmacht welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde
eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) “Kensington UK Pledgeco S.à r.l.” wie folgt
zu beurkunden.

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)mit dem Namen

“Kensington UK Pledgeco S.à r.l.” (die “Gesellschaft”) wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,

Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (einschließlich up-stream als auch side-stream Bürgschaften), Sicherheiten

leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt
oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-

geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-

96362

L

U X E M B O U R G

liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-

denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,

durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfzehntausend

Pfund Sterling (GBP 15.000), eingeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je
zwanzig Pfund Sterling (GBP 20).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung

vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht

anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die

keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-

gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse

um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und

abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der

Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren

96363

L

U X E M B O U R G

können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,

von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen

Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder

leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage”, „Streitsache”, „Prozess” oder
„Verfahren” finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit”
und „Ausgaben” beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-

schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die  Rechte  zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

96364

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage

vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens  acht  (8)  Tage  bevor  der  Beschluss  wirksam  werden  soll,  an  alle  Gesellschafter  an  ihre  im  Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember

eines jeden Jahres.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die  Gesellschafter  können  auf  der  Grundlage  eines  von  dem  alleinigen  Geschäftsführer,  beziehungsweise  der  Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet

werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179

(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich

nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2015 enden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt

in bar eingezahlt und gezeichnet:

96365

L

U X E M B O U R G

Einzahler

Zahl der

Geschäftsanteile

Einzahlungspreis

(GBP)

Kensington UK Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

GBP 15.000

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

GBP 15.000

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.

<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der

Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:

- BRE/Management 8 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue

Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer
B 195.140.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen

Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-

schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach

Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: S. LE MAREC, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 04 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/17364. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 09. Juni 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015086429/451.
(150098284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

Legal &amp; General Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 180.761.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 1 

<i>er

<i>juin 2015

En date du 1 

er

 juin 2015, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a pris la résolution suivante:

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, une société coopérative constituée et régie selon les lois du Grand-

Duché  de  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  à  l'adresse  suivante:  2,  rue  Gerhard  Mercator,  L-2182  Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B65477, en tant que réviseur
d'entreprises agréé de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle
des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société clôturés au 31 décembre 2015 et qui
se tiendra en l'année 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2015.

LEGAL &amp; GENERAL SICAV
Signatures

Référence de publication: 2015088154/20.
(150100496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

96366

L

U X E M B O U R G

MBERP II (Luxembourg) 26 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 197.472.

STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the twenty-seventh day of May;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

APPEARED:

The private limited liability company “Meyer Bergman European Retail Partners II Holdings S.à r.l.”, established and

having its registered office in L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, registered with the Trade and Companies
Registry of Luxembourg, section B, under the number 168924,

here represented by Mrs. Alexia UHL, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain
attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association of

a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") to establish as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become

shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2.
2.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or
exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

2.2. The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms
part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of
any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any
other manner or which forms part of the same group of entities as the Company;

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- acquire and sell real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or

indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

2.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

-  raise  funds  through  borrowing  in  any  form  or  by  issuing  any  securities  or  debt  instruments,  including  bonds,  by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad;

and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The Company will be incorporated under the name of “MBERP II (Luxembourg) 26 S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers. Branches
or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the manager
or the board of managers.

96367

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-

owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to

new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the

approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In case of several

managers, the managers shall form a board of managers.

The  manager(s)  is  (are)  appointed  by  the  general  meeting  of  shareholders  which  sets  the  term  of  their  office.  The

managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by

the joint signature of two managers or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the
sole manager / board of managers.

The sole manager / board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private

instrument.

Art. 12. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's
purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager acting individually at the place indicated

in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board
of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate
or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman, or by one manager.

96368

L

U X E M B O U R G

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

Art. 15. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general

meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 20. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

The board of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are

sufficient.

The share premium is freely distributable to the shareholders by the shareholders' meeting or by the board of managers.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which

do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of

the Company held by them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of

10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Transitory disposition

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31 

st

 of December 2015.

<i>Subscription and payment

The Articles thus having been established, the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by

the sole shareholder, the company “Meyer Bergman European Retail Partners II Holdings S.à r.l.”, prenamed and repre-
sented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of twelve thousand
five hundred Euros (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the
officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

<i>Resolutions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following

resolutions as sole shareholder:

1) The registered office is established in L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
2) The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined duration:
- Mr Frédéric GARDEUR, Senior Manager, born in Messancy (Belgium), on 11 July 1972, residing professionally in

L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch;

- Mr Walter TOCCO, Assistant Manager, born in San Gavino Monreale (Italy), on 12 October 1979, residing profes-

sionally in L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch; and

96369

L

U X E M B O U R G

- Mr Abdoulie Yorro JALLOW, Manager, born in Fajara (The Gambia), on 12 February 1975, residing professionally

in L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-sept mai;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée “Meyer Bergman European Retail Partners II Holdings S.à r.l.”, établie et ayant son

siège social à L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 168924,

ici représentée par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une

société à responsabilité limitée à constituer comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le

devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2.
2.1. La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de

participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché de
Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par sou-
scription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres
participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

2.2. La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la

Société détient une participation directe ou indirecte ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de
toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout dirigeant ou autre fondé de
pouvoir ou agent de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient une participation directe ou indirecte ou
un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe
d'entités que la Société;

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient une participation directe ou indirecte ou un droit de

toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que
la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière; et

- acquérir et vendre des biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, en ce compris la prise

de participations directes ou indirectes dans des sociétés, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, dont l'objet
principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immo-
biliers.

2.3. La Société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre

de son objet la Société peut notamment:

- lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous quelque forme que ce soit ou en émettant tout titre participatif

ou tout titre représentatif d'une dette, y compris des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en
accordant tout droit de toute nature, sous réserve des termes et conditions prescrits par la loi;

96370

L

U X E M B O U R G

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg

ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée vis-à-vis des dettes et engagements de

toute entité au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société est constituée sous le nom de “MBERP II (Luxembourg) 26 S.à r.l.”.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société
peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand Duché de Luxembourg ou dans tous autres
pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur de un Euro (EUR 1,-).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à

des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés
que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. S’il y a plus d’un gérant

à être nommé, les gérants devront constituer un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les

gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par

la signature conjointe de deux gérants ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront
été délégués par le gérant unique / conseil de gérance.

Le gérant unique / conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou

sous seing privé.

Art. 12. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis  des  tiers,  le  conseil  de  gérance  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  agir  au  nom  de  la  Société  en  toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d’un des gérants agissant individuellement au lieu

indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le
conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la
présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit
ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.

96371

L

U X E M B O U R G

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télé-

gramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou par

d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les
unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le
conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée
à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à
cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,

par le vice-président, ou par un gérant. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par un gérant.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Art. 18. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés

par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 19. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre

de la même année.

Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un

inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication
au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution

sont disponibles.

La prime d'émission est librement distribuable aux associés par l'assemblée générale des associés ou par le conseil de

gérance.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par

l'associée unique, la société “Meyer Bergman European Retail Partners II Holdings S.à r.l.”, pré désignée et représentée
comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte

96372

L

U X E M B O U R G

que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société,
ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Résolutions prises par l’associée unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes

en tant qu'associée unique:

1. Le siège social est établi à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Frédéric GARDEUR, Senior Manager, né à Messancy (Belgique), le 11 juillet 1972, demeurant profession-

nellement à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch;

- Monsieur Walter TOCCO, Assistant Manager, né à San Gavino Monreale (Italie) 12 Octobre 1979, demeurant pro-

fessionnellement à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch; et

- Monsieur Abdoulie Yorro JALLOW, Manager, née à Fajara (Gambie), le 12 février 1975, demeurant professionnel-

lement à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 4 juin 2015. 2LAC/2015/12296. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 9 juin 2015.

Référence de publication: 2015087379/349.
(150099433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2015.

Diaverum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 43.000.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.921.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 22 mai 2015

- Les associés ont accepté la démission de Mr. Håkan Johansson, né le 2 septembre 1969 à Höja, Suède, de son poste

de gérant de la Société, avec effet immédiat.

Par conséquent, les gérants de la Société au 22 mai 2015 sont les suivants:
- Robert Moores;
- Jana Oleksy;
- Daphné Charbonnet; et
- Davy Beaucé.
Les associés de la Société, Alcentra Mezzanine QPAM Fund Limited Partnership et Alcentra Mezzanine N°1 Fund

Limited Partnership, ont transféré leur siège social qui est désormais au Lime Grove House, Green Street, St Helier JE1
2ST, Jersey.

L'associé de la Société, Shiofra 1 S.à r.l., a également transféré son siège social qui est désormais au 47, Avenue John

F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015089517/23.
(150102530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2015.

96373

L

U X E M B O U R G

ERF Enschede S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 197.464.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen,
on the second day of the month of June.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

CS European Retail No. 1 S. à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with

registered office at 10 rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg and recorded with the Luxembourg trade and companies register
under number B 172907,

here represented by:
Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of proxy given under private seal in Luxembourg, on 26 May 2015.
Said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate name.
1.1 There is formed a private limited liability company under the name ERF Enschede S.à r.l. which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the
«Articles»).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to acquire, hold, administrate, manage and dispose of real estate (in particular land and

buildings as well as rights equivalent to real property (grundstücksgleiche Rechte) such as hereditary building rights (Erb-
baurechte) and part-ownership rights (Teileigentumsrechte); hereafter «Real Estate Assets»)). Rights equivalent to real
property may only be acquired if permanent income can be expected to accrue from such rights.

3.2 The Company may further acquire, hold, administrate, manage and dispose of interests and participations in Lu-

xembourg or foreign entities the object of which is, according to their articles, to either directly or via other companies,
whose articles contain respective provisions, hold, administrate, manage and dispose of Real Estate Assets (hereafter «Real
Estate Companies»). Interests and participations in Real Estate Companies shall only be acquired and held by the Company,
if permanent income can be expected to accrue and provided that the holding of participations in Real Estate Companies
must be at least as liquid as Real Estate Assets held directly by the Company.

3.3 Interest and participations in companies not qualifying as Real Estate Companies must not be acquired and held by

the Company.

3.4 To serve the object of the Company, the Company may on an ancillary basis perform the following activities provided

that as long as the Company is a direct or indirect subsidiary of the Cordea Savills European Retail Fund FCP-FIS such
activities do not result in a breach of the investment powers and restrictions applicable to the Cordea Savills European
Retail Fund FCP-FIS:

3.4.1 acquire, hold and dispose of any kind of asset necessary to manage Real Estate Assets;
3.4.2 render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which

it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter the «Connected Companies»), it being understood that the Company
will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector. In particular, the Company may:

96374

L

U X E M B O U R G

(a) borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited

to, debt or equity instruments, convertible or not provided that i) as long as the Company is a direct or indirect subsidiary
of the Cordea Savills European Retail Fund FCP-FIS such activities do not result in a breach of the restrictions pertaining
to the borrowing of outside capital by Cordea Savills European Retail Fund FCP-FIS and ii) in case of borrowings from
any Luxembourg or foreign Connected Company, the amount of the borrowing does not exceed 50% of the market value
of the Real Estate Assets held by the Company;

(b) advance, lend or deposit money or give credit to or with or subscribe to or purchase any debt instrument issued by

any Luxembourg or foreign Connected Company on such terms as may be thought fit and with or without security provided
that as long as the Company is a direct or indirect subsidiary of the Cordea Savills European Retail Fund FCP-FIS the terms
are market terms;

(c) give security for any borrowings through, including, but not limited to, any guarantee, pledge or any other form of

security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking and/or property assets
(present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company
and of any of the Connected Companies, within the limits of and in accordance with the provisions of Luxembourg law;
and

3.4.3 perform legal, commercial, technical and financial operations and, in general, perform transactions which are

necessary to fulfill its object as well as operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its
purpose in the areas described above.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by one hundred

twenty-five (125) shares, having each a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each (hereafter referred to as the
«Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is

admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III. - Management

Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of one

manager, he/she will be referred to as the «Sole Manager». In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers («conseil de gérance») (hereafter the «Board of Managers»)

8.2 The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a

resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the Sole Manager or of the Board of Managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without

prejudice  to  articles  8  and  10  of  the  present  Articles,  will  have  all  powers  to  act  in  the  name  of  the  Company  in  all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound

by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated.

96375

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Delegation and Agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers may delegate its/their powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any manager will determine any such agent's responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 12. Meeting of the Board of Managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager at least

twenty-four (24) hours in advance of the time set for such meeting except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. The convening requirements and formalities
may be waived by the consent in writing, by cable, telegram, telex, telefax, e-mail or any other means of communication
of each manager.

12.2 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.

12.3 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.4 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each
participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.5 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.6 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman of the meeting or all managers

present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager
or during a meeting of the Board of Managers.

Chapter IV. - General Meeting of Shareholders

Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholder(s) - Votes.
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'

meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his share holding. All Shares
have equal voting rights.

13.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be

validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five (25) Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to

be convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, resolutions can, instead of being passed at a general meeting of

Shareholders, be passed in writing. In this case, each Shareholder shall be served the precise wording of the text of the
resolution(s) to be passed, and shall give its vote in writing. Such resolutions passed in writing on one or several counterparts
in lieu of a general meeting of Shareholders shall have the force of resolutions passed at a general meeting of Shareholders.

13.6 Any reference in these Articles to resolutions of the general meeting of Shareholders shall be construed as including

the possibility of written resolutions of the Shareholders, provided that the total number of Shareholders of the Company
does in such event not exceed twenty-five (25).

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.8 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V. - Business year

Art. 14. Business year.

14.1 The Company's financial year starts on the 1 

st

 October and ends on the 30 

th

 September of the following year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality

of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers
prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

96376

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Distribution right of Shares.
15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the net profits thus determined, five per cent (5%) shall be deducted and allocated to a legal reserve fund.

That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth (10%) of the
Company's nominal capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by

law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that
cash available for remittance be distributed.

15.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a majority

vote of the Shareholders.

15.5 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a
statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a
reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI. - Liquidation

Art. 16. Dissolution and Liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders

who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. - Applicable Law

Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 30 

th

September 2016.

<i>Subscription - Payment

The appearing party hereby declares that it subscribes for all one hundred twenty-five (125) Shares representing the

total subscribed share capital.

All these Shares have been fully paid up by payment in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euros

(EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand euro.

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed

capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Michael Chidiac, manager, residing professionally at 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

- Mr Godfrey Abel, manager, residing professionally at 30 rue de Crecy, L-1364 Luxembourg.
- Ms. Nicola Hordern, manager, residing professionally at 33 Margaret Street, London W1G 0JD, United Kingdom.
- Ms Lorna Mackie, manager, residing professionally at 10, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

In accordance with article 10 of the Articles, towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature

of any two managers.

2) The Company shall have its registered office at 10 rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

96377

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, in the premises of the undersigned

notary, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, said person signed together with Us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze,
le deux juin.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

CS European Retail No. 1 S. à r.l. une société constituée conformément aux lois luxembourgeoises, ayant son siège

social au 10 rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 172907,

ici représentée par:
Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 26 mai 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.

1.1 Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «ERF Enschede S. à r.l.», qui sera régie par

les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale

extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à

transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet.
3.1 L’objet de la Société est d’acquérir, détenir, administrer, gérer et disposer de biens immobiliers (notamment des

terrains et des bâtiments de même que des droits assimilés à des biens immeubles (grundstücksgleiche Rechte) tel que le
droit emphytéotique (Erbbaurechte) et des droits de copropriété (Teileigentumsrechte) (ci après les «Biens Immobiliers»).
Les droits assimilés à des Biens Immobiliers ne peuvent être acquis à condition qu'ils génèrent un revenu permanent.

3.2  La  Société  peut  en  outre  gérer  et  disposer  d’intérêts  et  de  participations  dans  des  entités  luxembourgeoises  ou

étrangères dont l’objet est, conformément à leurs statuts, détenir, administrer, gérer et disposer d’intérêts et de participations
dans des Biens Immobiliers (ci après «Sociétés Immobilières»). Les intérêts et participations dans les Sociétés Immobilières
ne peuvent être acquis à condition qu'ils génèrent un revenu permanent et que la détention des participations dans des
Sociétés Immobilières soit aussi liquide que les Biens Immobilier détenus directement par la Société.

3.3 La Société ne doit ni acquérir ni détenir des sociétés que ne sont pas des Sociétés Immobilières.
3.4 Dans l’accomplissement de son objet, la Société peut, de manière accessoire, poursuivre les activités suivantes à

condition que pour aussi longtemps que la Société est une filiale directe ou indirecte de Cordea Savills European Retail
Fund FCP-FIS ces activités n’entraînent pas la violation des pouvoirs et des restrictions d’investissement applicables à
Cordea Savills European Retail Fund FCP-FIS:

3.4.1 acquérir, détenir et disposer d’avoirs de toute espèce nécessaire à la gestion des Biens Immobiliers;
3.4.2 prêter assistance, de toute manière, que ce soit par des prêts, garanties ou autrement à ses filiales ou à des sociétés

dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect et toute société étant un associé direct ou indirect de la Société ou toute
société faisant partie du même groupe que la Société (ci après les «Sociétés Liées»), étant entendu que la Société ne conclura
aucune transaction qui aurait pour effet de l’engager dans une activité qui pourrait être considérée comme une activité
régulière du secteur financier. La Société peut en particulier:

96378

L

U X E M B O U R G

(a) emprunter de l’argent de toute manière ou obtenir des crédits de quelque forme que ce soit, et lever des fonds, y

compris, mais sans limitation, par des instruments de dette ou de capital, convertibles ou non à condition que i) pour aussi
longtemps que la Société est une filiale directe ou indirecte de Cordea Savills European Retail Fund FCPFIS ces activités
n’entraînent pas la violation des pouvoirs et des restrictions d’investissement applicables à Cordea Savills European Retail
Fund FCP-FIS et ii) en cas d’emprunt d’une Société Liée luxembourgeoise ou étrangère, le montant de l’emprunt ne dépasse
pas 50% de la valeur du marché des Biens Immobiliers détenus par la Sociétés;

(b) avancer, prêter ou déposer de l’argent, ou accorder des crédits à ou avec, souscrire ou acquérir tout instrument de

dette émis par une Société Liée luxembourgeoise ou étrangère selon les termes jugés opportuns, et ce avec ou sans sûretés
à condition que i) pour aussi longtemps que la Société est une filiale directe ou indirecte de Cordea Savills European Retail
Fund FCP-FIS les conditions sont celles du marché;

(c) donner des sûretés pour tout emprunt, y compris mais sans limitation, par des garanties, gages ou autre forme de

nantissement, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou grève sur tout ou partie des avoirs et/ou enga-
gements  (présents  ou  futurs)  ou  par  toutes  ces  méthodes,  ou  l’une  d’entre  elles,  pour  l’exécution  de  tous  contrats  ou
obligations de la Société et de l’une des Sociétés Liées, dans les limites et conformément aux dispositions de la loi luxem-
bourgeoise; et

3.4.3 effectuer toute opération juridique, commerciale, technique et financière et, en général, effectuer toute opération

nécessaire dans l’accomplissement de son objet de même que les opérations liées directement ou indirectement afin de
faciliter l’accomplissement de son objet dans les domaines décrits ci-dessus.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital, Parts

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant chacune une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-). Les détenteurs de Parts
Sociales sont dénommés ci-après les «Associés».

5.2 En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée

pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des
Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par

Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.

Art. 7. Transfert des Parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre III. - Gérance

Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une décision des associé(s). Dans le cas

d'un seul gérant, il est dénommé ci-après le «Gérant Unique». En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil
de gérance (ci-après, le «Conseil de Gérance»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou

sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans

préjudice des articles 8 et 10 des Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée

par la seule signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants
ou par la signature de toute autre personne à qui ce pouvoir a été délégué.

96379

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Délégation et Mandataire du Gérant Unique et du Conseil de Gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un

ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 12. Réunion du Conseil de Gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance peuvent être convoquées par tout gérant au moins

vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour celle-ci, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Par l'assentiment écrit ou par câble, télégramme, télex, message
télécopié, e-mail ou tout autre moyen de communication de chaque gérant il peut être renoncé aux formalités de convocation.

12.2 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant, pour

autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un
gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ulté-
rieure.

12.3 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.4 L'utilisation d'un équipement de vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant

est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit
participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.5 Une décision écrite, signée par tous les gérants est valable et valide comme si elle avait été adoptée lors d'une

réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document
unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.6 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par le président de la séance ou par tous les

gérants présents ou représentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet
effet par un gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV. - Assemblée Générale des Associés

Art. 13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associé(s) - Votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des

Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts qu'il détient. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par
lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq (25) Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux assemblées à convoquer

conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, les décisions peuvent être adoptées par écrit au lieu d'être adoptées à une

assemblée générale des Associés. Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte de la/des décision(s) à adopter et donnera
son vote part écrit. Ces décisions adoptées par écrit sur un document unique ou sur plusieurs documents à la place d'une
assemblée générale des Associés ont la même force que les décisions prises à une assemblée générale des Associés.

13.6 Toute référence dans les présents Statuts à des décisions de l'assemblée générale des Associés doivent être comprises

comme incluant la possibilité de faire des décisions écrites des Associés, pour autant que, dans ce cas, le nombre total des
Associés de la Société n'excède pas vingt-cinq (25).

13.7 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en désignant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.8 Les décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social

les adoptent. Toutefois, les décisions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité des
Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve de toutes autres dispositions légales.

Titre V. - Exercice social

Art. 14. Exercice social.

14.1 L'année sociale commence le 1 

er

 octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des
actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.

96380

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortisse-

ments, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Du bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles
soient distribués.

15.4 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
15.5 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

Titre VI. - Liquidation

Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII. - Loi applicable

Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 septembre 2016.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante déclare par la présente que les cent vingt-cinq (125) Parts Sociales représentant la totalité du capital

social ont été souscrites par elle.

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros.

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les décisions suivantes:

1) Sont nommés Gérants de la Société pour une période indéterminée:
- Monsieur Michael Chidiac, gérant, demeurant professionnellement au 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
- Monsieur Godfrey Abel, gérant, demeurant professionnellement au 30 rue de Crecy, L-1364 Luxembourg.
- Madame Nicola Hordern, gérant, demeurant professionnellement 33 Margaret Street, W1G 0DJ Londres, Royaume-

Uni.

- Madame Lorna Mackie, gérant, demeurant professionnellement au 10, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg.
Conformément à l'article 10 des présents Statuts, la Société se trouvera engagée vis-à-vis des tiers par la signature

conjointe de deux gérants.

2) Le siège social de la Société est établi au 10, rue C.M. Spoo, L2546 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

96381

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a comprend et parle la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des

présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: B. D. KLAPP, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 juin 2015. Relation: EAC/2015/12790. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015087137/441.
(150099221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2015.

Dream Island S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 184.296.

L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de mai;
Pardevant  Nous  Maître  Carlo  WERSANDT,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme régie par les lois du Grand-

Duché de Luxembourg “DREAM ISLAND S.A.'', établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevars
Roosevelt,  inscrite  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg,  section  B,  sous  le  numéro  184296,  (la
“Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 janvier 2014, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 874 du 4 avril 2014,

et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Tobias FABER, juriste, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg,

15, boulevard Roosevelt.

Le Président désigne Madame Cathy KEMPENEERS, employée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-

bourg, 15, boulevard Roosevelt, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Felix FABER, Bachelor Arts in International Business, demeurant professionnellement

à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Echange des trois cent dix (310) actions existantes, d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, contre

trente et un mille (31.000) actions, avec une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune;

2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts;
3. Création de deux catégories d'administrateurs et modification subséquente des règles d'engagement de la Société;
4. Modification du premier paragraphe de l'article 4 des statuts;
5. Démission des administrateurs actuels, avec décharge;
6. Nomination d'un nouveau conseil d'administration, affectation aux membres du conseil d'administration d'une caté-

gorie et détermination de la durée des mandats des administrateurs;

7. Modification du registre des actionnaires afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à

tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder, pour le compte de la Société, à l'échange des
actions; et

8. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés

sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les mandataires et les membres du bureau

de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

96382

L

U X E M B O U R G

D)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  et  que  les  actionnaires,  présents  ou  représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'échanger les trois cent dix (310) actions existantes, d'une valeur nominale de cent euros (100,-

EUR) chacune, contre trente et un mille (31.000) actions, d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, de sorte à
ce que chaque actionnaire recevra cent (100) “nouvelles” actions contre une (1) “ancienne” action.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des Statuts afin de lui

donner la teneur suivante:

“Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et un mille (31.000) action

d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, entièrement libérées.”

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide:
- de créer deux catégories d'administrateurs, savoir les administrateurs de catégorie A et les administrateurs de catégorie

B;

- de modifier les règles d'engagement de la Société, de sorte à ce que le dernier alinéa de l'article 5 des Statuts aura

dorénavant la teneur suivante:

“La société est valablement engagée (i) soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) soit par la seule

signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil
d'administration.

Toutefois, si les actionnaires ont qualifié les administrateurs d'administrateurs de catégorie A ou d'administrateurs de

catégorie B, la société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un (1) administrateur de
catégorie A et d'un (1) administrateur de catégorie B.”

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide également de modifier le premier alinéa de l'article 4 des Statuts et de lui donner dorénavant la

teneur suivante:

“La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. L'assemblée générale

peut décider de créer deux catégories d'administrateurs (administrateur de catégorie A et administrateur de catégorie B).”

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide:
- d'accepter la démission des administrateurs actuels et de leur accorder, par vote spécial, décharge pleine et entière pour

l'exécution de leur mandat respectif;

- d'augmenter le nombre des membres du conseil d'administration à quatre (4);
- de nommer les personnes suivantes comme nouveaux administrateurs de la Société, leurs mandats expireront à l'as-

semblée générale annuelle de l'année 2020:

a) Monsieur Boris GONCHAROV, creative director, né à Samara (anciennement: Kuibyshev (Russie), le 25 novembre

1983, demeurant à CA-90014 Los Angeles, 600 S Spring street, unit 211, (Etats-Unis d'Amérique);

b) Monsieur Dmitry KOTOV, producer, né à Ozersk (Chelyabinks region) (Russie), le 30 septembre 1989, demeurant

à CA-90026 Los Angeles, 1812 N Alvaraldo street, apt. 3, (Etats-Unis d'Amérique);

c) Monsieur Claude FABER, expert-comptable, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 décembre

1956, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt; et

d) Monsieur Tobias FABER, juriste, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 18 janvier 1987, demeurant

professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt;

- d'attribuer la catégorie A aux administrateurs Messieurs Boris GONCHAROV et Dmitry KOTOV et la catégorie B

aux administrateurs Messieurs Claude FABER et Tobias FABER.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et d'accorder

pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder, pour le compte de la
Société, à l'échange des actions.

96383

L

U X E M B O U R G

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne

demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille deux cent dix euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. FABER, C. KEMPENEERS, F. FABER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 26 mai 2015. 2LAC/2015/11485. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 10 juin 2015.

Référence de publication: 2015087913/109.
(150100068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

MyBioBox S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 4A, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 185.820.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015086505/9.
(150098850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

Sautel Investissements Industriels S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 121.226.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 2 avril 2015:

Monsieur Marc Koeune, administrateur, est nommé Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015086699/11.
(150098924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2015.

Olky Payment Service Provider S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, 1, rue de Turi.

R.C.S. Luxembourg B 165.776.

<i>Extrait des principales résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 6 mai 2015

Le Conseil d'Administration décide de la nomination de 2 Administrateurs-Délégués et ce jusqu'à l'Assemblée Générale

des actionnaires qui se tiendra en l'année 2021.

Ces Administrateurs-Délégués sont:
- Monsieur ROUAYROUX Franck demeurant au 2, rue Josy Printz à L-5851 Hesperange.
- Monsieur HAUTOT Patrick demeurant au 501, rue Neuve à F-76520 La Neuville Chant d'Oisel.
Vis-à-vis des tiers la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs (un

administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B) dont obligatoirement celle de l'Administrateur-Délégué,
le cas échéant, soit par la signature individuelle de l'Administrateur-Délégué dans les limites de ses pouvoirs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015088303/17.
(150100899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

96384


Document Outline

Agriland Fund S.C.A., SICAV-FIS

Amlelux S.A.

BJR International S.A.

Business Angel Venture Management S.A.

BYOB

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)

Dania Presents S.à r.l.

Deltainvest S.A.

Desmag S.A.

Diaverum S.à r.l.

Disar S.A., SPF

Dream Island S.A.

ERF Enschede S.à r.l.

Gero S.à r.l.

InterV Investment S.à r.l.

INVESCO Paris CDG Airport Hotel Investments S.A.

Jeantet Luxembourg

Kensington UK Pledgeco S.à r.l.

Kern Tech 1

KMU/PME S.à r.l.

L'Air Liquide Luxembourg S.A.

Landlake Invest S.à r.l.

Legal &amp; General Sicav

Links Bidco S.à r.l. Propco 1

Lion Equity S.A.

Lux-Immo-Containers S.A.

Lux Rent Office S.A.

Maple Bidco S.à r.l.

MarketPrizm Group S.à r.l.

MBERP II (Luxembourg) 26 S.à r.l.

MFB International Holdings S.à r.l.

Monocle Fund SICAV

MyBioBox S.A.

N1ghtfor S.à r.l.

NBIM Otto NKE S.à r.l.

NBIM Otto W1 S.à r.l.

NBIM Otto W3 S.à r.l.

NBIM S.à r.l.

Olky Payment Service Provider S.A.

OT Luxco 1 S.à r.l.

OT Luxco 2 S.à r.l.

OT Luxco 3 &amp; Cy S.C.A.

Riward S.à r.l.

Robec SA

Robec SA

Robec SA

Sautel Investissements Industriels S.A.