This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1928
30 juillet 2015
SOMMAIRE
A 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92522
Access Capital Fund SICAV-SIF . . . . . . . . . . .
92520
Advent PPF (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . .
92520
Alander S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92522
Alpha Fund, S.C.A., SICAV-SIF . . . . . . . . . . .
92527
AmerisourceBergen Luxembourg . . . . . . . . . .
92521
Amethis Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92521
Astromancia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92525
Athena Equity Trading S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
92521
Auto-Ecole Dani Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92525
Bajacghi (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92527
Burnfort Investments S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
92525
Côte d'Emeraude S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92538
Danaher Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
92537
D.A.S. Luxemburg Allgemeine Rechtsschutz-
Versicherung S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92537
Duchy Digital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92537
Eastman Chemical Luxembourg Sàrl . . . . . . .
92538
ECommerce Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
92538
Eiffel PT 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92539
Electro-Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92538
Electro-Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92539
Energy Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92539
Escalet Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92539
Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . .
92542
FABS Luxembourg I SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92543
Faculté d'Ingénierie et de Recherche de Solu-
tions et Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92541
Fidelity Productions Participations S.A. . . . . .
92543
Frena Intermediate Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
92543
Genzyme Luxembourg S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
92544
German Falcon Investments S.A. . . . . . . . . . .
92498
Gestion Fiera Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
92544
Global Viewcomp Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . .
92544
LSREF3 Eve Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
92530
Maison é S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92528
Meltemi Entreprises S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
92514
MezzVest Luxembourg I S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
92528
NBIM Otto SZ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92513
NBIM Otto W1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92514
Orco Property Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92513
Pilot SA (Pédagogie, Instructions, Langues,
Organisation et Training) . . . . . . . . . . . . . . . .
92541
ResponsAbility BOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92522
Schleswig Retail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92534
Stirling Adjacent Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . .
92534
SWYP Lux S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92511
Tarpon Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92520
Team First S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92534
Teleteam V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92507
TPG Merl S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92534
Weiland HTS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92522
WishFish Technologies S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
92524
92497
L
U X E M B O U R G
German Falcon Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 196.692.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of the month of April;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
APPEARED:
SGG S.A., a public limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under the number B 65.906,
duly represented by Mrs Alexia UHL, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by mandatory and the officiating notary, will remain attached
to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the articles of association
of a public limited company ("Aktiengesellschaft"), which it deems to incorporate, as follows:
Art. 1. Form and Name.
1.1 There is hereby established a public limited liability company (“société anonyme”) (the Company) which will be
governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the Law), and by the present articles of incorporation (the Articles).
1.2 The Company will exist under the name of “German Falcon Investments S.A..”
1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of
directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.
2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are
imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in
the manner required for amendments of the Articles.
Art. 4. Corporate objects.
4.1 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
4.2 The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating
interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability
company, as well as the administration, management, control and development of such participations.
4.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio
comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and
control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or other-
wise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
4.4 The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of
companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.
4.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
4.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer
in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any
92498
L
U X E M B O U R G
patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and that aim to
promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital is set at one hundred thousand Euros (100,000.- EUR), consisting of one hundred (100)
shares with a par value of one thousand Euros (1,000.- EUR) each.
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
5.3 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General
Meeting in the manner required for amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at
the opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the Shareholders, subject to
the restrictions foreseen by Law.
6.2 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of
ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint
one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a sus-
pension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
6.3 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
Art. 7. Meetings of the shareholders of the Company.
7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In
these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or
powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.
7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the
General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on the second Thursday of the month of May at 2:00 pm. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional
circumstances so require.
7.5 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
7.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of
communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partici-
pating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.
Art. 8. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
8.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General
Meetings, unless otherwise provided herein.
8.2 Each share is entitled to one vote.
8.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in
original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.
8.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as
being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 9. Management.
9.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors composed
of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole Shareholder,
or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s) of the Company.
92499
L
U X E M B O U R G
In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors (A Directors and B
Directors).
9.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General
Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any director
may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall be eligible
for reappointment.
9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of share-
holders.
Art. 10. Meetings of the Board.
10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may
choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who need not
be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry
out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.
10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person delegated
to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting
the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given
to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency
where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency. This notice may be waived,
either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate
notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors.
10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or
e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.
10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the
directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by
the secretary to the board, if any, failing whom by any director.
10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event
that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or similar
means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating
in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent
in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 11. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts
of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles
to the General Meeting fall within the competence of the Board.
Art. 12. Delegation of powers. The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes
of performing specific functions at every level within the Company.
Art. 13. Binding signatures.
13.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two members
of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such
signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
13.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A
Director together with any B Director.
Art. 14. Conflict of interests.
14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate,
officer or employee of such other company or firm.
14.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.
92500
L
U X E M B O U R G
14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of
the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning
transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.
Art. 15. Statutory Auditor(s).
15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or,
where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be
elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remu-
neration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting
with or without cause.
Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
of January of each year and shall
terminate on the 31
st
of December of the same year.
Art. 17. Allocation of profits.
17.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the
Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.
17.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may
alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.
17.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places
and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Law.
Art. 18. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting
adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation
shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General
Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the
liquidator(s).
Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject
to the quorum and majority requirements referred to in the Law.
Art. 20. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitory dispositionsi>
1. The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and ends on the 31
st
of December 2015.
2. The first annual general meeting will be held in the year 2016.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the one hundred (100) shares have been subscribed by the sole shareholder
SGG S.A., predesignated and represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash,
so that the amount of one hundred thousand Euros (100,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company
and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10
th
, 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred fifty Euros
(EUR 1,250.-).
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the
subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:
1) The registered office of the Company is established at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
2) The number of Directors is fixed at four (4) and the number of statutory auditor at one (1).
92501
L
U X E M B O U R G
3) The following persons are appointed as Directors:
<i>Directors of category A:i>
(i) Mr. Thomas KATZUBA VON URBISCH, born in Oppeln (Germany), on January 25
th
, 1972, residing at 44,
boulevard d'Italie, MC-98000 Monaco;
(ii) Mr. Tunc GUVEN, born in Buras (Turkey), on April 19
th
, 1978, residing at Flat 8, 12 Queen's Terrace, St John's
Wood, London, NW8 6DF;
<i>Directors of category B:i>
(iii) Mr. François LANNERS, born in Mersch (Luxembourg), on October 3
rd
, 1948, with professional address at 412F,
route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
(iv) Mrs. Rosalba BARRETTA, born in Marsala (Italy), on January 3
rd
, 1971, with professional address at 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg;
4) FIN-CONTROLE S.A., a public limited company (société anonyme) existing under Luxembourg law, with registered
office at L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register,
under the number B 42.230, is appointed as statutory auditor.
5) The mandates of the directors and the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2020,
unless they previously resign or are revoked.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who speaks and understands English and German, states herewith that the present deed is
worded in English followed by a German version; on request of the appearing party and in case of divergences between
the English and the German version, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary,
by surname, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us, the notary, the present original
deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den neunundzwanzigsten des Monats April;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
SGG S.A., Aktiengesellschaft, gegründet und bestehend unter luxemburgischem Recht, mit Firmensitz in 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 65.906;
hier gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vertreten durch Frau Alexia UHL, Juristin, beruflich wohnhaft in Lu-
xemburg; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der
gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Statuten einer Akti-
engesellschaft, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Form und Name.
1.1 Es wird eine Aktiengesellschaft („public limited company“) (die Gesellschaft) gegründet, welche dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geän-
derten Fassung (das Gesetz), sowie der vorliegenden Satzung (die Satzung) unterliegen soll.
1.2 Die Gesellschaft führt den Namen „German Falcon Investments S.A.“.
1.3 Die Gesellschaft kann einen Einzelaktionär (der Einzelaktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft
kann nicht durch das Ableben, die Aussetzung der bürgerlichen Rechte, die Insolvenz, die Liquidation oder den Bankrott
des Einzelaktionärs aufgelöst werden.
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, errichtet.
2.2 Er kann innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats der Ge-
sellschaft (der Verwaltungsrat) bzw. im Fall eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds (das einzelne Verwaltungsratsmit-
glied) durch Beschluss des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds verlegt werden.
2.3 Falls der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse stattfinden
werden oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose
Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann er den Gesellschaftssitz
vorübergehend ins Ausland verlegen, bis diese außergewöhnlichen Umstände beendet sind. Diese vorübergehende Maß-
nahme hat jedoch keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
92502
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Dauer der Gesellschaft.
3.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
3.2 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung (wie nachstehend definiert) der Gesell-
schaft, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden.
Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1 Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännischen, gewerblichen oder finanziellen Geschäfte tätigen sowie sämtliche
Eigentumsübertragungen von Immobilien und Mobilien vornehmen.
4.2 Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich ferner auf sämtliche Geschäfte, die sich unmittelbar oder mittelbar auf
die Beteiligung in jeglicher Form an jeglichen Unternehmen (sowohl Kapital- als auch Personengesellschaften) beziehen
sowie auf die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.
4.3 Insbesondere kann die Gesellschaft ihr Vermögen zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Veräußerung eines
Portfolios aus jeglichen Wertpapieren und Patenten jeglicher Herkunft verwenden. Sie kann sich an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle eines jeglichen Unternehmens beteiligen. Sie kann jegliche Wertpapiere und Patente durch Einlage,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Weise erwerben und diese durch Verkauf, Übertragung,
Tausch oder auf andere Weise realisieren.
4.4 Die Gesellschaft kann ebenfalls Dritten Garantien gewähren und Sicherheiten stellen, um ihre Verpflichtungen zu
garantieren oder diejenigen von Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält, oder von
Gesellschaften, die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören. Sie kann ferner Gesellschaften, an denen
sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält oder die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft ge-
hören, sowie jeder anderen Gesellschaft oder jedem anderen Dritten Darlehen gewähren oder sie in sonstiger Weise
unterstützen.
4.5 Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auch durch Filialen in Luxemburg oder im Ausland ausüben.
4.6 Sie kann auch möblierte oder nicht möblierte Immobilien erwerben, verwalten, bewirtschaften, verkaufen oder
diesbezüglich Mietverträge abschließen, und ganz allgemein Immobiliengeschäfte jeglicher Art tätigen, außer den Immo-
bilienhändlern vorbehaltenen Geschäften. Die Gesellschaft kann auch ihre Liquiditäten platzieren und verwalten. Ganz
allgemein kann die Gesellschaft sämtliche vermögens-, mobilien- oder immobilienbezogene Geschäfte, Handelsgeschäfte,
gewerbliche oder finanzielle Geschäfte tätigen sowie sämtliche Transaktionen und Geschäfte, die geeignet sind, unmittelbar
oder mittelbar die Verwirklichung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital wird auf einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) festgelegt, eingeteilt in
einhundert (100) Stammaktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (1.000 EUR).
5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf das sämtliche Emissionsauf-
gelder, die auf eine Aktie zusätzlich zu ihrem Nennwert gezahlt werden, überwiesen werden. Das Guthaben dieses
Aufgeldkontos kann für die Bezahlung von Aktien, welche die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkauft, für den
Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, für Ausschüttungen an die Aktionäre oder für die Zuführung von Geldern in die
gesetzliche Rücklage verwendet werden.
5.3 Durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst
wird, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Aktien.
6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien oder Inhaberaktien oder ein Teil der Aktien sind Namensaktien und
der andere Teil sind Inhaberaktien, je nach Wahl des Einzelaktionärs bzw. bei mehreren Aktionären je nach Wahl der
Aktionäre, vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes.
6.2 Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an. Falls eine oder mehrere Aktien gemeinsam gehalten werden
oder falls die Eigentumstitel dieser Aktien geteilt, fragmentiert oder strittig sind, muss/müssen diejenige(n) Person(en), die
ein Recht an dieser/diesen Aktie(n) geltend macht/machen, einen einzigen Vertreter ernennen, um die Aktie(n) gegenüber
der Gesellschaft zu vertreten. Die Unterlassung dieser Ernennung hat die Suspendierung der Ausübung sämtlicher mit den
Aktien verbundenen Rechte zur Folge. Die gleiche Regel findet Anwendung im Fall eines Konflikts zwischen einem
Nießbraucher und einem Inhaber des Stammrechts oder zwischen einem Pfandgläubiger und einem Pfandschuldner.
6.3 Die Gesellschaft kann unter den von dem Gesetz vorgesehenen Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Art. 7. Aktionärsversammlungen der Gesellschaft.
7.1 Im Fall eines Einzelaktionärs hat dieser sämtliche der Hauptversammlung verliehenen Befugnisse. In dieser Satzung
ist jede Bezugnahme auf die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse eine Bezug-
nahme auf die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse, solange die Gesellschaft nur einen
Einzelaktionär hat. Die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse werden in Protokollen registriert.
7.2 Im Fall mehrerer Aktionäre vertritt jede ordnungsgemäß gebildete Hauptversammlung der Aktionäre der Gesell-
schaft (die Hauptversammlung) sämtliche Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse,
um alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu genehmigen.
92503
L
U X E M B O U R G
7.3 Die jährliche Hauptversammlung wird gemäß luxemburgischem Recht in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder
an einem anderen, in den Einberufungen angegebenen Ort der Gemeinde des Sitzes am zweiten Donnerstag des Monats
Mai um 14:00 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag für Banken in Luxemburg ein Feiertag ist, wird die jährliche Hauptver-
sammlung am ersten folgenden Werktag abgehalten.
7.4 Die Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen
feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies verlangen.
7.5 Die anderen Hauptversammlungen können an dem im jeweiligen Einberufungsschreiben angegebenen Ort und
Datum abgehalten werden.
7.6 Jeder Aktionär der Gesellschaft kann an der Hauptversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder eines
ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen (i) die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre
identifiziert werden können, (ii) jeder Teilnehmer der Hauptversammlung die anderen Teilnehmer hören kann und mit
ihnen sprechen kann, (iii) die Hauptversammlung direkt übertragen wird und (iv) die Aktionäre rechtsgültig beraten können.
Die Teilnahme an einer Hauptversammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen Teilnahme
an einer solchen Versammlung gleichwertig.
Art. 8. Einberufungsfristen, Beschlussfähigkeit, Vollmachten, Einberufungsschreiben.
8.1 Für die Einberufungsschreiben und die Abhaltung der Hauptversammlung gelten die von dem Gesetz vorgeschrie-
benen Einberufungsfristen und Beschlussfähigkeitsbestimmungen, sofern in der Satzung nichts anderes bestimmt wird.
8.2 Jede Aktie gewährt eine Stimme.
8.3 Soweit im Gesetz oder in der Satzung nichts anderes festgelegt ist, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß
einberufenen Hauptversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung
teilnehmenden Aktionäre gefasst.
8.4 Jeder Aktionär kann an den Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft teilnehmen, indem er schriftlich
entweder per Urschrift oder per Telefax oder per E-Mail (versehen mit einer elektronischen Unterschrift gemäß den An-
forderungen des luxemburgischen Rechts) eine andere Person zu seinem Vertreter ernennt.
8.5 Sind alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären, ordnungsgemäß einberufen
und über die Tagesordnung der Hauptversammlung informiert worden zu sein, so kann die Hauptversammlung auch ohne
vorherige Einberufung abgehalten werden.
Art. 9. Verwaltung der Gesellschaft.
9.1 Im Fall eines Einzelaktionärs kann die Gesellschaft von einem einzelnen Verwaltungsratsmitglied verwaltet werden.
Die genaue Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist dann vom Einzelaktionär festzulegen. Im Fall mehrerer Aktionäre wird
die Gesellschaft vom Verwaltungsrat, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, verwaltet. Die genaue Zahl der
Verwaltungsratsmitglieder ist dann von der Hauptversammlung festzulegen. Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) muss/
müssen nicht Aktionär(e) sein. Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern kann die Hauptversammlung beschließen, zwei
Kategorien von Verwaltungsratsmitgliedern (Verwaltungsratsmitglieder A und Verwaltungsratsmitglieder B) zu schaffen.
9.2 Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) wird/werden vom Einzelaktionär oder bei mehreren Aktionären von der
Hauptversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt worden sind.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden. Die Wie-
derwahl des scheidenden Verwaltungsratsmitglieds/der scheidenden Verwaltungsratsmitglieder ist zulässig.
9.3 Bei Vakanz des Postens eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt oder eines anderen Grundes
können die übrigen von der Hauptversammlung gewählten Verwaltungsratsmitglieder zusammentreten und ein Verwal-
tungsratsmitglied wählen, das die mit dem frei gewordenen Posten verbundenen Aufgaben bis zur nächsten Hauptver-
sammlung erfüllt.
Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrats.
10.1 Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern muss der Verwaltungsrat unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden
wählen und kann aus seiner Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann ebenfalls einen Schrift-
führer ernennen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und dem die Führung des Protokolls bei den Versammlungen
des Verwaltungsrats oder die Ausführung von administrativen oder anderen gelegentlich vom Verwaltungsrat beschlos-
senen Aufgaben übertragen werden kann.
10.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf eine Einberufung seines Vorsitzenden oder mindestens zweier Verwal-
tungsratsmitglieder hin an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort. Die die Versammlung einberufende(n) Person
(en) bestimmt/bestimmen die Tagesordnung. Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält mindestens acht Tage vor dem für die
Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine Mitteilung in Form eines Briefs, Telegramms, Telefax oder einer E-Mail, außer
im Fall einer Dringlichkeit. In einem solchen Fall muss das 24 Stunden vor der Versammlung versandte Einberufungs-
schreiben die Art dieser Dringlichkeit angeben. Das Erfordernis einer derartigen Einberufung braucht im Fall eines vor
oder nach der Versammlung erteilten Einverständnisses eines jeden Verwaltungsratsmitglieds in Form eines Briefs, Tele-
gramms, Telefax oder einer E-Mail nicht beachtet zu werden. Eine besondere Einberufung ist nicht erforderlich für
Versammlungen des Verwaltungsrats, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, die zuvor vom Ver-
waltungsrat beschlossen wurden.
92504
L
U X E M B O U R G
10.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich vertreten lassen, indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied per Brief,
Telegramm, Telefax oder E-Mail zu seinem Vertreter ernennt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nicht mehr als einen
seiner Kollegen vertreten.
10.4 Der Verwaltungsrat kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder
bei der Versammlung des Verwaltungsrats anwesend oder vertreten sind. Wenn die Beschlussfähigkeit nicht innerhalb
einer halben Stunde nach dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt gegeben ist, können die anwesenden Ver-
waltungsratsmitglieder die Versammlung an einen anderen Ort und auf einen späteren Zeitpunkt vertagen. Die Einberu-
fungsschreiben für die vertagten Versammlungen werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats gegebenenfalls durch den
Schriftführer übermittelt, ansonsten durch ein Verwaltungsratsmitglied.
10.5 Die Beschlüsse werden durch die Mehrheit der Stimmen der bei jeder Versammlung anwesenden oder vertretenen
Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Falls bei einer Versammlung des Verwaltungsrats Stimmengleichheit für oder gegen
einen Beschluss vorliegt, ist die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrats nicht ausschlaggebend. Bei Stimmen-
gleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.
10.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung des Verwaltungsrats mittels Telefon- oder Videokon-
ferenz oder eines ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen alle Teilnehmer der Versammlung sich
hören können. Die Teilnahme an der Versammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen
Teilnahme an dieser Versammlung gleichwertig.
10.7 Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Beschluss des Verwaltungsrats auch in Form eines Um-
laufbeschlusses gefasst werden, der sich aus einem oder mehreren Dokumenten ergibt, das/die die Beschlüsse enthält/
enthalten und das/die ausnahmslos von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet wird/werden. Das Datum eines
solchen Beschlusses ist dasjenige der letzten Unterschrift.
10.8 Dieser Artikel gilt nicht für den Fall, dass die Gesellschaft durch ein einzelnes Verwaltungsratsmitglied verwaltet
wird.
Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrats. Dem Verwaltungsrat sind die weitestgehenden Befugnisse übertragen, um
sämtliche Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Interesse der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche nicht aus-
drücklich durch das Gesetz oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit
des Verwaltungsrats.
Art. 12. Vollmachtserteilung. Der Verwaltungsrat ist auch befugt, eine Person, die kein Verwaltungsratsmitglied zu sein
braucht, für die Ausführung besonderer Aufträge auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft zu ernennen.
Art. 13. Unterschriften von Zeichnungsbefugten.
13.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedem Falle nur verpflichtet (i) durch die gemeinsame Unterschrift von
zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die Unterschrift des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds oder
(ii) durch die gemeinsamen Unterschriften aller Personen oder die alleinige Unterschrift der Person, denen/der eine Zeich-
nungsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, und soweit die ihr/ihnen übertragenen Befugnisse reichen.
13.2 Im Fall von Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und der Kategorie B wird die Gesellschaft rechtsgültig
durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds A und eines Verwaltungsratsmitglieds B verpflichtet.
Art. 14. Interessenkonflikt.
14.1 Kein Vertrag oder keine sonstige Transaktion zwischen der Gesellschaft und jeglicher anderen Gesellschaft oder
Körperschaft wird durch den Umstand beeinflusst oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder
Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder Körperschaft
haben sollten oder Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser sonstigen
Gesellschaft oder Körperschaft sind.
14.2 Ein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welches bzw. welcher Verwal-
tungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Körperschaft ist, mit der die
Gesellschaft einen Vertrag abschließt oder der gegenüber sie sich anderweitig geschäftlich verpflichtet, kann auf Grund
seiner Position in dieser anderen Gesellschaft oder Körperschaft nicht daran gehindert werden, in Bezug auf einen solchen
Vertrag oder dieses sonstige Geschäft zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
14.3 Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches und gegenläufiges Interesse an einem Geschäft
der Gesellschaft haben sollte, muss dieses Verwaltungsratsmitglied den Verwaltungsrat der Gesellschaft über sein per-
sönliches und gegenläufiges Interesse informieren, und dieses Verwaltungsratsmitglied wird in Bezug auf dieses Geschäft
weder an der Beratung noch an der Abstimmung teilnehmen. Über dieses Geschäft und das persönliche und gegenläufige
Interesse dieses Verwaltungsratsmitglieds ist bei der nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten. Die zwei vorste-
henden Absätze gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrats über die im Rahmen der laufenden Geschäfte der
Gesellschaft zu normalen Bedingungen abgeschlossenen Geschäfte.
Art. 15. Prüfer.
15.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Abschlussprüfer und in den von dem Gesetz
vorgesehenen Fällen durch einen externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Der Abschlussprüfer wird für
einen Zeitraum von maximal sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.
92505
L
U X E M B O U R G
15.2 Der Abschlussprüfer wird von der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft ernannt, welche die Zahl der
Abschlussprüfer, deren Vergütung und deren Mandatsdauer festlegt. Der amtierende Abschlussprüfer kann jederzeit durch
die Hauptversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben
Jahres.
Art. 17. Verwendung der Gewinne.
17.1 Ein Betrag in Höhe von 5% (fünf Prozent) wird dem Jahresnettogewinn der Gesellschaft entnommen und der
gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Die Entnahme dieses Betrages ist dann nicht mehr obligatorisch, wenn die gesetzliche
Rücklage 10% (zehn Prozent) des festgelegten (gegebenenfalls entsprechend Artikel 5.3 der Satzung erhöhten oder he-
rabgesetzten) Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht.
17.2 Die Hauptversammlung beschließt über die Zuweisung des Saldos des jährlichen Nettogewinns und beschließt
allein darüber, von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, wie sie es in ihrem Ermessen als dem Zweck und der Politik
der Gesellschaft am besten entsprechend erachtet.
17.3 Die Dividenden können in Euro oder in jeder sonstigen vom Verwaltungsrat gewählten Währung ausgeschüttet
werden und müssen an dem vom Verwaltungsrat gewählten Ort ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann beschlie-
ßen, Zwischendividenden unter den Bedingungen und in den Grenzen des Gesetzes auszuschütten.
Art. 18. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher
in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesell-
schaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können).
Diese werden durch den über die Liquidation entscheidenden Beschluss der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptver-
sammlung legt auch die Befugnisse und die Vergütung des oder der Liquidatoren fest.
Art. 19. Satzungsänderungen. Die vorliegende Satzung kann von Zeit zu Zeit durch die außerordentliche Hauptver-
sammlung unter Einhaltung der von dem Gesetz vorgeschriebenen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsbedingungen
geändert werden.
Art. 20. Anwendbares Recht. Sämtliche Fragen, die nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelt werden, werden
gemäß dem Gesetz entschieden.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2016 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die einhundert (100) Aktien durch die alleinige Gesell-
schafterin SGG S.A., vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt worden, so dass
der Betrag von einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtie-
renden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915, wie abge-
ändert, beachtet und erläutert wurden.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendzweihundert-
fünfzig Euro (EUR 1.250,-).
<i>Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterini>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienene Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird auf L-2086 Luxemburg, 412F, route d'Esch festgelegt.
2) Die Anzahl Verwaltungsmitglieder wird auf vier (4) festgelegt und die der Rechnungskommissare auf einen (1).
3) Folgende Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:
<i>Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A:i>
(i) Herr Thomas KATZUBA VON URBISCH, geboren in Oppeln (Deutschland), am 25. Januar 1972, wohnhaft in 44,
boulevard d'Italie, MC-98000 Monaco;
(ii) Herr Tunc GUVEN, geboren in Bursa (Türkei), am 19. April 1978, wohnhaft in Flat 8, 12 Queen's Terrace, St John's
Wood, London, NW8 6DF;
92506
L
U X E M B O U R G
<i>Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B:i>
(iii) Herr François LANNERS, geboren in Mersch, (Großherzogtum Luxemburg), am 3. Oktober 1948, mit Berufsad-
resse in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg;
(iv) Frau Rosalba BARRETTA, geboren in Marsala (Italien), am 3. Januar 1971, mit Berufsadresse in 412F, route d'Esch,
L-2086 Luxemburg.
4) FIN-CONTROLE S.A., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende „société
anonyme“ mit Gesellschaftssitz in L- 1882 Luxemburg, 12 rue Guillaume Kroll, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 42.230, wird zum Rechnungskommissar bestellt.
5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungskommissars enden beim Abschluss der ordentlichen
Hauptversammlung des Jahres 2020, es sei denn, sie treten vorher zurück oder werden abgewählt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der die englische und deutsche Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorlie-
gende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag des Komparenten
und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei, namens han-
delnd wie hiervor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, hat dieselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 5 mai 2015. 2LAC/2015/9676. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 12 mai 2015.
Référence de publication: 2015071608/524.
(150082090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Teleteam V, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.540.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 193.614.
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre avril.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de TELETEAM V, une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-1855 Luxembourg, 37A, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B193.614 (la Société), constituée suivant
les droits français et ayant changé la nationalité suivant un acte reçu par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 23 décembre, dont les statuts ont été publiés auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés le 18
février 2015, numéro 451 (les Statuts). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître
Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacher, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, en
date du 10 avril 2015, non encore publié au Mémorial C.
1. Astorg Partners SAS, une société par actions simplifiée de droit français avec siège social à F-75008 Paris, 68 Rue
du Faubourg Saint Honoré, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris (France) sous le numéro RCS B
419 838 545,
Ici représentée par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
2. MRN Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social à L-2086 Luxem-
bourg, 412F, Route d'Esch, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 184.732,
ici représentée par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
3. JL INVEST S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social à L-2086 Luxem-
bourg, 412F, Route d'Esch, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 172.434,
ici représentée par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
92507
L
U X E M B O U R G
4. ALEPH INVEST S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social à L-2086
Luxembourg, 412F, Route d'Esch, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 172.431,
ici représentée par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
5. M. François de Mitry, résidant au 4, Pembroke Villas, W86PG London, United Kingdom, ici représenté par Madame
Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue Kennedy, L-1855 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
6. M. Christian Couturier, résidant au 111bis, rue de Courcelles, 75017 Paris,
ici représenté par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
7. MAMCO SAS, une société par actions simplifiée de droit français avec siège social à F-75017 Paris, 111bis rue de
Courcelles, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 801 691 320.
ici représentée par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
8. M. Thibault Surer, résidant au 144Bis, Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris,
ici représenté par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront an-
nexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Qu'ils détiennent ensemble 100 % des parts sociales de la Société comme suit:
ASSOCIES
NOMBRE
DE PARTS
SOCIALES
ASTORG PARTNERS SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
MRN INVEST Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381.369
JL INVEST Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381.369
ALEPH Invest Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368.870
François de Mitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163.443
Christian Couturier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.000
MAMCO SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.722
Thibault Surer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.480
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.444.753
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social souscrit de la Société d'un montant de quatre-vingt-quinze mille deux cent quarante-
sept euros (EUR 95.247,-) afin de porter le capital social de son montant actuel d'un million quatre cent quarante-quatre
mille sept cent cinquante-trois euros (EUR 1.444.753,-) euros à un million cinq cent quarante milles euros (EUR
1.540.000,-) par l'émission de quatre-vingt-quinze mille deux cent quarante-sept (95.247) nouvelles parts sociales ayant
une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune;
2. Souscription et paiement de l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus par des versements en
espèces par dix (10) nouveaux associés, à savoir:
a) M. Jean Hubert Vial souscrit 13.870 parts sociales;
b) Mme Judith Charpentier souscrit 9.247 parts sociales;
c) Mme Sophie Pochard souscrit 7.398 parts sociales;
d) M. Nicolas Marien souscrit 5.548 parts sociales;
e) M. Thomas Carbonel souscrit 5.548 parts sociales;
f) M. Benjamin Dierickx souscrit 3.699 parts sociales;
g) M. Benjamin Cordonnier souscrit 14.796 parts sociales;
h) M. Charles-Hubert Le Baron souscrit 3.699 parts sociales;
i) Mme Marion Guillemain souscrit 1.850 parts sociales;
j) M. Jean Casamayou souscrit 29.592 parts sociales.
et renonciation des associés actuels à leur droit de souscription préférentiel;
3. Modification subséquente de l'article 5 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point
1. ci-dessus;
4. Divers.
I. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:
92508
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de quatre-vingt-quinze mille
deux cent quarante-sept euros (EUR 95.247,-) afin de porter le capital social de son montant actuel d'un million quatre cent
quarante-quatre mille sept cent cinquante-trois euros (EUR 1.444.753,-) euros à un million cinq cent quarante milles euros
(EUR 1.540.000,-) par l'émission de quatre-vingt-quinze mille deux cent quarante-sept (95.247) nouvelles parts sociales
ayant une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d'accepter et d'acter la souscription et la libération de l'augmentation de capital comme suit:
<i>Intervention - Renonciation - Souscription - Libérationi>
Et ainsi les associés actuels renoncent expressément à leur droit de souscription.
Sont ensuite intervenu aux présentes:
1. M. Jean Hubert Vial, résidant au 6, Avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris,
ici représenté par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
qui déclare souscrire à treize mille huit cent soixante-dix parts (13.870) parts sociales d'une valeur nominale de un euro
(1,- EUR) chacune; le montant a été entièrement libérés en espèces, de sorte que le montant total de treize mille huit cent
soixante-dix Euros (13.870,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.
2. Mme Judith Charpentier, résidant au 4, avenue Rodin, 75516 Paris,
ici représentée par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
qui déclare souscrire à neuf mille deux cent quarante-sept parts (9.247) parts sociales d'une valeur nominale de un euro
(1,- EUR) chacune; le montant a été entièrement libérés en espèces, de sorte que le montant total de neuf mille deux cent
quarante-sept Euros (9.247,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.
3. Mme Sophie Pochard, résidant au 4, rue de Rivoli 75 004 Paris,
ici représentée par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
qui déclare souscrire à sept mille trois cent quatre-vingt dix-huit parts (7.398) parts sociales d'une valeur nominale de
un euro (1,- EUR) chacune; le montant a été entièrement libérés en espèces, de sorte que le montant total de sept mille trois
cent quatre-vingt dix-huit Euros (7.398,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.
4. M. Nicolas Marien, résidant au 12, avenue de la Motte Picquet 75007 Paris,
ici représenté par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
qui déclare souscrire à cinq mille cinq cent quarante-huit parts (5.548) parts sociales d'une valeur nominale de un euro
(1,- EUR) chacune; le montant a été entièrement libérés en espèces, de sorte que le montant total de cinq mille cinq cent
quarante-huit Euros (5.548,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.
5. M. Thomas Carbonel, résidant au 13, rue Laugier 75017 Paris,
ici représenté par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
qui déclare souscrire à cinq mille cinq cent quarante-huit parts (5.548) parts sociales d'une valeur nominale de un euro
(1,- EUR) chacune; le montant a été entièrement libérés en espèces, de sorte que le montant total de cinq mille cinq cent
quarante-huit Euros (5.548,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.
6. M. Benjamin Dierickx, résidant au 4, Villa Monceau 75017 Paris,
ici représenté par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
qui déclare souscrire à trois mille six cent quatre-vingt dix-neuf parts (3.699) parts sociales d'une valeur nominale de
un euro (1,- EUR) chacune; le montant a été entièrement libérés en espèces, de sorte que le montant total de trois mille six
cent quatre-vingt dix-neuf Euros (3.699,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.
7. M. Benjamin Cordonnier, résidant au 218, rue de grenelle 75007 Paris,
ici représenté par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
qui déclare souscrire à quatorze mille sept cent quatre-vingt seize parts (14.796) parts sociales d'une valeur nominale
de un euro (1,- EUR) chacune; le montant a été entièrement libérés en espèces, de sorte que le montant total de quatorze
mille sept cent quatre-vingt seize Euros (14.796,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.
8. M. Charles-Hubert Le Baron, résidant au 9, rue Victor Hugo, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France,
92509
L
U X E M B O U R G
ici représenté par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
qui déclare souscrire à trois mille six cent quatre-vingt dix-neuf parts (3.699) parts sociales d'une valeur nominale de
un euro (1,- EUR) chacune; le montant a été entièrement libérés en espèces, de sorte que le montant total de trois mille six
cent quatre-vingt dix-neuf Euros (3.699,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.
9. Mme Marion Guillemain, résidant au 10, rue Aristide Bruant, 75018 Paris,
ici représentée par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
qui déclare souscrire à mille huit cent cinquante parts (1.850) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR)
chacune; le montant a été entièrement libérés en espèces, de sorte que le montant total de mille huit cent cinquante Euros
(1.850,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.
10. M. Jean Casamayou, résidant au 10, avenue de Lattre de Tassigny, 92340 Bourg la Reine, France,
ici représenté par Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée avec adresse professionnelle au 37A, avenue
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
qui déclare souscrire à vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt douze parts (29.592) parts sociales d'une valeur nominale
de un euro (1,- EUR) chacune; le montant a été entièrement libérés en espèces, de sorte que le montant total de vingt-neuf
mille cinq cent quatre-vingt douze Euros (29.592,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.
Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, resteront annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La preuve de l'apport en espèces d'un montant de quatre-vingt-quinze mille deux cent quarante-sept euros (EUR 95.247,-)
a été donnée au notaire sous forme d'un certificat de blocage.
Les Associés décident d'enregistrer que les parts sociales dans la Société seront, suivant la présente augmentation de
capital, désormais détenues comme suit:
ASSOCIES
NOMBRE
DE PARTS
SOCIALES
ASTORG PARTNERS SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
MRN INVEST Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381.369
JL INVEST Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381.369
ALEPH Invest Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368.870
François de Mitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163.443
Christian Couturier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.000
MAMCO SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.722
Thibault Surer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.480
Jean Hubert Vial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.870
Judith Charpentier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.247
Sophie Pochard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.398
Nicolas Marien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.548
Thomas Carbonel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.548
Benjamin Dierickx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.699
Benjamin Cordonnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.796
Charles-Hubert Le Baron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.699
Marion Estève Guillemain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.850
Jean Casamayou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.592
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.540.000
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, les associés actuels décident de modifier l'article 5 des Statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à un million cinq cent quarante mille euros (EUR 1.540.000,-), représenté par un million
cinq cent quarante mille (1.540.000) parts sociales, ayant une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés, statuant comme en matière de
modification des statuts.»
92510
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en
rapport avec la présente augmentation de capital est d'environ mille sept cents euros (EUR 1.700,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu à la personne comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: B. Moens-Colleaux et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 avril 2015. Relation: 2LAC/2015/9309. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
Référence de publication: 2015072013/208.
(150081752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
SWYP Lux S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 197.215.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am achten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxembourg,
IST ERSCHIENEN:
Die SWYP GmbH, eine Kapitalgesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 50823 Köln, Innere Kanalstr.
15, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 79700,
hier vertreten durch Herrn Bodo Demisch, Bankkaufmann, geboren am 2. Oktober 1944 in Hahnenklee/Harz (Bundes-
republik Deutschland), geschäftlich ansässig in L-1651 Luxembourg, 9, Avenue Guillaume, aufgrund einer Vollmacht
unter Privatschrift ausgestellt in Deutschland am 30. April 2015.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und dem amtie-
renden Notar, der vorliegenden Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleiben wird.
Diese Erschienene, vertreten wie angegeben, erklärt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche
der folgenden Satzung unterliegt.
Art. 1. Es wird hiermit zwischen der Erschienenen und jeder Person oder juristischen Person, die in der Zukunft Ge-
sellschafter werden könnte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche die Firmenbezeichnung "SWYP
Lux S.à r.l." annimmt.
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Administration, Vergabe und Überlassung von Nutzungsrechten, Marken-
rechten, Lizenzrechten, Domains und weiterem geistigem Eigentum, sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann jederzeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des ein-
zigen Gesellschafters oder der Gesellschafter verlegt werden. Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg sowie
im Ausland gründen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert fün-
fundzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit von dem einzigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern gemäß
Artikel 13 dieser Satzung abgeändert werden.
Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen
Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.
Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen.
Bruchteilseigentümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaftsanteile, die von dem einzigen Gesellschafter gehalten werden, können frei veräußert werden.
92511
L
U X E M B O U R G
Im Fall von mehreren Gesellschaftern können die Gesellschaftsanteile jedes Gesellschafters gemäß Artikel 189 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das Gesetz vom 10. August 1915) veräußert werden.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Konkurs
oder die Zahlungsunfähigkeit des einzigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Die Geschäftsführer brauchen nicht
Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, ernannt, widerrufen, und ersetzt.
Die Geschäftsführer sind befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung
ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Die folgenden Geschäfte der Gesellschaft bedürfen einer vorherigen Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung:
1. Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und Rechten an solchen, sowie Veräußerung oder Belastung
von Teilen des Geschäftsvermögens, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen;
2. Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen;
3. Aufnahme von Krediten jeder Art sowie Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Haftungen, welche
den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb überschreiten;
4. Zusage und Gewährung von Darlehen und Bürgschaften jeder Art;
5. Abschluss von Miet- oder sonstigen Dauerschuldverhältnissen mit einer Vertragsdauer von mehr als einem Jahr oder
mit einer Belastung von mehr als EUR 5.000,00 (fünftausend Euro);
6. Abschluss anderer Verträge, durch die der Gesellschaft Aufwendungen oder Verpflichtungen von über (im Einzelfall
oder insgesamt) EUR 5.000,00 entstehen, mit Ausnahme von Veräußerungsgeschäften im Rahmen des gewöhnlichen
Geschäftsbetriebs und solchen Einzelinvestitionen, die im genehmigten Jahresbudget aufgeführt sind;
7. Zusage von Betriebsrenten, Altersversorgungen o. ä.;
8. Verfügungen über Urheber- und Schutzrechte/Patente der Gesellschaft und geistiges Eigentum der Gesellschaft sowie
die Vergabe von Lizenzen;
9. Abschluss oder Änderung von Anstellungsverträgen jeder Art;
10. Einleitung von Rechtsstreitigkeiten jeder Art.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift eines Geschäftsführers verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung werden die Befugnisse und das Gehalt (wenn es ein Gehalt gibt) der Agenten, die Dauer
ihres Auftrages und jede relevante Bedingung ihres Mandats bestimmen.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertre-
tenen Geschäftsführer gefasst.
Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per Brief, Telefax, oder Telegramm zu seiner
Vertretung bevollmächtigen. Die Geschäftsführer können auch per Telefon abstimmen, müssen dies jedoch schriftlich
bestätigen.
Art. 12. Die Geschäftsführer gehen keine persönlichen Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten, die sie
im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind, ein.
Art. 13. Der einzige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Falls
es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder Gesellschafter das Recht, an den gemeinsamen Beschlüssen teilzunehmen, unab-
hängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Beschlüsse sind
rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen werden.
Ungeachtet Artikel 11 dieser Satzung kann der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, während
der ersten Gesellschafterversammlung, die direkt nach Gründung der Gesellschaft abgehalten wird, eine dritte Person dazu
bevollmächtigen, Gesellschaftsanteile in einer oder mehreren existierenden Gesellschaften zu erwerben.
Beschlüsse im Rahmen von Satzungsabänderungen bedürfen der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Ge-
sellschaftskapitals besitzen, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.
Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr ist
ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember 2015.
Art. 15. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31.Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und der
oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und Passiva
der Gesellschaft auf.
Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht jedes
Gesellschafters zur Verfügung.
Art. 16. Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Re-
ingewinn der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds
zurückzustellen, bis dieser Reservefonds zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der ver-
92512
L
U X E M B O U R G
bleibende Reingewinn kann an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet werden. Der oder
die Geschäftsführer können Zwischendividenden ausschütten.
Art. 17. Die Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liquidatoren
können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, die ihre
Rechte und ihr Gehalt festlegt.
Art. 18. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, verwiesen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle 125 Gesellschaftsanteile werden von SWYP GmbH, vorbenannt, gezeichnet und ganz in bar eingezahlt, so dass
der Betrag von EUR 12.500 der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar, der dies ausdrücklich
feststellt, der Nachweis erbracht wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer
Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise EUR 1.200,00.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1) Als jeweils alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
a) Herr Bodo Demisch, mit beruflicher Adresse in 9, Avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.
b) Herr Andreas Ahlf, Odenthaler Str. 164, 51069 Köln.
c) Frau Sabine Schlößer, Sülzer Burg 18, 51503 Rösrath.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 9, Avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.
Aufgenommen in Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, dem Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Signé: B. Demisch et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 mai 2015. Relation: 2LAC/2015/10739. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 1
er
juin 2015.
Référence de publication: 2015081907/127.
(150093144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Orco Property Group, Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 44.996.
Lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenu ce 28 mai 2015, la Société a pris note de la décision de terminer le
mandat de H.R.T. Révision S.A. en tant que Réviseur d'entreprises agréé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015082628/11.
(150094446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
NBIM Otto SZ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 181.814.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
92513
L
U X E M B O U R G
Per Arne Eriksen / Rupert Robinson
<i>Manageri> / <i>Manageri>
Référence de publication: 2015082586/11.
(150094996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
NBIM Otto W1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 171.609.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Per Arne Eriksen / Rupert Robinson
<i>Manager / Manageri>
Référence de publication: 2015082587/11.
(150095005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Meltemi Entreprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 184.630.
L'an deux mille quinze.
Le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
La société à responsabilité limitée de droit allemand FERROSTAAL INDUSTRIAL PROJECTS GmbH, ayant son
siège social à D-45128 Essen, Hohenzollernstraße 24, inscrite au "Handelsregister B des Amtsgerichts Essen" sous le
numéro HRB 840.
Laquelle comparante est ici représentée par Madame Sara CRAVEIRO, salariée, demeurant professionnellement à
L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 22 mai 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée
au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée Meltemi Entreprises S.à r.l., avec siège social à L-1143
Luxembourg, 24, rue Astrid, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 184.630
(NIN 2014 2405 335).
Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 février 2014, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 493 du 24 février 2014 et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 mars 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1290 du 20 mai 2014.
Que le capital social de la société s'élève à VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 25.000.-), représenté par DEUX
CENTS (200) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.
Ensuite la comparante, représentée comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide de modifier les statuts de la société pour leur donner la teneur suivante, en version originale
en langue anglaise, accompagnée d'une traduction en langue française suivante:
Introduction
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated August 10, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"),
which specify in the articles 7, 10, 11 and 15 the exceptional rules applying to one member company.
Company Object
Art. 2. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any
form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and manage-
ment of such interests, in particular in directly or indirectly controlled undertakings developing projects in the renewable
energy sector.
92514
L
U X E M B O U R G
The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans,
money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of sureties,
in any kind or form) to the Company's directly or indirectly controlled undertakings.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other
activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplish-
ment and development of the foregoing.
Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any license.
Company Name, Registered Office
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name "Meltemi Enterprises S.à r.l.",
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the managers, by
a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Capital, Shares, Shareholders
Art. 6. The Company's corporate capital is set at twenty five thousand euros (EUR 25,000.-) represented by two hundred
(200) shares of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-) each; all fully paid-up and subscribed.
The Company may redeem its own shares.
However, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available for the
redemption price. However, the decision regarding the redemption shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction
of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single
shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 15 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, only one owner being admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Board Of Managers: Composition, Powers, Functioning
Art. 12. The Company is managed by a board of managers. The managers need not to be shareholders. The managers
may be revoked ad nutum.
All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of managers.
The board of managers (gérants) of the Company shall be divided into three (3) classes: the Class A Managers the Class
B Managers and the Class C Managers. The board of managers shall comprise
- the Class A Managers, who shall be designated for election by Ferrostaal Industrial Projects GmbH;
- the Class B Managers who shall be designated for election by Relight Enterprises S.A. and Cambria Equity Partners
L.P.; and
- the Class C Managers.
For as long as the Company is an Affiliate of Ferrostaal Industrial Projects GmbH, the C Managers shall be designated
for appointment by Ferrostaal Industrial Projects GmbH to the board of mangers of the Company and who (i) must be
residents of the Grand Duchy of Luxembourg, (ii) shall be appointed for terms of one year, also in accordance to the voting
list mechanism set forth in the Articles of the Company, (iii) shall be independent to Ferrostaal Industrial Projects GmbH,
Relight Enterprises S.A. and Cambria Equity Partners L.P. and (iv) shall have the required standards of integrity and
technical competence to act as a professional company manager. Non-residents, employed or self-employed in the Grand
92515
L
U X E M B O U R G
Duchy of Luxembourg, whose aggregate income is taxable in the Grand Duchy for at least fifty percent (50%), shall for
this purpose be considered Luxembourg residents.
If one member of the board of managers resigns or otherwise ceases to hold office for any other reason, the new manager
shall be designated by the relevant entity which designated the outgoing manager. Any of the managers appointed shall
have the required standards of integrity and technical competence to serve in a professional manner the interests of the
Company and the projects the Company develops via its affiliates.
A manager may grant to any another manager, a power of attorney in order to be represented at any board meeting.
Board meetings are validly held if a majority of its members is present or validly represented.
Board meetings are convened by the chairman of the board of managers. Meetings are convened by twenty-four (24)
hours notice which sets out the place, time and agenda of the meetings. Board minutes are signed by the chairman of the
meeting.
The board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The board of
managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation
and any other relevant conditions of his agency.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. In
case of a draw of votes, the chairman of the board shall have a casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meetings.
Any manager can participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear another. The participation in a
meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be managed by the sole shareholder or, in case
the company has more than one shareholder, by the shareholders acting under their joint signatures. The board of managers
may from time to time establish such advisory committees as the board deems in its full discretion appropriate to establish.
The board shall determine the purposes and duties, the governance of such committees and shall appoint and revoke in its
full discretion the members of such committees who shall not need to be shareholders or members of the board of managers
of the Company.
Art. 13. Towards third parties, the Company is validly bound in all circumstances by the joint signature of any two (2)
managers of which one must be an A Manager.
Art. 14. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company.
Shareholders Meetings
Art. 15. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Financial Statements / Distributions / Liquidation
Art. 16. The Company's year starts on 1
st
January and ends on 31
st
December of each year.
Art. 17. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the
board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. The
annual accounts shall after approval by the shareholders be filed and published in accordance with applicable law.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under legal dispositions.
Art. 19. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
92516
L
U X E M B O U R G
Compliance
Art. 20. Luxembourg has signed the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Interna-
tional Business Transactions as well as Criminal Laws combating bribery of Non-Officials. The Company therefore
undertakes that in performing any of its responsibilities neither it nor its affiliates or respective officers, managers, em-
ployees or agents acting on its behalf will commit any criminal offence and/or infringement of mandatory legal
requirements; it shall undertake all necessary measures to prevent any such offence and/or infringement. In particular the
Company will not commit any corruption, breach of confidentiality, falsification of documents or data, offering, promising
or conferring benefits to any civil servant, official or other person bound to carry out public service duties and/or any
employees of a contractual partner, any violation of an applicable competition law, including collusive agreements on
prices or price elements, prohibited price recommendations or collusive agreements regarding the submission or non-
submission of bids and any profit sharing and payments to other bidders to the extent such acts and/or omissions are qualified
as criminal offence or infringements of mandatory legal requirements under the respective laws which are applicable to
such acts and/or omissions.
General
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
Follows the french translation; in case of divergencies, the english language version shall prevail over the French
language version:
Introduction
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que
par les statuts (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 15, les règles exceptionnelles s'ap-
pliquant à une société unipersonnelle.
Objets Social
Art. 2. L'objet de la Société est l'acquisition directe et indirecte et la détention de participations, sous quelque forme que
ce soit, au Luxembourg et/ou dans des entreprises étrangères, ainsi que l'administration, le développement et la gestion de
ces participations, notamment, la détention dans des entreprises directement ou indirectement contrôlées développant des
projets dans le secteur des énergies renouvelables. La Société peut également fournir une assistance sous quelque forme
que ce soit (y compris mais non limité à l'octroi d'avances, de prêts, dépôts d'argent et de crédits ainsi que la concession
de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés sous toute forme ou manière), aux entreprises
contrôlées directement ou indirectement par la Société.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et participer à
d'autres activités que la Société juge nécessaire, recommandée, convenante, accessoire à ou pas incompatible avec l'ac-
complissement et le développement de ce qui précède.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne peut conclure aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute
activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui exigerait de la Société de disposer une autorisation.
Dénomination, Siège Social
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «Meltemi Entreprises S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant suivant les règles prévues par les Statuts en cas de modifications des Statuts.
L'adresse du siège social pourra être transféré endéans la municipalité du siège par simple décision du conseil de gérance.
La Société pourra avoir des bureaux et des succursales, à la fois au Luxembourg et à l'étranger.
Capital, Parts Sociales, Associés
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à vingt cinq mille euros (€ 25.000,-), représenté par deux cent (200) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune; toutes entièrement libérées et souscrites.
La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles pour le prix
de rachat. La décision partant sur le rachat des parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent (100 %) du capital social, en une assemblée générale extraordinaire et entraînera une réduction du capital social
par annulation de toutes les parts sociales rachetées.
92517
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de
l'associé unique ou par décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 15 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre de parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, un seul propriétaire étant admis par part sociale.
Des copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans le cas d'un seul associé, les parts sociales de la Société détenues par l'associé unique sont librement
cessibles.
Dans le cas de pluralité d'associés, les parts sociales détenues par chaque associé peuvent être transférées en application
des dispositions de l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité ou de faillite
de l'associé unique ou de l'un des associés.
Conseil de gérance: composition, pouvoirs, fonctionnement
Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance. Les gérants ne doivent pas être associés. Les gérants peuvent
être révoqués ad nutum.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés sont
de la compétence du conseil de gérance.
Le conseil de gérance de la Société est divisé en trois (3) catégories:
- les Gérants de Catégorie A, les Gérants de Catégorie B et les Gérants de Catégorie C. Le conseil de gérance doit
comprendre:
- les Gérants de Catégorie A, qui seront désignés pour nomination par Ferrostaal Industrial Projects GmbH;
- les Gérants de Catégorie B, qui seront désignés pour nomination par Relight Enterprises SA et Cambria Equity Partners
L.P.; et
- les Gérants de Catégorie C.
Aussi longtemps que la Société est une filiale de Ferrostaal Industrial Projects GmbH, les Gérants de Catégorie C sont
désignés pour nomination par Ferrostaal Industrial Projets GmbH au conseil de gérance de la Société et ils (i) doivent être
des résidants du Grand-Duché de Luxembourg, (ii) sont nommés pour un mandat d'un an, conformément au mécanisme
de nomination prévu dans les Statuts de la Société, (iii) doivent être indépendants de Ferrostaal Industrial Projects GmbH,
Relight Enterprises S.A. et Cambria Equity Partners L.P. et (iv) doivent disposer des qualités requises d'intégrité et de
compétence technique pour agir comme un gérant professionnel. Les non-résidents, employés ou travailleurs indépendants
dans le Grand-Duché de Luxembourg, dont le revenu total est imposable dans le Grand-Duché pour au moins cinquante
pour cent (50%), sont à cet effet considérés comme des résidants du Luxembourg.
Si un membre du conseil de gérance démissionne ou cesse d'exercer ses fonctions pour toute autre raison, le nouvel
gérant doit être désigné par l'entité en question qui a désigné gérant sortant. Tous les gérants nommés auront les normes
requises d'intégrité et de compétence technique pour servir de manière professionnelle les intérêts de la Société et les projets
que la Société développe par l'intermédiaire de ses filiales.
Un gérant peut donner à un autre gérant, une procuration pour se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance.
Les réunions du conseil sont valablement tenues si une majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.
Les réunions du conseil sont convoquées par le président du conseil de gérance. Les réunions sont convoquées par avis
e convocation de vingt-quatre (24) heures qui énonce le lieu, l'heure et l'ordre du jour des réunions. Les procès-verbaux du
conseil de gérance sont signés par le président du conseil.
Le conseil de gérance peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le conseil de gérance arrêtera les responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de cet agent, la durée de la période
de représentation et toutes autres conditions pertinentes de ce mandat.
Les résolutions du conseil de gérance doivent être adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés. En cas
d'égalité des voix, le président du conseil de gérance aura une voix prépondérante.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions adoptées lors
des réunions des gérants.
Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par
d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre. La
participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion.
Au cas où les gérants sont temporairement incapables d'agir, les affaires de la Société peuvent être gérés par l'associé-
unique ou, au cas où la Société a plus d'un associé, par les associés agissant sous leurs signatures conjointes. Le conseil de
gérance peut de temps en temps créer des comités consultatifs jugées utile par décision discrétionnaire du conseil. Le conseil
de gérance arrête les raisons et les fonctions, la gouvernance de ces comités et nomme et révoque, à son entière discrétion,
les membres de ces comités qui n'auront pas besoin d'être associés ou membres du conseil de gérance de la Société.
92518
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Envers des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux
(2) gérants, dont l'un doit être un gérant de catégorie A.
Art. 14. Les gérants contractent, en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Assemblées des associés
Art. 15. L'associé-unique exerce tous les pouvoirs conférés à lui par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu'il détient.
Chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées par la majorité des associés
représentant au moins trois-quarts du capital social de la Société, sous réserve des dispositions de la Loi.
Etats - Financiers / Distributions / Liquidation
Art. 16. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, en référence à la fin de l'année de la Société, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil
de gérance établit un inventaire comprenant une indication à la valeur des actifs et passifs de la Société. Les comptes annuels
sont, après approbation par les associés, déposés et publiés conformément à la loi applicable.
Chaque associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.
Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissement
et charges constituent le bénéfice net. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à
la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'(aux) associé(s) proportionnellement à son (leur) participation dans le
capital de la Société.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, sous réserve des dispositions légales.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Conformité
Art. 20. Le Luxembourg a signé la Convention de l'OECD sur la Lutte contre la Corruption de Fonctionnaires Etrangers
dans les Transactions Commerciales Internationales et les Lois Criminelles visant à lutter contre la Corruption des Non-
Fonctionnaires. La Société s'engage donc que, dans l'exercice de ses responsabilités, ni elle, ni une de ses sociétés affiliées
ou un de ses dirigeants respectifs, administrateurs, employés ou agents agissant en leur nom, commettant une infraction
criminelle et/ou une violation des prescriptions légales obligatoires applicables; elle prendra toutes les mesures nécessaires
pour prévenir de telles violations et/ou infractions. En particulier, la Société ne commettra aucune corruption, violation de
confidentialité, falsification de documents ou de données, n'offrira, ne promettra ou ne confèrera pas d'avantages à quelque
fonctionnaire, officiel ou autre personne liée à exercer des fonctions de service public et/ou des employés d'un partenaire
contractuel, ni ne commettra quelque violation d'un droit de la concurrence applicable, y compris les accords collusoires
sur les prix ou les éléments de prix, des recommandations de prix prohibées ou des accords collusoires concernant la
présentation ou le non-dépôt des offres et de l'intérêt et de paiements à d'autres soumissionnaires dans la mesure où ces
actes et/ou omissions sont qualifiés de délit criminel ou infractions sociales aux obligations légales obligatoires en vertu
des lois respectives qui sont applicables à de tels actes et/ou omissions.
Général
Art. 21. Référence est faite aux dispositions de la Loi pour toutes les questions pour lesquelles aucune disposition
spécifique n'est faite dans les présents Statuts.»
En cas de divergence entre les versions anglaise et française des Statuts, la version anglaise fera foi.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique confirme, pour autant que de besoin, à la suite de l'adoption des modification statutaires selon la
première résolution, les résolutions adoptées en assemblée générale de la Société le 4 mai 2015, une copie du procès-verbal
de ladite assemblée après avoir été paraphée «ne varietur» par la comparante telle que représentée, étant annexée au présent
acte, les nominations et qualités des gérants et la durée des mandats des six (6) gérants de la Société comme suit:
a) Ont été nommés gérants de Catégorie A, leur mandat expirant le 4 mai 2016:
- Monsieur le Dr Daniel FUCHS, managing director, né à Wiesbaden (Allemagne), le 17 juillet 1959, demeurant pro-
fessionnellement à D-45128 Essen, Hohenzollernstraße 24, président du conseil de gérance.
92519
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Holger BOY, head of project development and sales wind, né à Essen (Allemagne), le 9 février 1968,
demeurant professionnellement à D-45128 Essen, Hohenzollernstraße 24.
- Monsieur Ralf NIETIET, managing director, né à Ibbenbüren (Allemagne), le 20 août 1966, demeurant profession-
nellement à D-45128 Essen, Hohenzollernstraße 24.
b) Ont été nommés gérants de Catégorie B, leur mandat expirant le 4 mai 2016:
- Monsieur Hakan BAYKAM, administrateur de société, né à Istanbul (Turquie), le 14 février 1972, demeurant à I-21000
Milan, via Procaccini, 43.
- Monsieur Mario MAURI, administrateur de société, né à Lugano (Suisse), le 20 octobre 1950, demeurant à I-6932
Breganzona, Via ai Ronchi, 1.
c) A été nommé gérant de Catégorie C, son mandat expirant le 4 mai 2016:
- Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de société, né à Chateauroux (France), le 14 août 1980, demeurant
professionnellement à L-1143 Luxembourg, 24 rue Astrid.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du
notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 1
er
juin 2015. Relation: GAC/2015/4539. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 03 juin 2015.
Référence de publication: 2015082520/331.
(150094299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Access Capital Fund SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 160.413.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Access Capital Fund SICAV-SIF
i>CACEIS Bank Luxembourg
Référence de publication: 2015082930/12.
(150095612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Advent PPF (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 160.940.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 juin 2015.
Référence de publication: 2015082938/10.
(150096083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Tarpon Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 173.638.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
92520
L
U X E M B O U R G
TARPON HOLDINGS S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015082813/11.
(150094965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
AmerisourceBergen Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.530.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 186.772.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 27 mai 2015 que Madame Peyton R. Howell
a démissionné son poste de gérant de type A de la Société avec effet au 21 mai 2015.
Il est décidé de nommer en remplacement de Madame Peyton R. Howell, Monsieur Tim Gerard Guttman, né le 25 mars
1959 à Berea, Ohio, Etats-Unis d'Amérique et résidant au 852 Nathan Hale Road, Berwyn, PA 19312, Etats-Unis d'Amé-
rique comme gérant de type A de la Société avec effet au 27 mai 2015 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- John G. Chou comme gérant de type A de la Société;
- Tim Gerard Guttman comme gérant de type A de la Société;
- Marjorie Allo comme gérante de type B de la Société; et
- Emmanuel Natale comme gérant de type B de la Société.
Le 4 juin 2015.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015082953/21.
(150095835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Amethis Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 173.953.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Amethis Partners SA
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2015082954/11.
(150095465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Athena Equity Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.265.
Par résolutions signées en date du 19 mai 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Geneviève Koschnicke, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
au mandat de gérant de classe B, avec effet au 28 avril 2015 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 28 avril 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2015.
Référence de publication: 2015082971/15.
(150095356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
92521
L
U X E M B O U R G
Alander S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 17.049.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2015082985/10.
(150095568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
ResponsAbility BOP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.075.
EXTRAIT
Il convient de prendre note que ResponsAbility BOP a désormais son siège social à 23, Avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2015.
Référence de publication: 2015082923/12.
(150095788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
A 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9907 Troisvierges, 13, rue d'Asselborn.
R.C.S. Luxembourg B 96.342.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015082927/10.
(150095708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Weiland HTS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9839 Rodershausen, 3, Dosberbreck.
R.C.S. Luxembourg B 197.251.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünfzehn am achtundzwanzigsten Mai
Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle SCHWACHTGEN mit Amtssitz in Wiltz.
Sind erschienen:
- Frau Luzia WEILAND (geborene MULLER), Hauswirtschaftlerin, geboren am 6ten Februar 1960 in Eschfeld (D),
wohnhaft in D-54687 Arzfeld, 14, Im Quobach
Die Komparentin, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Es wird hiermit durch die Komparentin und allen Personen, die später einmal Gesellschafter werden könnten,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden Gesetzesbestimmungen und im beson-
derem dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, und der vorliegenden Satzung
unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Hoch-, Tiefund Stahlbetonbauunternehmens, Spezialtiefbau, Be-
tonfertigteilwerke und die Herstellung sowie der Vertrieb von Transportbeton und Baustoffen. Ferner ist Gegenstand des
Unternehmens der Handel mit Waren aller Art, soweit es dem Unternehmen dienlich ist.
Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen
Unternehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.
Desweiteren ist Zweck der Gesellschaft die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen
Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch Ver-
92522
L
U X E M B O U R G
kauf, Tausch oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten
von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann an der Gründung und Entwicklung aller industrieller oder kommerzieller Unternehmen teilneh-
men und ihnen Unterstützung durch Darlehen, Garantien oder auf andere Art und Weise zukommen lassen.
Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen, sowie Obligationen ausgeben.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,
handels-oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbeweglichen Güter der betreffenden Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung
durch Immobilien.
Sie kann ihren Zweck direkt oder Indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Ver-
bindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der
Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.
Allgemein kann sie jegliche Überwachungs-und Kontrollmaßnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur
Entwicklung ihres Zieles und Zwecks für nötig hällt.
Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, die
mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes
beitragen könnten.
Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "Weiland HTS S.à r. l."
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Parc Hosingen.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf fünfundzwanzig Tausend Euro (25.000.-€) festgesetzt, eingeteilt in 100 (hundert)
Anteile mit einem Nominalwert von zweihundert Fünfzig Euro (250.-€).
Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind
die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung von Gesellschaftern,
welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, übertragen werden. Diese Bestimmung gilt auch
im Sterbefall für die Übertragung an Pflichterben und überlebende Ehegatten.
Art. 8. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die
Gesellschaft auf.
Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum
oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein
müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.
Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandate werden bei ihrer Ernennung
durch die Generalversammlung festlegt.
Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder
mehrere Bevollmächtigte weiterleiten.
Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben
wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einer Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens die Hälfte des
Gesellschaftskapitals vertreten.
Beschlüsse über die Änderung der Satzung sind nur rechtsgültig, soweit sie von einer Mehrheit der Gesellschafter gefasst
werden, die mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 14. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen
innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinnund Verlustrechnung.
Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung nehmen.
92523
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn
dar.
Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals
erreicht hat.
Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.
Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.
<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitalsi>
Das Gesellschaftskapital wird wie folgt gezeichnet:
1) Frau Luzia MÜLLER, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: zwei hundert Fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Diese Anteile wurden jeweils in bar zu ihrem Nennwert eingezahlt, so dass der Gesellschaft die Summe von fünfundz-
wanzig Tausend Euro (25.000.-Euro) zur freien Verfügung steht, so wie es dem verhandelnden Notar durch eine
Bankbescheinigung nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf neunhundert-
fünfzig Euro (980-EUR) geschätzt.
<i>Anmerkungi>
Der amtierende Notar hat die Komparentin darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft
vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Niederlassungsbewilligung in Bezug auf den Gesell-
schaftszweck sein muss, was die Komparentin ausdrücklich anerkannt hat.
<i>Generalversammlungi>
Sodann fassen die Gesellschafter, welche das gesamte Stammkapital vereinigen, folgende Beschlüsse:
1. Die Anzahl der Geschäftsführer liegt bei 2.
2. Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer werden ernannt:
- Herr Bernd DUNKEL, geboren in Bitburg (D) am28sten Februar 1984, wohnhaft in D-54673 Zweifelscheid, 5, En-
gelsdorf, als technischer Geschäftsführer.
- Herr Wolfgang WEILAND, geboren in Neuerburg (D) am 28sten August 1956, wohnhaft in D-54687 Arzfeld, 14, Im
Quobach, als administrativer Geschäftsführer.
3. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch Unterschrift beider Geschäftsführer.
4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in: L-9839 Rodershausen, 3, Dosberbreck
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Wiltz.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: Weiland W., Dunkel B., Weiland L., Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Diekirch, le 2 juin 2015. Relation: DAC/2015/8989. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.
Wiltz, le 3 juin 2015.
Référence de publication: 2015082863/120.
(150094513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
WishFish Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 180.774.
Les statuts coordonnés au 26/05/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
92524
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 03/06/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015082865/12.
(150094921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Astromancia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 189.726.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2015.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2015083004/11.
(150095847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Auto-Ecole Dani Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9050 Ettelbruck, 9, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 179.957.
Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la gérance
i>Signature
Référence de publication: 2015083006/11.
(150096089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Burnfort Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 172.556.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of May.
Before us Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- Barletta Business S.A., an International Business Company, incorporated under the laws the Republic of Seychelles
(Business Company Act 24 of 1994) on the 9
th
day of November 2004, registered with the Seychelles International Business
Authority (Registrar of International Business Company) under the Official Number 017269, and having its registered
office at c/o Fibco (Offshore) Services Limited, PO Box 308 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles (the “appearing
party”), represented by its Managing Director Mr Victor ANTIPOV, professionally residing at c/o Fibco (Offshore) Services
Limited, PO Box 308 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles,
here represented by Mr Julien DEMELIER-MOERENHOUT, employee, residing professionally in Hesperange,
by virtue of a power of attorney under private seal issued on 27
th
April 2015 and power of substitution dated 30
th
April
2015 (the “proxyholder”),
said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder and the officiating notary, will remain annexed to the present deed
to be filled with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated above, has requested the officiating notary to enact the following:
1.- The appearing party is the sole owner of “Burnfort Investments S.à.r.l.” (the «Company»), a société à responsabilité
limitée having its registered office at L-2311 Luxembourg, 55, Avenue Pasteur, incorporated pursuant to a deed of Maître
Paul DECKER, notary then residing in Luxembourg dated October 19
th
, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2938 of December 4
th
, 2012,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 172.556.
2.- The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) divided into
twelve thousand and five hundred (12,500) corporate units with a nominal value of one Euro (EUR 1.00-) each, fully paid
up.
92525
L
U X E M B O U R G
3.- The appearing party, as stated above, declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and of the
financial standing of the Company. Being the sole shareholder of the Company, it expressly declares to proceed to the
anticipated dissolution of the Company with immediate effect as well as to its liquidation.
4.- The appearing party, as stated above, appoints itself as liquidator of the Company.
Being the sole shareholder and liquidator of the Company, the appearing person declares that all assets of the Company
have been realized, and all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted
for. Regarding any eventual liability presently unknown to the Company and not paid until the date of dissolution, the sole
shareholder, irrevocably assumes the obligation to guarantee payment of any such liability, with the result that the liqui-
dation of the Company is to be considered closed.
5. The appearing party, as stated above, gives discharge to the Manager of the Company for his mandate up to this date.
6. The corporate books and documents of the Company will be kept for a period of five years at L-2311 Luxembourg,
55, Avenue Pasteur.
The appearing party has been informed about article 69 (2) of the law on commercial companies, that no confusion of
assets and liabilities between the dissolved Company and the share capital of the sole shareholder, or reimbursement to the
sole shareholder will be possible before the end of a period of thirty (30) days from the day of publication of the present
deed and subject to the fact that no creditor of the dissolved and liquidated Company requests the granting of any security
interest.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated
at EUR 1,160.-.
Whereof, the present deed is drawn up in Hesperange on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said person signed together with us, the
Notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahr zweitausendfünfzehn, den vierten Mai.
Vor Maître Martine DECKER, Notar mit Amtssitz in Hesperange, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
- Barletta Business S.A., eine International Business Company, gegründet nach dem Recht der Republik Seychellen
(Business Company Act 24 of 1994) am 9. November 2004, eingetragen beim Registrar of International Business Company
unter der Offiziellen Nummer 017269, und mit eingetragenem Gesellschaftssitz in c/o Fibco (Offshore) Services Limited,
PO Box 308 Premier Buildng, Victoria, Mahe, Seychelles, (die „Komparentin“), vertreten durch den Geschäftsführenden
Direktor Viktor Antipov
hier vertreten durch Herrn Julien DEMELIER-MOERENHOUT, Angestellter, beruflich wohnhaft in Hesperange,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 27. April 2015 und Vertretungsbefugnis datiert vom 30. April
2015 (der „Bevollmächtigte“),
welche Vollmacht, „ne varietur“ durch die Bevollmächtigte und den amtierenden Notar unterzeichnet, der gegenwär-
tigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
1. Die Komparentin ist die alleinige Eigentümerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft Burnfort Investments S.à.r.l. (die
„Gesellschaft“), mit Gesellschaftssitz in L-2311 Luxemburg, 55, Avenue Pasteur ist, gegründet gemäß Urkunde aufge-
nommen durch Notar Paul DECKER, mit dem damaligen Amtssitz zu Luxemburg, am 19. Oktober 2012, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2938 vom 4. Dezember 2012,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, unter Nummer B 172.556.
2. Das unterzeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,-EUR), aufgeteilt in zwölf-
tausend fünfhundert (12.500) Anteile von je einem Euro (1,- EUR), vollends eingezahlt.
3. Die Komparentin, handelnd wie erwähnt, erklärt, in voller Kenntnis der Satzung und der finanziellen Lage der Ge-
sellschaft zu sein. Als alleinige Eigentümerin sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals beschließt sie gegenwärtig die
Auflösung und Liquidation der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.
4. Die Komparentin, handelnd wie erwähnt, ernennt sich zum Liquidatorin der Gesellschaft.
Alleinige Eigentümerin sämtlicher Gesellschaftsanteile und in ihrer Eigenschaft als Liquidatorin der Gesellschaft erklärt
die Komparentin dass sämtliche Aktiva realisiert wurden und dass sämtliche Passiva beglichen wurden und dass die Passiva
in Verbindung mit der Gesellschaftsauflösung eingezahlt sind; des Weiteren verpflichtet sie sich unwiderruflich, dass
92526
L
U X E M B O U R G
eventuelle Passiva der Gesellschaft, welche am heutigen Tage noch nicht bekannt und nicht beglichen sind, durch sie
beglichen wird, mit dem Resultat dass somit die Liquidation der Gesellschaft als beendet gilt.
5. Die Komparentin, handelnd wie erwähnt, erteilt dem Geschäftsführer vollumfängliche Entlastung für die Ausübung
seines Mandates bis zum heutigen Tage.
6. Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während der gesetzlich festgelegten Dauer von fünf Jahren in
L-2311 Luxembourg, 55, Avenue Pasteur aufbewahrt.
Die Komparentin wurde alsdann vom amtierenden Notar über Artikel 69 (2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
belehrt, dass keine Verschmelzung zwischen dem Vermögen der Gesellschaft und dem des Rechtsnachfolgers und die
Übernahme des Gesellschaftsvermögens durch den vormalig alleinigen Gesellschafter, vor Ablauf einer Frist von (30)
dreißig Tagen, ab dem Tag der Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde geschehen kann und sofern kein Gläubiger der
derzeit aufgelösten und liquidierten Gesellschaft die Gewährung von Sicherheiten verlangt hat.
<i>Kosten:i>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger
Urkunde entstehen, werden auf ungefähr 1.160,- Euro geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Hesperange, Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben angeführten
Partei die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer Übersetzung in Deutsch. Auf Anfrage der
selben Partei, und im Fall einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, gilt die englische Version.
Nachdem das Dokument dem Komparenten, welcher dem Notar mit seinem Familien- und Vornamen, Wohnsitz und
Familienstand bekannt ist, vorgelesen und erklärt wurde, hat dieser es zusammen mit dem amtierenden Notar unterzeichnet.
Signé: Demelier-Moerenhout, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/14549. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 04 juin 2015.
Référence de publication: 2015083024/111.
(150095668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Bajacghi (SPF) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 173.795.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2015.
Stéphanie Paché.
Référence de publication: 2015083025/10.
(150096059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Alpha Fund, S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 134.597.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 21 mai 2015i>
- Le siège social de la Société a été transféré au 412F route d'Esch, L-1471 Luxembourg avec effet au 15 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié conforme
Référence de publication: 2015082950/12.
(150095998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
92527
L
U X E M B O U R G
Maison é S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand rue.
R.C.S. Luxembourg B 194.667.
<i>Auszug der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Juni 2015i>
Bei einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 04.06.2015 wurde einstimmig beschlossen, dass der Sitz der
Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung nach:
30, Grand Rue, L-1660 Luxembourg
Verlegt wird.
Luxemburg, den 4. Juni 2015.
Référence de publication: 2015083439/13.
(150095228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
MezzVest Luxembourg I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 78.731.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of May.
Before Us, Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
MezzVest Investments I Limited, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Jersey, having
its registered office at Ogier House, the Esplanade, JE4 9WG St Hélier, Jersey and registered with the JFSC Companies
Registry under number 93490 (the Sole Shareholder),
duly represented by Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing in Schouweiler, by virtue of a power
of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented through its proxy-holder, has requested the notary to state that:
I. the Sole Shareholder holds all the shares in MezzVest Luxembourg I S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at
9, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, with an issued and
paid-up share capital of thirty-one Euro (EUR 31,000) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 78731, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Joseph
Elvinger, then notary residing in Luxembourg, dated 2 November 2000, published in the official gazette, Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 363, on 17 May 2001 (the Company);
II. the Company’s articles of association (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a notarial deed
of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated 10 June 2009, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1356 of 14 July 2009; and
III. the Sole Shareholder, duly represented as stated here above, having recognised to be duly informed of the resolutions
to be taken, has decided to vote on all the items on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Dissolution and liquidation of the Company;
2. Appointment of MV Manager Limited as sole liquidator of the Company for the liquidation period and determination
of the powers of the liquidator; and
3. Miscellaneous.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
It was resolved, in accordance with article 141 and subsequent of the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended, (the Law) to declare the voluntary dissolution of the Company and to put it into liquidation with effect as from
the date of the present deed (the Liquidation).
92528
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
It was resolved to appoint MV Manager Limited, a company incorporated in Jersey, with office at Ogier House, the
Esplanade, JE4 9WG St Hélier, Jersey and registered with the JFSC Companies Registry under number 93081 as sole
liquidator of the Company (the Liquidator) and to grant the Liquidator with all necessary powers to undertake the liquidation
procedure of the Company and notably with the powers as provided for by Articles 144 and 145 of the Law.
It was further resolved that the Liquidator will notably be empowered to:
- represent the Company during the liquidation proceedings, to dispose of all assets, to discharge the liabilities and to
distribute, partially or entirely, the net assets of the Company in kind or in cash to the shareholders of the Company at any
time during the liquidation proceedings;
- accomplish any act provided for in Article 145 of the Law without having the prior approval of the shareholders of the
Company and notably contribute the assets of the Company to other companies;
- withdraw, with or without payment, all intangible, privileged, secured or mortgaged rights, actions in termination,
transcription, seizure, oppositions or other impediments;
- without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all movable properties and rights, and
alienate the said property or properties if the case arises; and
- under his sole responsibility, delegate its powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities.
<i>Declarationi>
Whereof the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, who is known to the notary by surname,
first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
MezzVest Investments I Limited, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois de Jersey, ayant son
siège social au Ogier House, the Esplanade, JE4 9WG St Hélier, Jersey et immatriculée auprès du JFSC Companies Registry
sous le numéro 93490 (l'Associé Unique),
ici dûment représentée par Madame Sofia Afosno-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Schouweiler, en vertu
d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au
présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. l`Associé Unique détient toutes les parts sociales de MezzVest Luxembourg I S.à r.l., une société à responsabilité
limité de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall 2, L-5365
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, ayant un capital social de trente-et-un mille Euro (31.000 EUR), immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 78731, constituée suivant acte notarié de Maître Joseph Elvinger,
alors notaire de résidence à Luxembourg, du 2 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 363 du 17 mai 2001 (la Société);
II. les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte notarié de Maître Joseph
Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 10 juin 2009, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1356 du 14 juillet 2009; et
III. l'Associé Unique, dûment représenté comme indiqué ci-dessus, ayant reconnu avoir été dûment informé des réso-
lutions à prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution et liquidation de la Société;
2. Nomination de MV Manager Limited comme liquidateur unique de la Société pour la période de liquidation et
détermination des pouvoirs du liquidateur; et
3. Divers.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions
suivantes:
92529
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
Il a été décidé, conformément à l’article 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi), de déclarer la dissolution volontaire de la Société et de la mettre en liquidation (la Liquidation).
<i>Deuxième résolutioni>
Il a été décidé de nommer MV Manager Limited, une société constituée selon les lois de Jersey, ayant son siège sis au
Ogier House, the Esplanade, JE4 9WG St Hélier, Jersey et immatriculée auprès du JFSC Companies Registry sous le
numéro 93081, en tant que liquidateur unique de la Société (le Liquidateur).
Il a été décidé de conférer au Liquidateur tous les pouvoirs nécessaires à la Liquidation et notamment les pouvoirs prévus
par les articles 144 à 151 de la Loi.
Il a été décidé que le Liquidateur soit notamment habilité à:
- représenter la Société durant la procédure de Liquidation, à vendre tous les actifs, à s'acquitter des dettes de la Société,
et à distribuer (en tout ou partie) les actifs nets de la Société en nature ou en espèces aux associés de la Société à tout
moment au cours de la procédure de liquidation.
- accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans autorisation préalable des associés de la Société, y compris
apporter ou distribuer les actifs de la Société à d'autres sociétés.
- disposer, avec ou sans paiement, de tous les droits incorporels, privilèges, gages ou hypothèques, actions résolutoires,
transcriptions, saisies, oppositions ou tout autre privilège.
- sans que l'énumération suivante ne soit limitative, vendre, échanger ou aliéner tous biens mobiliers et/ou droits de la
Société, le cas échéant, et
- sous sa propre responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques et déterminées ou à u
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l’assemblée a été levée.
<i>Déclarationi>
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été établi
en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les
versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,
celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 mai 2015. Relation: EAC/2015/11934. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015083450/127.
(150095598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
LSREF3 Eve Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.448.125,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 188.002.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of May,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
LSREF3 Dutch Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits
Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 176,886,003.- and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the “RCS”)
under number B 191119 (the “Sole Shareholder”)
hereby represented by Mrs. Valérie Fagnant, employee, professionally residing in Bertrange, by virtue of a power of
attorney, given in Bertrange, on 26 May 2015.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary,
shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the Sole Shareholder of the private limited liability
company (société à responsabilité limitée) LSREF3 Eve Holdings S.à r.l., registered with the RCS under number B 188002,
with a share capital of EUR 2,418,125.-, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits
92530
L
U X E M B O U R G
Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and incorporated under the initial name of LSREF3 Lux In-
vestments VI S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 6 June 2014 published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) dated 4 July 2014 number 1729, which articles of incorporation have been
amended for the last time on 7 April 2015 by a deed of the Maître Henri Beck notary residing in Echternach, Grand Duchy
of Luxembourg, not yet published in the Mémorial (the “Company”).
The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:
1. The entire issued share capital represented by 19,345 (nineteen thousand three hundred forty-five) shares is held by
the Sole Shareholder.
2. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this
extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below
agenda.
3. The agenda of the meeting is as follows:
a) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 30,000.- (thirty thousand euro) in order to increase
the current capital from its current amount of EUR 2,418,125.-, (two million four hundred eighteen thousand one hundred
twenty-five euro) to an amount of EUR 2,448,125.- (two million four hundred forty-eight thousand one hundred twenty-
five euro) by the creation and issue of 240 (two hundred) new ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one
hundred twenty-five euro) each (the “New Shares”); subscription and payment of the New Shares by the Sole Shareholder
by a contribution in cash for a total amount of EUR 30,000.- (thirty thousand euro) which shall be entirely allocated to the
share capital of the Company.
b) As a consequence, amendment of the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association as follows
to reflect the share capital increase proposed above:
“ Art. 6. Subscribed capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 2,448,125.- (two million four
hundred forty-eight thousand one hundred twenty-five euro), represented by 19,585 (nineteen thousand five hundred eighty-
five) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each.”; and
c) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and
authority to any manager of the Company and/or any employee of the Lone Star Capital Investments S.à r.l., to proceed,
under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the
Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.
The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 30,000.- (thirty
thousand euro)
so as to raise it from its current amount of EUR 2,418,125.- (two million four hundred eighteen thousand one hundred
twenty-five euro) to an amount of EUR 2,448,125.- (two million four hundred forty-eight thousand one hundred twenty-
five euro)
by the creation and issue of 240 (two hundred forty) New Shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred
twenty-five euro) each, in consideration of a contribution in cash by the Sole Shareholder for a total amount of EUR 30,000.-
(thirty thousand euro).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for 240 (two hundred forty) New Shares with
a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) per share and to make payment in full for such New Shares
by a contribution in cash for a total amount of EUR 30,000.- (thirty thousand euro) which is entirely allocated to the share
capital of the Company for an amount of EUR 30,000.- (thirty thousand euro).
All the 240 (two hundred forty) New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in cash by the Sole
Shareholder so that the amount of EUR 30,000.-(thirty thousand euro) is at the free disposal of the Company as it has been
proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
As a consequence of the above-resolved share capital increase, the Sole Shareholder now holds 19,585 (nineteen thou-
sand five hundred eighty-five) ordinary shares of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the
Company's articles of association, which English version shall be henceforth reworded as follows:
“ Art. 6. Subscribed capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 2,448,125.- (two million four
hundred forty-eight thousand one hundred twenty-five euro), represented by 19,585 (nineteen thousand five hundred eighty-
five) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each.”
92531
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the change resolved above
and hereby empower and authorise any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments
S.à r.l., to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the
share register of the Company and (ii) to any formalities in connection therewith.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated
at one thousand three hundred euro (EUR 1300).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the proxyholder of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder appearing signed,
together with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-sept mai,
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
LSREF3 Dutch Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un
capital social de EUR 176.886.003,- et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (le
«RCS») sous le numéro B 191119,
ici représentée par Mme Valérie Fagnant, employée, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, le 26 mai 2015.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de la société à responsabilité
limitée LSREF3 Eve Holdings S.à r.l., immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 188002, avec un capital social de
EUR 2.418.125,-, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,
Grand Duché de Luxembourg, et constituée sous le nom initial de LSREF3 Lux Investments VI S.à r.l. selon un acte du
notaire instrumentaire en date du 6 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»)
du 4 juillet 2014, numéro 1729, lesquels statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 7 avril 2015 par un acte
de Maître Henri Beck, notaire résidant à Echternach, Grand Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial (la
«Société»).
La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
1. La totalité du capital social, représentée par 19.345 (dix-neuf mille trois cent quarante-cinq) parts sociales, est détenu
par l'Associé Unique.
2. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société
sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises
sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.
3. L'ordre du jour est le suivant:
a) Augmentation du capital social de la Société par un montant de EUR 30.000,- (trente mille euros) afin d'augmenter
le capital social de son montant actuel de EUR 2.418.125,- (deux millions quatre cent dix-huit mille cent vingt-cinq euros)
à un montant de EUR 2.448.125,- (deux millions quatre cent quarante-huit mille cent vingt-cinq euros) par voie de création
et d'émission de 240 (deux cent quarante) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,-
(cent vingt-cinq euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»); souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales
par l'Associé par un apport en numéraire pour un montant total de EUR 30.000,- (trente mille euros) qui sera entièrement
alloué au capital social de la Société;
b) En conséquence, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit afin de refléter
l'augmentation de capital proposée ci-dessus:
« Art. 6. Capital Social. Souscrit Le capital social est fixé à EUR 2.448.125,- (deux millions quatre cent quarante-huit
mille cent vingt-cinq euros) représenté par 19.585 (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq) parts sociales ordinaires
d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»;
c) Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l., afin
92532
L
U X E M B O U R G
d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre
de parts sociales de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte des résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 30.000,- (trente mille euros)
afin de le porter de son montant actuel de EUR 2.418.125,- (deux millions quatre cent dix-huit mille cent vingt-cinq) à
un montant de EUR 2.448.125,- (deux millions quatre cent quarante-huit mille cent vingt-cinq euros)
par la création et l'émission de 240 (deux cent quarante) Nouvelles Parts Sociales, ayant une valeur nominale de EUR
125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, en contrepartie d'un apport en numéraire de l'Associé Unique d'un montant total de
EUR 30.000,- (trente mille euros).
<i>Souscription - Paiementi>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire aux 240 (deux cent quarante) Nouvelles Parts
Sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (EUR 125,-) par part sociale et libérer intégralement ces Nouvelles
Parts Sociales souscrites par un apport en numéraire pour un montant total de EUR 30.000,- (trente mille euros) qui est
entièrement alloué au capital social de la Société.
L'ensemble des 240 (deux cent quarante) Nouvelles Parts Sociales émises sont donc intégralement souscrites et libérées
en numéraire par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 30.000,- (trente mille euros) est à la libre disposition
de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus, l'Associé détient maintenant 19.585 (dix-neuf mille cinq cent quatre-
vingt-cinq) parts sociales ordinaires de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la
Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Capital Social Souscrit. Le capital social est fixé à EUR 2.448.125,- (deux millions quatre cent quarante-huit
mille cent vingt-cinq euros) représenté par 19.585 (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq) parts sociales ordinaires
d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués
ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de Lone Star Capital Investments
S.à r.l., afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription de l'émission des Nouvelles
Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec
ce point.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués
approximativement à mille trois cents euros (EUR 1300).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande du mandataire de la
partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction en langue française; à la demande
du même mandataire et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au bureau du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du document faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire comparant et le notaire ont
signé le présent acte original.
Signé: V. Fagnant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 mai 2015. 2LAC/2015/11714. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2015.
Référence de publication: 2015083426/180.
(150096067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
92533
L
U X E M B O U R G
Schleswig Retail S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 134.371.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 27 avril 2015i>
L'Assemblée décide de:
- Renouveler le mandat des Administrateurs suivants avec effet à partir du 27 avril 2015:
* Brian Conroy, en tant qu'Administrateur de type A;
* Andrew Whitty, en tant qu'Administrateur de type A;
* Bastow Charleton S.à r.l., en tant qu'Administrateur de type B.
Durée du mandat pour les trois administrateurs: jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
- Nommer en remplacement de la Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l. comme commissaire de la Société, Efficient
Services Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS sous le numéro B189972, dont le siège social est au 16, rue
d'Epernay, L - 1490 Luxembourg, avec effet rétroactif au 1
er
novembre 2014 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires
qui aura lieu en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015083571/21.
(150095624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Stirling Adjacent Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 280.650,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.100.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2015.
Référence de publication: 2015083591/10.
(150096095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
TPG Merl S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 716.476,25.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 160.273.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2015.
Référence de publication: 2015083669/10.
(150095990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Team First S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 197.285.
STATUTS
L'an deux mil quinze, le dix-neuf mai,
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
A comparu:
Monsieur Omar DIAWARA, commerçant, né le 1
er
janvier 1970 à Ouagadougou (Burkina Faso), demeurant à L-9215
Diekirch, 10, rue du Cimetière.
92534
L
U X E M B O U R G
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «TEAM FIRST s.à
r.l.»
Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Koerich.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet le commerce (achat, vente) d’appareils électroménagers et d’accessoires de la branche
électroménager, ainsi que de tous produits, articles et marchandises non-réglementés.
La société a encore pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets.
Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés,
marques commerciales et marques de fabrique, dessins, modèles, logiciels informatiques, noms de domaines et en exploiter,
en céder et en concéder toutes les licences.
La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait faire
partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de nature
à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception
la plus large.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entre-
prises, associations ou sociétés.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.
De manière générale, la société pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature à faciliter la réalisation de
son objet social.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales
de vingt-cinq Euros (Eur 25,-) chacune.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif
net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de
mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée
sur les sociétés commerciales.
Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien
déterminées pourront faire l’objet d’un contrat d’association ou de partenariat sous seing privé.
Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents
statuts.
Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d’effet vis-à-
vis des tiers qu’après avoir été dûment publié.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur
les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir
leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l’Assemblée générale.
92535
L
U X E M B O U R G
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.
Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les 3/4 du capital social.
Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de
leur mandat.
Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les
pièces comptables exigées par la loi.
Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal
jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Frais:i>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ mille cent Euros
(Eur 1.100,-).
Le notaire instrumentant attire l’attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présentement
fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.
Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l’octroi
d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires
en date du 16 mai 2001.
<i>Loi anti-blanchimenti>
En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare
en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées à l’article 506-1 du code
pénal luxembourgeois.
<i>Souscriptioni>
Les 500 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire
qui le constate expressément, et toutes souscrites par l’associé unique Monsieur Omar DIAWARA, préqualifié.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quinze.
<i>Assemblée généralei>
Le fondateur prénommé, détenant l’intégralité des parts sociales, s’est constitué en Assemblée Générale et a pris à
l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le siège social est fixé à L-8399 Windhof, 2, rue d’Arlon.
2) La société sera gérée par un gérant unique: Monsieur Omar DIAWARA, commerçant, né le 1
er
janvier 1970 à
Ouagadougou (Burkina Faso), demeurant à L-9215 Diekirch, 10, rue du Cimetière.
3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s’être
identifié au moyen de sa carte d’identité.
Signé: O. DIAWARA, C. MINES.
92536
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15975. Reçu soixante-quinze euros.
75,-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR COPIE CONFORME,
Capellen, le 28 mai 2015.
Référence de publication: 2015083657/124.
(150095535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
Duchy Digital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 24.240.
EXTRAIT
Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 13
Mars 2015, que:
L'Assemblée générale décide de renouveler les mandats comme administrateurs de Messieurs Elmar Heggen, Andrew
Buckhurst et Marcus Oswald, ayant leur adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L - 1543 Luxembourg, pour
une durée d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat comme commissaire aux comptes de Monsieur Eric Ambrosi,
ayant son adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L -1543 Luxembourg, pour une durée d'un an expirant à
l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015083870/17.
(150096679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Danaher Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 2.008.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 86.363.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour Danaher Luxembourg S.à.r.l.i>
Référence de publication: 2015083859/11.
(150096373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
D.A.S. Luxemburg Allgemeine Rechtsschutz-Versicherung S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 41.395.
EXTRAIT
La résolution suivante a été adoptée par les actionnaires en date du 6 mai 2015:
Le mandat de Réviseur d'entreprises agréé de KPMG Luxembourg S.à r.l., 39 avenue John F. Kennedy L-1855 Lu-
xembourg a été approuvée. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31
décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 juin 2015.
Référence de publication: 2015083857/14.
(150096665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
92537
L
U X E M B O U R G
Côte d'Emeraude S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 180.724.
Par les présentes, j’ai l’honneur de vous informer que je démissionne de mes fonctions d’administrateur de votre société,
immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B180724, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 1
er
juin 2015.
Loïc Stourm.
Référence de publication: 2015083856/10.
(150096700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Eastman Chemical Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 27.913.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 67.736.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2015.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015083914/13.
(150096914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
ECommerce Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 194.500.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par le conseil de surveillance de la Société en date du 4 juin 2015i>
En date du 4 juin 2015, le conseil de surveillance de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Philipp LEDERER, né le 5 avril 1971 à Francfort, Allemagne, résidant professionnellement à
l’adresse suivante: 20, Johannisstraße, 10117 Berlin, Allemagne, en tant que nouveau membre de classe A du directoire
de la Société avec effet immédiat et ce jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui statuera sur les
comptes arrêtés au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2015.
ECommerce Holding S.A
Référence de publication: 2015083915/16.
(150096799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Electro-Re, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 24.739.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1 i>
<i>eri>
<i> juin 2015i>
<i>4 i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer
Réviseur Indépendant de la société:
ERNST & YOUNG
7, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Münsbach
dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se terminant le 31 décembre 2015.
92538
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la Société
i>Fabrice FRERE
<i>Directeur Déléguéi>
Référence de publication: 2015083920/19.
(150096403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Eiffel PT 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 172.897.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EIFFEL PT 2 S.A.
Référence de publication: 2015083919/10.
(150097005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Electro-Re, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 24.739.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Fabrice FRERE
<i>Directeur Déléguéi>
Référence de publication: 2015083922/12.
(150096404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Escalet Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 164.368.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ESCALET PROPERTY S.A.
Référence de publication: 2015083902/10.
(150096829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Energy Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 178.618.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of the month of May.
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l. (the "Sole Shareholder"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, having a share
capital of €1,020,951 and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 138.092,
and incorporated by deed of Maître Martine Schaeffer on 2 April 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the “Mémorial”), number 1269 on 24 May 2008,
represented by Me Idir Elsa, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 May
2015 (such proxy to be registered together with the present deed),
being the sole shareholder of Energy Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, having a share capital of €12,500
92539
L
U X E M B O U R G
and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 178.618 (the “Company”) and
incorporated by deed of Maître Edouard Delosch on 28 June 2013, published in the Mémorial number 2108 on 29 August
2013. The articles of association of the Company have never been amended since the incorporation of the Company.
The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
(A) The Sole Shareholder holds all shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items of
the agenda.
(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. amendment of the accounting year of the Company so that it shall start on 1 January of each year and shall terminate
on 31 December of the same year; and consequential amendment of article 11 of the articles of association of the Company,
so as to read as follows:
Art. 11. Accounting year. “The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and end on 31
December of the same year”.
Thereupon the Sole Shareholder has passed the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to amend the accounting year of the Company, which shall begin on 1 January and shall end on 31 December
of the same year, such that the current accounting year which has started on 1 April 2015 shall end on 31 December 2015.
As a result of the above, the article 11 of the articles of association of the Company shall be amended to read as follows:
Art. 11. Accounting year. “The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and end on 31
December of the same year”.
There being no further item to be discussed on the agenda, the Meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at one thousand one hundred Euro (€ 1,100.-).
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto, this
deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of discrepancies
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Followed by a french translation
L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l. (l’«Associé Unique»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au
7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxem-
bourg sous le numéro B 138.202, ayant un capital social de €1.020.951 et constituée le 2 avril 2008 suivant acte reçu de
Maître Martine Schaeffer, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 1269 du
24 mai 2008,
représentée par Me Idir Elsa, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
en date du 28 mai 2015 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte),
étant l’associé unique et détenant l’ensemble des parts sociales émises dans Energy Services S.à r.l. (la «Société»), une
société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, ayant un capital
social de €12.500 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B
178.618, constituée le 28 juin 2013 suivant acte reçu de Maître Edouard Delosch, publié au Mémorial, numéro 2108 du 29
août 2013. Les statuts de la Société n’ont jamais été modifiés depuis sa constitution.
La partie comparante a déclaré et demandé au notaire soussigné d’arrêter comme suit:
(A) L’Associé Unique détient l’ensemble des parts sociales émises par la Société de telle sorte que les décisions peuvent
valablement être prises sur tous les points figurant à l’ordre du jour.
(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
1. modification de l’année comptable de la Société, de sorte qu'elle commence à compter du 1
er
janvier et se termine
le 31 décembre de la même année, et modification subséquente de l’article 11 des statuts de la Société de la manière suivante:
Art. 11. Année comptable. «L’année comptable de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine
le 31 décembre de la même année».
Sur ce l’Associé Unique a pris la résolution suivante:
92540
L
U X E M B O U R G
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé de modifier l’année comptable de la Société de sorte qu'elle commence à compter du 1
er
janvier et se
termine le 31 décembre de la même année, et que l’année comptable en cours, qui a commencé le 1
er
avril 2015, se termine
le 31 décembre 2015.
En conséquence, l’article 11 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
Art. 11. Année comptable. «L’année comptable de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine
le 31 décembre de la même année».
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance a été levée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société, sont estimés
à mille cent euros (€ 1.100,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande de la même partie, en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du présent procès-verbal, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: E. IDIR, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 juin 2015. Relation: DAC/2015/9228. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 05 juin 2015.
Référence de publication: 2015083900/94.
(150096834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Pilot SA (Pédagogie, Instructions, Langues, Organisation et Training), Société Anonyme,
(anc. Faculté d'Ingénierie et de Recherche de Solutions et Techniques).
Siège social: L-4920 Bascharage, 43, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 109.537.
L'an deux mille quinze, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
S'est réunie:
l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme «En français: FACULTE D'INGENIERIE ET DE RE-
CHERCHE DE SOLUTIONS ET TECHNIQUES En anglais: FINDING INNOVATIVE AND RELIABLE SOLUTIONS
AND TECHNIQUES», ayant son siège social à L-9456 Hoesdorf, 14D, Villa d'Epicéa.
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, de résidence à Mersch, en date du 27 juin 2005,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1240 du 21 novembre 2005 inscrite au registre de
commerce sous le numéro B 109.537;
La séance est ouverte sous la présidence de
Madame Miranda Bergmans, consultante, architecte d'intérieur, demeurant à L-4920 Bascharage, 43, rue de l'Eau.
L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que le présent acte a pour objet de:
1. Transfert du siège social de la société de L-9456 Hoesdorf, 14D, Villa d'Epicéa vers 43, rue de l'Eau à L-4920
Bascharage et modification du 1
er
alinéa de l'article 2 des statuts.
2. Changement de la dénomination sociale
3. Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur»
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne
varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.
92541
L
U X E M B O U R G
III.- Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant 100% du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer vala-
blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-
tration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide sous le réserve formelle de la conformité des présentes avec l'article 141 de la loi du 10
août 1915 de transférer le siège social de L-9456 Hoesdorf, 14D, Villa d'Epicea vers 43, rue de l'eau à L-4920 Bascharage
et de modifier par conséquent le 1
er
alinéa de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. (1
er
alinéa). Le siège de la société est établi dans la commune de Bascharage».
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société et en conséquence de changer la teneur
de l'article 1 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PILOT SA (Pédagogie, Instructions, Langues,
Organisation et Training SA)».
<i>Déclaration des comparantsi>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du
capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction
visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis l'article 135-5 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 750,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Miranda Bergmans, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 27 mai 2015. Relation: DAC/2015/8689. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 2 juin 2015.
Référence de publication: 2015083899/67.
(150096242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 175.927.
Les comptes annuels audités de la société pour la période au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015083903/12.
(150096573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
92542
L
U X E M B O U R G
Frena Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 900.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.057.
En date du 29 mai 2015, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Démission de Mr Martin Paul Galliver, du poste de gérant de classe B avec effet au 28 mai 2015;
- Démission de Mr Alex Legrand, du poste de gérant de classe B avec effet au 28 mai 2015;
- Nomination de Mr Fabian Sires, né le 27 septembre 1976 à Messancy, Belgique, ayant pour adresse professionnelle
le 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant de classe B avec effet au 29 mai 2015
et pour une durée indéterminée;
- Nomination de Mrs Jana Strischek, née le 12 juin 1975 à Potsdam, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle le
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant de classe B avec effet au 29 mai 2015
et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Frena Intermediate Holdings S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015083962/21.
(150096138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
FABS Luxembourg I SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 77.658.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 Juin 2015.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2015083963/13.
(150096481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Fidelity Productions Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 105.518.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société en date du 13 avril 2015 que:
- La nomination de Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz (France) et demeurant professionnellement
au 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommée Président du Conseil d'Administration, et ce jusqu'au terme de
son mandat en tant qu'administrateur.
Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 22 avril 2015 que:
- La démission de Jérôme TIBESAR, avec effet au 13 février 2015, en tant qu'administrateur de la Société, a été acceptée.
- Monsieur Martin HUBERT né le 28 avril 1982 à Messancy (Belgique) et demeurant professionnellement au 16 avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommé administrateur avec effet au 13 février 2015, et ce jusqu'à l'assemblée générale
qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2015.
Référence de publication: 2015083967/19.
(150096502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
92543
L
U X E M B O U R G
Gestion Fiera Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 816.969,74.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 180.910.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 22 avril 2015i>
En date du 22 avril 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Madame Sonia BALDAN, née le 27 janvier 1960 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant
à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de
la Société avec effet au 30 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Pierre BLANCHETTE, gérant de classe A
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant de classe B
- Madame Sonia BALDAN, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2015.
Gestion Fiera Capital S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2015083996/21.
(150096364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Global Viewcomp Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 488.025,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.947.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 3 juin 2015 que
- Monsieur Stef Oostvogels, a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 7 mai 2015.
- Monsieur François Pfister, né le 25 octobre 1961 à Uccle (Belgique), demeurant professionnellement au 2-4 rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2015.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2015083998/19.
(150096225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Genzyme Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 97.613.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2015.
Référence de publication: 2015084005/10.
(150096507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
92544
A 1 S.A.
Access Capital Fund SICAV-SIF
Advent PPF (Luxembourg) S.à r.l.
Alander S.A.
Alpha Fund, S.C.A., SICAV-SIF
AmerisourceBergen Luxembourg
Amethis Partners S.A.
Astromancia S.à r.l.
Athena Equity Trading S.à r.l.
Auto-Ecole Dani Sàrl
Bajacghi (SPF) S.A.
Burnfort Investments S.à.r.l.
Côte d'Emeraude S.A.
Danaher Luxembourg S.à r.l.
D.A.S. Luxemburg Allgemeine Rechtsschutz-Versicherung S.A.
Duchy Digital S.A.
Eastman Chemical Luxembourg Sàrl
ECommerce Holding S.A.
Eiffel PT 2 S.A.
Electro-Re
Electro-Re
Energy Services S.à r.l.
Escalet Property S.A.
Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l.
FABS Luxembourg I SA
Faculté d'Ingénierie et de Recherche de Solutions et Techniques
Fidelity Productions Participations S.A.
Frena Intermediate Holdings S.à r.l.
Genzyme Luxembourg S.àr.l.
German Falcon Investments S.A.
Gestion Fiera Capital S.à r.l.
Global Viewcomp Holdings S.àr.l.
LSREF3 Eve Holdings S.à r.l.
Maison é S.A.
Meltemi Entreprises S.à r.l.
MezzVest Luxembourg I S.à.r.l.
NBIM Otto SZ S.à r.l.
NBIM Otto W1 S.à r.l.
Orco Property Group
Pilot SA (Pédagogie, Instructions, Langues, Organisation et Training)
ResponsAbility BOP
Schleswig Retail S.A.
Stirling Adjacent Holdco S.à r.l.
SWYP Lux S.à r.l
Tarpon Holdings S.A.
Team First S.à r.l.
Teleteam V
TPG Merl S.à r.l.
Weiland HTS S.à r.l.
WishFish Technologies S.à r.l.