logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1894

28 juillet 2015

SOMMAIRE

Astromancia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90880

KMU/PME S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90866

Kodo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90866

KPI I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90867

Lapithus Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

90868

La Rosa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90880

LaSalle UK Ventures Property 9  . . . . . . . . . . .

90867

Leandre Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

90881

Lex Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90868

Lex II Investments Holdings S.A.  . . . . . . . . . .

90869

Lex Investments Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . .

90868

Liaoshi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90907

Liberia Administrado S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

90869

Ling-Ling s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90907

Liosoph S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90912

LNJ Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90908

Loevarth Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90908

Logistic Investment Holding S. à r.l.  . . . . . . . .

90880

LSRC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90909

Lucos Company Services  . . . . . . . . . . . . . . . . .

90909

Lugala S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90912

Luxair Immobilière S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

90912

Luxcellence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90909

Lux Drone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90909

Lux-Forst S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90910

Lux-Forst S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90910

Lux-Investment Professionals SICAV-FIS S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90910

Luxmaster S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90908

Luxmaster S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90911

Luxpar Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90912

Multi Opportunity Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90910

Natixis Alternative Assets (acronyme NAA)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90907

Nepomuk S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90912

Overseas Development S,A,  . . . . . . . . . . . . . . .

90868

Pitcairns Finance S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . .

90911

REM624  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90911

Résidence pour Personnes Agées Hertha Wi-

nandy, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90912

Rischette S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90911

Rischette S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90911

WSHP LuxCo 1 SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90882

90865

L

U X E M B O U R G

KMU/PME S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6636 Wasserbillig, 7, rue de Mertert.

R.C.S. Luxembourg B 74.665.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2001 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081519/9.
(150093124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Kodo S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 35.536.

L'an deux mille quinze, le treize mai.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, société de gestion de patrimoine familial

"KODO S.A." (numéro d’identité 2010 22 47 303), avec siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean, inscrite au
R.C.S.L. sous le numéro B 35.536, constituée suivant acte notarié daté du 6 décembre 1990, publié au Mémorial C, numéro
178 du 13 avril 1991 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par
le notaire Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 23 décembre 2013, publié au Mémorial C, numéro
557 du 3 mars 2014.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pascal JUNGLING, employé privé, demeurant professionnellement à Pétange.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sandy HAMES, employée privée, demeurant à Reckange-sur-Mess.
L'assemblée  désigne  comme  scrutateur  Monsieur  Jean-Marie  WEBER,  employé  privé,  demeurant  à  Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique).

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence,

laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera
annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la société a un capital social de deux cent cinquante mille euros (€ 250.000.-), représenté par dix mille (10.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25.-) chacune.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que les dix mille (10.000) actions de la société sont présentes ou représentées

et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés
à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Johan HEMELAERE, administrateur de société, né à

Zwevezele (Belgique) le 8 septembre 1951, demeurant à B-8500 Kortrijk, O.-L. Vrouwestraat, 40.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires,

pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

90866

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer la société de droit chypriote "FENDARE TRUST MANAGEMENT LIMITED", ayant

son siège social à Nicosia (Chypre), 77 Strovolou, Strovolos Center, Flat/Office 204, Strovolos, P.C. 2018, Nicosia, inscrite
au Registrar of Companies sous le numéro 237412 comme commissaire-vérificateur.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée accorde décharge pleine et entière à l’administrateur unique et au commissaire aux comptes pour les travaux

exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à mille euros (€ 1.000.-), sont à charge de la

société.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: JUNGLING, HAMES, J-M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15801. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 1 

er

 juin 2015.

Référence de publication: 2015081520/65.
(150092758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

KPI I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.001,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 154.101.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 29 mai 2015

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Michael Edward Dunn, administrateur de sociétés, de son mandat

de gérant de catégorie A avec effet au 31 mai 2015.

L'associé unique décide de nommer Monsieur Andrew Taylor, administrateur de sociétés, résidant professionnellement

à Park Point, 17 High Street, Longbridge, Birmingham B31 2UQ en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société
pour une période illimitée avec effet au 31 mai 2015.

Pour extrait
La Société

Référence de publication: 2015081521/16.
(150092795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

LaSalle UK Ventures Property 9, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 209.180,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 131.872.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société LaSalle UK Ventures Property 9, décidée par acte du notaire Maître Henri Hellinckx en date

du 18 décembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 21 mai
2015.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 41, avenue de la Liberté,

L-1931 Luxembourg

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents à la clôture de la liquidation

et dont la remise n'aurait pu leur être faite seront déposées à la Caisse de consignation de Luxembourg.

90867

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2015.

Référence de publication: 2015081532/18.
(150093284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Lapithus Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 153.177.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2015.

Référence de publication: 2015081527/10.
(150092830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Lex Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.494.

Le bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/06/2015.

Référence de publication: 2015081534/10.
(150093027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Lex Investments Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.496.

Le bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/06/2015.

Référence de publication: 2015081535/10.
(150093025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Overseas Development S,A,, Société Anonyme.

Siège social: L-2143 Luxembourg, 156, rue Laurent Ménager.

R.C.S. Luxembourg B 186.445.

<i>Extrait des résolutions écrites du Conseil d'administration de la Société prises le 20 février 2015

Le Conseil de la Société a décidé:
- D'acter le changement d'adresse de Madame Laure-Estelle Beaudoin, Administrateur délégué au 13-15 rue du Chemin

de Fer, L-8057 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg

- D'accepter la démission de Madame Brigitte Denis de son poste d'administrateurs de la Société avec effet au 9 février

2015;

- De nommer, en remplacement de Madame Brigitte Denis:
* la société «MPO - My Private Office sàrl», inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

no. B 191.987 et ayant son siège au 13-15 rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg en
qualité d'administrateur de la Société avec effet au 9 février 2015;

* pour une durée déterminée qui prendra fin à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en

2015;

* avec Madame Barbara Jourdaine, née le 28/07/1977 à Caen et domiciliée professionnellement au 13-15 rue du Chemin

de Fer, L-8057 Bertrange comme représentant permanent.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

90868

L

U X E M B O U R G

<i>Pour Overseas Development S.A.
Administrateur délégué

Référence de publication: 2015082632/24.
(150094272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Lex II Investments Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.289.

Le bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/06/2015.

Référence de publication: 2015081536/10.
(150093026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Liberia Administrado S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 197.200.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of the month of May;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

APPEARED:

The public limited company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “FINEX.LU

S.A. SOPARFI”, with registered office in L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, registered with the Trade and
Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 144705,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean

Engling, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne
varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded
with it.

Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association of a

private limited liability company (“Gesellschaft mit beschränkter Haftung”) to establish as follows:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There is hereby established a private limited company („Gesellschaft mit beschränkter

Haftung“) under the name “Libera Administrado SARL” (hereinafter the “Company”) governed by the law of 10 August
1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association (the
“Articles”).

Art. 2. Purpose.
2.1 The object of the Company is the administration of the Company's own assets, the acquisition of participations,

interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests
and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2 The Company may borrow and raise funds in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private

placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds
including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities such as, among others, the providing of loans and
the granting of guarantees or securities in any kind or form, to its subsidiaries or companies in which it has a direct or
indirect interest, even not substantial, or to any company being a direct or indirect corporate unit holder of the Company
or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Affiliated Companies”).
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Affiliated Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create securities over all or over
some of its assets.

2.3 Furthermore, the Company may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other

intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.

90869

L

U X E M B O U R G

2.5 The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect invest-

ments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting,
dividing, exhausting, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6 The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not restrictive.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of corporate unit

holders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered offices.
4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-

bourg).

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of corporate unit holders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of asso-
ciation.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Corporate capital - Corporate units

Art. 5. Corporate Capital.
5.1 The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500. - EUR), represented by twelve thousand

five hundred (12,500) corporate units with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each.

5.2 The Company’s capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of corporate unit holders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own corporate units.

Art. 6. Corporate units.
6.1 The Company’s capital is divided into corporate units, each of them having the same nominal value.
6.2 The corporate units of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several corporate unit holders, with a maximum of forty (40) corporate unit holders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the corporate unit holders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of corporate units - Transfer of corporate units.
7.1 A register of corporate unit holders shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available

for inspection by any corporate unit holder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates
of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant corporate unit holder.

7.2 The Company will recognise only one holder per corporate unit. In case a corporate unit is owned by several persons,

they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to
suspend the exercise of all rights attached to that corporate unit until such representative has been appointed.

7.3 The corporate units are freely transferable among corporate unit holders.
7.4 Inter vivos, the corporate units may only be transferred to new corporate unit holders subject to the approval of such

transfer given by the corporate unit holders at a majority of three quarters of the corporate capital.

7.5 Any transfer of corporate units shall become effective towards the Company and third parties through the notification

of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the corporate units of the deceased corporate unit holder may only be transferred to new

corporate unit holders subject to the approval of such transfer given by the surviving corporate unit holders at a majority
of three quarters of the corporate capital. Such approval is, however, not required in case the corporate units are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased corporate unit holder.

90870

L

U X E M B O U R G

C. Decisions of the corporate unit holders

Art. 8. Collective decisions of the corporate unit holders.
8.1 The general meeting of corporate unit holders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

8.2 Each corporate unit holder may participate in collective decisions irrespective of the number of corporate units which

he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) corporate unit holders, collective decisions

otherwise conferred on the general meeting of corporate unit holders may be validly taken by means of written resolutions.
In such case, each corporate unit holder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded
and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole corporate unit holder, such corporate unit holder shall exercise the powers granted to the general

meeting of corporate unit holders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In
such case, any reference made herein to the “general meeting of corporate unit holders” shall be construed as a reference
to the sole corporate unit holder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting
of corporate unit holders shall be exercised by the sole corporate unit holder.

Art. 9. General meetings of corporate unit holders. In case the Company has more than twenty-five (25) corporate unit

holders, at least one general meeting of corporate unit holders shall be held within six (6) months of the end of each financial
year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening
notice of such meeting. Other meetings of corporate unit holders may be held at such place and time as may be specified
in the respective convening notices of meeting. If all of the corporate unit holders are present or represented at a general
meeting of corporate unit holders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior
notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each corporate unit holder is entitled to as many votes as he holds corporate units.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

corporate unit holders are only validly taken in so far as they are adopted by corporate unit holders holding more than half
of the corporate capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the corporate unit
holders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time
by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast
whichever is the fraction of the corporate capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The corporate unit holders may change the nationality of the Company only by unanimous

consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of corporate unit holders (ii) representing three quarters of the corporate capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of corporate unit holders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of corporate unit holders which shall determine their

remuneration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the corporate unit holders representing more than half of the Company’s corporate capital.

14.3 The general meeting of corporate unit holders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being

class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the
relevant corporate unit holders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of

90871

L

U X E M B O U R G

the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of corporate unit holders which shall resolve on
the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of corporate unit holders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of corporate unit holders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
corporate unit holders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such
minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman, if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of corporate unit holders has appointed
different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by
one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of corporate unit holders has appointed different classes of managers (namely class A ma-
nagers and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature
of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of
such delegation.

90872

L

U X E M B O U R G

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) corporate unit holders, the operations of the

Company shall be supervised by one or several internal auditors (Rechnungskommissar(e)). The general meeting of cor-
porate unit holders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of corporate unit holders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the corporate unit holders of the Company appoint one or more independent qualified auditors (unabhängige(r)

qualifizierte(r) Wirtschaftsprüfer) in accordance with article 69 of the law of December 19, 2002 regarding the trade and
companies’ register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor
(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of corporate unit holders with cause or with

its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the corporate capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a corporate unit holder may also be allocated to the legal reserve

if the contributing corporate unit holder agrees with such allocation.

22.4 In case of a corporate capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the corporate capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of corporate unit holders shall determine

how the remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the corporate unit holders in proportion to the number of corporate units they hold

in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the corporate

unit holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of corporate unit
holders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise pro-
vided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities
of the Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the corporate unit holders in proportion to the number of corporate units of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitory disposition

The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and ends on December 31, 2015.

90873

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the twelve thousand five hundred (12,500) corporate units have been sub-

scribed by the sole shareholder, the company “FINEX.LU S.A. SOPARFI”, pre-designated and represented as said before,
and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros
(12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned
notary, who expressly attests thereto.

<i>Verification

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of

the amended law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Decisions taken by the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the

subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1) The registered office of the Company is established at 25A, Boulevard Royal in L-2449 Luxembourg.
2) Mr. Jacek Bogusław JANTOŃ, companies’ director, born in Zduñska Wola (Poland), on September 5, 1970, residing

in 95-200 Pabianice, Kunickiego 12 (Poland), is appointed as manager of the Company for an undetermined duration.

<i>Costs and expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand and twenty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

name, first name and residence, the said Proxyholder has signed with Us the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am achtzehnten Tag des Monats Mai;
Vor dem unterzeichnenden Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Aktiengesellschaft „FINEX.LU S.A.

SOPARFI”, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25A, Boulevard Royal, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 144705,

hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean

Engling, (der „Bevollmächtigte“), auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht, nach
„ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen
bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu gründ-

enden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Gegründet wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung

„Libera Administrado SARL“ (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung (die „Statuten“) unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen

und Anteilsscheinen in jeglicher Form in Luxemburg oder im Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile
und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien,
Anteile und andere Genussscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und ganz
allgemein alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen gleich
welcher Art begeben wurden.

2.2 Die Gesellschaft kann Mittel in jeglicher Form, außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot, aufnehmen und

beschaffen. Sie kann - ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung - Notes, Anleihen und Schuldverschreibungen sowie
Schuldtitel und/oder Aktienwerte emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen

90874

L

U X E M B O U R G

und/oder Emissionen von Schuldtiteln, unter anderem die Gewährung von Darlehen, Garantien oder Sicherheiten in jeg-
licher Art und Weise, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesell-
schafter  der  Gesellschaft  oder  einer  zur  gleichen  Gruppe  wie  die  Gesellschaft  gehörenden  Konzerngesellschaft  sind
(nachfolgend als die „verbundenen Unternehmen“ bezeichnet). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicher-
heiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu
besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder
in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.

2.3 Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder sons-

tigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

2.4  Die  Gesellschaft  kann  im  Allgemeinen  alle  Methoden  und  Instrumente  für  ihre  Investitionen  zum  Zwecke  des

effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen
Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.

2.5 Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten

Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb, Ei-
gentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Erschließung,
Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise
von beweglichem Vermögen oder Immobilien.

2.6 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen

Anspruch auf Vollständigkeit.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  durch  Beschluss  des  Rates  der  Geschäftsführer  im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in zwölftausendfünf-

hundert (12.500) Anteile zu je einem Euro (1,- EUR), welche voll eingezahlt sind.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten

darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

90875

L

U X E M B O U R G

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustim-
mung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen
werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-

lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit
statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in
einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die
Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schrift-
lichen  Konsultation  der  Gesellschafter  nicht  erreicht  wird,  können  die  Anteilseigner  ein  weiteres  Mal  mit  derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1  Die  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer  geleitet.  Falls  die  Gesellschaft  mehrere  Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

90876

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der beziehungsweise die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Be-

züge und Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem  Amt  ausscheidet,  muss  die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-

punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-

ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-

führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2  Sitzungen  des  Rates  der  Geschäftsführer  werden,  falls  vorhanden,  durch  den  Vorsitzenden  des  Rates  der  Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore
ernennen.

17.3  Jeder  Geschäftsführer  kann  an  einer  Sitzung  des  Rates  der  Geschäftsführer  teilnehmen,  indem  er  ein  anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine

90877

L

U X E M B O U R G

Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie
B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B),
werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens
eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii)
durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschrifts-
befugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung ernennt die
Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen  Fassung,  einen  oder  mehrere  unabhängige  qualifizierte  Wirtschaftsprüfer  ernennen,  entfällt  die  Funktion  des
Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-

sellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-

klang  mit  den  gesetzlichen  Anforderungen  ein  Inventar  der  Aktiva  und  Passiva,  eine  Bilanz  und  eine  Gewinn-  und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-

falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

90878

L

U X E M B O U R G

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von
1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an

die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Vorübergehende Bestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile durch die

alleinige Gesellschafterin, die Gesellschaft „FINEX.LU S.A. SOPARFI“, vorbenannt und vertreten wie hiervor erwähnt,
gezeichnet und voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich
bestätigt.

<i>Beglaubigung

Der  unterzeichnende  Notar  gibt  hiermit  an,  beglaubigt  und  ausdrücklich  vermerkt  zu  haben,  dass  die  aufgezählten

Bedingungen des Artikels 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hier erfüllt
worden sind.

<i>Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterin

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienen Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-

schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird festgelegt auf 25A, Boulevard Royal in L-2449 Luxemburg.
2) Herr Jacek Bogusław JANTOŃ, Gesellschaftsverwalter, geboren in Zduñska Wola (Polen), am 5. September 1970,

wohnhaft in 95-200 Pabianice, Kunickiego 12, (Polen), wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer ernannt.

<i>Kosten und Auslagen

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendzwanzig Euro.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben

genannten erschienen Partei, die vorliegenden Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Fassung; gemäß dem Wunsch derselben erschienen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
deutschen Text, ist die English Fassung maßgebend.

90879

L

U X E M B O U R G

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, handelnd wie zuvor er-

wähnt, dem Notar mit Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte mit Uns,
dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré a Luxembourg A.C. 2, le 21 mai 2015. Relation: 2LAC/2015/11225. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré a la société.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2015.

Référence de publication: 2015081538/596.
(150092888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Logistic Investment Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 346.200,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.752.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Logistic Investment Holding S.à r.l.

Référence de publication: 2015081539/10.
(150093515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

La Rosa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.306.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 21 mai 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation de la société suivante:

- LA ROSA SA, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 8 Bd Royal,
Le même jugement a nommé juge commissaire Madame Anita LECUIT, juge et liquidateur Me Marie-Christine GAU-

TIER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Pour extrait conforme
Maître Marie-Christine GAUTIER
22, rue Marie-Adélaïde
L-2128 Luxembourg

Référence de publication: 2015081548/18.
(150093080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Astromancia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 189.726.

L'an deux mille quinze, le vingt mai.
Par devant Nous Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique (l’“Assemblée”) de la société à responsabilité limitée régie par

les lois du Luxembourg “ASTROMANCIA S.à r.l.”, établie et ayant son siège social au 3 rue Thomas Edison, L-1445
Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous  le  numéro  189726  (la  “Société”),  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Paul  DECKER,  notaire  de  résidence  à
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 25 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2930 du 14 octobre 2014, et dont les statuts (les “Statuts”) n’ont jamais été modifiés.

90880

L

U X E M B O U R G

L'Assemblée est présidée par Sophie BECKER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 43, boule-

vard Prince Henri.

Le Président désigne comme secrétaire Lucca TORRES, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5,

rue de Bonnevoie.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Lucca TORRES, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5,

rue de Bonnevoie.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la Société au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

avec effet immédiat;

2. Modification subséquente de l’Article 4 des Statuts de la Société tenant compte de la décision ci-dessus;
B) Que l’associé unique, présent ou représenté, ainsi que le nombre de parts sociales possédées, sont portés sur une liste

de présence; cette liste de présence est signée par l’associé unique ou son mandataire, les membres du bureau de l’Assemblée
et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l’associé unique, signée “ne varietur” par le(s) mandataire(s) et les membres du bureau de

l’Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que l’associé unique, présent ou représenté, déclare

avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux
formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la Société au 2, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et de modifier subséquemment l’article 4, alinéa 1, des Statuts afin de lui
donner la teneur suivante:

“ Art. 4. Premier alinéa. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.”
Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée, le Président a ensuite clôturé l’Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent vingt euros (EUR
720,-).

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: BECKER, TORRES, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 mai 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 16059. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 3 juin 2015.

Référence de publication: 2015082121/59.
(150094974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Leandre Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 141.216.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 21 mai 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation de la société suivante:

90881

L

U X E M B O U R G

- LEANDRE INVESTISSEMENT SA, avec siège social à L-1449 Luxembourg, 18 rue de l'Eau,
Le même jugement a nommé juge commissaire Madame Anita LECUIT, juge et liquidateur Me Marie-Christine GAU-

TIER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Pour extrait conforme
Maître Marie-Christine GAUTIER
22, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg

Référence de publication: 2015081554/18.
(150093081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

WSHP LuxCo 1 SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 186.854.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of April,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of shareholders of WSHP LuxCo 1 SCA, a société en commandite par actions, incor-

porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 186.854,
incorporated on 30 April 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1832 dated 14 July 2014 (the "Company").

The articles of association have been amended for the last time on 28 November 2014, pursuant to a deed of the under-

signed notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3956 dated 20 December 2014.

The meeting was opened at 6.00 p.m. with Me Philippe Harles, professionally residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr David Al Mari, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Caroline Halembert, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the Company's share capital by an amount of one hundred seventy-three thousand eight hundred and fifty

euro (EUR 173,850), in order to bring it from its current amount of six million one hundred and thirteen thousand four
hundred and eighty-one euro (EUR 6,113,481) up to a new amount of six million two hundred eighty-seven thousand three
hundred and thirty-one euro (EUR 6,287,331) through the issuance of:

- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class A Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class B Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class C Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class D Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class E Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class F Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class G Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class H Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class I Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class J Shares;
with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
2. Reinstatement of the articles of association of the Company.
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders as the case may be and the

number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders or the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholder, initialled “ne varietur” by the appearing parties will also remain annexed to

this deed.

90882

L

U X E M B O U R G

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders present or

represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and hereby
waiving any convening requirement, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

The general meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution:

The general meeting acknowledges that the Company's shareholders (i) WSHP Orgentec Holdco, Ltd., a Cayman Islands

exempted limited company, having its registered office c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland
House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands, (ii) WSHP GP Sàrl, a société à responsabilité limité
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 186.813, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
(iii) ORGENTEC Holding GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung incorporated and existing under the laws of
Germany, with registered office at Carl-Zeiss-Strasse 49, 55129 Mainz, Germany, registered with the commercial register
of the local court of Mainz under number HRB 41710, (iv) SB Holding GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung
incorporated and existing under the laws of Germany, with registered office at Heinrich-Engel-Strasse 49a, 64572 Büttel-
born, Germany, registered with the commercial register of the local court of Darmstadt under number HRB 92833, and (v)
Doneco Limited, a limited company incorporated and existing under the laws of New Zealand, with registered office at 16
Wai-iti Crescent, Lower Hutt, Wellington, 5010, New Zealand, registered with the New Zealand registrar of companies
under number NZBN 9429041489208, have waived their preferential subscription rights to the extent applicable with
respect to the proposed capital increase.

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred seventy-three

thousand eight hundred and fifty euro (EUR 173,850), in order to bring it from its current amount of six million one hundred
and thirteen thousand four hundred and eighty-one euro (EUR 6,113,481) up to a new amount of six million two hundred
eighty-seven thousand three hundred and thirty-one euro (EUR 6,287,331) through the issuance of:

- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class A Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class B Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class C Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class D Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class E Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class F Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class G Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class H Shares;
- seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class I Shares;
seventeen thousand three hundred eighty-five (17,385) new Class J Shares;
with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
The new shares have been subscribed and entirely paid-up as follows:
1. WSHP Orgentec Holdco, Ltd., prenamed
here represented by Me Philippe Harles, by virtue of a proxy under private seal given on April 24, 2015, which will

remain attached to the present deed,

has subscribed:
- eleven thousand nine hundred and eleven (11,911) new Class A Shares;
- eleven thousand nine hundred and eleven (11,911) new Class B Shares;
- eleven thousand nine hundred and eleven (11,911) new Class C Shares;
- eleven thousand nine hundred and eleven (11,911) new Class D Shares;
- eleven thousand nine hundred and eleven (11,911) new Class E Shares;
- eleven thousand nine hundred and eleven (11,911) new Class F Shares;
- eleven thousand nine hundred and eleven (11,911) new Class G Shares;
- eleven thousand nine hundred and eleven (11,911) new Class H Shares;
- eleven thousand nine hundred and eleven (11,911) new Class I Shares;
- eleven thousand nine hundred and eleven (11,911) new Class J Shares;
with a nominal value of one euro (EUR 1) each and which have been paid up by a contribution in cash in an amount of

one hundred and nineteen thousand one hundred and ten euro (EUR 119,110) and shall be entirely allocated to the share
capital of the Company, so that the full amount is as of now at the disposal of the Company, proof of which is given to the
undersigned notary.

2. ORGENTEC Holding GmbH, prenamed

90883

L

U X E M B O U R G

here represented by Me Philippe Harles, by virtue of a proxy under private seal given on April 28, 2015, which will

remain attached to the present deed,

has subscribed:
- four thousand two hundred and seventy-seven (4,277) new Class A Shares;
- four thousand two hundred and seventy-seven (4,277) new Class B Shares;
- four thousand two hundred and seventy-seven (4,277) new Class C Shares;
- four thousand two hundred and seventy-seven (4,277) new Class D Shares;
- four thousand two hundred and seventy-seven (4,277) new Class E Shares;
- four thousand two hundred and seventy-seven (4,277) new Class F Shares;
- four thousand two hundred and seventy-seven (4,277) new Class G Shares;
- four thousand two hundred and seventy-seven (4,277) new Class H Shares;
- four thousand two hundred and seventy-seven (4,277) new Class I Shares;
- four thousand two hundred and seventy-seven (4,277) new Class J Shares;
with a nominal value of one euro (EUR 1) each and which have been paid up by a contribution in cash in an amount of

forty two thousand seven hundred and seventy euro (EUR 42,770) and shall be entirely allocated to the share capital of the
Company, so that the full amount is as of now at the disposal of the Company, proof of which is given to the undersigned
notary.

3. SB Holding GmbH, prenamed
here represented by Me Philippe Harles,
by virtue of a proxy under private seal given on April 28, 2015, which will remain attached to the present deed,
has subscribed:
- six hundred ninety-seven (697) new Class A Shares;
- six hundred ninety-seven (697) new Class B Shares;
- six hundred ninety-seven (697) new Class C Shares;
- six hundred ninety-seven (697) new Class D Shares;
- six hundred ninety-seven (697) new Class E Shares;
- six hundred ninety-seven (697) new Class F Shares;
- six hundred ninety-seven (697) new Class G Shares;
- six hundred ninety-seven (697) new Class H Shares;
- six hundred ninety-seven (697) new Class I Shares;
- six hundred ninety-seven (697) new Class J Shares;
with a nominal value of one euro (EUR 1) each and which have been paid up by a contribution in cash in an amount of

six thousand nine hundred and seventy euro (EUR 6,970) and shall be entirely allocated to the share capital of the Company,
so that the full amount is as of now at the disposal of the Company, proof of which is given to the undersigned notary.

4. Doneco Limited, prenamed,
here represented by Me Philippe Harles,
by virtue of a proxy under private seal given on April 28, 2015, which will remain attached to the present deed,
has subscribed:
- five hundred (500) new Class A Shares;
- five hundred (500) new Class B Shares;
- five hundred (500) new Class C Shares;
- five hundred (500) new Class D Shares;
- five hundred (500) new Class E Shares;
- five hundred (500) new Class F Shares;
- five hundred (500) new Class G Shares;
- five hundred (500) new Class H Shares;
- five hundred (500) new Class I Shares;
- five hundred (500) new Class J Shares;
with a nominal value of one euro (EUR 1) each and which have been paid up by a contribution in cash in an amount of

five thousand euro (EUR 5,000) and shall be entirely allocated to the share capital of the Company, so that the full amount
is as of now at the disposal of the Company, proof of which is given to the undersigned notary.

90884

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution:

The general meeting of the shareholders resolves to fully restate the articles of association of the Company which shall

read as follows:“

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form.
1.1 There exists a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name WSHP LuxCo 1

SCA (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, public offering, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities

or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders,

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the General Partner. It may be

transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting
of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the General Partner.

4.4 In the event that the General Partner determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at six million two hundred eighty-seven thousand three hundred and thirty-one

euro (EUR 6,287,331), represented by (i) one (1) unlimited share (the “Unlimited Share” and the holder thereof the “General
Partner”) and by (ii) six million two hundred eighty-seven thousand three hundred and thirty (6,287,330) ordinary shares
(the “Ordinary Shares” and the holder thereof the “Limited Partners”) divided as follows:

(i) six hundred and twenty-eight thousand seven hundred and thirty-three (628,733) class A shares (the “Class A Shares”),
(ii) six hundred and twenty-eight thousand seven hundred and thirty-three (628,733) class B shares (the “Class B Sha-

res”),

(iii)  six  hundred  and  twenty-eight  thousand  seven  hundred  and  thirty-three  (628,733)  class  C  shares  (the  “Class  C

Shares”),

(iv)  six  hundred  and  twenty-eight  thousand  seven  hundred  and  thirty-three  (628,733)  class  D  shares  (the  “Class  D

Shares”),

(v) six hundred and twenty-eight thousand seven hundred and thirty-three (628,733) class E shares (the “Class E Shares”),
(vi) six hundred and twenty-eight thousand seven hundred and thirty-three (628,733) class F shares (the “Class F Sha-

res”),

(vii) six hundred and twenty-eight thousand seven hundred and thirty-three (628,733) class G shares (the “Class G

Shares”),

90885

L

U X E M B O U R G

(viii) six hundred and twenty-eight thousand seven hundred and thirty-three (628,733) class H shares (the “Class H

Shares”),

(ix) six hundred and twenty-eight thousand seven hundred and thirty-three (628,733) class I shares (the “Class I Shares”)

and

(x) six hundred and twenty-eight thousand seven hundred and thirty-three (628,733) class J shares (the “Class J Shares”),
with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
The Unlimited Share is held by the General Partner (actionnaire commandité). The Ordinary Shares and the Unlimited

Share are hereafter together referred to as the “shares”.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s) in proportion to

the number of shares held by them in the Company's share capital. The General Partner shall determine the period of time
during which such preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from
the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription period.
Subject to the terms and conditions as may be set out in any Shareholders' Agreement, the general meeting of shareholders
may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amend-
ment of these articles of association.

5.4 Without any limitation to the foregoing, in case of plurality of Shareholders, each Shareholder shall have the right

to participate in any Additional Funding (as this term is defined here below) pro rata (based on the aggregate amount of
Ordinary Shares and PECs immediately prior to the relevant Additional Funding) and at the same terms and conditions as
those applicable to Water Street, i.e. to subscribe the same instruments to be issued in such Additional Funding (including
but not limited to shares, shareholder loans, or PECs) and in the same split as Water Street. This right to participate in any
Additional Funding shall not apply in respect of any capital increases against contribution in kind at arm's length terms by
an unrelated third party.

"Additional Funding" means any funds or capital which are made available to the Company as equity, shareholder loans

or hybrid instruments (including silent participation or other funding against profit participation rights) above and beyond
the total amounts contributed to the Company as share capital or PECs subscription as of 29 April 2015. The term Additional
Funding also comprises the aforementioned measures on the level of any subsidiary of the Company, unless such contri-
bution is made by Intermediate LuxCo, LuxCo 2, LuxCo 3, AcquiCo, Addon-AcquiCo, NZ AcquiCo, Centennial, CMH,
CMI or any other intermediate holding company, provided, that such contributing entities are and remain wholly owned
(directly or indirectly) subsidiaries of the Company.

5.5 The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.
5.6 The share capital may be reduced through cancellation of shares including by cancellation of one or more entire

class(es) through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class.

5.7 In the case of repurchases and cancellations of classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall

be made in the reverse alphabetical order (starting with the Class J Shares).

5.8 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of one or more share classes (i.e.

class J to A shares), the holders of the repurchased and cancelled class(es) of shares shall receive from the Company an
amount equal to the Cancellation Value Per Share for each of the relevant class(es) held by them and cancelled.

5.9 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account to which any share premium paid on

any share of the Company in addition to its nominal value is transferred. Any such share premium paid in by each shareholder
respectively shall be exclusively allocated to and reserved for distribution or repayment to such shareholder only. Without
prejudice to the provisions of this paragraph, the amount of the share premium account may be used to offset any net
realized losses or to allocate funds to the legal reserve.

5.10 Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will

become due and payable by the Company.

5.11 The Company may repurchase its shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by law.
5.12 For the purpose of this Article 5:
“Available Amount” means total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to which the

shareholder of the relevant class of shares would have been entitled to dividend distributions according to the provisions
of these articles of incorporation, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount
of the share premium and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses
(included carried forward losses), (ii) any sums to be placed into undistributable reserve(s) pursuant to the requirements
of law or of these articles of incorporation, each time as set out in the relevant interim accounts and (iii) any accrued and
unpaid dividends to the extent those have not already reduced the NP (without for the avoidance of doubt, any double
counting) so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + LD)
whereby:

90886

L

U X E M B O U R G

AA = Available Amount;
NP = net profits (including carried forward profits and share premium);
P = any freely distributable reserves;
CR = the amount of the share premium and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled;
L = losses (including carried forward losses);
LD = any accrued and unpaid dividends to the extent those have not already reduced the NP
LR = any sums to be placed into undistributable reserve(s) pursuant to the requirements of law or of these articles of

incorporation of the Company;

“Cancellation Value Per Share” means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the board of managers of the General Partner on the

basis of the relevant interim accounts of the Company as of a date not earlier than eight (8) days before the date of the
repurchase and cancellation of the relevant class of shares. The Total Cancellation Amount for each class of shares shall
be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved
by the board of managers provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available
Amount. The board of managers of the General Partner can choose to include or exclude in its determination of the Total
Cancellation Amount, the freely distributable share premium either in part or in totality.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.

Art. 7. Continuation of the Company - replacement of the General Partner.
7.1 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company. In the event of death, legal incapacity, dissolution, revo-
cation, resignation, hindrance, bankruptcy or any similar situation of the sole General Partner, the Company shall continue
to exist.

7.2 If any such event occurs with respect to the sole General Partner and if no replacement has been provided for

previously, any shareholder/shareholders representing 10% of the share capital shall as soon as possible convene a general
meeting of shareholders. The general meeting shall (without the approval of such General Partner but with the consent of
such replacement general partner) appoint a general partner in replacement.

7.3 A General Partner shall be appointed and may be removed as general partner at any time by a decision of the general

meeting of shareholders approved by shareholders representing more than 50 % of the Company's share capital. The sole
General Partner may only be removed if a replacement general partner is appointed at the same time.

7.4 As a consequence of such replacement, the Unlimited Share(s) held by such leaving General Partner is/are automa-

tically transferred to the newly appointed General Partner at the time of its appointment for a price equal to the subscription
price thereof. The General Partner is authorised to record such transfer in the share register of the Company.

Art. 8. Register of shares.
8.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the
relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

Art. 9. Liability of shareholders.
9.1 The Limited Shareholder(s) shall not interfere with the management of the Company vis-à-vis third parties. The

liability of the Limited Shareholders (actionnaires commanditaires) is limited to the amount of share capital for which they
have subscribed. However, Limited Shareholders are jointly and severally liable for all obligations of the Company in
which they have participated contrary to the foregoing restriction. Limited Shareholders are also jointly and severally liable
vis-à-vis third parties for all obligations of the Company in which they have not participated if they regularly act on behalf
of the Company in management matters vis-à-vis third parties. A limited partner acting as representative of the General
Partner does not, by the mere fact of acting in such capacity and to the extent that he indicates such capacity, incur the
aforementioned joint and several liability. The following matters do not constitute acts of management vis-à-vis third parties
in the sense of these articles of association:

- the exercise of shareholders' rights;
- advice given to the Company or its affiliates or their managers;
- the exercise of control and supervision of the affairs of the Company; and

90887

L

U X E M B O U R G

- granting of loans, security interests or any other assistance to the Company or its affiliates entities.
9.2 If more than one Unlimited Share is issued, its owners (actionnaires commandités) are jointly and severally liable

for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.

C. Transfer of shares

Art. 10. General principle.
10.1 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the law and of the rest of this section C.
10.2 The Unlimited Share(s) are only transferrable to unlimited shareholders jointly and severally liable for all liabilities

of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.

10.3 Any transfer of registered shares shall become effective towards the Company and third parties either (i) through

the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee
or their representatives, or (ii) upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.
The transfer of bearer shares occurs by the mere delivery of the related share certificate.

Art. 11. Shares' and/or PECs transfer offers. All Ordinary Shares and PECs held by Co-Investors are subject to an offer

to sell and transfer to Water Street, pursuant to certain terms and conditions as may be set out in any shareholders' agreement
that may exist from time to time between the shareholders and the Company (the “Shareholders' Agreement”).

Art. 12. Drag-along right and tag-along right.
12.1 If Water Street, in one or several steps, sells and transfers any of its shares and/or PECs in the Company to a

Prospective Buyer, all other Shareholders shall be obliged, at Water Street's request, (a) to take all measures and make all
declarations as are necessary or appropriate for the implementation of such sale and transfer, and (b) to sell and transfer to
the Prospective Buyer(s) a pro rata portion of their respective shares and/or PECs in the Company at the same (pro rata)
price and on the same other conditions, it being understood that the Co-Investors' liability shall in no event exceed the
proceeds actually received by the respective Co-Investor.

The transfer of the shares may be demanded only concurrently against payment of the purchase price or other conside-

ration.

12.2 If Water Street decides to sell and transfer any of its shares or PECs in the Company to a Prospective Buyer, Water

Street is obliged towards the other Shareholders to agree with the Prospective Buyer(s) that the latter must offer to the other
Shareholders to acquire a pro rata portion of their respective shares and PECs in the Company at the same (pro rata) price
and on the same or more favourable other conditions.

If the Prospective Buyer is not prepared to purchase and acquire all cosellers' shares and PECs as well as all Water

Street's shares and PECs offered to him, Water Street shall be obliged to sell and transfer such portions of the offered co-
sellers' shares and PECs as well as Water Street's shares and PECs pro-rata as regards their respective percentage ownership
in the Company's registered share capital.

12.3 Article 12.1 and Article 12.2 shall apply accordingly with respect to any other equity, debt or hybrid instrument

issued to a Shareholder in an Additional Funding according to Article 5.4.

12.4 Article 12.1 and Article 12.2 shall not apply to sales or transfers to (a) funds or entities which are advised or managed

by Water Street or their subsidiaries, provided, that they accede to any Shareholders' Agreement, as a party, (b) Water
Street, (c) a Co-Investor, (d) a Manager, and (e) wives, descendants and family trusts or the like of Dr. Becker, Dr. Berg,
Mrs. Cook and Mr. Cook. Article 12.1 and Article 12.2 shall only apply to sales or transfers in an IPO if and to the extent
such sales and transfers do not conflict with customary lock-up provisions as requested by the underwriter.

Art. 13. Transfer restrictions. Any transfer of shares or PECs of the Company held by Shareholders other than Water

Street may require, for a specific period of time, prior written consent of the General Partner as may be set out in any
Shareholders' Agreement.

D. General meetings of Shareholders

Art. 14. Powers of the general meeting of shareholders. The shareholders exercise their collective rights in the general

meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the
entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly
reserved to it by the Law and by these articles of association.

Art. 15. Convening of general meetings of shareholders.
15.1 The general meeting of shareholders may at any time be convened by the General Partner or, as the case may be,

by the Supervisory Board (as defined below).

15.2  It  must  be  convened  by  the  General  Partner  or  the  Supervisory  Board  upon  written  request  of  one  or  several

shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of
shareholders shall be held within a period of one (1) month from receipt of such request.

15.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of

the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and
eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.

90888

L

U X E M B O U R G

Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality
has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by
registered letters only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date
scheduled for the meeting

15.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any

convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 16. Conduct of general meetings of shareholders.
16.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company,

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the second Tuesday
in the month of April at 11:00 am o'clock. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the
next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices.

16.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary

and a scrutineer who need neither be shareholders nor the General Partner. If all the shareholders present at the general
meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide to only appoint
(i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case there is no need
to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the “board of the meeting” shall in such case be construed as a
reference to the “chairman and secretary” or, as the case may be, to the “single person who assumes the role of the board”,
depending on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in
accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requi-
rements, vote tallying and representation of shareholders.

16.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
16.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.

16.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video-conference or by any other means of

communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.

16.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile

or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice.
The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of
the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three
boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

16.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the

proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account
voting forms received prior to the general meeting to which they relate.

Art. 17. General Partner and Orgentec Holding consent.
17.1 The consent of the General Partner is not required for acts of the general meeting of shareholders affecting the

interests of the Company vis-à-vis third parties or amendments of the articles of association.

17.2 As long as Orgentec Holding and SB Holding jointly hold at least twenty percent (20 %) of the Company's Ordinary

Shares, the following shall apply:

- All matters requiring under the Law, at first call, a shareholder(s) resolution with a majority of at least two-third (2/3)

of the votes cast at a general meeting where more than half (1/2) of the share capital is present or represented according to
the present articles of association or mandatory law, shall require the consent of Orgentec Holding;

- All matters regarding changes to the present articles of association and the liability of the Co-Investors (e.g. issuance

of senior ranking PECs or shares other than for Additional Fundings in case of Emergency Funding Events), which in each
case are to the detriment of the Co-Investors, shall require the consent of Orgentec Holding.

- Any issuance of shares or options to additional employees or directors of the Company or any of its subsidiaries in

excess of an amount of 10% of the capital of the ordinary shares of the Company from time to time, shall require the consent
of Orgentec Holding.

Art. 18. Quorum and vote.
18.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.
18.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of sha-

reholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

90889

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein and without prejudice to Article

16 of these articles of association, these articles of association may be amended by a majority of at least two thirds of the
votes validly cast at a general meeting at which a quorum of more than half of the Company's share capital is present or
represented. If no quorum is reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and
these articles of association which may deliberate and without prejudice to Article 16 of these articles of association,
regardless of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast.
Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 20. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 21. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the General Partner may

adjourn any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The General Partner shall do so at the
request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an
adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

Art. 22. Minutes of general meetings of shareholders.
22.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by

the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

22.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the General Partner.

E. Management

Art. 23. Powers of the General Partner(s).
23.1 The Company shall be managed by the General Partner.
23.2 The General Partner shall be appointed and may be removed from office at any time, by a decision of the general

meeting of shareholders approved by shareholders representing more than 50 % of the Company's share capital. Article 7
shall apply.

23.3 The General Partner is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board.

Art. 24. Dealing with third parties.
24.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the sole signature of the General

Partner or by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been
delegated by the General Partner within the limits of such delegation.

F. Supervision of the company

Art. 25. Supervisory Board and independent auditor.
25.1 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of a supervisory board (the “Supervisory Board”) shall
be suppressed, except if expressly otherwise decided by the shareholders of the Company.

25.2 Any independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his

approval.

G. Financial year - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the General Partner draws up an inventory of assets

and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

27.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

27.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

27.5 Without prejudice to the foregoing, any distributable profits of the Company after application to any statutory

reserves, to be distributed prior to an Exit, shall be distributed in the following order and ranking:

90890

L

U X E M B O U R G

a. Firstly, the subscribers of the Vendor Notes shall receive on a pro rata and pari passu basis any outstanding principal

amount plus accrued interest under the Vendor Notes, irrespective of whether (i) the Vendor Notes are due in accordance
with their terms and (ii) the Vendor Notes have been released pursuant to the relevant terms and conditions as may be set
out in any Subordination Agreement.

b.  Secondly,  the  lenders  of  shareholder  loans  (if  any)  to  the  Target  Group  shall  receive  the  respective  outstanding

principal loan amounts plus accrued interest thereon on a pro rata (based on the aggregate principal amounts of such
shareholder loans) and pari passu basis until the lenders have received the full amount of the loans and the accrued interest.

c. Thirdly, the remaining distributable profits shall be paid to the holders of hybrid instruments such as PECs on a pro

rata basis and pari passu basis, until the holders of such hybrid instruments have received the full amount and the accu-
mulated and unpaid interests.

d. Fourthly, the remaining distributable profits shall be paid to the holders of Ordinary Shares in the following order of

priority:

- first, the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an

amount of zero point ten per cent (0.10%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,

- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point eleven per cent (0.11%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,

- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point twelve per cent (0.12%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,

- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point thirteen per cent (0.13%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,

- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fourteen per cent (0.14%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then,

- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then

- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point sixteen per cent (0.16%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then

- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point seventeen per cent (0.17%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then

- the holders of Class I Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point eighteen per cent (0.18%) of the nominal value of the Class I Shares, and then,

- the holders of Class J Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding class of shares (by reverse alphabetical order, e.g. initially Class J Shares) have been

cancelled following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend
distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g.
after the first cancellation, Class I Shares).

27.6 If and to the extent there has been an Additional Funding (in which all the Shareholders have the right to participate

according to Article 5.4) as a result of an Emergency Funding Event, such Shareholders who have decided to participate,
shall rank senior to the other holders of PECs or Ordinary Shares (for the avoidance of doubt: also senior to the Vendor
Notes or any shareholder loan) with regard to such Additional Funding and shall receive, out of the distributable profits of
the Company after application to any statutory reserves, (i) in case the Additional Funding has been provided by way of
debt funding the respective nominal loan amounts plus accrued unpaid interest thereon and/or (ii) in case the Additional
Funding has been provided through equity funding, the nominal amount of such equity instruments and any distributable
reserves and/or profits attached thereto, in each case pro rata (based on the aggregate (nominal) amounts of the relevant
Additional Funding and the relevant equity instrument of such Additional Funding) and a pari passu basis. In case of more
than one Additional Funding as a result of an Emergency Funding Event, they shall rank in inverse order, starting with the
latest Additional Funding. For the avoidance of doubt, with respect to any Additional Funding other than as a result of an
Emergency Funding Event (e.g. in order to finance add-on acquisitions), Article 27.5 shall apply.

"Emergency Funding Event" shall mean:
a. the Company or any Target is unable to pay its debts as they come due;
b. any third party financing, which finances or refinances the acquisition of the Targets or any add-on acquisition, has

become or will immediately become due for prepayment before the final maturity thereof;

c. the Company or any Target has received written notice from the lenders that any third party financing, which finances

or refinances the acquisition of the Targets or any add-on acquisition, will, within less than three (3) months, become due
for repayment before the final maturity thereof; or

d. an uncured breach of a financial covenant under any third party financing, which finances or refinances the acquisition

of the Targets or any add-on acquisition, occurs.

27.7 Upon recommendation of the General Partner, the general meeting of shareholders shall determine how any re-

mainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

90891

L

U X E M B O U R G

Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The General Partner may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.
28.2 Any share premium, assimilated premium, or other distributable reserve may be freely distributed to the sharehol-

ders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

H. Exit

Art. 29. Exit.
29.1 In case of an Exit (as defined below) any net proceeds (i.e. after repayment of any third party debt and deduction

of reasonable transaction costs and expenses incurred by the Company and Water Street as well as the Co-Investors in
connection with the Exit) shall be allocated and paid to the Shareholders and the subscribers of the Vendor Notes in the
following order and ranking:

a. Firstly, the subscribers of the Vendor Notes shall receive on a pro rata and pari passu basis any outstanding principal

amount plus accrued interest under the Vendor Notes, irrespective of whether (i) the Vendor Notes are due in accordance
with their terms and (ii) the Vendor Notes have been released pursuant to the relevant terms and conditions as may be set
out in any Subordination Agreement.

b.  Secondly,  the  lenders  of  shareholder  loans  (if  any)  to  the  Target  Group  shall  receive  the  respective  outstanding

principal loan amounts plus accrued interest thereon on a pro rata (based on the aggregate principal amounts of such
shareholder loans) and pari passu basis until the lenders have received the full amount of the loans and the accrued interest,
provided, that the shareholder loans are sold in connection with the Exit and the lenders do not receive a separate com-
pensation or repayment in addition to the purchase price for the Exit transaction.

c. Thirdly, the remaining net proceeds shall be paid to the holders of hybrid instruments such as PECs on a pro rata basis

and pari passu basis, until the holders of such hybrid instruments have received the full amount and the accumulated and
unpaid interest.

d. Fourthly, the remaining net proceeds shall be paid to the holders of Ordinary Shares (based on the aggregate number

of Ordinary Shares) following the procedure set out under Article 27.5 (d) mutatis mutandis.

29.2 Article 27.6 shall apply accordingly.
29.3 "Exit" shall mean the sale of all or substantially all of the shares in the Company, Intermediate LuxCo, LuxCo 2,

LuxCo 3, AcquiCo, the Targets, Addon-Acquico, NZ Acquico or Arotec (share deal) or all or substantially all of the assets
of the Target Group (asset deal) to a bona fide third party (the "Prospective Buyer") as well as any transaction which has
a similar economic effect (e.g., the liquidation of the Company) unless the transaction is structured in a way that the
Shareholders, being shareholders in the Company immediately prior to such merger or transaction(s), hold more than 50%
of the voting rights in the surviving entity.

29.4 As far as the costs in connection with a disposal of the business or shares are not borne by the Company, the costs

shall be borne by the selling Shareholders in proportion to their sold Ordinary Shares in the Company.

29.5 In the event of a sale of part of the shares in the Company (other than a sale permitted under Article 12.4), the net

proceeds  shall  also  be  allocated  according  to  Article  29.1  but  only  to  the  subscribers  of  the  Vendor  Notes  and  those
Shareholders who have sold shares in proportion to their relevant shares sold.

29.6 Upon the occurrence of an Insolvency Event affecting all the operating subsidiaries of the Company, the Share-

holders shall use all reasonable efforts to secure that any remaining proceeds from such insolvency shall, to the extent
permitted by applicable law, be distributed to the Shareholders and the subscribers of the Vendor Notes in accordance with
clause 29.1.

I. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders, deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities
of the Company.

J. Governing law

Art. 31. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

K. Definitions

Art. 32. General definitions. "Additional Funding" has the meaning assigned to it under Article 5.4.
“AcquiCo” means WSHP Holding GmbH, registered with the commercial register of the local court of Munich under

HRB 210402, and its successor.

“Addon-Acquico”  means  WSHP  NZ  Holding  GmbH,  registered  with  the  commercial  register  of  the  local  court  of

Munich under HRB 212849, and its successor

90892

L

U X E M B O U R G

“Arotec” means AROTEC Diagnostics Limited, incorporated in New Zealand and having its registered address at Raroa

Accountants Ltd, 14 Leary Street, Melling, Lower Hutt, 5010, New Zealand, and its successor.

“Available Amount” has the meaning assigned to it under Article 5.12.
“Cancellation Value Per Share” has the meaning assigned to it under Article 5.12.
“Centennial” means Centennial Medical Holding Corp., a corporation incorporated and existing under the laws of the

state of Delaware, and its successor.

“Class A Shares” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“Class B Shares” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“Class C Shares” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“Class D Shares” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“Class E Shares” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“Class F Shares” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“Class G Shares” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“Class H Shares” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“Class I Shares” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“Class J Shares” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“CMH” means a direct subsidiary of Centennial, Centennial Medical Holdings, Inc., a company incorporated in Dela-

ware, having its registered office at 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, USA, and its successor.

“CMI” means a direct subsidiary of CMH, Centennial Medical Integrated, Inc., a company incorporated in Nevada,

having its registered office at 311 S. Division Street Carson City, NV 89703, USA, and its successor

“Co-Investors” means SB Holding, Orgentec Holding and Cook SPV.
“Corgenix” means Corgenix Medical Corporation, a company incorporated in Nevada, having its registered office at

311 S. Division Street Carson City, NV 8970, USA and its successor.

“Company” has the meaning assigned to it under Article 1.1.
“Cook SPV” means Doneco Limited, a company incorporated in New Zealand, having its registered office at 16 Wai-

iti Crescent, Lower Hutt, Wellington, 5010, New Zealand, and its successor.

“Dr. Berg” means Dr. Wigbert Berg.
“Dr. Becker” means Dr. Stephan Becker.
"Emergency Funding Event" has the meaning assigned to it under Article 27.6.
"Exit" has the meaning assigned to it under Article 29.3.
“General Partner” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“IPO” means the public offering and initial listing of the Company's shares or the shares of another existing or newly

established holding company of the Target Group (in which the Shareholders directly or indirectly hold interests in the
same economic proportion as at such time in the Company) at any reputable stock exchange.

“Insolvency Event” shall have the same meaning, for the purpose of Article 29.6, as may be set out in any Subordination

Agreement.

“Intermediate LuxCo” means WSHP Intermediate Holding Sarl, a société à responsabilité limitée incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register
under number B 193.867, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, and its successor.

“Law” has the meaning assigned to it under Article 1.1.
“Limited Partner” has the meaning assigned to it under Article 5.1.
“LuxCo 2” means WSHP LuxCo 2 Sàrl, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 186.941,
having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, and its successor.

“LuxCo 3” means WSHP LuxCo 3 Sàrl, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 187.167,
having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, and its successor.

“Managers” means any directors or employees of the Company or any of its subsidiaries who has acquired shares in the

Company and has acceded to any Shareholders' Agreement, as the case may be.

“Mr. Cook” means Mr. Neil Cook.
“Mrs. Cook” means Mrs. Doris Echelmeier Cook.
“NZ Acquico” means WSHP Holding Limited, registered with the registrar of companies of New Zealand under number

9429041492963, and its successor

“Ordinary Shares” has the meaning assigned to it under Article 5.1.

90893

L

U X E M B O U R G

“Orgentec Holding” means ORGENTEC Holding GmbH, registered with the commercial register of the local court of

Mainz under HRB 41710, with business address at Carl-Zeiss-Straße 49, 55129 Mainz, and its successor.

“PEC” means preferred equity certificates, as issued by the Company from time to time.
“Prospective Buyer” has the meaning assigned to it under Article 29.2
“SB Holding” means SB Holding GmbH, registered with the commercial register of the local court of Darmstadt under

HRB 92833, with business address at Heinrich-Engel-Straße 49a, 64572 Büttelborn, and its successor.

“Shareholders” means (i) Water Street, (ii) the Co-Investors and (iii) the Managers.
“Shareholders' Agreement” has the meaning assigned to it under Article 11.
“Targets” means (i) Orgentec Diagnostika GmbH, registered in the commercial register at the local court (Amtsgericht)

of Mainz under HRB 4300 and (ii) Orgentec Capital GmbH, registered in the commercial register at the local court (Amts-
gericht) of Mainz under HRB 8449, and their respective successors.

“Target Group” means Intermediate LuxCo, LuxCo 2, LuxCo 3, AcquiCo, Addon-Acquico, NZ Acquico, the Targets,

Centennial, CMH, CMI, Arotec and Corgenix as well as any current and future direct and indirect subsidiaries of the
Company which the Company directly or indirectly controls within the meaning of article 309 of the Law.

“Subordination Agreement” means any subordination agreement that may exist from time to time between inter alia

Cook SPV and Dr. Berg as original subordinated creditors, NZ Acquico as NZ borrower and LuxCo 3 as agent for the
obligors (as amended, restated, varied, novated, supplemented or extended from time to time).

“Total Cancellation Amount” has the meaning assigned to it under Article 5.12
“Unlimited Share” has the meaning assigned to it under Article 5.1
“Vendor Notes” means the vendor notes, as issued by NZ Acquico from time to time.
“Water Street” means WSHP Orgentec Holdco Ltd., a Cayman Islands exempted limited company, having its registered

office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands, and its successor.”

There being no further business, the meeting is closed at 6.30 p.m.

Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing persons,

this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing persons and in case of
divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the above appearing persons, known to the notary, such persons signed together with

the notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-neuf avril,
par devant Maître Marc Loesch, notaire, de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-duché de Luxembourg,

s'est déroulée

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WSHP LuxCo 1 SCA, une société en commandite par actions

de droit luxembourgeois, existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.854,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 30 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés
et associations le 14 juillet 2014 sous le numéro 1832 (ci-après la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 28 novembre 2014, suivant acte reçu par le notaire

soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations le 20 décembre 2014 sous le numéro 3956.

L'assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Maître Philippe Harles, résidant professionnellement à

Luxembourg,

lequel désigne comme secrétaire Monsieur David Al Mari, résidant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit Madame Caroline Halemberg, résidant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.
L'assemblée étant ainsi constituée, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter I- Que l'ordre du jour

de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent soixante-treize mille huit cent cinquante euros

(EUR 173.850), afin de le porter de son montant actuel de six millions cent treize mille quatre cent quatre-vingt-un euros
(EUR 6.113.481) à six millions deux cent quatre-vingt-sept mille trois cent trente et un euros (EUR 6.287.331) par l'émission
de:

- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles Actions de Classe A;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles Actions de Classe B;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles Actions de Classe C;

90894

L

U X E M B O U R G

- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles Actions de Classe D;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles Actions de Classe E;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles Actions de Classe F;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles Actions de Classe G;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles Actions de Classe H;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles Actions de Classe I; et
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles Actions de Classe J;
ayant chacune une valeur nominale d'un d'Euro (EUR 1).
2. Refonte des statuts de la Société.
3. Divers.
II- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés le cas échéant, ainsi que

le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents ou les mandataires des actionnaires ainsi que les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La procuration des actionnaires représentés, signée ne varietur, par les personnes comparantes restera attachée à cet acte.
III- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur ont été communiqués au préalable et avoir renoncé à toute procédure de
convocation.

IV- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, demande au notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale reconnaît que les actionnaires de la Société, (i) WSHP Orgentec Holdco, Ltd., une exempted

limited company des Iles Caïmans, ayant son siège social au c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland
House, George Town, Grand Cayman, KYI-1104 Cayman Islands, (ii) WSHP GP Sàrl, une société à responsabilité limitée
constituée et existante sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.813, (iii) ORGENTEC Holding
GmbH, une Gesellschaft mit beschränkter Haftun constituée et existante sous les lois de l'Allemagne et ayant son siège
social à Carl-Zeiss-Strasse 49, 55129 Mainz, Allemagne, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Mainz sous
le numéro HRB 41710, et (iv) SB Holding GmbH, une Gesellschaft mit beschränkter Haftun constituée et existante sous
les lois de l'Allemagne et ayant son siège social à Heinrich-Engel-Strasse 49a, 64572 Büttelborn, Allemagne, inscrit au
Registre de Commerce et des Sociétés de Darmstadt sous le numéro HRB 92833, et (v) Doneco Limited, une société à
responsabilité limitée constituée et existante sous les lois de la Nouvelle Zélande, ayant son siège social au 16 Wai-iti
Crescent, Lower Hutt, Wellington, 5010, Nouvelle Zélande, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de la Nouvelle
Zélande sous le numéro NZBN 9429041489208, ont renoncé à leurs droits préférentiels de souscription dans le cadre de
l'augmentation de capital proposée.

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent soixante-

treize mille huit cent cinquante euros (EUR 173.850), afin de le porter de son montant actuel de six millions cent treize
mille quatre cent quatre-vingt-un euros (EUR 6.113.481) jusqu'au montant de six million deux cent quatre-vingt-sept mille
trois cent trente et un euros (EUR 6.287.331) par l'émission de:

- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles actions de Classe A;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles actions de Classe B;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles actions de Classe C;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles actions de Classe D;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles actions de Classe E;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles actions de Classe F;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles actions de Classe G;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles actions de Classe H;
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles actions de Classe I; et
- dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (17.385) nouvelles actions de Classe J;
ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (EUR 1).
Les nouvelles parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit:
1. WSHP Orgentec Holdco, Ltd., prénommé,
ici représentée par Maître Philippe Harles,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 24 avril 2015, qui restera annexée au présent acte,

90895

L

U X E M B O U R G

souscrit à:
- onze mille neuf cent onze (11.911) nouvelles Actions de Classe A
- onze mille neuf cent onze (11.911) nouvelles Actions de Classe B;
- onze mille neuf cent onze (11.911) nouvelles Actions de Classe C;
- onze mille neuf cent onze (11.911) nouvelles Actions de Classe D;
- onze mille neuf cent onze (11.911) nouvelles Actions de Classe E;
- onze mille neuf cent onze (11.911) nouvelles Actions de Classe F;
- onze mille neuf cent onze (11.911) nouvelles Actions de Classe G;
- onze mille neuf cent onze (11.911) nouvelles Actions de Classe H;
- onze mille neuf cent onze (11.911) nouvelles Actions de Classe I; et
- onze mille neuf cent onze (11.911) nouvelles Actions de Classe J;
ayant chacune une valeur nominale d'un d'Euro (EUR 1) et ont été entièrement payées en numéraires pour un montant

de cent dix-neuf mille cent dix euros (EUR 119.110), qui doit être alloué au capital social de la Société de telle sorte que
le montant est maintenant à disposition de la Société, ce dont la preuve est soumise au notaire soussigné.

2. ORGENTEC Holding GmbH, prénommé,
ici représentée par Maître Philippe Harles,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 avril 2015, qui restera annexée au présent acte,
souscrit à:
- quatre mille deux cent soixante-dix-sept (4.277) nouvelles Actions de Classe A;
- quatre mille deux cent soixante-dix-sept (4.277) nouvelles Actions de Classe B;
- quatre mille deux cent soixante-dix-sept (4.277) nouvelles Actions de Classe C;
- quatre mille deux cent soixante-dix-sept (4.277) nouvelles Actions de Classe D;
- quatre mille deux cent soixante-dix-sept (4.277) nouvelles Actions de Classe E;
- quatre mille deux cent soixante-dix-sept (4.277) nouvelles Actions de Classe F;
- quatre mille deux cent soixante-dix-sept (4.277) nouvelles Actions de Classe G;
- quatre mille deux cent soixante-dix-sept (4.277) nouvelles Actions de Classe H;
- quatre mille deux cent soixante-dix-sept (4.277) nouvelles Actions de Classe I; et
- quatre mille deux cent soixante-dix-sept (4.277) nouvelles Actions de Classe J;
ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) et ont été entièrement payées en numéraires pour un montant de

quarante-deux mille sept cent soixante-dix euros (EUR 42.770), qui doit être alloué au capital social de la Société de telle
sorte que le montant est maintenant à disposition de la Société, ce dont la preuve est soumise au notaire soussigné.

3. SB Holding Gmbh, prénommé,
ici représentée par Maître Philippe Harles,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 avril 2015, qui restera annexée au présent acte,
souscrit à:
- six cent quatre-vingt-dix-sept (697) nouvelles Actions de Classe A;
- six cent quatre-vingt-dix-sept (697) nouvelles Actions de Classe B;
- six cent quatre-vingt-dix-sept (697) nouvelles Actions de Classe C;
- six cent quatre-vingt-dix-sept (697) nouvelles Actions de Classe D;
- six cent quatre-vingt-dix-sept (697) nouvelles Actions de Classe E;
- six cent quatre-vingt-dix-sept (697) nouvelles Actions de Classe F;
- six cent quatre-vingt-dix-sept (697) nouvelles Actions de Classe G;
- six cent quatre-vingt-dix-sept (697) nouvelles Actions de Classe H;
- six cent quatre-vingt-dix-sept (697) nouvelles Actions de Classe I; et
- six cent quatre-vingt-dix-sept (697) nouvelles Actions de Classe J;
ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) et ont été entièrement payées en numéraires pour un montant de

six mille neuf cent soixante-dix euros (EUR 6.970), qui doit être alloué au capital social de la Société de telle sorte que le
montant est maintenant à disposition de la Société, ce dont la preuve est soumise au notaire soussigné.

4. Doneco Limited, prénommé,
ici représentée par Maître Philippe Harles,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 avril 2015, qui restera annexée au présent acte, souscrit à:
- cinq cent (500) nouvelles Actions de Classe A;
- cinq cent (500) nouvelles Actions de Classe B;
- cinq cent (500) nouvelles Actions de Classe C;

90896

L

U X E M B O U R G

- cinq cent (500) nouvelles Actions de Classe D;
- cinq cent (500) nouvelles Actions de Classe E;
- cinq cent (500) nouvelles Actions de Classe F;
- cinq cent (500) nouvelles Actions de Classe G;
- cinq cent (500) nouvelles Actions de Classe H;
- cinq cent (500) nouvelles Actions de Classe I; et
- cinq cent (500) nouvelles Actions de Classe J;
ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) et ont été entièrement payées en numéraires pour un montant de

cinq mille euros (EUR 5.000), qui doit être alloué au capital social de la Société de telle sorte que le montant est maintenant
à disposition de la Société, ce dont la preuve est soumise au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée générale des actionnaires décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société qui auront la

teneur suivante:

«A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.

1.1 Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination «WSHP LuxCo 1 SCA» (ci-après la «Société»)

qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'ad-
ministration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations en vue de sa réalisation par la
vente, l'appel public à l'épargne, l'échange ou autre.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des

sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte

d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en
émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle pourra être dissoute à tout moment avec et sans cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires,

prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision de l'Actionnaire Commandité. Il

pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des
actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision de

l'Actionnaire Commandité.

4.4 Dans l'hypothèse où l'Actionnaire Commandité estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,

économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la
cessation  complète  de  ces  circonstances  exceptionnelles;  ces  mesures  provisoires  n'auront  toutefois  aucun  effet  sur  la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à six millions deux cent quatre-vingt-sept mille trois cent trente et un euros

(EUR 6.287.331), représenté par (i) une (1) action de commandité («l'Action de Commandité» et son titulaire «l'Actionnaire
Commandité») et par six millions deux cent quatre-vingt-sept mille trois cent trente (6.287.330) actions ordinaires (les
«Actions Ordinaires» et leurs titulaires les «Actionnaire Commanditaire») y sont divisés comme suit:

90897

L

U X E M B O U R G

a. six cent vingt-huit mille sept cent trente-trois (628.733) actions de classe A («Actions de Classe A»),
b. six cent vingt-huit mille sept cent trente-trois (628.733) actions de classe B («Actions de Classe B»),
c. six cent vingt-huit mille sept cent trente-trois (628.733) actions de classe C («Actions de Classe C»),
d. six cent vingt-huit mille sept cent trente-trois (628.733) actions de classe D («Actions de Classe D»),
e. six cent vingt-huit mille sept cent trente-trois (628.733) actions de classe E («Actions de Classe E»),
f. six cent vingt-huit mille sept cent trente-trois (628.733) actions de classe F («Actions de Classe F»),
g. six cent vingt-huit mille sept cent trente-trois (628.733) actions de classe G («Actions de Classe G»),
h. six cent vingt-huit mille sept cent trente-trois (628.733) actions de classe H («Actions de Classe H»),
i. six cent vingt-huit mille sept cent trente-trois (628.733) actions de classe I («Actions de Classe I») and
j. six cent vingt-huit mille sept cent trente-trois (628.733) actions de classe J («Actions de Classe J»),
d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
L'Action de Commandité est détenue par l'Actionnaire Commandité. Les Actions Ordinaires et l'Action de Commandité

sont désignées ensemble ci-après les «actions».

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires

de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts.

5.3 Toutes nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à (aux) (l') actionnaire(s) existant

(s) en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. L'Actionnaire Commandité doit
déterminer la période au cours de laquelle ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé, qui ne peut être inférieure
à trente (30) jours à compter de l'envoi à chaque actionnaire d'une lettre recommandée annonçant l'ouverture de la période
de souscription. Sous réserve des termes et conditions éventuellement décrits dans un Pacte d'Actionnaire, l'assemblée
générale  des  actionnaires  peut  restreindre  ou  supprimer  le  droit  préférentiel  de  souscription  de  (des)  (l')actionnaire(s)
existant(s) conformément aux dispositions applicables en matière de modification des statuts.

5.4 Sans limitation de ce qui précède, en cas de pluralité d'Actionnaires, chaque Actionnaire a le droit de participer à

tout Financement Supplémentaire (tel que ce terme est défini ci-dessous) au prorata (sur la base du montant total d'Actions
Ordinaires et PEC immédiatement avant le Financement Supplémentaire pertinent) et suivant les mêmes termes et condi-
tions  que  ceux  applicables  à  Water  Street,  c'est-à-dire  souscrire  aux  mêmes  instruments  qui  seront  émis  dans  un  tel
Financement Supplémentaire (comprenant, sans se limiter à, des actions, des prêts d'actionnaires, ou des PECs) et suivant
la même répartition que Water Street. Ce droit de participer à tout Financement Supplémentaire ne s'applique pas à l'égard
des augmentations de capital contre contribution en nature effectuées par une tierce partie non liée, suivant les conditions
de pleine concurrence.

«Financement Supplémentaire» s'entend de tous fonds ou capitaux mis à la disposition de la Société sous la forme de

capitaux propres, dettes d'actionnaires ou instruments hybrides (y inclus les participations silencieuses ou autres finance-
ments effectués en contrepartie de droit de participation aux profits) en supplément et au-delà des montants totaux apportés
à la Société à titre de capital social ou souscription de PECs au 29 avril 2015. Le terme de Financement Supplémentaire
comprend également les mesures mentionnées ci-dessus au niveau de toute filiale de la Société, à moins que cette contri-
bution soit effectuée par la LuxCo Intermédiaire, LuxCo 2, LuxCo 3, AcquiCo, Addon-AcquiCo, NZ AcquiCo, Centennial,
CMH, CMI ou toute autre société holding intermédiaire, à condition que ces entités soient et restent exclusivement détenues
(directement ou indirectement) par la Société.

5.5 La Société peut racheter ses propres actions, dans les conditions prévues par la Loi.
5.6 Le capital social de la Société peut être réduit par le biais d'une annulation d'actions, y compris par annulation d'une

ou plusieurs classe(s) par le rachat ou l'annulation de toutes les actions émises dans cette classe.

5.7 En cas de rachat ou d'annulation de classes d'actions, ces annulations et rachats d'actions doivent être réalisés dans

l'ordre inverse de l'ordre alphabétique (en commençant par les Actions de Classe J).

5.8 Dans le cas d'une réduction de capital social par le biais d'un rachat ou d'une annulation d'une ou plusieurs classe(s)

(c'est-à-dire Classe J à Classe A), les détenteurs de cette/ces classe(s) d'actions auront droit à un montant équivalent à la
Valeur d'Annulation Par Action pour chaque classe(s) détenue(s) par eux et annulée(s).

5.9 Outre le capital social émis, il peut être constitué un compte de prime d'émission auquel toute prime d'émission

payée sur toute action de la Société en surplus de sa valeur nominale est transférée.

Toute prime d'émission payée par chaque actionnaire doit être exclusivement affectée et réservée à la distribution ou au

remboursement de cet actionnaire.

Sans préjudice des dispositions du présent paragraphe, le montant du compte de prime d'émission peut être utilisé pour

compenser les pertes nettes réalisées ou d'allouer des fonds à la réserve légale.

5.10 Suite au rachat et annulation d'actions des classes concernées, la Valeur d'Annulation par Action sera due et payable

par la Société.

5.11 La Société peut racheter ses actions comme disposé dans les présents statuts, seulement dans la mesure permise

par la loi.

5.12 Aux fins du présent Article 5:

90898

L

U X E M B O U R G

“Montant Disponible” signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) qui

auraient donné lieu à une distribution de dividendes aux actionnaires, aux conditions fixées par les présents statuts, augmenté
par (i) toute réserve librement distribuable et (ii) le cas échéant augmenté du montant de la prime d'émission et de la réserve
légale en relation avec la classe d'actions devant être annulées, mais réduit par (i) toute perte (y compris les pertes reportées),
(ii) toutes sommes devant être allouées à (aux) (la) réserve(s) non distribuable(s) suivant les provisions légales ou statutaires,
figurant à chaque fois dans les comptes intérimaires et (iii) tout dividende accumulé et non payé dans la mesure où celui-
ci n'a pas encore réduit les NP (sans, pour dissiper tout doute, double comptage) de telle sorte que:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + LD)
Où:
AA = Montant Disponible.
NP = Bénéfices Nets (y compris bénéfices nets reportés et prime d'émission).
P = toute réserve librement distribuable.
CR = le montant de la réduction de la prime d'émission et la réduction de la réserve légale relative à la classe d'actions

devant être annulée.

L = pertes (y compris les pertes reportées).
LD = tous dividendes accumulés et non payés dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore réduit les NP.
LR = toutes sommes à allouer aux réserves non distribuable(s) suivant les dispositions légales ou statutaires.
“Valeur d'Annulation par Action” sera calculée par la division du Montant Total d'Annulation par le nombre d'actions

émises dans la classe d'actions devant être rachetée et annulée.»

“Montant Total d'Annulation” signifie le montant déterminé par le conseil de gérance de l'Actionnaire Commandité sur

base  des  comptes  intérimaires  de  la  Société  qui  ne  peut  être  antérieure  à  huit  (8)  jours  avant  la  date  du  rachat  ou  de
l'annulation  des  actions  concernées.  Le  Montant  Total  d'Annulation  pour  chaque  classe  d'actions  doit  être  le  Montant
Disponible pour la classe d'actions concernée, sauf si le conseil de gérance en décide autrement, sans toutefois que le
Montant total d'Annulation ne puisse jamais être plus élevé que ce Montant Disponible. Le conseil de gérance de l'Ac-
tionnaire  Commandité  peut  choisir  d'inclure  ou  d'exclure  dans  la  fixation  du  Montant  Total  d'Annulation,  la  prime
d'émission librement distribuable soit en entier soit en partie.

Art. 6. Actions.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les actions de la Société sont nominatives.

Art. 7. Continuation de la Société - remplacement de l'Actionnaire Commandité.
7.1 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre

événement similaire concernant un actionnaire n'entraîne pas la dissolution de la Société. En cas de décès, de dissolution,
d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'évènement similaire dans le chef de l'Ac-
tionnaire Commandité, la Société continuera à exister.

7.2 En cas de survenance de l'un de ces évènements dans le chef de l'Actionnaire Commandité unique et s'il n'a pas déjà

été pourvu à son remplacement, le tout actionnaire/ actionnaires représentant 10% du capital social doi(ven)t dès que
possible convoquer une assemblée générale d'actionnaires dans les meilleurs délais. L'assemblée générale doit (sans l'accord
de l'Actionnaire Commandité mais avec l'accord de cet actionnaire commandité remplaçant) nommer un actionnaire com-
mandité remplaçant.

7.3 Un Actionnaire Commandité peut être révoqué en tant qu'actionnaire commandité à tout moment par une décision

de l'assemblée générale des actionnaires prise à une majorité de plus de 50% du capital social de la Société. L'Actionnaire
Commandité unique ne peut être révoqué que si un actionnaire commandité remplaçant est nommé concomitamment.

7.4 En conséquence de ce remplacement, l'Action (les Actions) de Commandité détenue(s) par cet Actionnaire Com-

mandité sortant est/sont automatiquement transférée(s) à l'Actionnaire Commandité fraîchement nommé, au moment de
sa nomination, pour un prix égal au prix de souscription correspondant. Tout Gérant, agissant à titre individuel, est autorisé
à retranscrire ce transfert/ cette cession dans le registre des actions de la Société.

Art. 8. Registre des actions.
8.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il sera mis à disposition de chaque actionnaire pour

consultation. Ce registre devra contenir toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription seront émis
sur demande et aux frais de l'actionnaire demandeur.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par action. Les copropriétaires indivis devront désigner un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés
à cette action, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

Art. 9. Responsabilité des actionnaires.
9.1 L'Actionnaire Commanditaire ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la Société vis-à-vis des tiers. La responsabilité

des Actionnaires Commanditaires est limitée au montant du capital qu'ils ont souscrit. Cependant, les Actionnaires Com-

90899

L

U X E M B O U R G

manditaires sont indéfiniment et solidairement tenus à l'égard des tiers de tous les engagements de la Société auxquels ils
auraient participé en méconnaissance de l'interdiction susmentionnée. Les Actionnaires Commanditaires sont également
tenus indéfiniment et solidairement des engagements de la Société vis-à-vis des tiers auxquels ils n'auraient pas participé
s'ils ont, à titre habituel, accompli des actes de gestion vis-à-vis de ceux-ci. Un actionnaire commanditaire agissant en
qualité de représentant d'un Gérant ou de l'Actionnaire Commandité n'encourt pas, du simple fait d'agir en cette qualité et
dans la mesure où il indique cette dernière qualité, la responsabilité indéfinie et solidaire susmentionnée. Ne constituent
pas des actes de gestion vis-à-vis des tiers au sens des présents statuts:

- l'exercice des prérogatives d'actionnaires;
- les conseils donnés à la Société ou à ses entités affiliées ou à leurs gérants;
- les actes de contrôle et de surveillance;
- l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la Société ou à ses entités affiliées.
9.2 Lorsque plusieurs Actions de Commandité sont émises, les titulaires de celles-ci (actionnaires commandités) sont

indéfiniment et solidairement tenus du passif auquel la Société ne peut faire face avec son actif.

C. Transfert des actions

Art. 10. Principes Généraux.
10.1 Les actions sont librement cessibles conformément aux dispositions de la loi et du reste de cette section C.
10.2 Les Actions de Commandité sont seulement transférables aux actionnaires commandités indéfiniment et solidai-

rement tenus du passif auquel la Société ne peut faire face avec son actif.

10.3 Tout transfert d'actions nominatives deviendra opposable à la Société et aux tiers soit (i) sur inscription d'une

déclaration de cession dans le registre des actionnaires, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants,
ou (ii) sur notification de la cession à la Société ou sur acceptation de la cession par la Société. Le transfert d'actions au
porteur s'opère par la seule tradition du titre correspondant.

Art. 11. Offres de transfert des Actions ou PECs. Toutes les Actions Ordinaires et PECs détenus par les Co-investisseurs

font l'objet d'une offre de vendre et tranférer à Water Street, conformément à certains termes et conditions qui peuvent être
énoncées  dans  tout  pacte  actionnaires  qui  peut  exister  de  temps  à  autre  entre  les  actionnaires  et  la  Société  (le  «Pacte
d'Actionnaires»).

Art. 12. Droit de sortie conjointe et droit de sortie.
12.1 Si Water Street, en une ou plusieurs étapes, vend et transfère toute action et / ou PEC qu'il détient dans la Société

à un Acheteur Eventuel, tous les autres Actionnaires sont tenus, à la demande de Water Street (a) de prendre toutes mesures
et effectuer toutes déclarations nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de cette vente et transfert, et (b) de vendre et
de transférer à l'/aux Acheteur Eventuel(s) une partie proratisée de leurs actions et / ou PEC de la Société au même prix
(proratisé) et suivant les mêmes autres conditions, étant entendu que la responsabilité des Co-investisseurs ne pourra en
aucun cas excéder le produit effectivement reçus par les Co-investisseurs respectifs.

Le transfert des actions ne peut être exigé que simultanément au paiement du prix d'achat ou toute autre contrepartie.
12.2 Si Water Street décide de vendre et transférer toute actions ou PEC qu'il détient dans la Société à un Acheteur

Eventuel, Water Street est tenu envers les autres actionnaires de convenir avec le ou les Acheteur Eventuel(s) que celui-
ci/ceux-ci doit/doivent offrir aux autres Actionnaires d'acquérir une partie proratisée de leurs actions et PEC dans la Société
au même prix (proratisé) et suivant les mêmes conditions ou à des conditions plus favorables.

Si l'Acheteur Potentiel n'est pas disposé à acheter et acquérir toutes les actions et PEC des co-cédant ainsi que toutes les

actions et les PEC de Water Street faisant partie de l'offre, Water Street est tenu de vendre et de transférer une partie des
actions et PEC des co-cédants ainsi que des actions et PEC de Water Street au prorata des pourcentages détenus dans le
capital social de la Société.

12.3 L'Article 12.1 et l'Article 12.2 s'appliquent en conséquent à l'égard de tout autre capitaux propres, dettes et instru-

ments hybrides émis à un Actionnaire dans le cadre d'un Financement Supplémentaire conformément à l'Article 5.4.

12.4 L'Article 12.1 et l'Article 12.2 ne s'applique pas aux ventes ou transferts à des (a) fonds ou entités qui sont gérés

ou conseillés par Water Street ou leurs filiales, à condition qu'ils adhèrent à tout Pacte d'Actionnaires, en qualité de parti,
(b) Water Street, (c) un Co-investisseurs, (d) un Directeur, et (e) les épouses, descendants et fiducies familiales ou autres
formes similaires, du Dr Becker, du Dr Berg., de Mme Cook et de Mr Cook. L'Article 12.1 et l'Article 12.2 ne s'appliquent
aux  ventes  ou  transferts  dans  le  contexte  d'une  IPO  que  si,  et  dans  la  mesure  où,  ces  ventes  et  transferts  ne  sont  pas
incompatibles avec les dispositions de blocage usuellement requises par le souscripteur.

Art. 13. Des restrictions de transfert. Tout transfert d'actions ou de PEC de la Société détenus par un Actionnaire autres

que Water Street peut être conditionnée, pendant une période de temps spécifique, par le consentement écrit préalable de
l'Associé Commandité, comme cela peut être prévu dans tout Pacte d'Actionnaires.

D. Assemblées générales des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires exercent leurs droits collectifs en assemblée

générale d'actionnaires. Toute assemblée générale d'actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'en-

90900

L

U X E M B O U R G

semble  des  actionnaires  de  la  Société.  L'assemblée  générale  des  actionnaires  est  investie  des  pouvoirs  qui  lui  sont
expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

Art. 15. Convocation des assemblées générales d'actionnaires.
15.1 L'assemblée générale des actionnaires peut, à tout moment, être convoquée par l'Actionnaire Commandité ou, le

cas échéant, par le Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous).

15.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par l'Actionnaire Commandité ou par

le Conseil de Surveillance sur demande écrite d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du
capital social de la Société. En pareil cas, l'assemblée générale des actionnaires devra être tenue dans un délai d'un (1) mois
à compter de la réception de cette demande.

15.3 Les convocations pour toute assemblée générale contiennent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée

et sont effectuées au moyen d'annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit (8) jours avant l'assem-
blée, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un journal luxembourgeois. Les convocations par
lettre doivent être envoyées huit (8) jours avant l'assemblée générale aux actionnaires en nom, sans qu'il ne doive être
justifié de l'accomplissement de cette formalité. Lorsque toutes les actions émises par la Société sont des actions nomina-
tives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée et devront être adressées à chaque actionnaire
au moins huit (8) jours avant la date prévue pour l'assemblée générale des actionnaires.

15.4 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée

générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable, ni publication.

Art. 16. Conduite des assemblées générales d'actionnaires.
16.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit au Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois d'avril à 11 heures. Si la
date indiquée est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le jour ouvrable suivant. Les autres assemblées
générales d'actionnaires pourront se tenir à l'endroit et l'heure indiqués dans les convocations respectives.

16.2 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale d'actionnaires, composé d'un président,

d'un secrétaire et d'un scrutateur, sans qu'il ne soit nécessaire que ces membres du bureau de l'assemblée soient actionnaires
ni Actionnaire Commandité. Si tous les actionnaires présents à l'assemblée générale décident qu'ils sont en mesure de
contrôler la régularité des votes, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, décider de nommer uniquement (i) un président et
un secrétaire ou (ii) une seule personne chargée d'assurer les fonctions du bureau de l'assemblée, rendant ainsi inutile la
nomination d'un scrutateur. Toute référence faite au «bureau de l'assemblée» devra en ce cas être entendue comme faisant
référence aux «président et secrétaire» ou, le cas échéant et selon le contexte, à «la personne unique qui assume le rôle de
bureau de l'assemblée». Le bureau doit notamment s'assurer que l'assemblée est tenue en conformité avec les règles ap-
plicables et, en particulier, en conformité avec les règles relatives à la convocation, aux conditions de majorité, au partage
des voix et à la représentation des actionnaires.

16.3 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale d'actionnaires.
16.4 Un actionnaire peut participer à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme

son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une personne
peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

16.5 Les actionnaires qui prennent part a une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de
s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, sont réputés être présents
pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de
l'assemblée.

16.6 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé,

envoyé par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société
ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la
Société qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions
soumises à l'assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur
ou contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant
la case appropriée.

16.7 Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii)

contre résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La Société ne tiendra
compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.

Art. 17. Consentement de l'Actionnaire Commandité et d'Orgentec Holding.
17.1 L'accord de l'Actionnaire Commandité n'est pas requis pour actes de l'assemblée générale des actionnaires qui

intéressent la Société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts.

17.2 Tant que Orgentec Holding et SB Holding détienent conjointement au moins vingt pour cent (20%) des Actions

Ordinaires de la Société, les dispositions suivantes s'appliquent:

90901

L

U X E M B O U R G

- Toute décision requérant en vertu de la Loi, sur première convocation, une résolution des actionnaire(s) prise avec une

majorité d'au moins deux-tiers (2/3) des votes exprimées à une assemblée générale à laquelle plus de de la moitié (1/2) du
capital social est présent ou représenté selon les présents statuts ou le droit applicable, requiert l'autorisation de Orgentec
Holding;

- Toute décision relative à la modification des présents statuts et à la responsabilité des Co-investisseurs (par exemple

l'émission de PEC de rang sénior ou d'actions en dehors des Financements Supplémentaires en cas d'Evénements de Fi-
nancement d'Urgence), qui dans chaque cas sont au détriment des Co-investisseurs, requièrent le consentement de Orgentec
Holding;

- Toute émission d'action ou d'option à des employés additionnels ou administrateurs de la Société ou l'une de ses filiales

dépassant 10% de la capitalisation représentée par les actions ordinaires de la Société telle qu'elle existe de temps à autres,
requiert le consentement de Orgentec Holding.

Art. 18. Quorum et vote.
18.1 Chaque action donne droit à une voix en assemblée générale d'actionnaires.
18.2 Sauf disposition contraire de la Loi ou des statuts, les décisions prises en assemblée générale d'actionnaires dûment

convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées
quelle que soit la part du capital social représentée. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 19. Modification des statuts. Sauf disposition contraire et sans préjudice de l'Article 16 des présents statuts, les

statuts  peuvent  être  modifiés  à  la  majorité  des  deux-tiers  des  voix  des  actionnaires  valablement  exprimées  lors  d'une
assemblée générale des actionnaires à laquelle plus de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint à une assemblée, une seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues
par la Loi et les présents statuts qui pourra alors délibérer et sans préjudice de Article 16 des présents statuts, quel que soit
le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à la majorité des deux-tiers des voix valablement exprimées.
Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 20. Changement de nationalité. Les actionnaires ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec l'accord

unanime des actionnaires.

Art. 21. Ajournement des assemblées générales d'actionnaires. Dans les conditions prévues par la Loi, l'Actionnaire

Commandité peut ajourner séance tenante une assemblée générale d'actionnaires de quatre (4) semaines. L'Actionnaire
Commandité peut prendre une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%)
du capital social de la Société. Dans l'hypothèse d'un ajournement, toute décision déjà adoptée par l'assemblée générale
des actionnaires sera annulée.

Art. 22. Procès-verbal des assemblées générales d'actionnaires.
22.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l'assemblée qui doit être

signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout autre actionnaire à sa demande.

22.2 Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à

remettre à tout tiers devra être certifié(e) conforme à l'original par le notaire dépositaire de l'acte original dans l'hypothèse
où l'assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par l'Actionnaire Commandité.

E. Administration

Art. 23. Pouvoirs du (des) Actionnaire Commandité(s).
23.1 La Société est gérée par l'Actionnaire Commandité.
23.2 L'Actionnaire Commandité est nommé et peut être révoqué à tout moment, par une décision de l'assemblée générale

des  actionnaires  adoptée  par  des  actionnaires  représentant  plus  de  50%  du  capital  social  de  la  Société.  L'article  8  est
applicable.

23.3 L'Actionnaire Commandité est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et prendre toutes

décisions nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi
ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance.

Art. 24. Relations avec les tiers.
24.1 La Société est engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances par (i) la seule signature de l'Actionnaire Com-

mandité ou par (ii) la signature conjointe ou seule de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été
délégué par l'Actionnaire Commandité dans les limites d'une telle délégation.

F. Surveillance de la société

Art. 25. Conseil de surveillance et réviseur d'entreprises agréé.
25.1 Si les actionnaires de la Société nomment un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article

69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, le conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance») est supprimé en tant
qu'organe, sauf décision expresse des actionnaires de la Société.

90902

L

U X E M B O U R G

25.2  Tout  réviseur  d'entreprises  agréé  peut  être  révoqué  par  l'assemblée  générale  des  actionnaires  pour  juste  motif

uniquement, ou avec son accord.

G. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 26. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le

trente-et-un décembre de la même année.

Art. 27. Comptes annuels - Affectation des bénéfices.
27.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et l'Actionnaire Commandité dresse un inventaire

de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la Loi.

27.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

27.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve

légale, si l'actionnaire apporteur y consent.

27.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

27.5 Sans préjudice de ce qui précède, les bénéfices distribuables de la Société après allocation à de toute réserve légale,

devant être distribués avant une Sortie, seront distribués dans l'ordre suivant:

a. Premièrement, les preneurs de Vendor Notes recevront sur une base proportionnelle et pari passu tous montants

restants à payer au titre du principal des Vendor Notes, majorés des intérêts courus, que les Vendor Notes soient ou non
(i) dues en application de leurs conditions générales, et (ii) libérées suivant les termes et conditions éventuellement décrits
dans le Contrat de Subordination.

b. Deuxièmement, les prêteurs sous prêts d'actionnaires (le cas échéant) au Groupe Cible recevront les montants res-

pectifs du capital restant à payer des prêts, majoré des intérêts courus au prorata (sur la base du montant total du principal
de ces prêts d'actionnaires) et sur base pari passu jusqu'à ce que les prêteurs aient reçu le montant total des prêts et des
intérêts courus.

c. Troisièmement, les bénéfices distribuables restants seront payés aux détenteurs d'instruments hybrides, tel que des

PECs, sur une base proportionnelle et pari passu, jusqu'à ce que les porteurs de ces instruments hybrides aient reçu la totalité
du montant et de l'intérêt accumulé restant dus.

d. Quatrièmement, les bénéfices distribuables doivent être versés aux porteurs d'Actions Ordinaires dans l'ordre de

priorité suivant:

- d'abord, les détenteurs d'Actions de la Classe A auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une

telle année d'un montant de zéro virgule dix pourcents (0.10%) de la valeur nominale des Actions de la Classe A détenues
par eux, puis

- les détenteurs d'Actions de la Classe B auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année

d'un montant de zéro virgule onze pourcents (0.11%) de la valeur nominale des Actions de la Classe B détenues par eux,
puis

- les détenteurs d'Actions de la Classe C auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année

d'un montant de zéro virgule douze pourcents (0.12%) de la valeur nominale des Actions de la Classe C détenues par eux,
puis

- les détenteurs d'Actions de la Classe D auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année

d'un montant de zéro virgule treize pourcents (0.13%) de la valeur nominale des Actions de la Classe D détenues par eux,
puis

- les détenteurs d'Actions de la Classe E auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année

d'un montant de zéro virgule quatorze pourcents (0.14%) de la valeur nominale des Actions de la Classe E détenues par
eux, puis

- les détenteurs d'Actions de la Classe F auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année

d'un montant de zéro virgule quinze pourcents (0.15%) de la valeur nominale des Actions de la Classe F détenues par eux,
puis

- les détenteurs d'Actions de la Classe G auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année

d'un montant de zéro virgule seize pourcents (0.16%) de la valeur nominale des Actions de la Classe G détenues par eux,
puis

- les détenteurs d'Actions de la Classe H auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année

d'un montant de zéro virgule dix-sept pourcents (0.17%) de la valeur nominale des Actions de la Classe H détenues par
eux, puis

- les détenteurs d'Actions de la Classe I auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année

d'un montant de zéro virgule dix-huit pourcents (0.18%) de la valeur nominale des Actions de la Classe I détenues par eux,
puis

90903

L

U X E M B O U R G

- les détenteurs des Actions de Classe J ont droit de recevoir le reste de la distribution de dividendes.
Si l'entière dernière classe d'actions (en ordre alphabétique inverse, ex. d'abord les Actions de la Classe J) a été annulée

suite à sa liquidation, son rachat ou autre au moment de la distribution, le reste de la distribution des dividendes sera alors
alloué à la précédente classe d'actions dans l'ordre alphabétique inverse (p.ex. après la première annulation, les Actions de
la Classe I).

27.6 Si et dans la mesure où il y a eu un Financement Supplémentaire (dans lequel tous les Actionnaires ont le droit de

participer en vertu de l'Article 5.4) à la suite d'un Evénement de Financement d'Urgence, les Actionnaires qui ont décidé
de participer auront un rang sénior par rapport aux autres détenteurs de PECs ou d'Actions Ordinaires (pour éviter tout
doute: auront aussi un rang senior par rapport aux Vendor Notes et tout prêt d'actionnaire), dans la limite de ce Financement
Supplémentaire, et recevront, sur les bénéfices distribuables de la Société après allocation à toute réserves légale, (i) dans
le cas où le Financement Supplémentaire a été fourni par le biais d'un financement par la dette, la valeur nominale respective
des prêts et des intérêts courus y liés non payés et/ou (ii) dans le cas où le Financement Supplémentaire a été financé par
les capitaux propres, le montant nominal de ces instruments de capitaux propres et toute réserve distribuable et/ou des
bénéfice qui y sont attachés, dans chaque cas, au prorata (sur base des montants totaux (nominaux) des Fonds Supplémen-
taires pertinents et des instruments de capitaux propres pertinents de ce Financement Supplémentaire) et sur une base pari
passu. Dans la situation où il existe plus d'un Financement Supplémentaire suite à un Evénement de Financement d'Urgence,
les participants prennent rang dans l'ordre inverse, en commençant par le dernier des Financements Supplémentaires. Pour
éviter tout doute, à l'égard de tout Financement Supplémentaire autre que la suite d'un Evénement de Financement d'Urgence
(par exemple, pour financer des acquisitions complémentaires), l'Article 27.5 s'applique.

«Evénement de Financement d'Urgence» désigne:
a. la Société ou toute Cible est dans l'incapacité de payer ses dettes à leur échéance;
b. tout financement par un tiers, finançant ou refinançant l'acquisition des Cibles ou toute acquisition complémentaire,

est devenu ou deviendra immédiatement exigible au titre de paiement anticipé avant l'échéance finale de celui-ci;

c. la Société ou toute Cible a reçu un avis écrit des prêteurs que tout financement par des tiers, finançant ou refinançant

l'acquisition de la Cible ou toute acquisition complémentaire, sera, dans un délai de moins de trois (3) mois, exigible au
titre de remboursement avant l'échéance finale; ou

d. une violation non résolue d'un engagement financier en vertu de tout financement par des tiers, finançant ou refinançant

l'acquisition des Cibles ou toute acquisition complémentaire, se produit.

27.7 Sur proposition de l'Actionnaire Commandité, l'assemblée générale des actionnaire décide de l'affectation du solde

des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

Art. 28. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
28.1 L'Actionnaire Commandité peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes dans le respect des conditions

prévues par la Loi.

28.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires

sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.

H. Sortie

Art. 29. Sortie.
29.1 Dans le cas d'une sortie (tel que définie ci-dessous) tout produit net (après remboursement de tout emprunts auprès

de tiers et de la déduction des frais raisonnables de transaction et des frais engagés par la Société et Water Street ainsi que
les Co-investisseurs dans le cadre de la Sortie) seront attribués et versés aux actionnaires et aux preneurs de Vendor Notes
dans l'ordre et suivant le classement suivant:

a. Premièrement, les preneurs de Vendor Notes recevront sur une base proportionnelle et pari passu tous montants

restants à payer au titre du principal des Vendor Notes, majorés des intérêts courus, que les Vendor Notes soient ou non
(i) dues en application de leurs conditions générales, et (ii) libérées suivant les termes et conditions éventuellement décrits
dans le Contrat de Subordination.

b. Deuxièmement les prêteurs sous prêts d'actionnaires (le cas échéant) au Groupe Cible recevront les montants respectifs

du capital restant à payer des prêts, majoré des intérêts sur celui-ci au prorata (sur la base du montant total du principal de
ces prêts d'actionnaires) et pari passu jusqu'à ce que les prêteurs aient reçu le montant total des prêts et les intérêts courus,
à condition que les prêts d'actionnaires soient vendus dans le cadre de la Sortie et que les prêteurs ne reçoivent pas une
indemnité ou un remboursement séparé en plus du prix d'achat de l'opération de Sortie.

c. Troisièmement, le produit net restant sera versé aux porteurs d'instruments hybrides, tels que des PECs, au pro rata

et sur une base pari passu, jusqu'à ce que les porteurs de ces instruments hybrides aient reçu le montant total et les intérêts
accumulés et restant dûs.

d.  Quatrièmement,  le  produit  net  restant  sera  versé  aux  porteurs  d'Actions  Ordinaires  (sur  la  base  du  nombre  total

d'Actions Ordinaires) suivant la procédure établie à l'Article 27.5 (d) mutatis mutandis.

29.2 L'Article 27.6 s'applique en conséquent.

90904

L

U X E M B O U R G

29.3 «Sortie» désigne la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actions de la Société, de la LuxCo Intermédiaire,

de LuxCo 2, de LuxCo 3, de AcquiCo, des Cibles, Addon-Acquico, NZ Acquico or Arotec (cession d'action) ou la vente
de  la  totalité  ou  de  la  quasi-totalité  des  actifs  du  Groupe  Cible  (cession  d'actifs)  à  un  tiers  de  bonne  foi  (l'«Acheteur
Probable») ainsi que toute transaction qui a une teneur économique similaire (par exemple, la liquidation de la Société),
sauf si la transaction est structurée de façon à ce que les Actionnaires, étant actionnaires de la Société immédiatement avant
une telle fusion ou une telle transaction(s), détiennent plus de 50% des droits de vote dans l'entité survivante.

29.4 S'agissant des coûts liés à la cession de l'activité ou des actions, ils ne devront pas être supportés par la Société et

seront supportés par les Actionnaires cédants en proportion de leurs Actions Ordinaires cédées dans la Société.

29.5 Dans le cas de vente d'une partie des actions de la Société (autres que les ventes autorisées en vertu de l'Article

12.4), les produits nets doivent également être attribués conformément à l'Article 29.1, mais uniquement aux preneurs de
Vendor Notes et aux Actionnaires qui ont vendu leurs actions en proportion des actions concernées vendues.

29.6 Lors de la survenance d'un Evénement d'Insolvabilité affectant l'ensemble des filiales de la Société, les actionnaires

doivent faire tous les efforts raisonnables pour assurer que tous revenus résiduels issus de cette insolvabilité soient, dans
la mesure permise par la loi applicable, distribués aux Actionnaires et aux preneurs de Vendor Notes conformément à la
clause 29.1.

I. Liquidation

Art. 30. Liquidation.
30.1 En cas de dissolution de la Société, conformément à l'Article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront
des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

J. Disposition finale - Loi applicable

Art. 31. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.

K. Définitions

Art. 32. Définitions Générales. «Acheteur Probable» a le sens qui lui est donné à l'Article 29.2.
«AcquiCo» signifie WSHP Holding GmbH, enregistrée au registre du commerce du tribunal local de Munich sous le

numéro HRB 210402, et ses successeurs.

«Addon-Acquico» signifie WSHP NZ Holding GmbH, immatriculée avec le registre de commerce du Tribunal d'instance

de Munich sous HRB 212849, et ses successeurs.

«Arotec» signifie AROTEC Diagnostics Limited, constituée en Nouvelle-Zélande et ayant son siège social à Raroa

Accountants Ltd, 14 Leary Street, Melling, Lower Hutt, 5010, Nouvelle-Zélande et ses successeurs.

«Action de Classe A» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Action de Classe B» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Action de Classe C» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Action de Classe D» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Action de Classe E» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Action de Classe F» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1
«Action de Classe G» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Action de Classe H» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Action de Classe I» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Action de Classe J» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Action de Commandité» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Actions Ordinaires» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Actionnaires» signifie (i) Water Street, (ii) les Co-investisseurs et (iii) les Directeurs.
«Actionnaire Commanditaire» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Actionnaire Commandité» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.
«Centennial» signifie Centennial Medical Holding Corp., une société constituée et existante selon les lois de l'état de

Delaware, et ses successeurs.

«Cibles» signifie (i) Orgentec Diagnostika GmbH, enregistrée au registre du commerce de la cour local (Amtsgericht)

de Mayence sous le numéro HRB 4300, et (ii) Orgentec Capital GmbH, enregistrée au registre du commerce de la cour
local (Amtsgericht) de Mayence sous le numéro HRB 8449, et leurs successeurs respectifs.

«CMH» signifie une filiale directe de Centennial, Centennial Medical Holdings, Inc., une société constituée en Delaware,

ayant un siège social à 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, Etats-Unis, et ses successeurs.

90905

L

U X E M B O U R G

«CMI» signifie une filiale directe de CMH, Centennial Medical Intergrated, Inc., une société constituée en Nevada,

ayant un siège social à 311 S. Division Street Carson City, NV 89703, Etats-Unis, et ses successeurs.

«Co-investisseurs» signifie SB Holding, Orgentec Holding et Cook SPV.
«Contrat de Subordination» signifie tout contrat de subordination qu'il peut exister de temps à autre entre notamment

Cook SPV et Dr. Berg en tant que créanciers initiaux subordonnés, NZ Acquico en tant qu'emprunteur NZ et LuxCo 3 en
tant qu'agent des débiteurs (tel que amendé, mis à jour, modifié, nové, complété ou prorogé de temps à autre).

«Cook SPV» signifie Doneco Limited, une société constituée en Nouvelle-Zélande, ayant son siège social au 16 Wai-

iti Crescent, Lower Hutt, Wellington, 5010, Nouvelle-Zélande et ses successeurs.

«Corgenix» signifie Corgenix Medical Corporation, une société constituée en 311 S. Division Street Carson City, NV

89703, Etats-Unis et ses successeurs.

«Directeurs» désigne tout directeur ou employé de la Société ou de l'une de ses filiales ayant acquis des actions de la

Société et adhéré à un Pacte d'Actionnaires, le cas échéant.

«Dr. Berg» signifie Dr. Wigbert Berg.
«Dr. Becker» signifie Dr. Stephan Becker.
«Evénement de Financement d'Urgence» a le sens qui lui est donné à l'Article 27.6.
«Evénement d'Insolvabilité» a le sens, dans le cadre de l'article 29.6, qui pourra lui être donné par le Contrat de Sub-

ordination.

«Financement Supplémentaire» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.4.
«Groupe Cible» signifie Luxco Intermédiaire, LuxCo 2, LuxCo 3, AcquiCo, Addon-Acquico, NZ Acquico, les Cibles,

Centennial, CMH, CMI, Arotec et Corgenix ainsi que toutes les filiales actuelles et futures, directes et indirectes de la
Société que la Société contrôle directement ou indirectement au sens de l'article 309 de la Loi.

«IPO» signifie l'offre au public et l'inscription initiale à la cotation des actions de la Société ou des actions d'une autre

société holding existante ou nouvellement créée du Groupe Cible (dans laquelle les Actionnaires détiennent directement
ou indirectement des intérêts dans la même proportion économique, à ce moment donné, que dans le Société) sur un marché
financier de renom.

«Loi» a le sens qui lui est donné à l'Article 1.1.
«LuxCo Intermédiaire» signifie WSHP Intermediate Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et

existante selon les lois de Luxembourg, enregistré au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 193.867, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et ses successeurs.

«LuxCo 2» signifie WSHP LuxCo 2 Sàrl, une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois de

Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.941, ayant son
siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et ses successeurs.

«LuxCo 3» signifie WSHP LuxCo 3 Sàrl, une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois de

Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B187.167, ayant son
siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et ses successeurs.

«Montant Disponible» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.12.
«Montant Total d'Annulation» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.12.
«Mr. Cook» signifie Mr. Neil Cook.
«Mme Cook» signifie Mme Doris Echelmeier Cook.
«NZ Acquico» signifie WSHP Holding Limited, immatriculée auprès du registre des sociétés de la Nouvelle-Zélande

sous le numéro 9429041492963, et ses successeurs.

«Orgentec Holding» signifie ORGENTEC Holding GmbH, enregistrée au registre du commerce local de Mayance sous

le numéro HRB 41710, ayant son centre d'affaire à Carl-Zeiss-Straße 49, 55129 Mainz, et ses successeurs.

«Pacte d'Actionnaires» a le sens qui lui est donné à l'Article Article 11.
«PEC» signifie certificats d'actions privilégiées, émises par la Société de temps à autres.
«SB Holding» signifie SB Holding GmbH, enregistrée au registre du commerce local de d'Armdtadt sous le numéro

HRB 92833, ayant son centre d'affaire à Heinrich-Engel-Straße 49a,64572 Büttelborn, et ses successeurs.

«Société» a le sens qui lui est donné à l'Article 1.1.
«Sortie» a le sens qui lui est donné à l'Article 29.3.
«Valeur d'Annulation des Actions» a le sens qui lui est donné à l'Article 5.12.
«Vendor Notes» signifie les vendor notes, émises par NZ Acquico de temps à autres.
«Water Street» signifie WSHP Orgentec Holdco Ltd., une exempted limited company des Iles Caïmans ayant son siège

social à c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104
Iles Caïmans, et successeurs.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.30 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg à la date en tête des présentes.

90906

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de ces mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Harles, D. Al Mari, C. Halembert, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 5 mai 2015. GAC/2015/3844. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 3 juin 2015.

Référence de publication: 2015082868/1386.
(150095016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Liaoshi, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 151.741.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 mars 2015 que l'assemblée a

décidé de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Christophe ANTINORI, établi à L-1660 Luxembourg, 30,
Grand-Rue, de Monsieur Xavier FABRY, établi à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, et de Monsieur Louis GUERRIER,
demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice

clos au 31 décembre 2018.

L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Didier KIRSCH.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos

au 31 décembre 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015081557/18.
(150092972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Ling-Ling s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 5, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 166.547.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081558/9.
(150093790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Natixis Alternative Assets (acronyme NAA), Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 39, rue Alphonse München.

R.C.S. Luxembourg B 94.282.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2015

En date du 13 mai 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Eric Lellouche, Monsieur Jean-Eloi Dussartre et de Natixis, représenté par M.

Fabien Chevillon en qualité d’Administrateurs pour une durée d’un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2016,

- de renouveler la mandat de Deloitte Audit en qualité de Réviseur d’Entreprises Agréé pour une durée d’un an, jusqu'à

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.

90907

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 28 mai 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Natixis Alternative Assets (acronyme NAA)
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2015081640/18.
(150093051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

LNJ Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 146.541.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2014

I. L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur unique de Monsieur Norbert MEISCH, né le 20 août

1950 à Luxembourg, demeurant professionnellement 36, rue Emile Mayrisch à L-4240 ESCH-SUR-ALZETTE, arrive à
échéance. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler son mandat pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

II. L'assemblée générale des actionnaires constate que le mandat de commissaire aux comptes de la société COMMIS-

SAIRE AUX COMPTES S.A., établie et ayant son siège au 44, rue Pasteur à L-4276 Esch-sur-Alzette et immatriculée au
RCS de Luxembourg sous le numéro B131.410, arrive à échéance. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler
son mandat pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2020 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015081561/20.
(150093584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Loevarth Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 133.107.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 4 mai 2015

Renouvellement du mandat des administrateurs pour 6 ans:
Aniel Gallo
Mireille Masson
Madeleine Alié
Renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué pour 6 ans:
Aniel Gallo
Démission du mandat de commissaire aux comptes:
Fiduciaire et Expertises (Luxembourg) S.A.
Nomination du mandat de commissaire aux comptes pour 6 ans:
FGA (Luxembourg) S.A. - 53 Route d'Arlon - L8211 Mamer

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015081562/19.
(150092726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Luxmaster S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.823.

<i>Extrait des résolutions prises en date du 22 mai 2015

I1 a été convenu comme suit:
- Démission de la société Fiduciaire Mevea Luxembourg SARL, en tant que Commissaire aux Comptes, avec effet

immédiat;

90908

L

U X E M B O U R G

- Nommer C.A.S. Services SA, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que com-

missaire aux comptes et jusqu'à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2016

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2015.

Référence de publication: 2015081582/15.
(150093852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

LSRC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 118.838.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LSRC S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2015081568/11.
(150093521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Lucos Services, Lucos Company Services, Société Anonyme.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 55.776.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081569/9.
(150092837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Lux Drone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 184.813.

Lux Drone Sàrl procède aux changements suivants avec effet au 1 

er

 juin 2015:

- la démission du gérant unique technique de Mr Kevin MARTIN au 01/06/2015
- la cession des 70 parts sociales de Mr Kevin MARTIN au Bénéfice de Monsieur Abdelhamid ZERARGUI
- la cession des 30 parts sociales de Mr Kevin MARTIN au Bénéfice de Monsieur Nassim ZERARGUI
Le nouveau gérant technique est Mr ZERARGUI Abdelhamid
L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal

Monsieur Kevin MARTIN / Signature.

Référence de publication: 2015081571/14.
(150093342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Luxcellence, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 64.695.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2015

En date du 29 avril 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Lucien Euler, en qualité d'administrateur avec effet au 6 novembre 2014,
- de ratifier la cooptation de Madame Marie-Victoire Menez, en qualité d'administrateur, avec effet au 6 novembre 2014,

en remplacement de Monsieur Lucien Euler, démissionnaire,

- de renouveler les mandats de Madame Marie-Victoire Menez, de Monsieur Olivier Storme et de Monsieur Jean-Marc

Servais en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016,

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, 2 Rue Gerhard Mercator, 2182 Luxembourg, en tant que Réviseur

d'Entreprises agréé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.

90909

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Luxcellence
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2015081581/20.
(150093481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Lux-Forst S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 34.525.

Par la présente, je vous informe de ma démission avec effet immédiat du poste de gérant de votre société.

Luxembourg, le 29 mai 2015.

Claude SEYLER.

Référence de publication: 2015081572/9.
(150092951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Lux-Forst S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 34.525.

<i>Résolutions prises par l'associé unique en date du 29 mai 2015

Suite à la démission du co-gérant Monsieur SEYLER Claude en date du 29 mai 2015, l'associé unique décide:
- de nommer Monsieur KLEIN Julien, né à Luxembourg, le 9 octobre 1965, demeurant à L-8558 REICHLANGE, 7a,

rue Jean Bernard, en tant que gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 29 mai 2015.

Référence de publication: 2015081573/14.
(150093453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Lux-Investment Professionals SICAV-FIS S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-

sement Spécialisé.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 173.125.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081574/10.
(150093439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Multi Opportunity Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 110.631.

<i>Extrait de la résolution prise par l'Assemblée Générale de la Société en date du 29 Avril 2015

L'Assemblée Générale de la Société décide:
1. de renommer Madame Simona BORTOLAZZI comme Président du Conseil d'administration de la Société, avec effet

immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra au cours de l'année 2016;

2. de renommer Monsieur Raffaele BARTOLI comme Membre du Conseil d'administration de la Société, avec effet

immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra au cours de l'année 2016;

3. de renommer Monsieur Pierre-Antoine BOULAT comme Membre du Conseil d'administration de la Société, avec

effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra au cours de l'année 2016;

4. de renommer Ernst &amp; Young, ayant son siège social au 7 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, comme Réviseur

d'entreprises agréé de la Société, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra au cours de l'année
2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

90910

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2015081608/21.
(150093916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Luxmaster S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.823.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXMASTER S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015081583/11.
(150093973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Rischette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6130 Junglinster, 4, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 97.302.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081791/9.
(150093323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Rischette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6130 Junglinster, 4, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 97.302.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081792/9.
(150093324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Pitcairns Finance S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 33.106.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081750/9.
(150093695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

REM624, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 117.486.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d'administration

Référence de publication: 2015081786/10.
(150093038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

90911

L

U X E M B O U R G

Résidence pour Personnes Agées Hertha Winandy, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Berschbach, 47, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 88.562.

Les Comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 01/06/2015.

<i>Pour RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES HERTHA WINANDY, S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2015081788/12.
(150092915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Nepomuk S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 122.408.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081669/9.
(150093227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Luxair Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 144.812.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081542/9.
(150093469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Liosoph S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4645 Niedercorn, 141, route de Pétange.

R.C.S. Luxembourg B 89.403.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081560/9.
(150093200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Luxpar Management, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 154.784.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015082507/9.
(150094814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Lugala S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 40.372.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015082500/9.
(150094377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

90912


Document Outline

Astromancia S.à r.l.

KMU/PME S.à r.l.

Kodo S.A.

KPI I S.à r.l.

Lapithus Management S.à r.l.

La Rosa S.A.

LaSalle UK Ventures Property 9

Leandre Investissement S.A.

Lex Holdings S.A.

Lex II Investments Holdings S.A.

Lex Investments Holdings S.A.

Liaoshi

Liberia Administrado S.à r.l.

Ling-Ling s.à r.l.

Liosoph S.à r.l.

LNJ Participations S.A.

Loevarth Invest S.A.

Logistic Investment Holding S. à r.l.

LSRC S.à r.l.

Lucos Company Services

Lugala S.A.

Luxair Immobilière S.à r.l.

Luxcellence

Lux Drone S.à r.l.

Lux-Forst S.à r.l.

Lux-Forst S.à r.l.

Lux-Investment Professionals SICAV-FIS S.A.

Luxmaster S.A.

Luxmaster S.A.

Luxpar Management

Multi Opportunity Sicav

Natixis Alternative Assets (acronyme NAA)

Nepomuk S.A.

Overseas Development S,A,

Pitcairns Finance S.A. - SPF

REM624

Résidence pour Personnes Agées Hertha Winandy, s.à r.l.

Rischette S.à r.l.

Rischette S.à r.l.

WSHP LuxCo 1 SCA