This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1852
24 juillet 2015
SOMMAIRE
Atento S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88873
Coveris Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88896
EJL Real Estate G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . .
88887
Eltis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88853
Erilielux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88855
Eschtari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88855
ESO Investco I Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88855
Eurinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88894
Europe One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88854
Fer.bel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88885
Fotex Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88854
Frankfurt BICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88854
Fuddermann S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88854
Geldilux-TS-2015 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88874
Livin Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88856
MSplus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88853
Mytilus SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88851
NC² Luxembourg Development S.à r.l. . . . . . .
88851
Neon Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88853
New Energy Above Training . . . . . . . . . . . . . .
88851
New Rehab Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88850
NeXenS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88851
Nexyard S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88850
Nies Alliance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88850
Ni Vu Ni Connu Productions S.à r.l. . . . . . . . .
88852
Noliwang International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
88852
Northern Trust Luxembourg Management
Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88850
Novarte Renovation Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88851
NTMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88852
Nuti Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88850
Oakfield Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88857
Ocean Luxury Investments . . . . . . . . . . . . . . . .
88852
PCO HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88856
Pfaudler International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
88856
Quaesta Capital Umbrella SICAV-SIF . . . . . .
88855
SilverStreet Private Equity Strategies M So-
parfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88867
Société européenne d'investissement et promo-
tion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88853
Spinnaker Bidco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88870
Spinnaker HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
88870
Sun European Investment III S.à r.l. . . . . . . . .
88860
System and Management Investment S.A. . . .
88893
Tikehau Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88894
Tivana Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88858
Tuvalu International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
88857
Universal Premium Holding SA . . . . . . . . . . . .
88857
Urban 67 (European RE Club) S.à r.l. . . . . . .
88885
88849
L
U X E M B O U R G
Nuti Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 181.676.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081649/9.
(150094089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Northern Trust Luxembourg Management Company, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 99.167.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.
Référence de publication: 2015081647/10.
(150093190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
New Rehab Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 141.003.
A compter du 1
er
juin 2015, l'adresse professionnelle de l'administrateur unique, Monsieur Henny SCHIPPER, est 31,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081670/10.
(150093416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Nies Alliance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 14-16, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 180.449.
Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la gérance
i>Signature
Référence de publication: 2015081673/11.
(150093419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Nexyard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 176.638.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 12 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1358 du 8 juin 2013.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NEXYARD S.à r.l
Signature
Référence de publication: 2015081671/14.
(150093988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
88850
L
U X E M B O U R G
Mytilus SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 33.617.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081639/9.
(150093817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
New Energy Above Training, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 11, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 170.989.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081643/10.
(150093769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
NC² Luxembourg Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 23.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 148.649.
Les comptes annuels au 31 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2015.
Référence de publication: 2015081667/10.
(150093591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
NeXenS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 155.544.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NeXenS S.A.
i>Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015081645/12.
(150093221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Novarte Renovation Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3240 Bettembourg, 59, rue Michel Hack.
R.C.S. Luxembourg B 160.779.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2015081677/13.
(150093402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
88851
L
U X E M B O U R G
NTMC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 181.462.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081678/9.
(150093218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Noliwang International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 166.251.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015081676/10.
(150093381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Ni Vu Ni Connu Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 85, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 157.037.
Les Comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 01/06/2015.
<i>Pour Ni Vu Ni Connu Productions S.à r.l.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2015081672/12.
(150092919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Ocean Luxury Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 196.404.
<i>Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises en date du 29 mai 2015i>
L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
1/ De révoquer le mandat de Mr Olivier HANCE, Gérant de la Société, avec effet au 29 mai 2015.
2/ De nommer les personnes suivantes:
- Madame Sophie MATEOS, née le 27 octobre 1987 à Commercy, France, ayant son adresse professionnelle au 8A,
Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société avec effet au 29 mai 2015 et ce pour une
durée indéterminée;
- Madame Filipa FREITAS, née le 28 avril 1982 à Funchal, Portugal, ayant son adresse professionnelle à Sítio da Piedade,
9200-044 Caniçal, Portugal, en qualité de Gérant de la société avec effet au 29 mai 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Madame Sophie MATEOS, Gérant; et
- Madame Filipa FREITAS, Gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2015081682/23.
(150093005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
88852
L
U X E M B O U R G
MSplus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 172.396.
Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015081637/9.
(150092778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Société européenne d'investissement et promotion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 176.426.
Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la gérance
i>Signature
Référence de publication: 2015081829/11.
(150093485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Eltis, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 46.635.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. Juni 2015.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2015082279/14.
(150094806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Neon Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 185.956.
EXTRAIT
Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 29 mai 2015 que BRE/Management 7 S.A. a
démissionné en tant que gérant unique de la Société avec effet au 29 mai 2015.
L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société BRE/Management 8 S.A., société anonyme de droit
Luxembourgeois, ayant son siège social au 35 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 195.140, en tant que gérant unique de la Société avec effet au 29 mai 2015
pour une durée indéterminée.
La Société est désormais gérée par la société BRE/Management 8 S.A. en qualité de gérant unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015081642/20.
(150092858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
88853
L
U X E M B O U R G
Fotex Holding, Société Européenne.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 146.938.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015082306/9.
(150094458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Fuddermann S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6225 Hersberg, 37, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 183.766.
Les comptes annuels du 09/01/2014 au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015082308/10.
(150094589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Europe One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 101.735.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société EUROPE ONE S.A.i>
Lors de sa réunion du 17 février 2015, le conseil d’administration a pris la décision suivante:
- Me Lex THIELEN, avocat à la Cour, né le 21 juillet 1962 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1636
Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, est nommé comme dépositaire des actions au porteur de la société, conformément à
l’article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des
actions nominatives et du registre des actions au porteur.
Luxembourg, le 17 février 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015082298/14.
(150094133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Frankfurt BICC, Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.018.500,00.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 127.692.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 27 avril 2015i>
L'Assemblée décide de:
- Renouveler le mandat des Administrateurs suivants avec effet à partir du 27 avril 2015:
* Brian Conroy, en tant qu'Administrateur de type A;
* Andrew Whitty, en tant qu'Administrateur de type A;
* Bastow Charleton S.à r.l., en tant qu'Administrateur de type B.
Durée du mandat pour les trois administrateurs: jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
- Nommer en remplacement de la Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l. comme commissaire de la Société, Efficient
Services Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS sous le numéro B189972, dont le siège social est au 16, rue
d'Epernay, L - 1490 Luxembourg, avec effet rétroactif au 1
er
novembre 2014 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires
qui aura lieu en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015082307/21.
(150094456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
88854
L
U X E M B O U R G
Eschtari S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 58.273.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015082291/9.
(150094769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Erilielux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 173.820.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015082290/10.
(150094239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Quaesta Capital Umbrella SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 138.552.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 mai 2015i>
En date du 20 mai 2015, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler le mandat de Monsieur Christian Altorfer, en qualité d’Administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire devant se tenir en 2018.
Luxembourg, le 29 mai 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Quaesta Capital Umbrella SICAV
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2015082674/16.
(150094085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
ESO Investco I Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.507.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société en date du 26 mai 2015 que:
- La démission de Monsieur Philip Godley de ses fonctions de gérant de la Société a été acceptée avec effet au 26 mai
2015.
- Monsieur Rolf Caspers, né le 12 mars 1968 à Trèves en Allemagne, demeurant professionnellement au 51, avenue
John F. Kennedy L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant de la Société,
à compter du 26 mai 2015, pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2015.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A
Référence de publication: 2015082292/19.
(150094716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
88855
L
U X E M B O U R G
Pfaudler International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 38.700.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 191.423.
EXTRAIT
Par résolutions écrites en date du 31 mai 2015 l’associé de la Société a:
- pris connaissance de la démission de Günter Bachmann de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société avec effet
immédiat;
- nommé Thomas Kehl, né le 3 mars 1960 à Bad Hersfeld, Allemagne et résidant au Altkönigstr. 1a, D-65835 Liederbach,
Allemagne en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet au 1
er
juin 2015 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015082645/17.
(150094906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Livin Real Estate, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 36, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 152.266.
En date du 25 mars 2015, a eu lieu la cession de parts sociales suivante:
- La société POLYFORM S.A., a cédé 20 parts sociales qu'elle détenait à la société Aspen S.à r.l., sise 219, rue Albert
Unden à L-2652 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B187233
Au terme de cette cession de parts sociales, la répartition du capital de la société LIVIN REAL ESTATE est la suivante:
- POLYFORM S.A. est propriétaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 parts sociales,
- Unit S.à r.l. est propriétaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 parts sociales,
- aspen S.à r.l., est propriétaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 parts sociales,
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015083415/18.
(150095433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.
PCO HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 125.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 145.612.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 20 mai 2015.i>
L'associé unique de la Société a décidé le 20 mai 2015 de:
1 prendre acte et accepter la démission de Monsieur Brian Anthony Byrne, gérant de la Société avec effet au 30 avril
2015;
2 élire en tant que gérant de la Société, pour une période indéterminée, Monsieur Stephen Gauci, né le 16 juin 1978 à
Malte, et résidant professionnellement à Triq L-Abate Rigord, bâtiment Marina Business Centre, 5
ème
étage, Ta'Xbiex,
XBX 1127 Malte.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015082655/19.
(150095013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
88856
L
U X E M B O U R G
Tuvalu International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 155.642.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 01.06.2015.
<i>Pour TUVALU INTERNATIONAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015081965/14.
(150092845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Universal Premium Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 148.538.
<i>Extrait de la réunion du conseil d'administration du 20 mai 2015i>
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer de Mazars Luxembourg, 10A henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg avec numéro RCS B 159.962 en qualité de Commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire.
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 8, avenue Marie Thérèse,
L-2132 Luxembourg avec effet immédiat
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015081968/15.
(150093245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Oakfield Property, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.600,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 190.741.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 24 avril 2015i>
En date du 24 avril 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de catégorie B de la
Société avec effet au 30 avril 2015;
- de nommer Madame Laetitia ANTOINE, née le 30 mars 1973 à Woippy, France, résidant à l'adresse professionnelle
suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet au
30 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Anthony Francis FERNANDES, gérant de catégorie A
- Monsieur Ruben Emir GNANALINGHAM BIN ABDULLAH, gérant de catégorie A
- Monsieur Kamarudin BIN MERANUN, gérant de catégorie A
- Monsieur Véronique MARTY, gérant de catégorie B
- Madame Laetitia ANTOINE, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2015.
Oakfield Property
Signature
Référence de publication: 2015079761/25.
(150091020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
88857
L
U X E M B O U R G
Tivana Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.212.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 187.123.
In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of May,
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
Tivana Topco S.A., a public limited liability company (société anonyme) existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 191.489,
hereby represented by Maître Alexander KOCH, Senior Associate, with professional address in Luxembourg, by virtue
of proxy given under private seal.
Said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration, after initialed “ne varietur” by the proxy-
holder of the appearing party and by the undersigned notary.
The appearing party, represented as above stated, is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Tivana Midco S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 6, rue Eugene Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
pursuant to a deed of Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) on
15 May 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1932 dated 24 July 2014, registered
with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 187.123 (the "Company").
The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Danielle
Kolbach, prenamed, on 23 March 2015, in the course of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
The Sole Shareholder, represented as above stated and representing the entire share capital of the Company, has requested
the undersigned notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of two hundred thousand Euro
(EUR 200,000.-), so as to raise it from its current amount of two million twelve thousand five hundred Euro (EUR
2,012,500.-) to an amount of two million two hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 2,212,500.-), by the issue
of two hundred thousand (200,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, having the rights and privileges
as set forth in the Company's articles of association and to be paid up in full.
<i>Subscription / Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder declares to subscribe to the two hundred thousand (200,000) shares with a par value
of one Euro (EUR 1.-) each, having the rights and privileges as set forth in the Company's articles of association and to
fully pay such shares, as well as a share premium amount of five million twenty-five thousand three hundred and eighty-
one Euro (EUR 5,025,381.-), by a contribution in cash in an aggregate amount of share premium amount of five million
two hundred and twenty-five thousand three hundred and eighty-one Euro (EUR 5,225,381.-).
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in articles 183
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended by article 1832 of the civil code, as amended have
been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Company's article of association which shall now read as follows:
" Art. 6. The company's corporate capital is fixed at two million two hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR
2,212,500.-) represented by two million two hundred and twelve thousand five hundred (2,212,500) shares with a par value
of one Euro (EUR 1.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve."
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
deed, are estimated at approximately three thousand five hundred euros (EUR 3,500.-).
88858
L
U X E M B O U R G
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the proxyholder of the appearing parties,
the present deed is drafted in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English
and the French text, the English text shall prevail.
The document having been read to the appearing parties’ proxyholder, who is known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-neuf mai.
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Tivana Topco S.A., une société anonyme constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 191.489,
ici représentée par Maître Alexander KOCH, Senior Associate, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, qui après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire et par le notaire instrumentant, devra être
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, est l’associé unique (l'«Associé Unique») de Tivana Midco S.à
r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par acte notarié de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) le 15 mai 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1932 en date du 24 juillet 2014, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 187.123 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié de Maître Danielle Kolbach, prénommé,
le 23 mars 2015, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’Associé Unique, représenté comme ci-avant et représentant l’intégralité du capital social de la Société, a requis le
notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent mille euros (EUR
200.000,-), afin de le porter de son montant actuel de deux millions douze mille cinq cents euros (EUR 2.012.500,-) à un
montant de deux millions deux cent douze mille cinq cents euros (EUR 2.212.500,-) par l'émission de deux cent mille
(200.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, conférant les droits et privilèges comme
indiqués dans les statuts de la Société et à libérer intégralement.
<i>Souscription - Libérationi>
Dès lors, l’Associé Unique, représenté comme ci-avant, déclare souscrire aux deux cent mille (200.000) nouvelles parts
sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les droits et privilèges comme indiqués dans les
statuts de la Société, et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales ainsi qu'une prime d'émission de cinq millions
vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-un euros (EUR 5.025.381,-) par un apport en numéraire d'un montant total de cinq
millions deux cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-un euros (EUR 5.225.381,-).
La preuve de ce paiement a été fournie au notaire soussigné qui déclare que les conditions énoncées aux articles 183 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par l'article 1832 du code civil, tel que modifié,
ont été remplies et témoigne expressément de leur accomplissement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société qui se lira désormais de la manière suivante
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à deux millions deux cent douze mille cinq cents euros (EUR 2.212.500,-)
représenté par deux millions deux cent douze mille cinq cents (2.212.500) parts sociales d'une valeur nominale d’un euro
(EUR 1.-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.»
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes, qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte
notarié sont estimés approximativement à trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,-).
88859
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la mandataire des parties contrac-
tantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même mandataire et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire par son nom,
prénom usuel, état civil et domicile, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: A. KOCH, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 21 mai 2015. Relation: DAC/2015/8567. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITON CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 1
er
juin 2015.
Référence de publication: 2015080839/121.
(150092072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2015.
Sun European Investment III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 197.192.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth of May.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
I. Commodore European Investment Co. I S.à r.l., a company having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, under number B 187627,
here represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, with professional address in Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal;
II. Ensign European Investment Co. I S.à r.l., a company having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, under number B 187623,
here represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, with professional address in Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal;
III. Plenium Partners. S.L., a company incorporated under Spanish law, having its registered office at calle Velázquez,
47-7° planta, Madrid, Spain,, registered with the Registro Mercantil de Madrid, under number B85-116671,
here represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, with professional address in Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal;
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing parties, through their proxyholder, declare to incorporate a société à responsabilité limitée, the articles
of incorporation of which they have established as follows:
Title I. - Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may become
members in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by law
pertaining to such an entity as well as by the present articles of incorporation (the “Company”).
Art. 2. The objects of the Company are to invest in a portfolio of domestic or foreign securities or similar instruments,
including but not limited to shares (preferred and common), warrants, options and other equity securities, debt securities,
bonds, notes, certificates of deposit, rights or participations in senior or mezzanine or other loans, and in financial instru-
ments, financial derivatives agreements and other debt instruments or securities, trade receivables and other forms of claims,
obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) (individually and collectively, “Investments”); to
enter into any agreements relating to such portfolio and to grant pledges, guarantees or other security interests of any kind
under any law to Luxembourg or foreign entities; and to do all things relating thereto as permitted under Luxembourg laws.
The Company may in addition establish, acquire, manage, develop and dispose of Investments and other assets of
whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, Investments and other assets, to
realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to - or for the benefit of - companies in which
the Company has a direct and/or indirect participation and/or entities of the group, any assistance, loan, advance or gua-
rantee.
88860
L
U X E M B O U R G
The Company may among others: (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
Investments or other assets, including without limitation, any assets (including derivatives) representing ownership rights,
claims or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached
to these Investments or the assets; (iii) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap
agreements; (iv) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in
which it holds an interest or participation or which are members of its group, in particular by granting loans, facilities,
security interests over its assets or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and
assistance in any form whatsoever including group treasury services; (v) make deposits at banks or with other depositaries
and invest it in any other manner; (vi) in order to raise funds which it needs to carry out its activity within the frame of its
object, take up loans in any form whatsoever, accept any deposit from companies or entities in which it holds a participation
or which is part of its group, to issue debt instruments in any form whatsoever; and (vii) enter into all necessary agreements,
including, but not limited to underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agree-
ments, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, interest and/or currency exchange
agreements and other voting agreements, financial derivative agreements, bank and cash administration agreements, li-
quidity facility agreements, indemnity agreements, guarantees, credit insurance agreements and any agreements creating
any kind of security interest. The enumeration above is enunciatively and not restrictive.
The Company may issue any type of preferred equity certificates as well as classes thereof.
The Company may borrow in any form and may proceed to the private issue of bonds and debentures and provide
security in relation thereto. The Company’s object is also, in any form whatsoever, the purchase and the sale, the renting
and the administration, either directly or indirectly through subsidiaries or branches or otherwise, of movable and real estate
property located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial,
financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and deve-
lopment of its objects.
Art. 3. The Company is incorporated under the name of “Sun European Investment III S.à r.l.”.
Art. 4. The Company has its registered office in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of
the sole manager or of the board of managers (the “Board”).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
sole manager or of the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary developments (such as political or military developments) have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg
company.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Title II. - Capital - Shares
Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares, each with a par value of one euro (EUR 1.-) per share, all fully subscribed and entirely paid
up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
shares in existence.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the member(s) adopted in the manner required
for amendment of these articles of incorporation.
The Company will recognise only one holder in respect of a share. In case of joint ownership, the Company may suspend
the exercise of any right related thereto until one person has been designated to represent the joint owners towards the
Company.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable
to non-members but only with the prior approval of the members representing three-quarters of the capital. In the same
way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of
shares representing three-quarters of the rights owned by the survivors.
88861
L
U X E M B O U R G
Title III. - Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers appointed and revoked, ad nutum, by the sole member or,
as the case may be, the members. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. There
may be managers of the category A (the “Managers A”, each individually a “Manager A”) and managers of the category
B (the “Managers”, each individually a “Manager B”).
The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented by virtue of a
proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to a third party.
Resolutions shall require a majority vote. No resolution can be passed without the approval of at least a Manager A, if
applicable. The chairman of the board must be a Manager A, if applicable. In case of equality of votes, the chairman of the
board, if any, shall have a casting vote.
The Managers will physically attend the Board meetings in the Grand Duchy of Luxembourg.
The manager(s) is/are appointed for an unlimited duration and is/are vested with the broadest powers in the representation
of the Company towards third parties. The Company will be bound by the individual signature of the sole manager or, if
several managers have been appointed, by the individual signature of a Manager A or by the joint signature of two managers
(at least one of whom must be a Manager A, if applicable).
Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific
matters pre-determined by the manager(s).
The manager(s) is/are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the Luxembourg
law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “1915 Law”).
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by
them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their mandate.
Title IV. - Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII of
the 1915 Law on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the
members.
Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.
The meetings of the members will be physically held in the Grand Duchy of Luxembourg.
Any amendments of the articles of incorporation shall be resolved by the sole member or by a general meeting of
members at the quorum and majority requirements provided for by the 1915 Law.
Title V. - Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 11. At the end of each financial year, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company,
as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve until
such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the
legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one
tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the
sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant
laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI. - Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
The dissolution of the Company shall be resolved by the sole member or by a general meeting of members at the same
majority requirements applying to an amendment of the articles of incorporation and the liquidation shall be carried out by
the manager(s) in office or failing him/them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general
meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets
and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to
the members proportionally to the shares they hold.
88862
L
U X E M B O U R G
Title VII. - General provisions
Art. 13. Neither creditors nor heirs may for any reason require the sealing of the assets or documents of the Company.
For all matters not provided for in the present articles of incorporation, it shall be referred to the 1915 Law.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2015.
<i>Subscription and paymenti>
7,881 (seven thousand eight hundred eighty one) shares have been subscribed by Commodore European Investment Co.
I S.à r.l., prenamed;
4,119 (four thousand one hundred nineteen) shares have been subscribed by Ensign European Investment Co. I S.à r.l.,
prenamed;
500 (five hundred) shares have been subscribed by Plenium Partners. S.L., prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand euro (EUR 1,000.-).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the members, representing the entirety of the subscribed capital
have passed the following resolutions:
1) The following persons are appointed Managers A of the Company for an unlimited duration:
- Mr. Marc LIESCH, born in Luxembourg, on 22 July 1954, with professional address at 74, rue de Merl, L-2146
Luxembourg;
- Mr. Taavi DAVIES, born in Ukarumpa, Papua New Guinea, on 25 May 1975, with professional address at 5-11,
Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
2) The following persons are appointed Managers B of the Company for an unlimited duration:
- Mr. Peter A. HEAPS, born on 05 June 1962 in Preston, UK, with professional address at 5 Beach Lane, 2283 West
Bay Road, PO Box 30872, Grand Cayman KY1-1204, Cayman Islands;
- Mr. Pedro Alejandro SANABRIA SMITH, born on 27 December 1977 in Madrid, Spain, with professional address at
calle Velázquez, 47-7° planta, Madrid, Spain.
3) The Company shall have its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholders of the appearing parties known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholders have signed with Us the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède.
L'an deux mille quinze, le dix-huit mai.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
I. Commodore European Investment Co. I S.à r.l., une société ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 187627,
ici représentée par Mr. Henri DA CRUZ, employé, résidant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé;
II. Ensign European Investment Co. I S.à r.l., une société ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 187623
ici représentée par Mr. Henri DA CRUZ, employé, résidant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé;
III. Plenium Partners S.L., une société ayant son siège social à calle Velázquez, 47-7° planta, Madrid, Espagne, enre-
gistrée auprès du Registro Mercantil de Madrid, Espagne, sous le numéro B85-116671,
88863
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Mr. Henri DA CRUZ, employé, résidant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé;
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexées
aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont
elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts (la «Société»).
Art. 2. L’objet de la Société est d’investir dans un portefeuille comprenant des titres, nationaux ou étrangers, ou d’autres
instruments, incluant mais non limités aux actions (préférentielles et communes), warrants, options et autres titres de capital,
titres de dettes, des obligations cotées et non cotées, des droits ou des participations dans des prêts prioritaires ou mezzanine
ou dans d’autres prêts, et dans des instruments financiers, des contrats sur des produits dérivés et autres instruments simi-
laires d’endettement, des créances commerciales et autres formes de créances, des dettes, des obligations (notamment, sans
que ceci soit limitatif, des obligations de couvertures synthétiques) (individuellement et collectivement, «Investissements»),
de conclure des contrats relatifs à ce portefeuille et de fournir des gages, garanties et autres sûretés de toutes sortes soumis
à une quelconque loi et accordés à des entités luxembourgeoises ou étrangères; et de faire toutes choses relatives au présent
objet permises par les lois luxembourgeoises.
La Société pourra de plus créer, acquérir, administrer, développer et céder des Investissements et tous autres actifs de
toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous Investissements et autres actifs,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles
la Société détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance ou
garantie.
La Société peut entre autres: (i) acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous Inves-
tissements ou autres actifs, incluant sans limitation, tous Investissements (y inclus des instruments dérivés) représentant
des droits de propriété, droits de créance ou des valeurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé
quelconque; (ii) exercer tous droits quelconques attachés à ces Investissements ou actifs; (iii) entrer dans toute forme de
contrats de crédit dérivés tels que, mais sans que cela soit limitatif, des contrats de swap; (iv) accorder toute assistance
financière directe et/ou indirecte quelle qu'elle soit aux sociétés et/ou entités dans lesquelles elle a un intérêt ou une parti-
cipation ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d’avances, de sûretés portant sur ses avoirs ou de
garanties sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous quelque forme
que ce soit comprenant des services de trésorerie pour le groupe; (v) faire des dépôts auprès de banques ou tous autres
dépositaires et les placer de toute autre manière; (vi) en vue de se procurer les moyens financiers dont elle a besoin pour
exercer son activité dans le cadre de son objet social, contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit, accepter
tous dépôts de la part de sociétés ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, émettre tous
titres de dettes sous quelque forme que ce soit; et (vii) conclure tous les contrats nécessaires, et notamment, sans que cette
liste soit limitative, des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils,
des contrats d’administration et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d’échange sur devises ou
taux d’intérêts et tous autres pactes de votation, contrats sur des produits dérivés, des contrats bancaires, des contrats de
facilités de crédit, des contrats d’indemnisation, des garanties, des contrats d’assurance-crédit et tout contrat portant création
de garanties de quelque nature que ce soit. L’énumération précitée est énonciative et non limitative.
La Société peut procéder à l’émission de toutes sortes de certificats préférentiels de capitaux, de même que différentes
classes de tels instruments.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature et fournir
les sécurités y relatives.
L’objet de la Société est également, sous quelque forme que ce soit, l’acquisition et la vente, la location et l’adminis-
tration, soit directement soit indirectement à travers des filiales ou succursales ou d’une autre manière, de tout bien mobilier
ou immobilier situé au Grand-duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des
transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplissement
et au développement de son objet social.
Art. 3. La Société prend la dénomination de «Sun European Investment III S.à r.l.».
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du gérant unique ou du conseil
de gérance (le «Conseil»).
88864
L
U X E M B O U R G
II peut être créé par simple décision du gérant ou du Conseil, des succursales, filiales ou bureaux (autres que le siège
statutaire de la Société) tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque le Conseil estime que des évènements extraordinaires (tels que des évènements d'ordre politique ou militaire)
de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II. - Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des
parts sociales existantes.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associé(s) adopté suivant la manière requise
pour modifier les statuts.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si la propriété de la part sociale est indivise, la Société
pourra suspendre l'exercice de l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale jusqu'à ce qu'une seule personne soit
désignée pour représenter les indivisaires à l'égard de la Société.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Titre III. - Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués ad nutum par l'associé unique ou,
selon le cas, les associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Il peut y avoir des
gérants de la catégorie A (les “Gérants A”, chacun individuellement un “Gérant A”) et des gérants de la catégorie B (les
“Gérants B”, chacun individuellement un “Gérant B”).
Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d’une procuration,
qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou à un tiers.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. Aucune décision ne peut être prise sans l’accord d’au moins
un Gérant A, le cas échéant. Le président du conseil doit être un Gérant A, le cas échéant. En cas d’égalité de voix, la voix
du président du Conseil, le cas échéant sera prépondérante.
Les gérants assisteront physiquement aux réunions du Conseil au Grand Duché de Luxembourg.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) pour une durée indéterminée et est/ sont investi(s) dans la représentation de la Société
vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. La Société sera engagée par la signature du gérant unique ou, en cas de
pluralité de gérants, par la signature individuelle d’un Gérant A ou par la signature conjointe de deux gérants (dont un au
moins doit être un Gérant A, le cas échéant).
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des
affaires déterminées par le(s) gérant(s).
Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de la
loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-
lièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Titre IV. - Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII de
la Loi de 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par les associés.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Les réunions des associés se tiendront physiquement au Grand Duché de Luxembourg.
Toute modification aux statuts sera décidée par l’actionnaire unique ou par l’assemblée générale des associés aux con-
ditions de quorum et de majorité prévues par la Loi de 1915.
88865
L
U X E M B O U R G
Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. A la fin de chaque année sociale, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan
et un compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,
constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à
ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle raison,
la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait
jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI. - Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
La dissolution de la Société sera décidée par l'associé unique ou par l'assemblée des associés délibérant aux mêmes
conditions de majorité que celles exigées pour la modification des statuts et la liquidation sera faite par le(s) gérant(s) en
fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée
des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII. - Dispositions générales
Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il y a lieu de s’en référer à la Loi de 1915.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
7.881 (sept mille huit cent quatre-vingt-un) parts sociales ont été souscrites par Commodore European Investment Co.
I S.à r.l., préqualifiée;
4.119 (quatre mille cent dix-neuf) parts sociales ont été souscrites par Ensign European Investment Co. I S.à r.l., pré-
qualifiée;
500 (cinq cents) parts sociales ont été souscrites par Plenium Partners S.L., préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Résolutionsi>
Et à l'instant les associés, représentant la totalité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants A de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Marc LIESCH, né à Luxembourg, le 22 juillet 1954, avec adresse professionnelle au 74, rue de Merl, L-2146
Luxembourg;
- Monsieur Taavi DAVIES, né à Ukarumpa, Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 25 mai 1975, avec adresse professionnelle
au 5-11, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
2) Sont nommés gérants B de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Peter A. HEAPS, né le 5 juin 1962 à Preston, GB, avec adresse professionnelle au 5 Beach Lane, 2283 West
Bay Road, PO Box 30872, Grand Cayman KY1-1204, Cayman Islands
- Monsieur Pedro Alejandro SANABRIA SMITH, né le 27 décembre 1977 à Madrid, Espagne, avec adresse profes-
sionnelle à calle Velázquez, 47-7° planta, Madrid, Spain.
3) Le siège social de la Société est établi au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
88866
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties
comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état civil et
domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 21 mai 2015. Relation GAC/2015/4290. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
Référence de publication: 2015080776/376.
(150092718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2015.
SilverStreet Private Equity Strategies M Soparfi, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 187.859.
In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of the month of May;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
SILVERSTREET PRIVATE EQUITY STRATEGIES SICAR, a company in the form of a limited corporate partnership
(“société en commandite simple”) qualifying as an investment company in risk capital (“Société d'Investissement en Capital
à Risque”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry
of Luxembourg under number B 153487, with registered office at 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
duly represented by its general partner SilverStreet Management S.àr.l., (the “General Partner”), having its registered
office at 6, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg
under number B 153488,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal on May 8, 2015; such proxy, after having been
signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be
recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of the private limited liability company (“société
à responsabilité limitée”) existing under the name of “SilverStreet Private Equity Strategies M Soparfi”, (the “Company”),
with registered office at 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Trade and Companies Registry
of Luxembourg under number B 187859, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on June 3, 2014,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2197 of August 19, 2014,
and whose articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on
February 20, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1037 of April 20, 2015;
- The Company's capital is currently set at three hundred and six thousand eight hundred and ninety-six US dollars (USD
306,896.-) represented by three hundred and six thousand eight hundred and ninety-six (306,896) shares of a nominal value
of one US dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up;
- The agenda is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred and fifty-one thousand nine hundred and
twenty US dollars (USD 151,920.-) in order to bring it from its present amount of three hundred and six thousand eight
hundred and ninety-six US dollars (USD 306,896.-) to four hundred and fifty-eight thousand eight hundred and sixteen US
dollars (USD 458,816.00-) by the creation and the issue of one hundred and fifty-one thousand nine hundred and twenty
(151,920) new shares of a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each (the “New Shares”), having the same rights and
privileges as the existing shares.
2. Subscription and payment of all the one hundred and fifty-one thousand nine hundred and twenty (151,920) newly
issued shares by the Sole Shareholder by a contribution in kind consisting in the conversion of a certain, liquid and enfor-
ceable claim.
3. Amendment of article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company as a consequence of the increase
of the share capital of the Company.
4. Miscellaneous.
The Sole Shareholder then passed the following resolutions:
88867
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred and fifty-one
thousand nine hundred and twenty US dollars (USD 151,920.-) in order to bring the share capital from its present amount
of three hundred six thousand eight hundred and ninety-six US dollars (USD 306,896.-) represented by three hundred six
thousand eight hundred and ninety-six (306,896) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each, to four
hundred and fifty-eight thousand eight hundred and sixteen US dollars (USD 458,816.-) and to issue in this respect one
hundred and fifty-one thousand nine hundred and twenty (151,920) new shares (the “New Shares”) with a nominal value
of one US dollar (USD 1.-) each (the “New Shares”), having the same rights and privileges as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The one hundred and fifty-one thousand nine hundred and twenty (151,920) New Shares are entirely subscribed by the
Sole Shareholder.
All the New Shares have been fully paid-up by a contribution in kind consisting in the conversion of a certain, liquid
and enforceable claim (the “Claim”) that the Sole Shareholder holds against the Company.
The existence and the valuation of the Claim results from a certificate issued by the Company’s manager on May 8,
2015, which, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed after signature for the purpose of registration.
It results that nothing opposes to the conversion arising from the Claim of an amount of one hundred and fifty-one
thousand nine hundred and twenty US dollars (USD 151,920.-) into capital of the Company.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company is
amended and shall henceforth read as follows:
“ Art. 6. paragraph 1. The Company's capital is set at four hundred and fifty-eight thousand eight hundred and sixteen
US dollars (USD 458,816.-) represented by four hundred and fifty-eight thousand eight hundred and sixteen (458,816)
shares of a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid-up.”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand four hundred
and fifty Euros (EUR 1,450.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
his name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed together with Us, the notary, the present
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le douzième jour du mois de mai;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
SILVERSTREET PRIVATE EQUITY STRATEGIES SICAR, une société en commandite simple qualifiée de société
d'investissement en capital à risque, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153487, avec siège social au 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
dûment représentée par son associé commandité SilverStreet Management S.àr.l., (l’“Associé Commandité”), ayant son
siège social au 6, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 153488,
ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxem-
bourg, 12, rue Jean Engling, (le “Mandataire”), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 8 mai 2015; laquelle
procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
88868
L
U X E M B O U R G
- La partie comparante est l’associé unique (l’“Associé Unique”) de la société à responsabilité limitée existant sous la
dénomination de “SilverStreet Private Equity Strategies M Soparfi”, (la “Société”), avec siège social au 6, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187859,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 3 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 2197 du 19 août 2014,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 20 février 2015,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1037 du 20 avril 2015;
- Le capital social de la Société est actuellement fixé à trois cent six mille huit cent quatre-vingt-seize dollars US
(306.896,- USD), représenté par trois cent six mille huit cent quatre-vingt-seize (306.896) parts sociales d'une valeur
nominale d'un dollar US (1,- USD) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées;
- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt dollars US
(151.920,- USD) afin de le porter de son montant actuel de trois cent six mille huit cent quatre-vingt-seize dollars US
(306.896,- USD) à quatre cent cinquante-huit mille huit cent seize dollars US (458.816,- USD), par la création et l’émission
de cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt (151.920) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale d'un dollar US (1,-
USD) chacune (les “Nouvelles Parts Sociales”), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
2. Souscription et paiement des cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt (151.920) parts sociales nouvellement émises
par l’Associée Unique, par l’apport en nature consistant en la conversion d’une créance certaine, liquide et exigible.
3. Modification de l’article 6, alinéa 1
er
, des statuts de la Société en conséquence de l’augmentation du capital social
de la Société.
4. Divers.
L‘Associé Unique a ensuite pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L‘Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent cinquante-et-un mille neuf
cent vingt dollars US (151.920,- USD) pour porter le capital social de son montant actuel de trois cent six mille huit cent
quatre-vingt-seize dollars US (306.896,- USD), représenté par trois cent six mille huit cent quatre-vingt-seize (306.896)
parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar US (1,- USD) chacune, à un montant de quatre cent cinquante-huit mille
huit cent seize US (458.816,- USD), et d’émettre à cet égard cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt (151.920) nouvelles
parts sociales (les “Nouvelles Parts Sociales”) d'une valeur nominale d'un dollar US (1,- USD) chacune, ayant les mêmes
droits et privilèges que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
Les cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt (151,920) Nouvelles Parts sont entièrement souscrites par l’Associé
Unique, prénommée.
Les Nouvelles Parts Sociales ont été libérées moyennant apport en nature consistant en la conversion d’une créance
certaine, liquide et exigible (la “Créance”) que l’Associé Unique détient envers la Société.
L’existence et la valeur de cette Créance résulte d’un certificat émis par le gérant de la Société en date du 8 mai 2015,
qui, après avoir été signé “ne varietur” par le Mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé
au présent acte en vue de leur enregistrement.
Il en résulte que rien ne s’oppose à la conversion découlant de la Créance d’un montant de cent cinquante-et-un mille
neuf cent vingt dollars US (151.920,- USD) en capital social de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède l’article 6, alinéa 1, des statuts de la Société est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
“ Art. 6. alinéa 1. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante-huit mille huit cent seize dollars US (458.816,- USD),
représenté par quatre cent cinquante-huit mille huit cent seize (458.816) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar
US (1,- USD) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.”
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille quatre cent cinquante
euros (1.450,-EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
88869
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
noms, prénoms, état civil et domiciles, ledit Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 19 mai 2015. 2LAC/2015/10840. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 29 mai 2015.
Référence de publication: 2015080759/160.
(150091933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2015.
Spinnaker Bidco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Spinnaker HoldCo S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,01.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 189.065.
In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of May.
before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Triton IV LuxCo No.11 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share
capital of twelve thousand five hundred euro and two cent (EUR 12,500.02) with registered office at 2C, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 190167 (the ”Shareholder”);
hereby represented by Maître Cristiana Musteanu, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal on 12 May 2015.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The Shareholder requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of Spinnaker
HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share
capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having been incorporated following a deed dated 4 July 2014, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2720 of 3 October 2014 and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 189065 (the "Company"). The articles of incorporation of the
Company have not been amended yet.
The Shareholder, represented as above mentioned, declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the
basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To change the name of the Company from Spinnaker HoldCo S.à r.l. to Spinnaker Bidco S.à r.l.
2. To increase the corporate capital of the Company by an amount of one euro cent (EUR 0.01) so as to raise it from its
present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand five hundred euro and one cent
(EUR 12,500.01).
3. To issue one (1) new share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges
as the existing shares.
4. To accept subscription for this new share, with payment of a share premium in a total amount of twenty million four
hundred sixty-seven thousand four hundred seventy-three euro and eighteen cent (EUR 20,467,473.18) by Triton IV LuxCo
No.11 S.à r.l. and to accept payment in full for such new share by a contribution in kind.
5. To amend articles 1 and 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the foregoing items of
the agenda.
6. Miscellaneous.
The Shareholder requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to change the name of the Company from Spinnaker HoldCo S.à r.l. to Spinnaker Bidco S.à
r.l.
88870
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one euro cent (EUR 0.01) so
as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to an amount of twelve thousand
five hundred euro and one cent (EUR 12,500.01).
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to issue one (1) share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), and having the same
rights and privileges as the existing shares of the various classes.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon appeared:
Triton IV LuxCo No.11 S.à r.l., aforementioned, represented as stated above.
The Shareholder declared to subscribe for (1) new share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), to be issued
with a share premium in an amount of twenty million four hundred sixty-seven thousand four hundred seventy-three euro
and eighteen cent (EUR 20,467,473.18), and to make payment in full for such new share by contribution in kind in an
amount of twenty million four hundred sixty-seven thousand four hundred seventy-three euro and nineteen cent (EUR
20,467,473.19) (the “Contribution”).
The Contribution represents an aggregate amount of twenty million four hundred sixty-seven thousand four hundred
seventy-three euro and nineteen cent (EUR 20,467,473.19).
Proof of the ownership by the Shareholder of the Contribution has been given to the undersigned notary.
The Shareholder declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist
no impediments to the proposed conversion of the claims against the Company without restriction or limitation and that
valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a
valid contribution of claims against the Company.
The Shareholder further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution
is described and valued (the “Valuation Report”).
The conclusions of the Valuation Report read as follows:
“Based on our valuation methodology, we have no observation to mention on the value of the Contribution which
corresponds at least to the nominal value of the Issued Share, together with the share premium thereon.”
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the one (1) new share according to the
above mentioned subscriptions.
<i>Fifth resolutioni>
In view of the above, the Shareholder resolved to amend the articles 1 and paragraph one of article 5 of the articles of
incorporation of the Company so as to reflect the foregoing resolutions.
As a result, articles 1 and 5 shall from now on read as follows:
““ Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of In-
corporation”).
The Company is, at incorporation, composed of one single shareholder.
The Company will exist under the name of “Spinnaker Bidco S.à r.l.”.
“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro and one cent
(EUR 12,500.01) divided into one million two hundred fifty thousand and one (1,250,001) shares with a nominal value of
one euro cent (EUR 0.01) each, all of which are fully paid up.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at five thousand eight hundred euro (EUR 5,800,-).
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of inconsistencies
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil
status and residence, such person signed together with the notary this original deed.
88871
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le douzième jour du mois de mai,
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
Triton IV LuxCo No.11 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège
social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, avec un capital de douze mille
cinq cent euros et deux centimes (EUR 12.500,02) et enregistrée au Registre des Sociétés et du Commerce du Luxembourg
sous le numéro B 190167 (l’«Associé»);
représenté par Maître Cristiana Musteanu, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration donnée sous seing privé et datée du 12 mai 2015.
Ladite procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, sera annexée au présent acte à des
fins d’enregistrement.
L’Associé a demandé au notaire soussigné d’acter que l’Associé est l’unique associé de Spinnaker HoldCo S.à r.l., une
société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-), avec siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte en date du 4 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2720 en date du 3 octobre 2014 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 189065. Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés.
L’Associé, représenté comme mentionné ci-dessus reconnaît être pleinement informé des décisions à prendre sur base
de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de la dénomination de la Société de Spinnaker HoldCo S.à r.l. pour Spinnaker Bidco S.à r.l.
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un centime d’euro (EUR 0,01) pour le porter de son
montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cents euros et un centime (EUR
12.500,01).
3. Émission d’une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01), et ayant les mêmes
droits et privilèges que les parts sociales existantes.
4. Acceptation de la souscription de cette nouvelle part sociale, avec une prime d’émission d’un montant total de vingt
millions quatre cent soixante-sept mille quatre cent soixante-treize euros et dix-huit centimes (EUR 20.467.473,18) par
Triton IV LuxCo No.11 S.à r.l. et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle part sociale par apport en nature.
5. Modification des articles 1 et 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées ci-dessus.
6. Divers.
L’Associé a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé d’accepter la modification de la dénomination de la Société de Spinnaker HoldCo S.à r.l pour
Spinnaker Bidco S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un centime d’euro (EUR 0,01) pour le
porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cents euros et un centime
(EUR 12.500,01).
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé a décidé d’émettre une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01), et
ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu:
Triton IV LuxCo No.11 S.à r.l., susmentionné, représenté comme mentionné ci-dessus.
L’Associé a déclaré souscrire à une part sociale nouvelle d'une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01), à
émettre avec une prime d’émission d’un montant de vingt millions quatre cent soixante-sept mille quatre cent soixante-
treize euros et dix-huit centimes (EUR 20.467.473,18), et libérer intégralement cette part sociale souscrite par l’apport en
nature d’un montant de vingt millions quatre cent soixante-sept mille quatre cent soixante-treize euros et dix-neuf centimes
(EUR 20.467.473,19) (l’«Apport»).
L’Apport représente un montant total de vingt millions quatre cent soixante-sept mille quatre cent soixante-treize euros
et dix-neuf centimes (EUR 20.467.473,19).
88872
L
U X E M B O U R G
La preuve par l’Associé de la propriété de l’Apport a été rapportée au notaire soussigné.
L’Associé a déclaré encore que l’Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction à la
proposition de conversion des créances existantes contre la Société et que des instructions valables ont été données en vue
d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un apport valable des créances
existantes détenu contre le Société.
L’Associé a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l’Apport est décrit et évalué (le
«Rapport d’Evaluation»).
Les conclusions du Rapport d’Evaluation sont les suivantes:
«Sur la base du travail effectué et décrit ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à mentionner quant à la valeur de
l’Apport qui est au moins égale à la valeur nominale de la Part Sociale Emise, avec prime d’émission.».
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’allouer une (1) part sociale conformément à la
souscription ci-dessus mentionnée.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’Associé a décidé de modifier les articles 1 et 5 des statuts de la
Société afin de refléter les précédentes résolutions:
En conséquence, les articles 1 et 5 auront dorénavant la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»)
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et les présents statuts (les «Statuts»).
La Société comporte, lors de sa constitution, un associé unique.
La Société adopte la dénomination «Spinnaker Bidco S.à r.l.»
« Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros et un centime (EUR 12.500,01)
divisé en un million deux cent cinquante mille une (1.250.001) parts sociales ayant une valeur nominale d’un centime
d’euro (0,01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à cinq mille huit cents euros (EUR 5.800,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande au même comparant, et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Musteanu, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 19 mai 2015. GAC/2015/4251. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 2 juin 2015.
Référence de publication: 2015081837/187.
(150093191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Atento S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 33.173,72.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 185.761.
Les comptes consolidés au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 Juin 2015.
Référence de publication: 2015080998/10.
(150093758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
88873
L
U X E M B O U R G
Geldilux-TS-2015 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 197.230.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of May.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Stichting Caditris, a foundation (Stichting) established under the laws of the Netherlands, having its statutory seat
(statutaire zetel) in the Netherlands at Debussylaan 18, 1082 MD Amsterdam, registered with the Trade Register of the
Chamber of Commerce of Amsterdam (Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam) under number
53406729,
Being represented by Annick Braquet, employee, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which, proxy after being signed "ne varietur"
by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed
at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following
articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which it declared to establish.
Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration.
1. Form, Corporate name.
1.1 There is hereby formed a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) (the "Company") go-
verned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the Luxembourg law of 10 August 1915 on
commercial companies as amended (the "1915 Law") and by the present articles of incorporation (the "Articles"). The
Company shall be subject to the Luxembourg law dated 22 March 2004 on securitisation, as amended (the "Securitisation
Law").
1.2 The Company exists under the name of "Geldilux-TS-2015 S.A.".
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the
sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder" or the "Shareholder") or in case of plurality of shareholders by
means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles.
2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") or the sole director of the Company (the "Sole
Director") is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s registered office.
2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely
to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The
decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors or by the Sole Director.
3. Object.
3.1 The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the context of one or several
securitisation operations governed by and under the Securitisation Law.
3.2 The Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through
another entity or synthetically, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or
part of the activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be financed
by the issuance of securities (valeurs mobilières) by itself or by another securitisation entity, the value or return of which
depends on the risks acquired or assumed by the Company. For the avoidance of doubt, the Company is not subject to any
risk-diversification requirements.
3.3 Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:
(a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense of
the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies;
(b) subscribe or acquire any other participations in companies, partnerships or other undertakings, which do not qualify
as securities or financial instruments, provided that the Company will not actively intervene with the management of such
undertakings in which it holds a holding, directly or indirectly;
(c) acquire loan receivables which may or may not be embedded in securities;
88874
L
U X E M B O U R G
(d) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial instru-
ments, and provide, within the limits of article 61 (3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security
rights, by way of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;
(e) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions and repo, pledge or any
agreements of a similar kind;
(f) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options)
and any similar transactions;
(g) issue bonds, notes or any other form of debt securities (including by way of participation interest) or equity securities
the return or value of which shall depend on the risks acquired or assumed by the Company; and
(h) enter into loan agreements as borrower within the scope of the Securitisation Law, in particular in order to fund the
acquisition or assumption of risks (i.e. prior to the issuance of the securities or, more generally, where the Company acts
as acquisition entity), to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or any agreement
entered into within the context of its activities and insofar it seems to be useful and necessary within the context of the
transaction.
3.4 The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The
corporate object of the Company shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided
it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.
3.5 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or development
of its corporate object to the largest extent permitted under the Securitisation Law.
4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. - Capital
5. Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (€ 31,000), divided into thirty-one thousand (31,000)
registered shares with a par value of one Euro (€ 1) each, all of which are fully paid up (by 100%).
6. Form of the shares. The shares are in registered form and subject to the relevant legal conditions.
The ownership of the shares is evidenced by the entry in the share register, held at the registered office of the Company.
7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon
conditions, which the Board of Directors or the Sole Director shall from time to time determine. Any amount called up on
shares will be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.
8. Modification of capital.
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the Sole Shareholder or by
resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.
8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.
Chapter III. - Bonds, Notes and other debt instruments
9. Registered or bearer form. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered, or bearer
form. Bonds, notes, certificates or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into
bearer form.
Chapter IV. - Directors, Board of directors and approved statutory auditor(s)
10. Board of directors or sole director.
10.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least
three members (the "Directors" and each a "Director"), who need not be shareholders.
10.2 In case the Company is established by a Sole Shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders,
it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors
consisting of either one Director, named the Sole Director, until the next ordinary general meeting of the shareholders
noticing the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of the
Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such case, such legal entity must designate a permanent
representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only
remove its permanent representative if it appoints its successor at the same time.
10.3 The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders deciding on the remune-
ration and the term of appointment for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any
time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been
appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years
from the date of his election.
10.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement, resignation or otherwise,
the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next
88875
L
U X E M B O U R G
general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election. In the event of vacancy of the Sole Director
because of the death, retirement, resignation or otherwise, an extraordinary general meeting of the Shareholders or the Sole
Shareholder shall elect a Director to fill such vacancy. In case of resignation, the resigning Director will remain in function
until his/her successor has been appointed.
11. Meetings of the board of directors.
11.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman may
be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by
a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.
11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the
Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of its members is present or represented
by proxies.
11.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his
proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.
11.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has
a casting vote.
11.6 The use of video-conferencing equipment or the use of telecommunication means shall be allowed, provided that
each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology,
shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
11.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the
Directors in person (résolutions circulaires). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax
or email. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings, duly
convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.
11.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such
vote is confirmed in writing.
11.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts
shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.
12. General powers of the board of directors / Sole director.
12.1 The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of administration
and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the Board of Directors or the Sole Director.
12.2 The Board of Directors or the Sole Director is authorised to sell, transfer, assign, charge or otherwise dispose of
the assets of the Company in such manner and for such compensation as the Board of Directors or the Sole Director deems
appropriate.
13. Delegation of powers.
13.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs
of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members
of the Board of Directors, Directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such
terms and with such powers as the Board of Directors or the Sole Director shall determine.
13.2 The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons who
need not to be Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
14. Representation of the company. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole
Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of Directors, by the joint signatures of any
two Directors or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors
or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.
15. Approved statutory auditor(s).
15.1 The accounts of the Company are audited by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises
agréé(s)) appointed by the Board of Directors or by the Sole Director.
15.2 The approved statutory auditor(s) is/are appointed for a determined period amongst the auditors registered with the
Commission de Surveillance du Secteur Financier.
15.3 The approved statutory auditor(s) is/are re-eligible.
16. Conflict of interests.
16.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has an interest in, or is a Director,
associate, officer or employee of such other company or firm, provided that paragraph 16.3 is complied with.
88876
L
U X E M B O U R G
16.2 Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.
16.3 In the event that any Director of the Company may have any opposing interest in any transaction of the Company,
such Director shall make known to the Board of Directors such opposing interest and shall not consider or vote upon any
such transaction, and such transaction, and such Director's interest therein, shall be reported to the next following general
meeting of the shareholders of the Company.
16.4 If there is only one Director, by derogation to paragraph 16.3, the minutes shall only mention the operations
intervened between the Company and its Sole Director having an interest opposing with that of the Company.
16.5 The provisions of the preceding paragraphs are not applicable when the decisions of the Board of Directors or of
the Sole Director concern day-to-day operations engaged in normal conditions.
Chapter V. - General meeting of shareholders
17. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.
17.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be
held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the company.
17.2 If there is only one shareholder, that Sole Shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting of
shareholders and shall take the decision in writing.
17.3 In the event of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of
shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. Its resolutions are binding for all shareholders of the Company, irrespective of classes of shares they hold.
17.4 Any general meeting shall be convened in accordance with the 1915 Law by means of convening notice sent to
each registered shareholder by registered letter at least fifteen days before the meeting. It must be convened following the
request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. In the event that all the
shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they
may waive all convening requirements and formalities of publication. Shareholders representing at least ten per cent (10%)
of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of
shareholders. Such request must be addressed to the Company's registered office be registered mail at least five (5) days
before the date of the meeting.
17.5 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
17.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive or
negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, only the forms received by the company three (3)
days prior to the general meeting of shareholders they relate to shall be taken into account.
17.7 The shareholders are entitled to participate in the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means of
communication must comply with technical features guaranteeing effective participation in the meeting whereof the deli-
berations and resolutions are transmitted on a continuous basis.
17.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
shareholders shall be taken by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.
17.9 When the Company has a Sole Shareholder, his decisions are written resolutions.
17.10 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If
the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles
or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both mee-
tings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-thirds of the votes cast of the shareholders present or
represented.
17.11 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be
increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal
requirement.
18. Place and date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is held
in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the first Tuesday
of June at 10.00 a.m.. If such day is a public holiday, the annual general meeting of shareholders will be held on the next
following business day.
19. Other general meetings. Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened
at the written request of the shareholders which together represent one tenth of the capital of the Company with an indication
of the agenda.
88877
L
U X E M B O U R G
20. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general
meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.
Chapter VI. - Business year, Distribution of profits
21. Business year.
21.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each
year.
21.2 The Board of Directors or the Sole Director shall draw up the balance sheet and the profit and loss account. It shall
submit these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual
general meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.
22. Distribution of profits.
22.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation
is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.
22.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distri-
bution of net profits.
22.3 The Board of Directors or the Sole Director may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms
prescribed by law.
Chapter VII. - Dissolution, Liquidation
23. Dissolution, Liquidation.
23.1 The Company may be dissolved by a decision of the Sole Shareholder or by the general meeting of Shareholders
voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.
23.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
Sole Shareholder or the general meeting of shareholders.
23.3 If no liquidators are appointed by the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders, the Directors or the
Sole Director shall be deemed to be liquidator(s) vis-à-vis third parties.
Chapter VIII. - Applicable law
24. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law
and the Securitisation Law.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the Company and ends on 31 December 2015.
The first annual general meeting shall be held on 2016.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for thirty-one thousand (31,000) shares
as follows:
Stichting Caditris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 shares
Total: thirty-one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 shares
All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euro (€ 31,000) is forthwith at the free
disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the 1915
Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 2,500.-
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, Stichting Caditris, considering itself as
duly convened, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting of
the shareholders passed the following resolutions:
1. The Company’s address is fixed at 11, rue Pierre d'Aspelt L-1142, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors, each with a mandate expiring on occasion of the annual general meeting
of shareholders to be held in 2016:
88878
L
U X E M B O U R G
(a) Mr Frédéric Luc Dominique Gardeur, senior manager, born on 11 July 1972 in Messancy (Belgium), with professional
address at 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(b) Mr Smaïn Bouchareb, senior manager, born on 19 August 1978 in Mulhouse (France), with professional address at
412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
(c) Mrs Candice De Boni, senior manager, born on 31 December 1973 in Strasbourg (France), with professional address
at 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the German text, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with Us, the notary,
the present original deed.
Es Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am zwanzigsten Mai.
Vor Uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
ERSCHIEN
Stichting Caditris, eine Stiftung (Stichting) nach dem Recht der Niederlande mit Geschäftssitz (statutaire zetel) in,
Debussylaan 18, 1082 MD Amsterdam, eingetragen bei der Handelskammer in Amsterdam (Handelsregister van de Kamer
van Koophandel voor Amsterdam) unter der Nummer 53406729,
hier vertreten durch Annick Braquet, geschäftsansässig in 101, rue Cents, L-1319 Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg, aufgrund einer ihm, erteilten privatschriftlichen Vollmacht, die, durch den Erschienenen und den unterzeichneten
Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde beigefügt bleibt und zeitgleich mit dieser bei den Registerstellen ein-
gereicht wird.
Der Erschienene, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, hat den Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer
Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen, die er nach eigener Aussage zu gründen wünscht.
Kapitel I. - Firma, Sitz, Dauer des Bestehens, Gesellschaftszweck
1. Rechtsform, Name der Gesellschaft.
1.1 Die Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) (die "Gesellschaft"), gegründet nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") und der vorliegenden Satzung. Die Gesellschaft unterliegt
dem Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung in seiner aktuellen Fassung (das "Verbriefungsgesetz").
1.2 Die Gesellschaft handelt unter dem Namen "Geldilux-TS-2015 S.A.".
2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).
2.2 Der Sitz kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs der Gesellschaft (der "Alleinaktionär" oder der "Aktionär"),
beziehungsweise im Falle des Vorhandenseins mehrerer Aktionäre durch einen den Anforderungen an Satzungsänderungen
genügenden Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre in eine andere Gemeinde innerhalb des
Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.3 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") oder der alleinige Verwaltungsrat der Gesellschaft (der
"alleinige Verwaltungsrat") ist ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde zu verlegen, in der sich
der Sitz der Gesellschaft befindet.
2.4 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen,
aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem Ausland
zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände vorübergehend
ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt, die ungeachtet der
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Sitzverlegung ins Ausland trifft der
Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat.
3. Gesellschaftszweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende
und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbergesellschaft und/oder Emittentin zu fungieren.
3.2 Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar oder über eine andere
Gesellschaft oder synthetisch Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder Ver-
bindlichkeiten Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der
Erwerb oder die Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst
oder eine andere Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere ausgeben, deren Wert oder Rendite von den seitens der Gesellschaft
88879
L
U X E M B O U R G
erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft keinen
Risikodiversifizierungsanforderungen unterliegt.
3.3 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung darf die Gesellschaft insbesondere:
(a) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital- oder Personengesellschaften
begebene Wertpapiere und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwerben;
(b) andere Unternehmensbeteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder anderen Unternehmen zu
erwerben, die nicht als Wertpapiere oder Finanzinstrumente qualifizieren, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft nicht aktiv
in das Management solcher Unternehmen eingreift, in welchen sie, direkt oder indirekt, Unternehmensbeteiligungen hält;
(c) Darlehensforderungen zu erwerben, die verbrieft oder unverbrieft sein können;
(d) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente ver-
walten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Abs. 3 des Verbriefungsgesetzes an den
von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Pfandrechten,
Grundpfandrechten, Gebühren oder jeder andere Form von Sicherheit bestellen;
(e) in Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Wertpapierleihen und Wertpapierpensionsgeschäfte
abschließen sowie Verpfändungen und ähnliche Handlungen vornehmen;
(f) Derivatgeschäfte (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und
vergleichbare Transaktionen abschließen und durchführen;
(g) Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten) oder Aktienwerte
ausgeben, deren Wert oder Rendite von den von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt und
(h) als Kreditnehmer Darlehensvereinbarungen im Rahmen des Verbriefungsgesetzes eingehen, insbesondere zum
Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner,
sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungsoder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr aufgrund
der von ihr ausgegebenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit ihren Tätig-
keiten abgeschlossen hat und insoweit im Rahmen der jeweiligen Transaktion als sinnvoll und erforderlich erscheinen.
3.4 Die oben genannten Beschreibungen sind im weitesten Sinne zu verstehen und ihre Aufzählung ist nicht einschrän-
kend. Der Gesellschaftszweck umfasst und beinhaltet jegliche Handlungen und Verträge, welche die Gesellschaft eingeht,
es sei denn diese stehen nicht in Einklang mit den vorstehenden aufgezählten Zwecken.
3.5 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen,
die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen
und geeignet sind, die Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks im weitesten durch das Verbriefungsgesetz
erlaubte Maß voranzubringen.
4. Dauer des Bestehens. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Kapitel II. - Kapital
5. Kapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000 EUR), eingeteilt in ein-
unddreißigtausend (31.000) Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1 EUR) und ist vollständig
einbezahlt (100%).
6. Form der Anteile. Die Anteile lauten auf den Namen und unterliegen den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.
Das Eigentum an den Anteilen wird durch die Eintragung in das Aktienregister nachgewiesen, das am Sitz der Gesell-
schaft geführt wird.
7. Zahlungen auf Anteile. Zahlungen auf Anteile, die zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht voll eingezahlt waren,
können zu dem Zeitpunkt und zu den Bedingungen erfolgen, wie von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwal-
tungsrat jeweils von Zeit zu Zeit festgelegt. Eingeforderte Einzahlungen auf Anteile werden von allen in Umlauf
befindlichen und nicht voll eingezahlten Anteilen zu gleichen Teilen eingefordert.
8. Kapitalerhöhungen oder - Herabsetzungen.
8.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Ak-
tionäre erhöht oder herabgesetzt werden, der den rechtlichen Anforderungen die für Satzungsänderungen gelten entsprechen
muss.
8.2 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen der rechtlich vorgesehenen Grenzen zurückkaufen.
Kapitel III. - Anleihen, Schuldverschreibungen und Andere Schuldtitel
9. Namens - Oder Inhaberpapiere. Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel als
Namens- oder Inhaberpapiere begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate oder andere Schuldtitel, die als Na-
menspapiere begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht oder umgewandelt werden.
88880
L
U X E M B O U R G
Kapitel IV. - Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat und Zugelassener Wirtschaftsprüfer
10. Verwaltungsrat oder Alleiniger Verwaltungsrat.
10.1 Im Falle des Vorhandenseins einer Mehrzahl von Aktionären, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen
Verwaltungsrat zu führen, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht (die "Verwaltungsratsmitglieder" und jeder ein
"Verwaltungsratsmitglied"), bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss.
10.2 Wird die Gesellschaft durch einen Alleinaktionär gegründet oder wird während einer Hauptversammlung der
Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen Ver-
waltungsrat zu führen, bestehend entweder aus einem einzigen Verwaltungsratsmitglied, genannt der alleinige Verwal-
tungsrat, bis zum Zeitpunkt der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, die das Bestehen von mehr als einem Aktionär
feststellt oder bestehend aus mindestens drei Verwaltungsratsmitgliedern. Eine juristische Person kann Mitglied des Ver-
waltungsrats sein. In einem solchen Falle muss die juristische Person einen ständigen Vertreter benennen, der diese Aufgabe
namens und im Auftrag der juristischen Person erfüllt. Die jeweilige juristische Person kann ihren ständigen Vertreter nur
seines Amtes entheben, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt.
10.3 Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwaltungsrat werden von der Hauptversammlung der Aktionäre
gewählt. Diese legt sowohl deren Vergütung als auch die jeweilige Amtszeit fest. Die Amtszeit darf sechs Jahre nicht
überschreiten, wobei eine Wiederwahl der jeweiligen Mitglieder zulässig ist. Sie können jederzeit durch einen Beschluss
der Hauptversammlung ihres Amtes enthoben werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt worden
sind. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied ohne Angabe der Amtsdauer ernannt wird gilt es als für einen Zeitraum von sechs
Jahren ab Ernennung ernannt.
10.4 Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes, Ausscheidens, Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds oder aus
anderen Gründen frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung abhalten und mit einer Mehrheit
der Stimmen ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz ausfüllt, bis die nächste Hauptversammlung statt-
findet, die zur Bestätigung dieser Wahl aufgefordert werden wird. Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes,
Ausscheidens, Rücktritts des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder aus anderen Gründen frei, soll eine außerordentliche
Hauptversammlung der Aktionäre oder der Alleinaktionär ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz ausfüllt.
Im Fall des Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds, bleibt das zurücktretende Verwaltungsratsmitglied solange im Amt,
bis sein/ihr Nachfolger ernannt worden ist.
11. Sitzungen des Verwaltungsrats.
11.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der erste Vorsitzende kann
von der ersten Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann, wird
er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden Ver-
waltungsratsmitglieder gewählt wird.
11.2 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglied
einberufen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Ein-
haltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten.
11.3 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner
Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte ordnungsgemäß vertreten ist.
11.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich ein anderes
Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes
Verwaltungsratsmitglied auch, telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.
11.5 Sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei
Abstimmungen ist im Fall von Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
11.6 Die Teilnahme per Videokonferenz oder durch Benutzung von Telekommunikationsmedien ist erlaubt, vorausge-
setzt, dass jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen
diese Technologie verwendenden Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind be-
rechtigt per Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.
11.7 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrates kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Un-
terschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen (résolutions circulaires). Die Zustimmung kann in
einem oder mehreren gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Auf diesem
Wege gefasste Beschlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen des Verwal-
tungsrats gefasste Beschlüsse. Das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.
11.8 Stimmabgaben können weiterhin auf anderem Wege erfolgen, wie beispielsweise per Fax, E-Mail oder Telefon,
wobei im letzteren Falle die Stimmabgabe einer schriftlichen Bestätigung bedarf.
11.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrats wird von allen bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmit-
gliedern unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebigen Verwaltungsrats-
mitgliedern beglaubigt.
88881
L
U X E M B O U R G
12. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats oder des Alleinigen Verwaltungsrats.
12.1 Dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat stehen die weitestgehenden Befugnisse zur Vornahme
von Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von Rechts
wegen oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des
Verwaltungsrats oder der alleinige Verwaltungsrat.
12.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat ist berechtigt, Vermögenswerte der Gesellschaft in einer
Weise und für eine solche Ausgleichszahlung zu verkaufen, übertragen, abzutreten, belasten oder anderweitig darüber zu
verfügen, wie sie der Veraltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat für angemessen erachtet.
13. Übertragung von Befugnissen.
13.1 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der
Gesellschaft und zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts auf ein oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrats oder andere Handlungsbevollmächtigte übertragen, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft
handeln muss; die näheren Bedingungen und die übertragenen Befugnisse legt der Verwaltungsrat oder der alleinige Ver-
waltungsrat fest.
13.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann sämtliche Befugnisse oder speziellen Aufgaben auch
an Personen übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sein müssen, Handlungsbevollmächtigte und
Angestellte anstellen und entlassen und deren Bezüge festlegen.
14. Vertretung der Gesellschaft. Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt, für den Fall des allei-
nigen Verwaltungsrats, durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsrats und im Falle von mehreren Verwaltungs-
ratsmitgliedern, durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift
der Person, die eine solche Unterschriftsbefugnis von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder vom alleinigen Verwaltungsrat
übertragen wurde, jedoch nur, soweit diese Befugnis reicht.
15. Zugelassener Wirtschaftsprüfer.
15.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren zugelassenen Wirtschaftprüfern (réviseur
(s) d'entreprises agréé(s)) geprüft, welche(r) vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat gewählt wird.
15.2 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer werden/wird aus dem Kreis der bei der Commission de Surveillance
du Secteur Financier registrierten Wirtschaftsprüfer gewählt und für eine bestimmte Zeit bestellt.
15.3 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer kann/können wiedergewählt werden.
16. Interessenkonflikte.
16.1 Verträge oder sonstige Rechtsgeschäfte der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder Firma werden nicht
dadurch beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Angestellte oder Handlungs-
bevollmächtigte der Gesellschaft ein Interesse an der anderen Gesellschaft oder Firma haben oder Verwaltungsratsmit-
glieder, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte der anderen Gesellschaft oder Firma sind, sofern die
Bestimmungen der Ziffer 16.3 beachtet werden.
16.2 Ein Verwaltungsratsmitglied, Angestellter oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welcher als Verwal-
tungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter in einer Gesellschaft oder Firma tätig ist, mit der die
Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, ist nicht allein aufgrund dieser Verbindung
mit der anderen Gesellschaft oder Firma gehindert, über alle mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbe-
ziehung verbundenen Fragen zu beraten, abzustimmen oder damit zusammenhängende Handlungen auszuführen.
16.3 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein entgegenstehendes Interesse an einem Rechtsgeschäft der
Gesellschaft hat oder verfolgt, teilt das Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat dieses entgegenstehende Interesse
mit und nimmt im Hinblick auf dieses Rechtsgeschäft nicht an Beratungen oder Abstimmungen teil. Von dem Rechtsge-
schäft sowie dem Interesse des Verwaltungsratsmitglieds, wird bei der nächstfolgenden Hauptversammlung der Aktionäre
der Gesellschaft berichtet.
16.4 Bei Vorhandensein nur eines Verwaltungsratsmitglieds, soll das Protokoll, unter Abänderung des Artikels 16.3,
nur den Ablauf zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Verwaltungsrat, der ein Interesse hat, welches dem der
Gesellschaft entgegensteht, aufführen.
16.5 Die Regelungen der vorstehenden Absätze gelten nicht, wenn die Beschlüsse des Verwaltungsrats oder des allei-
nigen Verwaltungsrats laufende Geschäftstätigkeiten zu üblichen Konditionen betreffen.
Kapitel V. - Hauptversammlung
17. Befugnisse des Alleinaktionärs / Der Hauptversammlung.
17.1 Die Gesellschaft kann einen Alleinaktionär zum Zeitpunkt der Gründung haben, wenn alle Anteile der Gesellschaft
von einer einzelnen Person gehalten werden. Tod oder Auflösung des Alleinaktionärs führt nicht zur Auflösung der Ge-
sellschaft.
17.2 Hat die Gesellschaft einen Alleinaktionär, soll dieser Alleinaktionär sämtliche Befugnisse erhalten, die der Haupt-
versammlung zustehen, Beschlussfassungen sollen schriftlich durch den Alleinaktionär erfolgen.
88882
L
U X E M B O U R G
17.3 Soweit die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Hauptversammlung die Gesamtheit der Aktionäre der
Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von
Angelegenheiten der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft, ohne Rücksicht darauf, welche
Klassen von Anteilen sie halten.
17.4 Die Einberufung der Hauptversammlung soll mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung durch den Verwal-
tungsrat und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 an jeden Inhaber von Namensaktien durch schriftliche Einberufungs-
mitteilung per Einschreiben erfolgen. Eine Hauptverhandlung muss einberufen werden, wenn dies ein oder mehrere
Aktionäre, die zusammen mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals halten, verlangen. Sofern sämtliche
Aktionäre während der Hauptversammlung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und sie alle erklären, dass sie
von der Tagesordnung ordnungsgemäß unterrichtet wurden, können diese auf die Einhaltung sämtlicher Anforderungen
bezüglich Einberufung der Versammlung und Veröffentlichung der Tagesordnung verzichten. Ein oder mehrere Aktionäre,
die zusammen mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals halten, können verlangen dass ein oder mehrere
zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung für eine Hauptversammlung gesetzt werden. Ein solcher Antrag ist mindestens
fünf (5) Tage vor der Versammlung per Einschreiben an den Sitz der Gesellschaft zu schicken.
17.5 Ein Aktionär kann sich bei einer Aktionärsversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder
durch andere entsprechende elektronische Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss,
und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten zu
lassen.
17.6 Die Aktionäre sind berechtigt, mittels eines Abstimmungsformulars, das eine Zustimmung, Ablehnung oder
Stimmenthaltung vorsieht, im Umlaufverfahren abzustimmen. Nur die Formulare, die spätestens drei (3) Tage vor der
Hauptversammlung bei dem Sitz der Gesellschaft oder der Adresse, auf die in dem Einberufungsschreiben verwiesen wird,
eingegangen sind, sollen bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschaft berücksichtigt werden.
17.7 Die Aktionäre sind berechtigt, per Videokonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie iden-
tifizieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit und
Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht ge-
eignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen
fortwährend zu übertragen sind.
17.8 Soweit nicht durch Gesetz oder durch die Satzung abweichend geregelt, werden Beschlüsse in den ordnungsgemäß
einberufenen jährlichen oder ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, ungeachtet des Anteils des durch diese Stimmen jeweils vertretenen Kapitals.
17.9 Sofern die Gesellschaft einen Alleinaktionär hat, ergehen dessen Beschlüsse schriftlich.
17.10 Eine zur Änderung der Satzungsbestimmungen einberufene außerordentliche Hauptversammlung kann nur wirk-
sam beraten, wenn mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten ist und die geplante Satzungsänderung sich der Tagesord-
nung entnehmen lässt. Wenn die erste der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung in
der gemäß der Satzung oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgeschriebenen Weise einberufen werden. In
der Einberufungsmitteilung ist die Tagesordnung erneut mitzuteilen und das Datum und die Ergebnisse der vorangegan-
genen Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung kann ungeachtet des Anteils des bei der Versammlung
vertretenen Kapitals wirksam beraten. Bei beiden Hauptversammlungen bedarf eine gültige Beschlussfassung einer Zwei-
drittelmehrheit aller abgegebenen Stimmen.
17.11 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung oder Verringerung der Verbindlichkeiten
der Aktionäre kann dagegen nur einvernehmlich durch alle Aktionäre, unter Einhaltung aller weiteren rechtlichen Erfor-
dernisse beschlossen werden.
18. Zeit und Ort der Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung wird jeweils am ersten Dienstag im Monat
Juni um 10.00 Uhr, an einem Ort in der Stadt Luxemburg abgehalten, der in der Einberufungsmitteilung näher angegeben
wird. Falls dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, wird die Jahreshauptversammlung am ersten darauffolgenden
Geschäftstag abgehalten.
19. Weitere Hauptversammlungen. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Eine
Hauptversammlung ist auf schriftliches Verlangen von Aktionären einzuberufen, die gemeinsam ein Zehntel des Kapitals
der Gesellschaft vertreten unter Angabe der Tagesordnung.
20. Stimmen. Jeder Anteil gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung, selbst bei der Jah-
reshauptversammlung, handeln, indem er schriftlich eine andere Person bevollmächtigt.
Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
21. Geschäftsjahr.
21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats
Dezember eines jeden Jahres.
21.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat soll die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung er-
stellen. Er soll diese Unterlagen zusammen mit einem Geschäftsbericht der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der
88883
L
U X E M B O U R G
Jahreshauptversammlung den externen Wirtschaftprüfern vorlegen, die einen Bericht mit einer Bewertung der vorgelegten
Unterlagen erstellen.
22. Gewinnausschüttung.
22.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisen. Eine
solche Zuweisung zu den Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindes-
tens ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.
22.2 Nachdem die Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen erfolgt ist, entscheidet die Hauptversammlung über Ver-
wendung und Ausschüttung der Nettogewinne.
22.3 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den rechtlich vorgeschriebenen
Bedingungen Interimsdividenden auszuschütten.
Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation
23. Auflösung, Liquidation.
23.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst
werden, für den dieselben Anforderungen an Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gelten wie für die Änderung
der Satzung.
23.2 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere vom Alleinaktionär oder
von der Hauptversammlung bestellte Liquidatoren.
23.3 Wenn keine Liquidatoren von dem Alleinaktionär oder der Hauptversammlung bestellt werden, gelten die Ver-
waltungsratsmitglieder gegenüber Dritten als Liquidator(en).
Kapitel VIII. - Geltendes Recht
24. Geltendes Recht. Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des
Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.
Die erste Generalversammlung findet im 2016 statt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei einunddreißigtausend (31.000) Anteile wie nach-
stehend angegeben gezeichnet:
Stichting Caditris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 Anteile
Insgesamt: einunddreißigtausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 Anteile
Diese Anteile sind sämtlich voll eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000 EUR) der Ge-
sellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26, 26-3 und 26-5 des
Gesetzes von 1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer
Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf ca. 2.500.- EUR geschätzt.
<i>Erste Beschlüsse des Alleinaktionärsi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei Stichting Caditris, die die Versammlung
als ordnungsgemäß einberufen erachtet, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals und in Ausübung der Befugnisse
der Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Als Anschrift der Gesellschaft wird 11, rue Pierre d'Aspelt L-1142 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg vorge-
sehen.
2. Die folgenden Personen wurden als Verwaltungsratsmitglieder gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre
2016 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:
(a) Herr Frédéric Luc Dominique Gardeur, senior manager, geboren am 11 Juli 1972 in Messancy (Belgium), ge-
schäftsansässig in 412F route d'Esch, L-2086 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
(b) Herr Smaïn Bouchareb, senior manager, geboren am 19 August 1978 in Mulhouse (Frankreich), geschäftsansässig
in 412F route d'Esch, L-2086 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
(c) Frau Candice De Boni, senior manager, geboren am 31 December 1973 in Strasbourg (Frankreich), geschäftsansässig
in 412F route d'Esch, L-2086 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
88884
L
U X E M B O U R G
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, aktiert hiermit, dass auf Anfrage der oben
genannten erschienenen Person, die vorliegende Ausfertigung in Englisch verfasst ist, welcher eine deutsche Übersetzung
beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Person und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, wird der englische Text maßgebend sein.
Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn genannten Tage in Luxemburg
errichtet.
Nachdem die Urkunde der erschienenen Person vorgelesen wurde, unterzeichnete die erschienene Person gemeinsam
mit dem Notar diese Originalurkunde.
Gezeichnet: A. BRAQUET und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 22 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/16016. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 2. Juni 2015.
Référence de publication: 2015081387/617.
(150093993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Urban 67 (European RE Club) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 192.794.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2015.
Pour statuts coordonnés
Référence de publication: 2015080021/11.
(150091224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Fer.bel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8814 Bigonville, 3, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 197.233.
STATUTS
L'an deux mil quinze, le vingt mai.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Monsieur Romain BELCHE, né à Luxembourg, le 2 janvier 1967, demeurant à L-8814 Bigonville, 3, rue des Champs.
2. Madame Louise SCHAAF, née à Luxembourg, le 5 juin 1962, demeurant à L-8814 Bigonville, 3, rue des Champs.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet le commerce et l’achat-vente de produits divers.
Elle peut en outre faire toutes opérations mobilières ou immobilières, industrielles, commerciales ou financières se
rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui sont de nature à favoriser ou à
développer l'activité de la société.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de Fer.bel S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Bigonville.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
88885
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts
sociales de cent euros (100.- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l'article 199 de la loi concernant
les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés
que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.
Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à que celui-ci ait atteint
dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont
remplies.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Romain BELCHE, prénommé,
Trente-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
2. Madame Louise SCHAAF, préqualifiée,
Quatre-vingt-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
TOTAL: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison de sa constitution est évalué à EUR 1.200.-
88886
L
U X E M B O U R G
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-8814 Bigonville, 3, rue des Champs.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L'assemblée désigne comme gérant unique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Romain BELCHE, prénommé.
Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et autoriser
les actes et opérations relatifs à son objet par sa seule signature.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. BELCHE, L. SCHAAF et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 22 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/16019. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 juin 2015.
Référence de publication: 2015081344/95.
(150094017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
EJL Real Estate G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 166.913.
Im Jahre zweitausend und fünfzehn.
Den zwölften Mai.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts EJL GROUP GmbH, mit Sitz in D-72379 Hechingen, Im
Nasswasen 10, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 751167 (ehemals EJL
GROUP S.A., HRL B 166222),
hier vertreten durch Herrn Eugen LÖWENSTEIN, Geschäftsführer, wohnhaft in D-72379 Hechingen-Boll, Weidenweg
32, aufgrund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift vom 12. Mai 2015,
welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparentin erklärte, dass sie die alleinige Anteilhaberin der Luxemburger Gesellschaft EJL Real Estate
G.m.b.H. war, mit Sitz in L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister
Luxembourg unter der Nummer B 166.913.
Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. Februar
2012, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 816 vom 28. März 2012, und deren
Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 2. Juli 2014, veröffentlicht
im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2438 vom 10. September 2014.
Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, dem unterfertigten Notar, zwecks Hinterlegung zu seinen Urkunden,
eine beglaubigte Ausfertigung einer notariellen Urkunde aufgenommen durch Dr. Ulrich DEMPFLE, Notar in Trier,
Deutschland, am 26. August 2014, Urkundenrolle Nummer 1607/2014U NA, überreicht.
Vorerwähnte Urkunde beinhaltet die Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EJL
Real Estate G.m.b.H. von Luxembourg nach Deutschland.
Die Gesellschaft EJL Real Estate GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB
752317 eingetragen.
Nachdem die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, hiermit die in Deutschland getroffenen Beschlüsse gutgeheissen
hat, ersuchte sie den amtierenden Notar die vorerwähnte Gesellschaft mit beschränkter Haftung EJL Real Estate G.m.b.H.
im Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg zu streichen.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem
Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit
dem Notar unterschrieben.
88887
L
U X E M B O U R G
Gezeichnet: E. LÖWENSTEIN, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 13 mai 2015. Relation: GAC/2015/4118. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Es folgt die Ausfertigung der Urkunde des Notars Justizrat Dr. Ulrich DEMPFELE:
Ausfertigung
der
URKUNDE
des Notars
JUSTIZRAT DR. ULRICH DEMPFLE
Weberbach 66 - 54290 Trier
Nachstehende Ausfertigung stimmt mit der Urschrift überein und wird erteilt für:
EJL Real Estate G.m.b.H. mit dem Sitz in Luxemburg.
Trier, den 11 Februar 2015.
Justizrat Dr Dempfle, Notar
APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1. Land: Bundesrepublik Deutschtand
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Notar Justizrat Dr. Dempfle in Trier
3. in seiner / Eigenschaft als Notar in Trier
4. sie ist versehen mit dem Siegel /
des Justizrat Dr. Ulrich Dempfle, Notar in Trier
Bestätigt
5. in Trier 6. am 13. Februar 2015
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nummer: -91aE 79/2015-
9. Siegel /
10. Unterschrift
In Vertretung:
(Wolfgang Specht)
Vorsitzender Richter am Landgericht
Urkundenrolle Nummer 1607 /2014U NA
Verhandelt in Trier am 26. August 2014.
Vor dem unterzeichnenden
Dr. Ulrich Dempfle
Notar in Trier
erschien - ausgewiesen durch Vorlage des amtlichen Lichtbildausweises -:
Herr Eugen Löwenstein, geboren am 24. Mai 1979, wohnhaft in 72379 Hechingen, Weidenweg 32,
hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als alleiniger Geschäftsführer der im Handels- und Gesellschaftsregister
des Großherzogtums Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer B 166222 eingetragenen EJL GROUP S.A. mit Sitz in
Luxemburg.
Der Notar bescheinigt aufgrund elektronischer Einsichtnahme in das Handels- und Gesellschaftsregister des Großher-
zogtums Luxemburg vom 25. August 2014 die vorstehende Vertretungsberechtigung.
Der Erschienene ließ folgenden
Grenzüberschreitenden Formwechsel
beurkunden und erklärte, handelnd wie angegeben:
I. Sachverhalt
Im Handels- und Gesellschaftsregister des Großherzogtums Luxemburg ist unter der Nummer B 166913 die EJL Real
Estate G.m.b.H. mit Sitz in Luxemburg eingetragen. Das Gesellschaftskapital beträgt 25.000,- Euro und ist aufgeteilt in
200 Anteile mit einem Nennbetrag jeweils von 125 - Euro. Sämtliche Anteile werden von der EJL GROUP S.A. als alleiniger
Gesellschafterin gehalten. Nach Angabe des Erschienenen ist das Gesellschaftskapital durch Bareinzahlung vollständig
erbracht.
88888
L
U X E M B O U R G
II. Formwechsel
Sodann hält die EJL GROUP S.A. - vertreten durch den Erschienenen - unter Verzicht auf sämtliche Formen und Fristen
als alleinige Gesellschafterin eine Gesellschafterversammlung der EJL Real Estate G.m.b.H. ab und beschließt mit allen
Stimmen:
§1. Umwandlungsbeschluss.
1. Die EJL Real Estate G.m.b.H. mit dem Sitz in Luxemburg wird durch Formwechsel in eine GmbH deutschen Rechts
umgewandelt. Der Gegenstand der Gesellschaft bleibt unverändert.
2. Die Firma der GmbH lautet: EJL Real Estate GmbH. Sie hat ihren Sitz in Hechingen.
3. Die EJL Real Estate GmbH erhält ein Stammkapital von 25.000,- Euro. In entsprechender Anwendung des § 247
Abs. 1 UmwG wird das Gesellschaftskapital der luxemburgischen EJL Real Estate G.m.b.H. in Höhe von 25.000,- Euro
zum Stammkapital der deutschen EJL Real Estate GmbH.
4. Das Stammkapital bleibt weiterhin eingeteilt in Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils 125 - Euro, die sämtlich
von der EJL GROUP S.A. als alleiniger Gesellschafterin übernommen werden.
5. Die Erschienenen stellen sodann für die EJL Real Estate GmbH die Satzung gemäß Anlage 1 dieser Urkunde fest,
auf die hiermit verwiesen wird. Die Feststellung der Satzung ist Bestandteil des Formwechselbeschlusses. Zu überneh-
mende Festsetzungen über Sondervorteile, Sacheinlagen oder Sachübernahmen enthält die Satzung der EJL Real Estate
G.m.b.H. mit Sitz in Luxemburg nicht.
6. Ein Abfindungsangebot nach § 207 UmwG ist nicht erforderlich, da die EJL GROUP S.A. alleinige Gesellschafterin
ist (§ 194 Abs. 1 Nr. 6 UmwG).
7. Die Erstellung eines Umwandlungsberichtes ist ebenfalls nicht erforderlich (§ 192 Abs. 2 S. 1 UmwG). Jedenfalls
wird auf dessen Erstellung verzichtet.
8. Bei der formwechselnden Gesellschaft besteht kein Betriebsrat. Die EJL Real Estate GmbH hat derzeit keine Ar-
beitnehmer.
9. Die EJL Real Estate G.m.b.H. ist Eigentümerin des bei dem Amtsgericht Hechingen im Grundbuch von Hechingen
BI. 6431 unter lfd. Nr. I (Flurstück 1975/4) vorgetragenen Grundbesitzes. Die Berichtigung des Grundbuchs und Eintragung
der EJL Real Estate GmbH mit Sitz in Hechingen wird allerorts beantragt.
§2. Geschäftsführerbestellung. Zum Geschäftsführer der EJL Real Estate GmbH wird bestellt:
Herr Eugen Löwenstein, wohnhaft in 72379 Hechingen.
Er vertritt die Gesellschaft einzeln, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind. Ihm wird vollständige Befreiung
von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt.
III. Durchführungsvollmacht
Erforderliche Genehmigungen zu dieser Urkunde sollen wirksam werden mit ihrem Eingang bei dem Notar in gehöriger
Form.
Die Vertragsbeteiligten erteilen:
1. Frau Claudine Wagner, Bürovorsteherin,
2. Frau Margarete Elsenberg, Notarfachangestellte,
dienstansässig beim amtierenden Notar, je einzeln Vollmacht, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB,
Erklärungen, Bewilligungen und Anträge materiell- oder formellrechtlicher Art zur Ergänzung oder Änderung des Ver-
trages abzuändern, soweit Änderungen nach Ansicht des Registergerichts oder der Industrie- und Handelskammer
erforderlich sind.
Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen als auf die Teilnahme an Gesell-
schafterversammlungen, insbesondere zur Fassung von Gesellschafterbeschlüssen und Vornahme von Wahlen, sowie zur
Änderung von Registeranmeldungen.
IV. Hinweise, Schlussbestimmungen
Der Notar hat insbesondere darauf hingewiesen,
- dass der Formwechsel erst mit der Eintragung in das Handelsregister wirksam wird,
- dass die bisherigen Organe zu diesem Zeitpunkt ihre Funktion kraft Gesetzes verlieren,
- dass Gläubiger der Gesellschaft unter Umständen Sicherheit für ihre Forderungen verlangen und die Geschäftsführer
der form wechselnden G.m.b.H. auf Schadensersatz in Anspruch nehmen können,
- dass Sonderrechte, die in der form wechselnden G.m.b.H. zugunsten Dritter bestehen, diesen Dritten in vergleichbarer
Form auch in der EJL Real Estate GmbH zu gewähren sind,
- dass die Sachgründungsvorschriften des GmbHG zu beachten sind, also insbesondere die Erstellung eines Sachgrün-
dungsberichtes und ein Wertnachweis über die Sacheinlage erforderlich sind.
Die Kosten dieser Urkunde und ihrer Durchführung trägt die Gesellschaft.
88889
L
U X E M B O U R G
Diese Niederschrift nebst Anlage wurde dem Erschienenen von dem Notar vorgelesen, von ihm genehmigt und von ihm
und dem Notar, eigenhändig, wie folgt, unterschrieben:
Anlage zu der UR.Nr. 1607 /2014 U
des Notars Dr. Ulrich Dempfle mit dem Amtssitz in Trier
Unterschrift
<i>Notari>
Gesellschaftsvertrag
§1. Firma und Sitz.
1 Die Firma der Gesellschaft lautet:
EJL Real Estate GmbH
2 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hechingen.
§2. Gegenstand des Unternehmens. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung
von Immobilien.
Gegenstand des Unternehmens ist auch der Erwerb von Beteiligungen jedweder Form an anderen in- und ausländischen
Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,
Kauf oder in anderer Form, und dieselben durch Verkauf, Abtretung Tausch oder in anderer Weise veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben
und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt maßgeblich
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung , Darlehen Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-
Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der
Gesellschaft förderlich sind.
§3. Stammkapital und Geschäftsanteile.
1. Das Stammkapital beträgt 25.000,- Euro
(in Worten: funfundzwanzigtausend Euro)
2. Es bestehen 200 Geschäftsanteile im Nennbetrag von je 125,00 Euro.
Diese sind aufgrund des Formwechsels von der EJL GROUP S.A. übernommen worden.
Das Stammkapital wird durch Formwechsel der EJTL Real Estate G.m.b.H. mit Sitz in Luxemburg erbracht. Das Ge-
sellschaftskapital der EJL Real Estate G.m.b.H. mit Sitz in Luxemburg in Höhe von 25.000,- Euro wird in der bisherigen
Höhe zum Stammkapital des neuen Rechtsträgers.
§4. Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr, Kündigung.
1. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, das mit dem auf die
Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister folgenden 31. Dezember endet.
3. Die Gesellschaft kann mit sechsmonatiger Frist zum Schluss des Geschäftsjahres von jedem Gesellschafter gekündigt
werden. Die Kündigung bedarf einer an die Gesellschaft zu richtenden und durch eingeschriebenen Brief zu übersendenden
Erklärung des kündigenden Gesellschafters.
4. Die Kündigung hat nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern das Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters
zum Ende des Geschäftsjahres zur Folge. Von diesem Stichtag an ruhen alle Gesellschafterrechte des ausgeschiedenen
Gesellschafters. Die Gesellschaft wird von den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt, wenn diese nicht unverzüglich die
Auflösung beschließen.
5. Der kündigende Gesellschafter hat den verbleibenden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung am Stamm-
kapital oder einem von den verbleibenden Gesellschaftern zu benennenden Dritten seinen Geschäftsanteil abzutreten oder
die Einziehung gemäß § 10 dieses Vertrages zu dulden. Ein unteilbarer Spitzenbetrag steht dem Gesellschafter mit dem
kleinsten Geschäftsanteil zu.
Der Anteil des ausgeschiedenen Gesellschafters ist gem. § 12 dieses Vertrages zu vergüten.
§5. Geschäftsführung und Vertretung.
1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
2. Die Gesellschaft wird vertreten;
a) wenn nur ein Geschäftsführer vorhanden ist, durch diesen,
b) wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Ge-
schäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.
88890
L
U X E M B O U R G
3. Durch Beschluss der Gesellschafter kann:
a) für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, einzelnen von ihnen die Befugnis zur Einzel Vertretung
gewährt werden,
b) bestimmt werden, dass ein Geschäftsführer nur aus wichtigem Grund abberufen werden kann,
c) sowohl einem Geschäftsführer oder Liquidator als auch mehreren oder allen vollständige Befreiung von den Bes-
chränkungen des § 181 BGB erteilt werden.
4. Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführer ergeben sich aus dem Gesetz, dem Anstellungsvertrag und den von den
Gesellschaftern gegebenen Anweisungen. Die Gesellschafter können mit einer 3/4-Mehrheit eine Geschäftsordnung für
die Geschäftsführer beschließen.
5. Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer (im Außenverhältnis) ist unbeschränkt. Geschäftsführungsmaßnahmen,
die über den gewöhnlichen Geschäftsverkehr hinausgehen, und solche, die die Geschäftsordnung bestimmt, bedürfen je-
doch (im Innenverhältnis) der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.
6. Die Absätze 1. bis 3 gelten für Liquidatoren entsprechend.
§6. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen oder durch schriftliche, fernschriftliche
oder elektronische Abstimmungen gefasst, wenn sich alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden
erklären oder sich an ihr beteiligen.
2. Beschlüsse, die nicht in Gesellschafterversammlungen gefasst werden, haben die Geschäftsführer sämtlichen Ge-
sellschaftern durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen.
3. Je 1,- EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.
4. Die Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit nichts anderes im Gesetz oder nach diesem Gesellschaftsvertrag bes-
timmt ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
5. Einer 3/4-Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedürfen folgende Beschlüsse:
- Auflösung der Gesellschaft,
- Erhöhung des Stammkapitals, sofern nicht allen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile ein Bezugsrecht
eingeräumt wird,
- Änderung der für Gesellschafterbeschlüsse erforderlichen Mehrheiten.
6. Gesellschafterbeschlüsse, deren Zustandekommen oder Inhalt nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften
verstößt, können nur innerhalb drei Monaten seit Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Hinsichtlich in der
Versammlung nicht anwesenden und nicht vertretenen Gesellschaftern beginnt die Frist erst mit dem Zugang des Bes-
chlussprotokolls.
§7. Gesellschafterversammlung.
1. Eine Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn dies nach dem Gesetz oder nach dem Wortlaut dieses Ge-
sellschaftsvertrages erforderlich ist, in jedem Fall, wenn die Einberufung aus sonstigen Gründen im Interesse der
Gesellschaft Hegt bzw. von Gesellschaftern, die zusammen mindestens 10 % des Stammkapitals innehaben, verlangt wird.
Jährlich einmal ist eine ordentliche Gesellschafter-Versammlung abzuhalten, die über die Feststellung des Jahresabschlus-
ses und die Gewinnverwendung sowie die Entlastung der Geschäftsführung beschließt.
2. Die Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft statt. Den Vorsitz fuhrt der Gesellschafter mit dem
größten Anteil am Stammkapital. Die Versammlung kann mit einfacher Mehrheit einen anderen Vorsitzenden wählen.
3. Die Versammlung wird durch die Geschäftsführung einberufen. Es genügt die Einberufung durch einen Geschäfts-
führer.
Sollten Gesellschafter, die mindestens 10 % des Stammkapitals innehaben gemäß vorstehendem Absatz (1) die Einbe-
rufung einer Gesellschafterversammlung verlangt haben und der/die Geschäftsführer diesem Verlangen nicht innerhalb
von 14 Tagen nachgekommen sein, haben diese Gesellschafter das Recht, anstelle des/der Geschäftsführer(s) eine Gesell-
schafterversammlung einzuberufen.
4. Die Einladung zur Gesellschafterversammlung erfolgt schriftlich und unter Angabe der Tagesordnung und des Ta-
gungsortes. Bei der ordentlichen Gesellschafterversammlung ist eine Frist von drei Wochen, bei einer außerordentlichen
Gesellschafterversammlung eine Frist von einer Woche einzuhalten, wobei der Tag der Absendung des Briefes und der
Tag der Versammlung nicht mitgerechnet werden.
5. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist. Fehlt
es daran, so ist innerhalb von vier Wochen eine neue Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die dann
ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital immer beschlussfähig ist. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
6. Über sämtliche Beschlüsse ist - soweit nicht notarielle Beurkundung erforderlich ist - eine Niederschrift unter Angabe
der Beschlussgegenstände zu fertigen und von den Geschäftsführern zu unterzeichnen.
88891
L
U X E M B O U R G
§8. Jahresabschluss, Ergebnisverwendung.
1. Alle Geschäftsführer haben innerhalb der gesetzlichen Frist des § 264 1 HGB für das vergangene Geschäftsjahr den
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung nebst Anlagen) fertigen zu lassen und mit einem Vorschlag über
die Ergebnisverwendung, also darüber, inwieweit der Jahresüberschuss zuzüglich eines Gewinnvortrages und abzüglich
eines etwaigen Verlustvortrages in Gewinnrücklagen eingestellt, als Gewinn vorgetragen oder an die Gesellschafter aus-
geschüttet wird, der Gesellschafter-Versammlung zur Genehmigung vorzulegen. Dabei sind die handelsrechtlichen
Vorschriften zu befolgen und steuerliche Vorschriften sowie Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte zu berücksichtigen.
2. Etwaig ausgeschütteter Gewinn steht den Gesellschaftern entsprechend ihren Geschäftsanteilen zu, soweit sie nicht
unter Zustimmung der Betroffenen etwas anderes beschließen. Die Gesellschafter können beschließen, dass die Auszahlung
erst nach Ablauf einer bestimmten Frist erfolgen soll.
3. Die Organe der Gesellschaft sind nicht befugt, einem Gesellschafter außerhalb satzungsmäßiger Gewinnausschüt-
tungsbeschlüsse Vorteile zu gewähren, die einem Dritten bei ordnungsmäßiger Geschäftsführung nicht gewahrt würden.
Wird hiergegen verstoßen, so hat der begünstigte Gesellschafter den Vorteil an die Gesellschaft zurückzuerstatten. Das gilt
insbesondere dann, wenn von der Finanzverwaltung rechtskräftig eine verdeckte Gewinnausschüttung angenommen wird.
Der Anspruch entsteht bereits im Zeitpunkt der Vorteilsgewährung. Zurückliegende Bilanzen sind entsprechend zu be-
richtigen.
§9. Veräußerung von Geschäftsanteilen.
1. Die Abtretung oder Verpfändung eines Geschäftsanteils oder von Teilen eines Geschäftsanteils sowie die Bestellung
von Nießbrauchsrechten bedarf der schriftlich zu erklärenden Genehmigung durch die Gesellschaft, deren Erteilung im
Innenverhältnis von einem mindestens mit einfacher Mehrheit zu fassenden Zustimmungsbeschluss der Gesellschafter-
versammlung abhängig ist.
Das gleiche gilt für die Übertragung im Wege der Erbauseinandersetzung und für Verpflichtungsgeschäfte in Ansehung
eines Geschäftsanteils oder von Teilen eines solchen.
2. Die Abtretung von Geschäftsanteilen an Mitgesellschafter, an Ehegatten oder Abkömmlinge eines Gesellschafters
bedarf keiner Genehmigung. Dies gilt nicht für die Verpfändung und Nießbrauchsrechtsbestellung.
3. Falls diese Gesellschaft persönlich haftende Gesellschafterin einer Kommanditgesellschaft ist, ist die Veräußerung
eines Geschäftsanteils nur wirksam, wenn gleichzeitig der Kommanditanteil an denselben Erwerber abgetreten wird, bei
der Veräußerung eines Teilgeschäftsanteils ein entsprechender Teilkommanditanteil, der demselben Beteiligungsverhältnis
entspricht.
4. Der/die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den Personen der Gesell-
schafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschriebene Gesellschafterliste der Gesellschaft zum
Handelsregister einzureichen. Die Veränderungen sind dem bzw. den Geschäftsführern schriftlich mitzuteilen und nach-
zuweisen. Als Nachweis sind im Allgemeinen entsprechende Urkunden in Urschrift oder beglaubigter Abschrift vorzule-
gen. Für den Nachweis der Erbfolge gilt § 35 GBO entsprechend.
§10. Einziehung.
1. Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist mit Zustimmung des betreffenden Gesellschafters jederzeit zulässig. Sie
wird wirksam mit Zugang des Einziehungsbeschlusses an den betreffenden Gesellschafter.
Die Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich, wenn
a) über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren angeordnet ist oder das Insolvenzverfahren mangels
Masse abgelehnt wird bzw. wenn der Gesellschafter die Zahlungen einstellt,
b) Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, insbesondere Pfändungen in den Geschäftsanteil, aufgrund eines nicht nur vor-
läufig vollstreckbaren Titels eingeleitet werden oder erfolgt sind, die nicht innerhalb von drei Monaten wieder aufgehoben
werden.
c) in der Person des Gesellschafters ein wichtiger Grund gegeben ist, der seine Ausschließung aus der Gesellschaft
rechtfertigt.
Ein Geschäftsanteil, der mehreren Inhabern nach Bruchteilen oder zur gesamten Hand zusteht, kann eingezogen werden,
wenn die Voraussetzungen auch nur für einen Mit berechtigten vorliegen.
2. Bei Beschlüssen über die Zwangseinziehung eines Geschäftsanteils hat der betroffene Gesellschafter kein Stimmrecht.
3. In allen Fällen der Einziehung ist ein nach § 12 dieses Vertrages zu bemessendes Entgelt zu zahlen. In allen Fällen
der Einziehung des Geschäftsanteils hat die Auszahlung des Gegenwertes zinslos innerhalb von sechs Monaten nach er-
folgter Beschlüssfassung zu erfolgen.
4. Die Einziehung gegen Entgelt ist jedoch dann ausgeschlossen, wenn dieses nicht aus vorhandenen, offen ausgewie-
senen Überschüssen erbracht werden kann bzw. wenn zu dessen Aufbringung eine Kapitalherabsetzung nicht wirksam
beschlossen werden kann.
5. Anstelle der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass der Anteil gegen Entgelt von der
Gesellschaft erworben oder auf von ihr benannte Personen, die auch selbst Gesellschafter sein können, übertragen wird.
Der Gesellschafter, dessen Geschäftsanteil erworben wird, hat in diesen Fällen kein Stimmrecht. Die Höhe des Entgeltes
und die Zahlungsweise bestimmen sich nach § 12 dieses Vertrages.
88892
L
U X E M B O U R G
6. Die Einziehung bleibt wirksam auch wenn über die Höhe des Abfindungsentgelts gestritten wird. Eine statt der
Einziehung beschlossene Abtretung hat zu erfolgen, auch wenn die Höhe des Abfindungsentgelts noch nicht festgestellt
ist.
§11. Tod eines Gesellschafters. Der Geschäftsanteil eines jeden Gesellschafters ist vererblich. Falls ein Gesellschafter
nicht ausschließlich von Mitgesellschaftern, seinem Ehegatten oder seinen Abkömmlingen beerbt wird, kann der Ge-
schäftsanteil des verstorbenen Gesellschafters gegen Entgelt eingezogen werden. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach
§ 12 dieses Vertrages.
§12. Abfindungsanspruch.
1. Scheidet ein Gesellschafter durch Kündigung, Einziehung oder durch eine die Einziehung ersetzende Übertragung
an einen Dritten aus der Gesellschaft aus, steht ihm eine Abfindung zu.
2. Zur Bewertung des Anteils des ausscheidenden Gesellschafters hat die Geschäftsführung den Wert des Unternehmens
zu bewerten oder bewerten zu lassen. Maßgeblich sind die in IDW-Standard Sl in seiner jeweiligen Fassung festgelegten
Kriterien. Von dem auf den ausscheidenden Gesellschafter entfallenden Anteil am Untemehmenswert ist ein Sicherheit-
sabschlag von 40% zu machen.
3. Die Abfindung ist in drei gleichen Jahresraten zu entrichten. Die erste Rate ist einen Monat nach Ausscheiden des
Gesellschafters fällig. Der jeweils offenstehende Teil der Abfindung ist mit einem um 2 %-Punkte über dem Basiszinssatz
nach § 247 BGB liegenden Jahressatz zu verzinsen. Die aufgelaufenen Zinsen sind mit jeder Rate zu bezahlen. Die Ge-
sellschafter oder der Übernehmer ist jederzeit berechtigt, die Abfindung ganz oder teilweise vorzeitig zu entrichten, ohne
zum Ausgleich der entfallenden Zinszahlungen verpflichtet zu sein.
4. Entsteht über die Höhe der nach den obenstehenden Regelungen geschuldete Abfindung Streit, so ist dieser Wert für
beide Seiten verbindlich von einem Sachverständigen zu ermitteln, der auf Antrag des ausscheidenden Partners oder der
Gesellschaft durch den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer zu benennen ist. Der Sachverständige entscheidet
nicht über die Wirksamkeit der Abfindungsklausel.
5. Sicherheiten für den Abfindungsanspruch können von dem ausscheidenden Gesellschafter nicht verlangt werden.
6. Soweit zwingende Gesetzesbestimmungen nicht entgegenstehen, kann ein eingezogener Geschäftsanteil durch eins-
timmigen Beschluss der Gesellschafter neu gebildet werden.
§13. Wettbewerb.
1. Den Gesellschaftern ist es untersagt, sich im Bereich des Gegenstandes des Unternehmens der Gesellschaft zu betä-
tigen.
2. Durch Gesellschafterbeschluss können einzelne oder alle Gesellschafter von diesem Wettbewerbsverbot befreit wer-
den. Die Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche und ein eventuelles Entgelt werden ebenfalls durch Gesellschafterbeschluss
festgelegt.
§14. Bekanntmachungen. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.
§15. Schlussbestimmungen.
1. Durch die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages werden die anderen Bestimmungen nicht berührt. An
die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt dann die gesetzliche Regelung.
2. Ergänzungen oder Änderungen des Gesellschaftsvertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der notariellen Beur-
kundung.
Enregistré à Grevenmâcher Actes Civils, le 13 mai 2015. Relation: GAC/2015/4118. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Echternach, den 2. Juni 2015.
Référence de publication: 2015082277/353.
(150094228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
System and Management Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 62.633.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2015.
Référence de publication: 2015077399/10.
(150088207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.
88893
L
U X E M B O U R G
Tikehau Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 186.113.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 22 mai 2015i>
En date du 22 mai 2015, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Bruno de Pampelonne, de Monsieur Bertrand Gibeau et de Monsieur Jean-
Marc Delfieux, en qualité d’Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016,
- de renouveler le mandat de Ernst & Young, en qualité de Réviseur d’Entreprises agréé jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2016.
Luxembourg, le 1
er
juin 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Tikehau Fund
i>CACEIS Bank Luxembourg
Référence de publication: 2015082799/17.
(150094104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Eurinvest, Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 112.452.
L'an deux mille quinze, le quinze mai.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EURINVEST S.A., avec siège social à L-1313 Luxembourg,
14, rue des Capucins, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B112.452, constituée
suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, notaire alors de résidence à Remich, le 17 novembre 2005, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 52 du 9 janvier 2006. Les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et en dernier lieu par-devant Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 21
décembre 2012, publié au dit Mémorial C, Numéro 490 du 27 février 2013.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Christelle DEMICHELET, employée privée, demeurant professionnel-
lement à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri, qui désigne comme secrétaire Sophie BECKER, employée
privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri,
L'assemblée choisit comme scrutateur Sophie BECKER, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Revue et approbation des comptes intérimaires.
2. Absence de rapport justificatif du conseil d'administration prévu par le paragraphe (3) de l’article 265 de la loi sur les
sociétés commerciales;
3. Absence de rapport de l’expert indépendant sur le projet de fusion, prévu par le paragraphe (5) de l’article 266 de la
loi sur les sociétés commerciales;
4. Constatation de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales;
5. Approbation du projet de fusion tel qu'il a été publié au Mémorial C numéro 978 en date du 13 avril 2015;
6. Augmentation du capital social à concurrence de trente mille euros (30.000,- EUR) par l’émission de trois cents (300)
actions nouvelles, et ce en échange des actions et de la transmission de tous les actifs et passifs de la société BY INTERNET
S.A. à la Société, à la date de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés fusionnantes statuant
sur la fusion;
7. Attribution à l’actionnaire de la Société des actions nouvellement émises, ainsi que tous les droits qui y sont attachés,
avec jouissance à la date de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés fusionnantes statuant
sur la fusion;
8. Modification de l’article 5 alinéa 1
er
des statuts afin de refléter l’augmentation de capital;
9. Divers.
88894
L
U X E M B O U R G
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l’enregistrement.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront
également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre
du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.
IV.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:
1. Publication au Mémorial C numéro 978, en date du 13 avril 2015, du projet de fusion établi par le conseil d’admi-
nistration de chacune des sociétés qui fusionnent, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées
à se prononcer sur le projet de fusion.
2. Absence de rapport justificatif du conseil d'administration prévu par le paragraphe (3) de l’article 265 de la loi sur les
sociétés commerciales.
3. Absence de rapport de l’expert indépendant sur le projet de fusion, prévu par le paragraphe (5) de l’article 266 de la
loi sur les sociétés commerciales.
4. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social respectif de
chacune des sociétés un mois avant la date de la réunion de l’assemblée générale de chacune des société en vue de leur
inspection par l’actionnaire unique.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le président soumet à l’assemblée pour revue les comptes de la Société arrêtés en date du 31 décembre 2014.
Le président informe l’assemblée que le projet de fusion est établi sur base de ces comptes.
Après revue, l’assemblée approuve les comptes de la Société arrêtés en date du 31 décembre 2014.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate la décision de l’actionnaire unique de ne pas faire établir de rapport par le conseil d'administration
de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions, conformément au
paragraphe (3) de l’article 265 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée constate la décision de l’actionnaire unique de ne pas faire établir de rapport établi par un réviseur d'en-
treprises indépendant, conformément au paragraphe (5) de l’article 266 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée constate que le dépôt des documents exigé par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales a été
effectué au siège social de la Société un mois au moins avant la tenue de la présente assemblée générale, ainsi qu'il en est
justifié au notaire par un certificat établi par le conseil d'administration de la société, lequel restera annexé aux présentes.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée approuve le projet de fusion entre la Société BY INTERNET S.A., agissant en tant que la société absorbée,
et la Société, agissant en tant que société absorbante, tel que ce projet de fusion a été établi par les conseil d’administration
desdites sociétés et publié au Mémorial C, numéro 978 en date du 13 avril 2015, soit plus d'un mois avant la présente
assemblée.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le porter de
son montant actuel d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) à un montant d'un million trente mille euros (1.030.000,- EUR)
par l’émission de trois cents (300) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, et ce en
échange des cent (100) actions sans valeur nominale et de la transmission de tous les actifs et passifs de la société BY
INTERNET S.A. à la Société, à la date de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés fusion-
nantes statuant sur la fusion.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide qu’en échange de l’apport de tous ses actifs et passifs par la société absorbée, la Société émet trois
cents (300) actions nouvelles à allouer à l’actionnaire actuel de la Société. L'entrée en jouissance de ces actions est à la
date de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés fusionnantes statuant sur la fusion.
88895
L
U X E M B O U R G
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à la modification de l’article 5 alinéa 1 des statuts afin de refléter l’augmentation de
capital précitée.
L'article 5.1 aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million trente mille euros (1.030.000,- EUR) représenté par dix
mille trois cents (10.300) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune."
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant, conformément à l’article 271, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et
atteste par les présentes l’existence du projet de fusion et tous les autres actes et exigences formels imposés à la Société
par la fusion projetée.
<i>Frais, évaluationi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société sont évalués
à trois mille trois cents euros (EUR 3.300,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et
demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: DEMICHELET, BECKER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 mai 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 16051. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 3 juin 2015.
Référence de publication: 2015082295/113.
(150094891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.
Coveris Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 178.003.
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 28 mai 2015, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Laura Spitoni, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- Isabelle Arker, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- Anita Lyse, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Gary Masse, administrateur de catégorie A, avec adresse professionnelle au 8600, West Bryn Mawr Avenue, Suite
800N, 60631 Chicago, Illinois, Etats-Unis
- Michael Alger, administrateur de catégorie A, avec adresse professionnelle au 8600, West Bryn Mawr Avenue, Suite
800N, 60631 Chicago, Illinois, Etats-Unis
pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice
social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;
2. Renouvellement du mandat de réviseur d’entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec adresse professionnelle
au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;
3. Nomination de Stéphane Gatto, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat d'administrateur de catégorie B, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l’assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en
2016;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2015.
Référence de publication: 2015081161/27.
(150093047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
88896
Atento S.A.
Coveris Holdings S.A.
EJL Real Estate G.m.b.H.
Eltis
Erilielux S.à r.l.
Eschtari S.A.
ESO Investco I Sàrl
Eurinvest
Europe One S.A.
Fer.bel S.à.r.l.
Fotex Holding
Frankfurt BICC
Fuddermann S.à r.l.
Geldilux-TS-2015 S.A.
Livin Real Estate
MSplus S.A.
Mytilus SPF
NC² Luxembourg Development S.à r.l.
Neon Investment S.à r.l.
New Energy Above Training
New Rehab Group S.A.
NeXenS S.A.
Nexyard S.à r.l.
Nies Alliance S.à r.l.
Ni Vu Ni Connu Productions S.à r.l.
Noliwang International S.A.
Northern Trust Luxembourg Management Company
Novarte Renovation Sàrl
NTMC
Nuti Luxco S.à r.l.
Oakfield Property
Ocean Luxury Investments
PCO HoldCo S.à r.l.
Pfaudler International S.à r.l.
Quaesta Capital Umbrella SICAV-SIF
SilverStreet Private Equity Strategies M Soparfi
Société européenne d'investissement et promotion S.à r.l.
Spinnaker Bidco S.à r.l.
Spinnaker HoldCo S.à r.l.
Sun European Investment III S.à r.l.
System and Management Investment S.A.
Tikehau Fund
Tivana Midco S.à r.l.
Tuvalu International S.A.
Universal Premium Holding SA
Urban 67 (European RE Club) S.à r.l.