logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1825

22 juillet 2015

SOMMAIRE

Alpenland Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87591

AltaFund Invest IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

87554

Carrée S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87560

CBRE S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87559

CF Stefano S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87592

Colian S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87556

Compagnie Luxembourgeoise de Financement

de Commerces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87558

Consolidated Energy Finance S.A.  . . . . . . . . .

87562

Constellation Software Luxembourg . . . . . . . .

87564

Corporation Distribution S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

87562

Cozen s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87562

DAH Real Estates S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

87559

Danyl S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87557

D Ebco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87558

Decision Advantage Science S.à r.l.  . . . . . . . . .

87555

DesignU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87557

DK Lux TT SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87560

Doman (SPF) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87556

Do Way S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87557

DxO S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87561

Earl Place (Luxembourg) Holding SA . . . . . . .

87561

ECommerce Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

87568

Edmond de Rothschild Assurances et Conseil

(Europe)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87558

Edmond de Rothschild Europportunities II

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87562

Elisana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87555

EMC S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87563

EPF Acquisition Co 30 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

87598

Eurofins Discovery Services LUX Holding  . . .

87557

Eurofins Hygiène Alimentaire France LUX

Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87558

Hipoteca VIII Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

87559

international quiding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

87600

Leverlake S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87555

Longbow Investment N°3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

87555

LuxeHeat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87554

Luxembourg Irtysh Petroleum Sàrl  . . . . . . . .

87554

Luxinva S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87554

Meridian Hotel Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

87561

Nouvelle Financière Bi-Sam S.à r.l.  . . . . . . . . .

87556

Ragof Heusenstamm S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

87560

Sanichaufer S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87561

VPB-Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87567

Windmill Lux Subco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

87598

87553

L

U X E M B O U R G

AltaFund Invest IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 162.491.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 609 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015079014/9.
(150091277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

Luxinva S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 128.373.

Les statuts coordonnés au 19 mai 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 29 mai 2015.

Référence de publication: 2015079615/10.
(150091307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

Luxembourg Irtysh Petroleum Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 146.697.

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 5 mai 2015

Le 5 mai 2015, l’Associé Unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. D'accepter la démission de Mr. Jiqiang Shang en tant que Gérant de la Société avec effet immédiat;
2. De nommer Mr. Kuang Jun, né le 29 juillet 1964 à Xinjiang, Chine, demeurant au 27/F Zhongtian Plaza, 165 Xinhua

North Road, 83000 Urumqi, Chine, en tant que Gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 19 mai 2015.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015079613/16.
(150090661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

LuxeHeat, Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.

R.C.S. Luxembourg B 170.949.

<i>Résolution du Conseil d'Administration

Il résulte d'une résolution du Conseil d'administration que:
Monsieur  Thierry  Leyssens  a  démissionné  en  tant  qu'Administrateur  Délégué  de  la  société  Luxeheat,  domiciliée  3

Grevelsbarrière à L-8055 Bertrange à dater du 30 avril 2014.

Monsieur Paul Henri Vincent, Président de la société Luxeheat SA, assumera les fonctions de l'Administrateur Délégué

jusqu'un nouveau Administrateur Délégué sera nommé.

Cette résolution sera soumise à la ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 25 mars 2015.

<i>Pour la société Luxeheat SA
Paul-Henri VINCENT
<i>Président

Référence de publication: 2015079614/19.
(150091301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

87554

L

U X E M B O U R G

Decision Advantage Science S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 185.775.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1.6.2015.

Référence de publication: 2015080299/10.
(150092155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Elisana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 148.914.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2015.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015080335/13.
(150092047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Leverlake S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 143.844.

EXTRAIT

En date du 5 mai 2015, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Leverlake S.à r.l. a décidé de renouveler le

mandat des gérants de la Société, Lize-Mari Barnes et Réjean Besner pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale
annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2016,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2015.

Leverlake S.à r.l.

Référence de publication: 2015079601/15.
(150091521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

Longbow Investment N°3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 7.011.700,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 172.273.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 mai 2015 que:
- Monsieur Alexis de Montpellier a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société, avec effet au

21 mai 2015.

- Monsieur Eric Lie, né le 19 juin 1981 à Sedan, France et résident professionnellement au 6C rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach, Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie A de la Société avec effet au 21 mai 2015 pour une
durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 26 mai 2015.

Référence de publication: 2015079605/16.
(150091610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

87555

L

U X E M B O U R G

Nouvelle Financière Bi-Sam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.725.442,00.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 182.673.

<i>Extrait des Résolutions des associés du 23 Mai 2015

En date du 23 Mai 2015, les associés ont décidé de renouveler le mandat du gérant Vladimir Mornard, avec adresse

professionnelle au 6 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 Mai 2015.

Salvatore Rosato
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015079737/16.
(150090610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

Colian S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9654 Gruemelscheid, 39, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 186.105.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 17 février 2015.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 17 février 2015 que

<i>Résolution unique

Le conseil d'administration décide de nommer la banque «BANQUE INTERNATIONAL A Luxembourg (BIL)» se

situant à, 69, route d'Esch, L - 2953 Luxembourg comme dépositaire conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à
l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions
au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la
loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, entrée en vigueur le 18 août 2014.

Gruemelscheid, le 17 février 2015.

Pour extrait conforme
Fiduciaire ARBO S.A.

Référence de publication: 2015080282/18.
(150092533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Doman (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 130.604.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 4 mai 2015

Renouvellement du mandat des administrateurs pour 6 ans:
Aniel Gallo
Mireille Masson
Madeleine Alié
Renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué pour 6 ans:
Aniel Gallo
Démission du mandat de commissaire aux comptes:
Fiduciaire et Expertises (Luxembourg) S.A.
Nomination du mandat de commissaire aux comptes pour 6 ans:
FGA (Luxembourg) S.A. - 53 Route d'Arlon - L-8211 Mamer

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015080324/19.
(150092713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

87556

L

U X E M B O U R G

Danyl S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 136.152.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015080308/9.
(150092319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Eurofins Discovery Services LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.250.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 172.972.

Les comptes annuels pour la période du 1 

er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015080341/11.
(150092683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

DesignU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 163.642.

Suite à l'Assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2015, pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence

au Luxembourg, acte enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2015 relation:2LAC/2015/11011

L'associé unique de la société à décidé de rectifier l'adresse professionnelle de Mademoiselle Inga-Christin Schmidt au

5, rue du Saint Esprit, L-1475, Luxembourg

 Luxembourg, le 28 mai 2015.

Référence de publication: 2015080303/12.
(150092329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Do Way S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 2a, rue J.B. Esch.

R.C.S. Luxembourg B 186.425.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2015

L'assemblée générale prend acte de la cession de parts en date du 30 avril 2015, que Monsieur Wei DU, propriétaire de

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la société, cède sept mille cinq cents (7.500) parts sociales à Madame
Diana DU, et deux mille cinq cents (2.500) parts sociales à Monsieur Wenjiang DU, de fait que la nouvelle répartition des
parts sociales s'établit comme suit:

- Madame Diana DU, sept mille cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.500

- Monsieur Wei DU, deux mille cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

- Monsieur Wenjiang DU, deux mille cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

Total: douze mille cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Changement d'adresse d'associé
L'adresse privée de Monsieur Wei DU est à L-2434 Senningerberg, 4, rue des Résidences.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/04/2015.

<i>Pour la société
Do Way S.à r.l.

Référence de publication: 2015080306/22.
(150092420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

87557

L

U X E M B O U R G

Edmond de Rothschild Assurances et Conseil (Europe), Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 18, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 105.897.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015080334/10.
(150091789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Eurofins Hygiène Alimentaire France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 600.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 165.606.

Les comptes annuels pour la période du 1 

er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015080344/11.
(150092686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

D Ebco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 62.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 178.439.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 26 mai 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission d'Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2015.

Référence de publication: 2015080293/15.
(150091667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Compagnie Luxembourgeoise de Financement de Commerces, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 22, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 59.741.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 29 mai 2015, tenue au siège de la société.

Les mandats des Administrateurs, à savoir Messieurs Christophe MOUTON, né le 20/11/1971 à Saint-Mard (Belgique),

résidant professionnellement au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Jean-Luc LINSTER, né le 27/03/1971 à Lu-
xembourg, résidant au 13 rue Glesener, L-1361 Luxembourg et Monsieur Robert GOERES, né le 23/09/1971 à Luxem-
bourg, résidant au 22 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en
2021.

Le mandat du Commissaire aux Comptes, à savoir la société ACCOUNTIS Sàrl (anciennement Fiduciaire Jean-Marc

Faber &amp; Cie Sàrl), ayant son siège au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg sous le
numéro B 60219, est également reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT DE COMMERCES S.A.

Référence de publication: 2015080284/18.
(150092354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

87558

L

U X E M B O U R G

DAH Real Estates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 126.578.

Les statuts coordonnés au 242... août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 29 mai 2015.

Référence de publication: 2015079282/10.
(150091361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

Hipoteca VIII Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 190.386.

EXTRAIT

La Société a pris connaissance que l'adresse de son gérant, Monsieur Maqboolali Mohamed, se trouve désormais au 15

Sackville Street, Londres W1S 3DJ, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015076076/14.
(150086774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

CBRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 77.325.

<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenant lieu d’Assemblée Générale Ordinaire du 12 janvier

<i>2015

Les actionnaires de la société CBRE S.A. réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 12 janvier 2015, ont décidé à

l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L’assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs de
- Monsieur Laurent COOREMAN, Administrateur de classe A, demeurant 157, route de Longwy à L-1941 Luxembourg
- Monsieur Gérald MERVEILLE, Administrateur de classe A, demeurant 9, rue du Hirtzenberg à B-6700 Udange
- Monsieur Gaëtan CLERMONT, Administrateur de classe B, demeurant 22a, avenue des Sorbiers à B-1180 Uccle
- Monsieur Philip EMBUREY, Administrateur de classe B, demeurant à Winterstoke, Logs Hill Close Chislehurst à GB

- BR7 5LP Kent

étant venu à échéance en 2014, décide de renouveler rétroactivement leur mandat pour une nouvelle période de 5 années

soit jusqu'à l’assemblée générale se tenant en 2019.

D’autre part, l’assemblée générale constatant que le mandat du commissaire aux comptes de:
- Madame Myriam AINOUSS, née à Bruxelles le 26 juin 1976, demeurant 146, Milcamps à B-1030 Bruxelles
étant venu à échéance en 2014, décide de renouveler rétroactivement son mandat pour une nouvelle période de 5 années

soit jusqu'à l’assemblée générale se tenant en 2019.

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration lors d'une réunion tenue en date du 13 janvier 2015 que:
- Monsieur Gaëtan CLERMONT a été nommé Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'ad-

ministrateur de la Société qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2019

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015080267/30.
(150092038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

87559

L

U X E M B O U R G

Ragof Heusenstamm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.204.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18. Mai 2015.

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notar

Référence de publication: 2015076096/14.
(150086638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

DK Lux TT SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 16, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 86.720.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 21 mai 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère
Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de:

- La société anonyme DK LUX TT SA (RCS B86.720), avec siège social à L-3898 FOETZ, 16, rue du Commerce, de

fait inconnue à cette adresse,

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Ana ALEXANDRE
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015079300/17.
(150091416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

Carrée S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 87.388.

<i>Extrait du P.V. de l'AGO tenue extraordinairement en date du 11 juillet 2014 appelée à statuer sur les comptes 2013

Les mandats des administrateurs, administrateurs délégués, Président du Conseil d'Administration et commissaire aux

comptes ont été reconduits pour une durée de 6 ans. Ils prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020
appelée à statuer sur les comptes de 2019.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

<i>Administrateurs et Président du Conseil d'Administration:

- PLAZA MANAGEMENT OVERSEAS SA, Pasea Estate, Road Town BVI Tortola
- Jan VAN HOLSBEECK, 156 rue Albert Unden L-2652 Luxembourg
- Johannes, Karel, Josef REIJTENBAGH, 3 rue des Giroflées F-98000 MONTE CARLO-MONACO + Président du

Conseil d'Administration

<i>Administrateurs délégués:

- PLAZA MANAGEMENT OVERSEAS SA, Pasea Estate, Road Town BVI Tortola
- Jan VAN HOLSBEECK, 156 rue Albert Unden L-2652 Luxembourg
- Johannes, Karel, Josef REIJTENBAGH, 3 rue des Giroflées F-98000 MONTE CARLO-MONACO

<i>Commissaire aux comptes:

- READ SARL, 3A, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg
Référence de publication: 2015079239/23.
(150091435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

87560

L

U X E M B O U R G

Meridian Hotel Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.200,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 175.173.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015077105/9.
(150088214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

DxO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 181.548.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2015.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2015079280/11.
(150090958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

Sanichaufer S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.250,00.

Siège social: L-3504 Dudelange, 58, rue Pierre Krier.

R.C.S. Luxembourg B 7.343.

EXTRAIT

Il résulte de décision prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 2015, que la démission par Monsieur

Fernand WINTRINGER de son mandat de gérant Technique du département électricité et frigoriste a été constatée avec
effet à compter du 30 avril 2015.

Par conséquent, Monsieur Nico BIEVER devient gérant unique de la Société.

Luxembourg, le 20 mai 2015.

Référence de publication: 2015077342/14.
(150087651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Earl Place (Luxembourg) Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 151.046.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 11 mai 2015, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Maximilien Dambax, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Stéphane Bourg, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Thomas Schmuckli, avec adresse au 35a, Oberer Chämletenweg, 6333 Hünenberg See, Suisse
- Jürg Roth, avec adresse au 30, Giesshübelstrasse, 8045 Zurich, Suisse
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social

se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

2. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de KPMG Luxembourg, avec siège social au 39, avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2015.

Référence de publication: 2015079312/20.
(150090770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

87561

L

U X E M B O U R G

Cozen s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3862 Schifflange, 56A, Cité Op Soltgen.

R.C.S. Luxembourg B 143.054.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015078357/9.
(150089943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Consolidated Energy Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 188.543.

Les comptes annuels pour la période allant du 3 juillet 2014 au 31 décembre 2014 enregistrés et déposés à Luxembourg

le 15 mai 2015 référencés L150083027 sont rectifiés par les présents comptes annuels.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CONSOLIDATED ENERGY FINANCE S.A.

Référence de publication: 2015078320/11.
(150089691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Edmond de Rothschild Europportunities II S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 154.205.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2015.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2015079327/12.
(150091256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

Corporation Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la foire.

R.C.S. Luxembourg B 142.586.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale de l'associé unique (l' «Assemblée») tenue en date du 21 mai 2015 que:
- La démission de Mr. Tarcisio PICCO, en tant que gérant de la Société a été prise en compte à partir de la date de

l'Assemblée,

- La démission de Mr. Raffaele SAURWEIN, en tant que gérant de la Société a été prise en compte à partir de la date

de l'Assemblée,

- La nomination de Mr. Eddy DOME, né le 16 août 1965 à Waremme (Belgique), avec adresse professionnelle au 11-13

Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en tant que gérant de la Société, a été acceptée à partir de la date de l'Assemblée,
et ce jusqu'à l'assemblée générale de l'associé unique qui se tiendra en 2021,

Ainsi le nouveau conseil de gérance de la Société est constitué désormais de:
- Mr. Eddy DOME, gérant et
- Mr. Marco LAGONA, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2015.

Référence de publication: 2015078323/22.
(150089488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

87562

L

U X E M B O U R G

EMC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9154 Grosbous, 10A, rue d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 158.649.

L'an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EMC S.A., ayant son siège social à L-9154

Grosbous, 10A, rue d’Ettelbruck, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous
le numéro 158.649 (la"Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à
Rambrouch, en date du 24 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 883 du 3 mai
2011. Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés depuis sa constitution.

L'assemblée  est  présidée  par  Serge  PAULY,  salarié,  demeurant  professionnellement  à  L-9154  Grosbous,  10A,  rue

d’Ettelbruck.

Le président désigne comme secrétaire Tessy BODEVING, employée privée, demeurant professionnellement à L-9201

Diekirch, 4, rue Alexis Heck.

L'assemblée nomme comme scrutateur Serge PAULY, salarié, demeurant à demeurant professionnellement à L-9154

Grosbous, 10A, rue d’Ettelbruck.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée

par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Cette liste et les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte afin d'être soumises aux formalités

d’enregistrement avec le présent acte.

II. Tous les actionnaires représentés ont déclaré avoir été préalablement suffisamment informés de l’ordre du jour de

l’assemblée générale et ont renoncé à leurs droits à un avis de convocation y relatif, de sorte que l’assemblée générale peut
se prononcer valablement sur tous les points inscrits à l’ordre du jour.

III. Il ressort de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions de la Société sont représentées à la présente

assemblée de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour
tel qu'il suit:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination de Monsieur Serge PAULY, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité par les actionnaires de la Société:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l’assemblée

générale décide la dissolution anticipée de la Société et décide sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de nommer en qualité de liquidateur:
- Monsieur Serge PAULY, salarié, né le 30 janvier 1968 à Luxembourg, demeurant à L-9154 Grosbous, 10, rue d’Et-

telbruck.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas

où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges,

hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypo-
thécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

87563

L

U X E M B O U R G

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement au montant de mille deux cents euros (EUR
1.200,-).

DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire instrumentant par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. PAULY, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 26 mai 2015. Relation: DAC/2015/8591. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 28 mai 2015.

Référence de publication: 2015079356/67.
(150090619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

Constellation Software Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.757.180,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.680.

In the year two thousand and fifteen on the second day of April.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Constellation Software Inc. Luxembourg Branch, the Luxembourg branch of Constellation Software Inc., a company

incorporated under the laws of Ontario, Canada, such branch registered with the Luxembourg trade and companies register
under the number B 150631,

in its capacity as sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Constellation Software Luxembourg, a Gesellschaft mit

beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée, private limited company), organised under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 412F, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the trade and companies register
of Luxembourg under the number B 151.680 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg, on 22 December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
on 13 April 2010, number 769. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant
to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 1 October 2014, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations under number 3767 on 8 December 2014.

here represented by Stefanie Kreuzer, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the

appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following

resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty-nine thousand five

hundred thirty United States dollars (USD 49,530) so as to raise it from its present amount of three million seven hundred
seven thousand six hundred and fifty United States dollars (USD 3,707,650) consisting of nineteen thousand (19,000)
Ordinary Shares and three million six hundred and eighty-eight thousand six hundred fifty (3,688,650) MRPS up to an
amount of three million seven hundred fifty-seven thousand one hundred eighty United States dollars (USD 3,757,180) by
the issue of forty-nine thousand five hundred thirty (49,530) MRPS with a par value of one US dollar (USD 1.-) each.

<i>Subscription and payment

Thereupon, Constellation Software, Inc., Luxembourg Branch, prenamed, here represented as aforementioned, declares

to subscribe for forty-nine thousand five hundred thirty (49,530) MRPS with a par value of one US dollar (USD 1.-) each,
and to fully pay them up by way of a contribution in kind of a claim held by Constellation Software, Inc., Luxembourg
Branch, in an amount of four million nine hundred fifty-three thousand United States dollars (USD 4,953,000) (the "Con-
tribution").

The total amount of the Contribution of four million nine hundred fifty-three thousand United States dollars (USD

4,953,000) will be allocated as follows:

87564

L

U X E M B O U R G

- forty-nine thousand five hundred thirty United States dollars (USD 49,530) to the share capital account of the Company;
- four million eight hundred ninety-eight thousand five hundred seventy-one United States dollars (USD 4,898,517) to

the MRPS premium account of the Company; and

- four thousand nine hundred fifty-three United States dollars (USD 4,953) to the legal reserve account of the Company.
The proof of the existence and of the value of the Contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the first Resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the

articles of association so that it reads henceforth as follows:

“ Art. 6. The share capital is set at three million seven hundred fifty-seven thousand one hundred eighty United States

dollars (USD 3,757,180), consisting of nineteen thousand (19,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”), having a par
value of one US dollar (USD 1.-) each and three million seven hundred thirty-eight thousand one hundred eighty (3,738,180)
mandatorily redeemable preferred shares (the “MRPS”), having a par value of one US dollar (USD 1.-) each, all in registered
form, all subscribed and fully paid-up. All MRPS issued by the Company are redeemable shares. MRPS have the same
voting rights as the Ordinary Shares.”

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to authorise any manager of the Company and/or any employee of SGG Luxembourg

S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of
the Company.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation

to this deed are estimated at approximately EUR 4,000.-.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREUPON the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with the

notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, den zweiten April.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Constellation Software Inc. Luxemburg Branch, die luxemburgische Niederlassung von Constellation Software Inc.,

einer Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Ontario, Kanada, als Niederlassung eingetragen in das luxemburgische
Handelsregister unter der Nummer B 150631,

in ihrer Eigenschaft als Einzelgesellschafterin (nachfolgend “die Einzelgesellschafterin”) der Constellation Software

(Luxembourg), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Luxemburger Recht mit
Gesellschaftssitz in 412 F, route d’ Esch, L-1471 Luxemburg, eingetragen in das Luxemburger Handelsregister unter der
Nummer B 151.680 (nachfolgend die “Gesellschaft”), wirksam gegründet gemäß notarieller Urkunde des unterzeichnenden
Notars mit Amtssitz in Luxemburg, am 22. Dezember 2009 und veröffentlicht im Mémorial C, Receuil des Sociétés et
Associations, am 13. April 2010 unter der Nummer 769. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt geändert aufgrund
einer Urkunde von Maître Henri Hellinckx am 1. Oktober 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, am 8 Dezember 2014 unter der Nummer 3767.

hier rechtmäßig vertreten durch Stefanie Kreuzer, Rechtsanwältin, beruflich ansässig in Luxemburg, gemäß privat-

schriftlicher Vollmacht.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung “ne varietur” durch den unterzeichnenden Notar und durch die/ den für die Er-

schienene Bevollmächtigte(n) der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene, welche wie zuvor beschrieben, wirksam vertreten wird, ersucht den unterzeichnenden Notar folgendes

zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von neun-

undvierzigtausendfünfhundertunddreissig US Dollar (USD 49.530) zu erhöhen, sodass das gegenwärtige Gesellschafts-
kapital in Höhe von derzeit drei Millionen siebenhundertsiebentausend sechshundertfünfzig US Dollar (USD 3.707.650),

87565

L

U X E M B O U R G

bestehend aus neunzehntausend (19.000) Ordinary Shares und drei Millionen sechshundertachtundachtzigtausend sechs-
hundertfünfzig (3.688.650) MRPS auf dreimillionensiebenhundertsiebenundfünfzigtausendeinhundertachtzig US Dollar
(USD 3.757.180) durch die Ausgabe von neunundvierzigtausendfünfhundertunddreissig (49.530) MRPS mit jeweils einem
Nominalwert von einem US Dollar (USD 1,-) erhöht wird.

<i>Zeichnung und Zahlung

Darauf erklärt die vorgenannte Constellation Software Inc., Niederlassung Luxemburg, neunundvierzigtausendfünf-

hundertunddreissig (49.530) MRPS zu zeichnen, mit jeweils einem Nominalwert von einem US Dollar (USD 1,-), deren
Gegenwert vollständig zu bezahlen im Wege einer Sacheinlage bestehend aus einer Forderung der Constellation Software,
Inc., Luxembourg Branch in einem Gesamtwert in Höhe von viermillionenneunhundertdreiundfünfzigtausend US Dollar
(USD 4.953.000) (die "Einlage").

Der Gesamtwert der Einlage in Höhe von viermillionenneunhundertdreiundfünfzigtausend US Dollar (USD 4.953.000)

wird wie folgt zugeteilt:

(i) neunundvierzigtausendfünfhundertunddreissig US Dollar (USD 49.530) dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft;
(ii) viermillionenachthundert achtundneunzigtausendfünfhundertsiebzehn US Dollar (USD 4.898.517) als Ausgabeagio

den Kapitalrücklagen der Gesellschaft, welche an die MRPS gebunden sind; und

(iii) viertausendneunhundertdreiundfünfzig US Dollar (USD 4.953) den gesetzlichen Rücklagen der Gesellschaft.
Das Bestehen und der Wert der Einlage wurden dem unterzeichnenden Notar jeweils dargelegt.

<i>Zweiter Beschluss

Als Konsequenz des ersten Beschlusses, beschliesst die Einzelgesellschafterin, den ersten Absatz des Artikels 6 der

Gesellschaftssatzung in der Weise zu ändern und dergestalt neu zu formulieren, dass er nun wie folgt lautet:

“  Art. 6.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  dreimillionensiebenhundertsiebenundfünfzigtausendeinhundertachtzig  US

Dollar (USD 3.757.180) bestehend aus neunzehntausend (19.000) Ordinary Shares mit einem Nominalwert von einem US
Dollar (USD 1,-) und dreimillionensiebenhundertachtunddreissigtausendeinhundertachtzig (3.738.180) MRPS mit einem
Nominalwert von einem US Dollar (USD 1,-), jeweils Namensanteile, die vollständig gezeichnet und einbezahlt sind. Alle
MRPS,  die  von  der  Gesellschaft  emittiert  worden  sind,  sind  rückkaufbare  Anteile.  Die  MRPS  sind  mit  den  gleichen
Stimmrechten wie die Ordinary Shares versehen.“

<i>Dritter Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, jedem Geschäftsführer der Gesellschaft und/ oder jedem Angestellten von SGG

Luxemburg S.A. die Befugnis einzuräumen, für die Gesellschaft die Eintragung der hiermit ausgegebenen Anteile in das
Gesellschaftsregister der Gesellschaft zu veranlassen.

<i>Kostenschätzung

Die im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde entstehenden Auslagen, Kosten Gebühren und Belastungen,

gleich welcher Art, werden von der Gesellschaft getragen und betragen schätzungsweise EUR 4.000,-.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der er-

schienen Partei, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung; im Falle von
Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, soll die englische Fassung maßgeblich sein.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde

erwähnt wird.

Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienen Partei vorgelesen, ferner haben der Bevollmächtigte und der

Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. KREUZER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 9 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/11093. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 22. Mai 2015.

Référence de publication: 2015078321/143.
(150089559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

87566

L

U X E M B O U R G

VPB-Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 42.828.

L'an deux mille quinze, le vingt mai.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société VPB Finance S.A., une société anonyme de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 janvier 1993, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 194 du 30 avril 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1 

er

 août 2014, publié au Mémorial

Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2827 du 9 octobre 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Romain Moebus, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Julia Holm-Hadulla demeurant professionnellement à Luxembourg
et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Julia Weihsweiler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que toutes les actions sont nominatives.
II.- Que le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le bureau de l'assemblée, le mandataire de l'actionnaire représenté et le notaire soussigné. Ladite liste
de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. La procuration
de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants, restera également annexée au présent
acte.

III.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social,

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du Jour

1. Désignation de Monsieur Romain Moebus comme président de l'assemblée;
2. Modification de l'objet social de la société et par conséquent de l'article 3 des statuts de sorte que la société ne preste

plus de services prévus à l'article 101 (3) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En l'absence du président du conseil d'administration, l'assemblée décide de nommer Monsieur Romain Moebus, comme

président de l'assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société de sorte que la société ne preste plus de services prévus à

l'article 101 (3) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement en supprimant les phrases suivantes
de l'article 3 de ses statuts:

«La Société peut en outre fournir les services de (a) gestion de portefeuilles d'investissements sur une base discrétionnaire

et individualisée et (b) conseils en investissement tel que prévu à l'article 101(3) de la Loi de 2010 et /ou l'article 5(4) de
la Loi de 2013.

La Société peut fournir les services auxiliaires suivants: conseils en investissement portant sur des instruments tels que

des valeurs mobilières, des parts d'un OPC, des instruments du marché monétaire, des contrats financiers à terme, des
contrats à terme sur taux d'intérêt, des contrats d'échange, des options.»

Par conséquent, l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

« Art. 3. Objet. L'objet de la Société est:
1. la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) luxembourgeois et étrangers autorisés

conformément à la directive européenne 2009/65/CE ainsi que la gestion d'autres organismes de placement collectif (OPC)
luxembourgeois et étrangers, conformément à l'article 101 (2) et à l'annexe II de la loi luxembourgeoise du 17 décembre
2010 concernant les organismes de placement collectif (telle qu'amendée) (la «Loi de 2010»); et

87567

L

U X E M B O U R G

2.  l'exercice,  pour  des  fonds  d'investissement  alternatifs  (FIA)  luxembourgeois  et  étrangers  au  sens  de  la  directive

européenne 2011/61/UE, de fonctions de gestion, d'administration et de commercialisation et d'autres activités liées aux
actifs de FIA, conformément à l'article 5(2) et à l'annexe I de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 concernant les
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la «Loi de 2013»); et

3. l'exercice de la fonction de société de gestion au sens de l'article 89, paragraphe (2) de la Loi de 2010 pour des fonds

communs de placement, des sociétés d'investissement à capital variable et des sociétés d'investissement à capital fixe établis
au Luxembourg et qui répondent aux critères des FIA au sens de la directive européenne 2011/61/UE, conformément aux
articles 125-1 et 125-2 de la Loi de 2010.

La Société peut également fournir les services susmentionnés de gestion, d'administration et de commercialisation aux

filiales d'OPCVM, d'OPC et de FIA auxquels elle fournit des services, y compris des services de domiciliation et de support
administratif.

La Société peut exercer des activités autorisées en dehors du Luxembourg au titre de la libre prestation de services et/

ou par l'établissement de succursales.

De manière plus générale, la Société peut exercer toute activité liée aux services qu'elle fournit aux OPCVM, OPC et

FIA dans la mesure la plus large permise par la Loi de 2010, la Loi de 2013 et toute autre loi ou tout autre règlement
applicable.

La Société peut exercer toute autre activité jugée utile ou nécessaire à l'accomplissement et au développement de son

objet, tout en restant, cependant, dans les limites, mais dans la mesure la plus large permise par le chapitre 15 de la Loi de
2010, la Loi de 2013 et de toute autre loi en vertu desquelles elle a été autorisée par l'autorité de surveillance luxembour-
geoise à exercer ses activités.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. MOEBUS, J. HOLM-HADULLA, J. WEIHSWEILER, T. STEIGER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 22 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/16018. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2015.

Référence de publication: 2015080888/84.
(150092650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

ECommerce Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 177.435.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of April,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing

under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 184.665, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “Global Fin Tech Holding”),

being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares and five thousand two hundred

fifty (5,250) series A shares,

here represented by Mr. Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy, given under private seal;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-

chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter
“Bambino 53. V V”),

being the holder of one (1) common share,
here represented by Mr. Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given under private seal;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws

of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRA 98863, having its business address at Kaiserstraße

87568

L

U X E M B O U R G

14b, 80801 Munich, Germany, represented by its general partner, HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, a limited
liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany, registered with the com-
mercial  register  at  the  local  court  of  Munich,  Germany,  under  no.  HRB  185098  B,  having  its  registered  address  at
Kaiserstraße 14 b, 80801 Munich, Germany, (hereinafter “Holtzbrinck”),

being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, eight hundred forty-four (844) series

B shares and eight hundred fifty-four (854) series C shares,

here represented by Mr. Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given under private seal;

4. AI Zencap Holdings LLC, a limited liability company under the laws of Delaware, United States of America, registered

with the Secretary of State of the state of Delaware under registration number 5227608, with its statutory seat in 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America (hereinafter “Access”),

being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, eight hundred forty-four (844) series

B shares, and eight hundred fifty-four (854) series C shares,

here represented by Mr. Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given under private seal;

5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda with its statutory

seat in Hamilton, Bermuda, having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11
(hereinafter, “TJT”),

being the holder of four hundred (400) series C shares,
here represented by Mr. Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given under private seal;

6. Mr. David W. Zalaznick, born in New York, United States of America, on 16 April 1954, professionally residing in

9 West 57 

th

 Street - 33 

rd

 Floor, New York, NY 10019, USA (hereinafter “DZ”),

being the holder of four hundred (400) series C shares,
here represented by Mr. Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given under private seal;

7. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 176.544, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “Aismare”),

being the holder of eight hundred (800) series C shares,
here represented by Mr. Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given under private seal;

8. FEC Lux S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de
Commerce et des Sociétés) under number B 173.487, having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “FEC”),

being the holder of one thousand nine hundred seventy-five (1,975) series C shares,
here represented by Mr. Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given under private seal;

9. Bambino 110. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-

chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under no. HRB 140400 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter
“Bambino 110. V V”),

being the holder of nine hundred forty (940) series D shares and four thousand seven hundred two (4,702) series E

shares,

here represented by Mr. Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given under private seal; and

10. Arrowgrass Master Fund Ltd., a private limited liability company incorporated under the laws of the Cayman Islands

with registered number MC193941 and having its registered address at PO Box 242, 45 Market Street, Gardenia Court,
Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (hereinafter “Arrowgrass”),

becoming the holder of two thousand six hundred sixty-eight (2,668) series E shares,
here represented by Mr. Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given under private seal;

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

87569

L

U X E M B O U R G

The parties listed 1. to 9. (the “Existing Shareholders”) represent the entire share capital of ECommerce Holding II S.à

r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 177.435 and incorporated pursuant to a deed of
Maître Wersandt notary residing in Luxembourg, on 7 May 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 1651 dated 10 July 2013. The articles have been amended for the last time by deed of Maître Wersandt
on November 21, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 22 December 2014, N° 3961.
The articles of association have not been amended since.

The Existing Shareholders representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda whereby
Arrowgrass participates and votes for the purpose of item 3 of the following Agenda only:

<i>Agenda

1. Acceptance of Arrowgrass Master Fund Ltd., a private limited liability company incorporated under the laws of the

Cayman Islands with registered number MC193941 and having its registered address at PO Box 242, 45 Market Street,
Gardenia Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, as new shareholder of the Company.

2. Increase of the Company's share capital by an amount of six thousand two hundred eighty-one euro (EUR 6,281) so

as to raise it from its current amount of thirty-seven thousand six hundred thirteen euro (EUR 37,613) up to forty-three
thousand eight hundred ninety-four euro (EUR 43,894) by issuing (i) two thousand six hundred seventy (2,670) series C
shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each; (ii) one hundred fifty-eight (158) series D shares with a nominal
value of one euro (EUR 1) each; and (iii) three thousand four hundred fifty-three (3,453) series E shares with a nominal
value of one euro (EUR 1) each.

3. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders accepts Arrowgrass Master Fund Ltd. a private limited liability company incor-

porated under the laws of the Cayman Islands with registered number MC193941 and having its registered address at PO
Box 242, 45 Market Street, Gardenia Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, as new shareholder
of the Company.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of six thousand

two hundred eighty-one euro (EUR 6,281) so as to raise it from its current amount of thirty-seven thousand six hundred
thirteen euro (EUR 37,613) up to forty-three thousand eight hundred ninety-four euro (EUR 43,894) by issuing (i) two
thousand six hundred seventy (2,670) series C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each; (ii) one hundred
fifty-eight (158) series D shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each; and (iii) three thousand four hundred fifty-
three (3,453) series E shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

The new shares have been duly subscribed as follows:
- one thousand one hundred thirteen (1,113) series C shares have been subscribed by Global Fin Tech Holding, afore-

mentioned, for the price of one thousand one hundred thirteen euro (EUR 1,113);

- one thousand one hundred thirteen (1,113) series C shares have been subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, for

the price of one thousand one hundred thirteen euro (EUR 1,113);

- four hundred forty-four (444) series C shares have been subscribed by Access, aforementioned, for the price of four

hundred forty-four euro (EUR 444);

- one hundred fifty-eight (158) series D shares and seven hundred eighty-five (785) series E shares have been subscribed

by Bambino 110. V V, aforementioned, for the price of nine hundred forty-three euro (EUR 943); and

- two thousand six hundred sixty-eight (2,668) series E shares have been subscribed by Arrowgrass, aforementioned,

for the price of two thousand six hundred sixty-eight euro (EUR 2,668).

<i>Payment

The one thousand one hundred thirteen (1,113) series C shares subscribed by Global Fin Tech Holding, aforementioned,

have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand one hundred thirteen euro (EUR
1,113).

The one thousand one hundred thirteen (1,113) series C shares subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, have been

entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand one hundred thirteen euro (EUR 1,113).

87570

L

U X E M B O U R G

The four hundred forty-four (444) series C shares subscribed by Access, aforementioned, have been entirely paid up

through a contribution in cash in an amount of four hundred forty-four euro (EUR 444).

The one hundred fifty-eight (158) series D shares and the seven hundred eighty-five (785) series E shares subscribed

by Bambino 110. VV, aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of nine
hundred forty-three euro (EUR 943).

The thousand six hundred sixty-eight (2,668) series E shares subscribed by Arrowgrass, aforementioned, have been

entirely paid up through a contribution in cash in an amount of two thousand six hundred sixty-eight euro (EUR 2,668).

The proof of the existence and of the value of the above contributions has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of six thousand two hundred eighty-one euro (EUR 6,281) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend and fully restate the Company's articles of association and

acknowledges that the Company's shareholders have unanimously waived the prior consent requirement for the amendment
of the Company's articles of association set forth by article 22.8 of the articles of association of the Company. The articles
of association shall henceforth read as follows:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name ECommerce

Holding II S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 The Company may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may

be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at forty-three thousand eight hundred ninety-four Euro (EUR 43,894.00), repre-

sented by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter "Common Shares"),

5.1.2 twelve thousand five hundred (12,500) series A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Series A Shares”),

87571

L

U X E M B O U R G

5.1.3 one thousand six hundred eighty-eight (1,688) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series B Shares”),

5.1.4 seven thousand nine hundred fifty-three (7,953) series C shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series C Shares”),

5.1.5 one thousand ninety-eight (1,098) series D shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series D Shares”)

5.1.6 eight thousand one hundred fifty-five (8,155) series E shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series E Shares”), the Series A Shares, the Series B Shares, the Series C Shares, the Series D Shares and the
Series E Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Global Fin Tech Holding S.à. r.l. (“Rocket”), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG

(“Holtzbrinck”), (iii) AI Zencap Holdings LLC ("Access"), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”),
(v) David W. Zalaznick (“DZ”), (vi) Aismare Lux Holdings S.à r.l. (“Aismare”), (vii) FEC Lux S.à r.l. (“FEC”), (viii)
Arrowgrass Master Fund Ltd (“Arrowgrass”) and (ix) Joh. Berenberg, Gossler &amp; Co. KG (“Berenberg”) if and when it
becomes a shareholder of the Company(Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT, DZ, Aismare, FEC, Arrowgrass and Berenberg
jointly the “Investors” and each an “Investor”), shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued
in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a
company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a
“Third Party Investor”) and which has been approved with a majority vote of at least seventy-five percent (75 %) of the
votes of all shareholders of the Company (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party
Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior
to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each
respective Investor shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks if it intends to exercise its right
pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3, following which the Third Party Investment (to the extent not taken
up by the Investors under this Article 5.3) may proceed.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

the  shareholders  at  a  majority  of  three  quarters  of  the  share  capital  and  subject  to  the  provisions  of  any  shareholders
agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along
rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent that such
approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company affiliated to

such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct
or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Controlled” or
“Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing
shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a contractual voting
pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies of a person,
whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one or more
shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

87572

L

U X E M B O U R G

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under the simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation proce-

dures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company,
if the shareholders of the Company hold more than fifty per cent (50 %) in any surviving legal entity after such transfor-
mation procedure.

7.5 In the cases provided for in art. 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of first

refusal, rights of pre-emption or tagalong rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”)
(which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased shareholder). Such approval is, however, not required
in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased
shareholder.

Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, only if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is

rejected for lack of assets;

8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such

enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration of
redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its share
register and to proceed with the relevant filings required by law.

8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one person;

independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way through
one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.

8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).

Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date

is the date before the redemption resolution.

9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding amounts

including interest.

9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable compensation for redemption, such compensation is to

be determined by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is
reached the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a share-
holder or of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be
borne by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off
with the compensation for redemption and the compensation for redemption shall be reduced accordingly. The shareholder
shall bear the remaining costs in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the
expert opinion.

Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a person

named  by  the  Company  (including  another  shareholder  of  the  Company),  including  also  partial  redemption  or  partial
assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company, subject to articles 189 and 190 of the Law.

87573

L

U X E M B O U R G

10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
as a guarantor for such sum.

C. Decisions of the shareholders

Art. 11. Collective Decisions of the Shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.

11.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also

be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a
shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of
managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be cast in abstention
from voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

11.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must
state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must
be sent to each shareholder in writing without undue delay.

11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.

Art. 12. General Meetings of Shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be

specified in the respective convening notices of meeting.

12.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or registered

letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of notice of
at  least  four  (4)  weeks  for  ordinary  shareholders'  meetings  and  at  least  two  (2)  weeks  for  extraordinary  shareholders'
meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders' meeting is not
counted in the calculation of the period of notice.

12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another shareholder

authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.

12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders'
resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders' meeting (for
purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.

Art. 13. Quorum and Vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.

Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If there is no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance
with Article 12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if
this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 14. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 15. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.

87574

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Shareholders' Resolutions Requiring Specific Majority.
16.1 Shareholders' Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company;
16.1.3 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq. German

Stock Corporation Act (AktG));

16.1.4 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation in
the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners.

16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the prior consent

of the Investors.

16.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
16.2.2 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and

transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.

16.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold all
the issued shares of that class (and, for the avoidance of doubt, in the case of the Series E Shares, Arrowgrass).

D. Board of managers - Advisory board

Art. 17. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the "sole manager".

17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 18. Election, Removal and Term of Office of Managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 19. Vacancy in the Office of a Manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 20. Convening Meetings of the Board of Managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-
ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

87575

L

U X E M B O U R G

Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.

21.8 The managers shall require the consent of at least two (2) of the shareholders Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT,

DZ, Aismare, FEC, Arrowgrass and Berenberg (if Berenberg is at the relevant time a holder of shares), which at the relevant
time hold jointly more than fifty per cent (50%) of the Company's registered share capital (the “Investor Majority”) for the
legal transactions and measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been
precisely defined and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Investor Majority:

21.8.1 formation, acquisition, closure or disposal of enterprises or partial-businesses;
21.8.2 amendment of statutes, these articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as

exercise (or waiver) of shareholders' rights in companies in which an interest is held;

21.8.3 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
21.8.4 establishment, relocation and closure of branch establishments and places of business;
21.8.5 modification of the fields of business of the Company and the termination of existing and commencement of new

fields of business (Geschäftsfelder);

21.8.6 approval of the annual plan, in particular the budget plan for each following year;
21.8.7 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

21.8.8 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,

however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

21.8.9 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two hundred

thousand  Euros  (EUR  200,000.00)  in  the  individual  case  and  amendments  to  the  credit  framework  and  extraordinary
repayments, excluding, however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Com-
pany;

21.8.10 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

21.8.11 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.12 conclusion, amendment and dissolution of employment contracts providing for a remuneration in excess of one

hundred fifty thousand Euros (EUR 150,000) per year;

21.8.13 promise or granting of bonuses and gratuities of any kind outside of existing employment contracts as well as

payment of advances or grant of loans to managers and employees in excess of fifty thousand Euros (EUR 50,000) in the
individual case;

21.8.14 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

21.8.15 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount

in controversy of more than ten thousand Euros (EUR 10,000.00) in the individual case;

87576

L

U X E M B O U R G

21.8.16 acquisition, disposition and/or licensing of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights

including copyrights or any other property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation
by the enterprise and/or a third party, as well as the grant or acquisition of licences, as well as the amendment of agreements
with respect thereto, excluding, however, such dispositions between the Company and direct and indirect subsidiaries of
the Company;

21.8.17 granting of a power of attorney, by which a proxy grants power of attorney to another proxy, in order to conclude

an agreement with him at the expense of the Company;

21.8.18 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company (including, for the avoidance of doubt, Global Founders
GmbH (formerly: European Founders Fund, “GF”) and GF's direct and indirect shareholders (i.e. the Samwer brothers),
but excluding any direct or indirect shareholders of Holtzbrinck and/or Access and/or TJT and/ or DZ and/or Aismare and/
or FEC and/or Arrowgrass and/or Berenberg (if Berenberg is at the relevant time a holder of Shares), affiliated companies
pursuant to §§ 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to § 15 German Tax Code
(AO) of direct or indirect shareholders, as far as the latter (except GF and GF's direct and indirect shareholders) - individually
or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent requirement pursuant to this Article 21.8.18 does
not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business of the Company and is at arm's length;

21.8.19 changing of the Company's auditors;
21.8.20 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in a shareholders' agreement;

21.8.21 exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent that

this exercise would require the consent of the Investor Majority under these articles of association if the Company was
concerned, i.e. according to this Article 21.8 or Article 16.

21.8.22  Notwithstanding  the  above  and  in  addition  to  the  Investor  Majority  requirement,  the  managers  shall,  after

Arrowgrass has acquired Series E Shares, require the consent of the holders of Series E Shares other than Bambino 110.
V V UG (haftungsbeschränkt) (hereinafter the "Trustee") (the consent of the majority of Series E Shares - other than those
being held by the Trustee - being sufficient in this respect) as from the date Series E Shares were for the first time sold or
transferred, for the legal transactions and measures specified in Articles 21.8.5 and 21.8.18.

21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also required

for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further transactions
and measures requiring the consent of the Investor Majority. The Investor Majority may give its consent also in advance
for certain groups and kinds of transactions and measures.

21.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in the
future.

Art. 22. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 23. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and
class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 24. Advisory Board.
24.1 The Company shall have an advisory board. The shareholders' meeting may by way of a unanimous shareholders'

resolution increase or decrease the number of voting members of the advisory board, provided that the appointment rights
set out at Article 24.3 are respected and provided further that Rocket shall not be entitled to nominate more than four (4)
voting members unless Rocket increases its percentage holding in the Company.

87577

L

U X E M B O U R G

24.2 The shareholders' meeting shall only set and/or amend rules of procedure for the advisory board by way of a

unanimous shareholders' resolution.

24.3 The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's respective

appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

24.3.1 Four (4) voting members of the advisory board shall be nominated by the shareholder Rocket in its sole discretion;
24.3.2 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Holtzbrinck in its sole

discretion;

24.3.3 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Access in its sole discretion;
24.3.4 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Aismare in its sole discretion;
24.3.5 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder FEC in its sole discretion;

and

24.3.6 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Arrowgrass in its sole

discretion.

24.4 The advisory board has voting and non-voting members as observers.
24.5 The advisory board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall be

the chairman of the advisory board. The rules of procedure of the advisory board may provide for further provisions in
particular on the self organization of the advisory board. The advisory board shall adopt resolutions with the simple majority
of votes cast. The advisory board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.

24.6 The advisory board shall be competent for advising the Company's managers on the strategy and operational matters

and shall discuss with the managers the budget of the Company.

24.7 The advisory board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 26. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 27. Annual Accounts and Allocation of Profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

27.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

27.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold

in the Company.

Art. 28. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and Article 27.6 and may not exceed realized
profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased

87578

L

U X E M B O U R G

by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow
to be distributed.

28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation.
29.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

29.2 Any resolution to dissolve and liquidate the Company requires, in addition to any majority provided for by Law

and any Investor Majority requirement under these articles of association, the approval of the holders of a majority of Series
E Shares other than those held by the Trustee.

H. Final clause - Governing Law

Art. 30. Governing Law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with the
provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted
by Luxembourg law.

30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs and expenses

The  expenses,  costs,  remunerations  or  charges  in  any  form  whatsoever  which  shall  be  borne  by  the  Company  are

estimated at approximately one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholders signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreißigsten April,
vor uns, der unterzeichnenden Notarin, Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Sind Erschienen:

1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) ge-

gründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.665, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg („Global Fin Tech Holding“),

Inhaberin von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen und fünftausendzweihundertfünfzig

(5.250) Anteilen der Serie A,

hier vertreten durch Herrn Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer

privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter

deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB
126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),

Inhaberin eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Herrn Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer

privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit sat-

zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland, vertreten durch ihren

87579

L

U X E M B O U R G

unbeschränkt haftenden Gesellschafter (general partner), HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, einer Gesellschaft mit
beschränkter  Haftung  bestehend  unter  deutschem  Recht,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts  München,
Deutschland, unter der Nummer HRB 185098 B, mit Sitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland („Holtz-
brinck“),

Inhaberin von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A, achthundertvierundvierzig (844)

Anteilen der Serie B und achthundertvierundfünfzig (854) Anteilen der Serie C,

hier vertreten durch Herrn Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer

privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

4. Al Zencap Holdings LLC, eine Gesellschaft (limited liability company) nach dem Recht des Bundesstaates Delaware,

Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen beim Secretary of State des Bundesstaates Delaware unter der Eintragungs-
nummer  5227608,  mit  satzungsmäßigem  Sitz  in  2711  Centerville  Road,  Suite  400,  Wilmington,  Delaware  19808,
Vereinigte Staaten von Amerika („Access“),

Inhaberin von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A, achthundertvierundvierzig (844)

Anteilen der Serie B und achthundertvierundfünfzig (854) Anteilen der Serie C,

hier vertreten durch Herrn Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer

privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft (limited liability company) nach dem Recht der

Bermuda-Inseln, mit satzungsmäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street,
Hamilton, Bermuda HM11 („TJT“),

Inhaberin von vierhundert (400) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer

privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

6. Herr David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954 in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, geschäftsansässig

in 9 West 57 

th

 Street - 33 

rd

 Floor, New York, NY 10019, USA („DZ“),

Inhaber von vierhundert (400) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer

privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

7. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg („Aismare“),

Inhaberin von achthundert (800) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer

privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

8. FEC Lux S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und beste-

hend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
(Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 173.487, mit Sitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg („FEC“),

Inhaberin von eintausendneunhundertfünfundsiebzig (1.975) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer

privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

9. Bambino 110. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter

deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB
140400 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 110. V V“),

Inhaberin von neunhundertvierzig (940) Anteilen der Serie D und viertausendsiebenhundertzwei (4.702) Anteilen der

Serie E,

hier vertreten durch Herrn Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer

privatschriftlich ausgestellten Vollmacht; und

10. Arrowgrass Master Fund Ltd., eine Gesellschaft (private limited liability company) gegründet nach dem Recht der

Kaimaninseln (Cayman Islands), eingetragen unter der Nummer MC193941, mit Sitz in PO Box 242, 45 Market Street,
Gardenia Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands („Arrowgrass“),

zukünftige Inhaberin von zweitausendsechshundertachtundsechzig (2.668) Anteilen der Serie E,
hier vertreten durch Herrn Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer

privatschriftlich ausgestellten Vollmacht.

Besagte Vollmachten, welche von den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

87580

L

U X E M B O U R G

Die unter den Punkten 1. bis 9. aufgelisteten Parteien (die „Bestehenden Gesellschafter“) vertreten das gesamte Ge-

sellschaftskapital der ECommerce Holding II S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in
5,  Heienhaff,  L-1736  Senningerberg,  Großherzogtum  Luxemburg,  eingetragen  im  Luxemburger  Handels-  und  Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 177.435, gegründet am 7. Mai 2013 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars
Maître Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 10. Juli 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 1651 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 21. November 2014 gemäß einer
Urkunde des Notars Maître Wersandt geändert, welche am 22. Dezember 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nr. 3961 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.

Da die bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und erklären, auf jegliche Ladungsfor-

malitäten verzichtet zu haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam
über alle Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei Arrowgrass ausschließlich für Punkt 3 der folgenden
Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Aufnahme von Arrowgrass Master Fund Ltd., einer Gesellschaft (private limited liability company) gegründet nach

dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands) mit der Eintragungsnummer MC193941 und mit Sitz in PO Box 242, 45
Market Street, Gardenia Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, als neue Gesellschafterin der
Gesellschaft.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von siebenunddreißigtausend-

sechshundertdreizehn Euro (EUR 37.613) um einen Betrag von sechstausendzweihunderteinundachtzig Euro (EUR 6.281)
auf einen Betrag von dreiundvierzigtausendachthundertvierundneunzig Euro (EUR 43.894) durch die Ausgabe von (i)
zweitausendsechshundertsiebzig (2.670) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1); (ii)
einhundertachtundfünzig (158) Anteilen der Serie D mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1); und (iii) drei-
tausendvierhundertdreiundfünfzig (3.453) Anteilen der Serie E mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

3. Änderung und vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung nimmt Arrowgrass Master Fund Ltd., eine Gesellschaft (private limited liability com-

pany) gegründet nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands) mit der Eintragungsnummer MC193941 und mit
Sitz in PO Box 242, 45 Market Street, Gardenia Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands („Ar-
rowgrass“), als neue Gesellschafterin der Gesellschaft an.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag

von siebenunddreißigtausendsechshundertdreizehn Euro (EUR 37.613) um einen Betrag von sechstausendzweihundertei-
nundachtzig Euro (EUR 6.281) auf einen Betrag von dreiundvierzigtausendachthundertvierundneunzig Euro (EUR 43.894)
durch die Ausgabe von (i) zweitausendsechshundertsiebzig (2.670) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je
einem Euro (EUR 1); (ii) einhundertachtundfünfzig (158) Anteilen der Serie D mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1); und (iii) dreitausendvierhundertdreiundfünfzig (3.453) Anteilen der Serie E mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die neuen Anteile wurden wie folgt ordnungsgemäß gezeichnet:
- eintausendeinhundertdreizehn (1.113) Anteile der Serie C wurden von Global Fin Tech Holding, vorbenannt, zu einem

Preis von eintausendeinhundertdreizehn Euro (EUR 1.113) gezeichnet;

- eintausendeinhundertdreizehn (1.113) Anteile der Serie C wurden von Holtzbrinck, vorbenannt, zu einem Preis von

eintausendeinhundertdreizehn Euro (EUR 1.113) gezeichnet;

vierhundertvierundvierzig (444) Anteile der Serie C wurden von Access, vorbenannt, zu einem Preis von vierhundert-

vierundvierzig Euro (EUR 444) gezeichnet;

- einhundertachtundfünfzig (158) Anteile der Serie D und siebenhundertfünfundachtzig (785) Anteile der Serie E wurden

von Bambino 110. V V, vorbenannt, zu einem Preis von neunhundertdreiundvierzig Euro (EUR 943) gezeichnet; und

- zweitausendsechshundertachtundsechzig (2.668) Anteile der Serie E wurden von Arrowgrass, vorbenannt, zu einem

Preis von zweitausendsechshundertachtundsechzig Euro (EUR 2.668) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Global Fin Tech Holding, vorbenannt, gezeichneten eintausendeinhundertdreizehn (1.113) Anteile der Serie C

wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendeinhundertdreizehn Euro (EUR 1.113).

87581

L

U X E M B O U R G

Die von Holtzbrinck, vorbenannt, gezeichneten eintausendeinhundertdreizehn (1.113) Anteile der Serie C wurden voll-

ständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendeinhundertdreizehn Euro (EUR 1.113).

Die von Access, vorbenannt, gezeichneten vierhundertvierundvierzig (444) Anteile der Serie C wurden vollständig

eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von vierhundertvierundvierzig Euro (EUR 444).

Die von Bambino 110. V V, vorbenannt, gezeichneten einhundertachtundfünfzig (158) Anteile der Serie D und die

siebenhundertfünfundachtzig (785) Anteile der Serie E wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von
neunhundertdreiundvierzig Euro (EUR 943).

Die von Arrowgrass, vorbenannt, gezeichneten zweitausendsechshundertachtundsechzig (2.668) Anteile der Serie E

wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von zweitausendsechshundertachtundsechzig Euro (EUR
2.668).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlagen wurde der unterzeichnenden Notarin

erbracht.

Die  Einlage  in  Höhe  von  sechstausendzweihunderteinundachtzig  Euro  (EUR  6.281)  wird  vollständig  dem  Gesell-

schaftskapital zugeführt.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Änderung und vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft

und nimmt zur Kenntnis, dass die Gesellschafter der Gesellschaft auf das vorherige Zustimmungserfordernis zur Änderung
der Satzung der Gesellschaft gemäß Artikel 22.8 der Satzung einstimmig verzichtet haben. Die Satzung der Gesellschaft
lautet nunmehr wie folgt:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

ECommerce Holding II S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1  Zweck  der  Gesellschaft  ist  das  Halten  von  Beteiligungen  jeglicher  Art  an  luxemburgischen  und  ausländischen

Gesellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch  Aufnahme  von  Darlehen  in  jeglicher  Form  oder  mittels  Ausgabe  aller  Arten  von  Anleihen,  Wertpapieren  und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Die Gesellschaft kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung auf-

gelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  durch  Beschluss  des  Rates  der  Geschäftsführer  im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

87582

L

U X E M B O U R G

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  dreiundvierzigtausendachthundertvierundneunzig  Euro  (EUR

43.894,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile”),

5.1.2 zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A“),

5.1.3 eintausendsechshundertachtundachtzig (1.688) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B“),

5.1.4 siebentausendneunhundertdreiundfünfzig (7.953) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie C”),

5.1.5 eintausendachtundneunzig (1.098) Anteilen der Serie D mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie D“),

5.1.6 achttausendeinhundertfünfundfünfzig (8.155) Anteilen der Serie E mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie E“, wobei die Anteile der Serie A, die Anteile der Serie B, die Anteile der Serie C, die
Anteile der Serie D und die Anteile der Serie E im Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 (i) Global Fin Tech Holding S.à r.l. („Rocket“), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG („Holtz-

brinck“), (iii) AI Zencap Holdings LLC („Access“), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. („TJT”), (v) David
W. Zalaznick („DZ“), (vi) Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (vii) FEC Lux S.à r.l. („FEC“), (viii) Arrowgrass
Master Fund Ltd (“Arrowgrass”) und (ix) Joh. Berenberg, Gossler &amp; Co. KG („Berenberg“), sofern und sobald Berenberg
ein Gesellschafter der Gesellschaft wird (Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT, DZ, Aismare, FEC, Arrowgrass und Berenberg
gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich
weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des
deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der mit einer Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig
Prozent (75%) der Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) -
unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte -
und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und
dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jeder jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch
eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorste-
henden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte, wobei die Investition eines Dritten nach Ablauf dieser Frist (soweit
nicht von den Investoren nach diesem Artikel 5.3 übernommen) durchgeführt wird.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten

darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-

venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwi-

87583

L

U X E M B O U R G

schen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitver-
kaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern übertragen werden. Sofern
eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen Investor an eine

mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen

Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder
indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von diesem
Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert
Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnet, durch (a) die Leitung der
Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit
der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder indirekt die
Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberechtigter Wertpa-
piere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere Gesellschafter
dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten, welcher

Anteile unter der vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen
Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Umwand-

lungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmel-
zung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als
fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und

Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder
anderen Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt
hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten, einer
solchen Übertragung zustimmen (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt
werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die über-
lebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, nur wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 9. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile ent-

spricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

87584

L

U X E M B O U R G

9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist diese Aus-

gleichszahlung von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemein-
schaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser
auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondisse-
ment)  bestimmt.  Die  Entscheidung  des  Schiedsgutachters  ist  bindend.  Die  Kosten  für  das  Gutachten  werden  von  der
Gesellschaft und dem betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende
Teil mit der Ausgleichszahlung für den Rückkauf verrechnet und die Ausgleichszahlung für den Rückkauf dementspre-
chend  herabgesetzt  wird.  Der  Gesellschafter  hat  die  übrigen  Kosten  zu  tragen,  sofern  der  Rückkaufspreis  die  dem
Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person,
vorbehaltlich der Artikel 189 und 190 des Gesetzes von 1915.

10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant für diese Summe haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschrif-

ten  des  Abschnitts  XII  des  Gesetzes  von  1915  und  dieser  Satzung  aus.  In  diesem  Fall  ist  jede  Bezugnahme  auf  die
„Gesellschafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusam-
menhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleinge-
sellschafter ausgeübt.

Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche in

der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

12.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

87585

L

U X E M B O U R G

12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine schrift-

liche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer unter der
Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung  anwesenden  oder  vertretenen  Gesellschaftern  zu  unterzeichnen  (als  Nachweis,  nicht  als  Voraussetzung  für  die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Ge-

sellschaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres  Mehrheitsverhältnis  vorsehen,  bedürfen  gemeinsame  Entscheidungen  der  Gesellschafter  der  Zustimmung  von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich
im  Einklang  mit  Artikel  12.2  eine  neue  Gesellschafterversammlung  mit  derselben  Tagesordnung  einzuberufen.  Diese
Gesellschafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf
in der die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen gefasst.

Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 15. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.

Art. 16. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;
16.1.3 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.1.4 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (zur Klarstellung, nicht durch die Veräußerung von Anteilen) jegli-

cher  Art  einschließlich  stiller  Beteiligungen  und  sämtlicher  Verträge,  durch  welche  die  andere  Vertragspartei  eine
Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft abhängig
ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge, welche im
Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie Verträge
mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbepartnern.

16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die vor-

herige Zustimmung der Investoren.

16.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
16.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.

16.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten (und, zur Klarstellung, von Arrowgrass, im Falle von Anteilen
der Serie E), verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 17. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1  Die  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer  geleitet.  Falls  die  Gesellschaft  mehrere  Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

87586

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und ihre

Amtszeit festlegt.

18.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterver-
sammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige
Ernennung entscheidet.

19.2  Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem  Amt  ausscheidet,  muss  die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des

Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

20.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-

punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-

ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-

führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

21.2  Sitzungen  des  Rates  der  Geschäftsführer  werden,  falls  vorhanden,  durch  den  Vorsitzenden  des  Rates  der  Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikations-
mittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, oder per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer
kann seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des be-
treffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

87587

L

U X E M B O U R G

21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung von mindestens zwei (2) der Gesellschafter Rocket, Holtzbrinck,

Access, TJT, DZ, Aismare, FEC, Arrowgrass und Berenberg (sofern Berenberg zum gegebenen Zeitpunkt ein Inhaber von
Anteilen ist), die zum gegebenen Zeitpunkt gemeinsam mehr als fünfzig Prozent (50%) des eingetragenen Gesellschafts-
kapitals der Gesellschaft halten (die „Mehrheit der Investoren“), für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen.
Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus
von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Mehrheit der Investoren genehmigt wurden:

21.8.1 Gründung, Erwerb, Schließung oder Veräußerung von Unternehmen oder Teilbetrieben;
21.8.2 Änderung der Statuten, dieser Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge, sowie die Aus-

übung (oder der Ausschluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, in denen eine Beteiligung gehalten wird;

21.8.3 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
21.8.4 Gründung, Verlegung und Schließung von Filialen und Niederlassungen;
21.8.5 Änderung der Geschäftsfelder der Gesellschaft und Aufgabe bestehender und Aufnahme neuer Geschäftsfelder;
21.8.6 Genehmigung des Jahresplans, insbesondere des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr;
21.8.7 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

21.8.8 Gewährung von Darlehen, die, im Einzelfall, einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00)

überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochter-
gesellschaften der Gesellschaft;

21.8.9 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,

einen  Betrag  von  zweihunderttausend  Euro  (EUR  200.000,00)  überschreiten  und  Änderungen  des  Kreditrahmens  und
außerordentliche Rückzahlungen, allerdings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten oder
indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

21.8.10 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

21.8.11 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
21.8.12 Abschluss, Änderung und Auflösung von Arbeitsverträgen, die eine Vergütung von einhundertfünfzigtausend

Euro (EUR 150.000,00) pro Jahr überschreiten;

21.8.13 Zusicherung oder Gewährung von Sonderzulagen und Gratifikationen jeglicher Art außerhalb bestehender Ar-

beitsverträge, sowie Zahlung von Vorschüssen oder Gewährung von Darlehen an Geschäftsführer und Angestellte, die, im
Einzelfall, einen Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,00) überschreiten;

21.8.14 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheb-

licher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

21.8.15 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-

wert von über zehntausend Euro (EUR 10.000,00) im Einzelfall;

21.8.16 Erwerb, Verfügung und/oder Lizenzierung von Nutzungsrechten jeglicher Art hinsichtlich der Rechte an geist-

igem Eigentum, einschließlich Urheberrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte, sowie die Weitergabe von Know-how
zur eigenen Verwertung durch die Firma und/oder Drittparteien, sowie die Erteilung oder der Erwerb von Lizenzen und
die Abänderung diesbezüglicher Verträge, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen zwischen der Gesellschaft und di-
rekten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

21.8.17 Erteilung einer Vollmacht, durch welche ein Bevollmächtigter einen anderen Bevollmächtigten dazu ermächtigt,

auf Kosten der Gesellschaft einen Vertrag mit diesem zu schließen;

21.8.18 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.

Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft (einschließlich, zur Klarstellung, Global
Founders GmbH (vormals: European Founders Fund, „GF“) und GF's direkte und indirekte Gesellschafter (z.B. die Samwer
Brüder), aber ausschließlich direkter oder indirekter Gesellschafter von Holtzbrinck und/oder Access und/oder TJT und/
oder DZ und/oder Aismare und/oder FEC und/oder Arrowgrass und/oder Berenberg (sofern Berenberg zum gegebenen
Zeitpunkt ein Inhaber von Anteilen ist), verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG),
sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß §§ 15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere
(mit Ausnahme von GF und GF's direkten und indirekten Gesellschaftern) - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt
eine Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 21.8.18 ist nicht erforderlich, wenn die Trans-
aktion zum gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

21.8.19 Änderung der Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft;
21.8.20 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteilsoder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den
Gesellschaftern in einer Gesellschaftervereinbarung vereinbart wurde;

21.8.21 Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, deren Gesellschafter die Gesellschaft

ist, sofern diese Ausübung, wenn die Gesellschaft betroffen wäre, die Zustimmung der Mehrheit der Investoren nach dieser
Satzung erfordern würde, d.h. gemäß dieses Artikels 21.8 oder Artikels 16.

87588

L

U X E M B O U R G

21.8.22 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen und zusätzlich zur Mehrheit der Investoren benötigen die Ge-

schäftsführer nach dem Erwerb von Anteilen der Serie E durch Arrowgrass die Zustimmung der Inhaber von Anteilen der
Serie E, mit Ausnahme von Bambino 110. V V UG (haftungsbeschränkt) (nachfolgend der „Treuhänder“), (wobei die
Zustimmung der Mehrheit der Anteile der Serie E - mit Ausnahme derer, die vom Treuhänder gehalten werden - diesbe-
züglich ausreicht) für die in Artikel 21.8.5 und 21.8.18 aufgeführten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen ab dem Zeitpunkt,
ab dem die Anteile der Serie E zum ersten Mal verkauft oder übertragen wurden.

21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,

so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung der
Mehrheit der Investoren erfordern. Die Mehrheit der Investoren kann ihre Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten
von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des Alleinigen Ge-

schäftsführers.

22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden),
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder
deren Vertreter) gemeinsam unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder
auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) gemeinsam unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer  hat,  durch  die  gemeinsamen  Unterschriften  zwei  (2)  beliebiger  Geschäftsführer  wirksam  verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschaf-

terbeschluss die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats erhöhen oder herabsetzen, vorausgesetzt, dass die
Ernennungsrechte gemäß Artikel 24.3 eingehalten werden und dass Rocket nicht dazu berechtigt ist, mehr als vier (4)
stimmberechtigte Mitglieder zu ernennen, es sei denn, Rocket erhöht seinen Anteilsbesitz an der Gesellschaft.

24.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesell-

schafterbeschluss festlegen und/oder verändern.

24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

24.3.1 Vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter Rocket nach eigenem Ermessen

ernannt;

24.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Holtzbrinck nach eigenem Ermessen

ernannt;

24.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Access nach eigenem Ermessen

ernannt;

24.3.4 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare nach eigenem Ermessen

ernannt;

87589

L

U X E M B O U R G

24.3.5 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter FEC nach eigenem Ermessen er-

nannt; und 24.3.6 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Arrowgrass nach eigenem
Ermessen ernannt.

24.4 Der Beirat hat stimmberechtigte und nicht-stimmberechtigte Mitglieder als Beobachter.
24.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimmbe-

rechtigtes  Mitglied  ist  der  Vorsitzende  des  Beirats.  Die  Geschäftsordnung  des  Beirats  hat  weitere  Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.

24.6 Der Beirat ist für die Beratung der Geschäftsführer der Gesellschaft hinsichtlich Strategie und operativer Angele-

genheiten zuständig und berät mit den Geschäftsführern über den Haushalt der Gesellschaft.

24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.

25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-

sellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-

klang  mit  den  gesetzlichen  Anforderungen  ein  Inventar  der  Aktiva  und  Passiva,  eine  Bilanz  und  eine  Gewinn-  und
Verlustrechnung.

27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

27.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-

falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-

mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-

stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

27.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 und
des Artikels 27.6 verteilt und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen
Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert
durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder
dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

87590

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation.
29.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

29.2 Beschlüsse bezüglich der Auflösung und der Liquidation der Gesellschaft erfordern neben einer durch das Gesetz

von 1915 vorgesehenen Mehrheit und einer Mehrheit der Investoren gemäß dieser Satzung zusätzlich die Genehmigung
der Inhaber einer Mehrheit der Anteile der Serie E, mit Ausnahme derer, die vom Treuhänder gehalten werden.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft eingehen und durch die
bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Bestimmungen
einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien,
soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“ Da die Tagesordnung erschöpft
ist, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr eintausendsechshundert Euro (EUR 1.600) geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche der Notarin mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt sind, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesen Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.

Gezeichnet: L. AGUERRE ENRIQUEZ, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 04 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/13822. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Mai 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015078417/1299.
(150089630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Alpenland Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 158.661.

Les statuts coordonnés au 05/05/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/05/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015076474/12.
(150087951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

87591

L

U X E M B O U R G

CF Stefano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 197.104.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of the month of May.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CF Stefano Holdings LP, a limited partnership governed by the laws of Delaware, having its registered office at Cor-

poration Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, registered with the Delaware Secretary of State
under number 5742683,

represented by Maître Mathieu Girotto, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 19 May 2015

(such proxy to be registered together with the present deed).

The appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary to draw up the articles of asso-

ciation of a limited liability company CF Stefano S.àr.l. ("société à responsabilité limitée") which is hereby established as
follows:

Art. 1. Name. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "CF Stefano S.àr.l." (the

"Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The Company
will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participation in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which
the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  an
extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of asso-
ciation.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect
on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a
Luxembourg  company.  Such  temporary  measures  will  be  taken  and  notified  to  any  interested  parties  by  the  board  of
managers.

Art. 5. Share Capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR

12,500) divided into twelve thousand and five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required
for amendment of these articles of association.

87592

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Transfer of shares. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share

transfer to nonmembers is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the Company's
capital.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers who need not be members.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad
nutum) at any time. The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being
class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the
relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held
by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by
another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers shall meet upon call by any manager. Notice of any meeting shall be given by letter, cable,

telegram, telephone, facsimile transmission, telex or e-mail advice to each manager at least 24 hours before the meeting,
except in the case of an emergency, in which event a twelve hours notice shall be sufficient. The convening notice may be
waived by the consent in writing or by fax or telegram or email of each manager. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Managers.

A duly called meeting of the board of managers shall be duly quorate if at least a majority of the managers are present

or represented, provided that at least two of the Managers shall be participating, either physically or by proxy, in such
meeting from Luxembourg. Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the
managers of the Company (including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board
of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class
B manager (which may be represented).

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will
form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

Resolutions of the board of the managers will be recorded in minutes signed by any manager of the Company.
Managers' resolutions, including circular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued

under the individual signature of any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive powers

to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the manager(s).

However, if the shareholder(s) have qualified the managers as category A managers or as category B managers, the

Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) category A manager and one (1)
category B manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to

whom special signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits of such power.

Art. 8. Liability managers. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents

of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Decision by members. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to

the number of shares he owns and may validly participate in written resolutions and act at any meeting of members through
a special proxy.

Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as set out herein or to the extent

mandatory as prescribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held
including meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing members
taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another; the participation in a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the
Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by the board of managers by convening notice addressed by registered mail to members to their

address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting.
If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

87593

L

U X E M B O U R G

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed

in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions.
The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions
(or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may
be passed at any time without prior notice.

However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members

(ii) representing at least three quarters of the issued share capital. In case and for as long as the Company has more than
25 members, an annual general meeting shall be held on 31 May at 12.00 pm CET. of each year. If such day is not a business
day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

Art. 11. Accounting year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year.

Art. 12. Annual accounts. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the board of

managers.

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 14. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the board of

managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable
reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account (if any) may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.

The general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.

Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be

but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers
and remunerations.

Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member

company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1

and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31 

st

 December, 2015.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscriber

Number

of shares

Payments

(Euro)

CF Stefano Holdings LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

EUR 12,500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,250

EUR 12,500

Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro 1,500.-.

<i>Extraordinary general meeting

The above named sole shareholder, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital, has

immediately taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an undetermined period of time subject

to the articles of association of the Company:

- Mr Constantine Dakolias, manager, born on 20 June 1966 in Washington DC, United States of America, with profes-

sional address at 1345 Avenue of the Americas, 46 

th

 Floor, New York, NY 10105;

87594

L

U X E M B O U R G

- Mr Marc Furstein, manager, born on 11 February 1968 in New York, United States of America, residing professionally

at 1 Market Street, Spear Tower, 42 

nd

 Floor, San Franscisco, CA 94105.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an undetermined period of time subject

to the articles of association of the Company:

- Mr Tomas Lichy, manager, born on 25 November 1972 in Ostrava, Czech Republic, professionally residing at 4, rue

Beck, L-1222 Luxembourg;

- Mrs Fulvia Bizzozero, manager, born on 3 June 1968 in Liège, Belgium, with professional address at 4, rue Beck,

L-1222 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, the said proxy holder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CF Stefano Holdings LP, une société à responsabilité limitée, régie par le droit du Delaware, ayant son siège social au

Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, inscrite auprès du registre de commerce du
Delaware sous le numéro 5742683,

Représentée par Maître Mathieu Girotto, maître en droit, demeurant à Luxembourg en vertu de la procuration du 19 mai

2015, laquelle sera enregistrée avec le présent acte.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les

statuts d'une société à responsabilité limitée CF Stefano S.àr.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1 

er

 . Nom.  Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associées, une société à

responsabilité limitée sous la dénomination de «CF Stefano S.àr.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les présents
statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres
valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La
Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de
succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut également accomplir tous types de transactions relatives directement ou indirectement à l’acquisition

de biens immobiliers, propriétés et droits immobiliers à Luxembourg ou à l’étranger et de participations dans des entreprises
immobilières ou entité de toute autre forme, et l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces partici-
pations et avoirs.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de

certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient
la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accom-
plissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou

indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social,

de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu
lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation

87595

L

U X E M B O U R G

complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société
qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront
prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) divisé

en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (1 EUR) chacune. Le capital de la Société
peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents
Statuts.

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions con-

traires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné par
au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

Art. 7. Gestion. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, par une décision prise à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment. L’assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes,
à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B. Une telle classification des gérants devra être dûment consignée
dans le procès-verbal de l’assemblée concernée et les gérants être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils
appartiennent.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant
à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les uns avec les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une
réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion
tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans
limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance se réunira sur demande d’un gérant. Convocation à toute réunion sera donnée par lettre, câble,

télégramme, téléphone, télécopieur, télex ou courrier électronique à chaque gérant au minimum 24 heures avant la réunion,
sauf urgence, auquel cas un délai de douze (12) heures sera suffisant. Il peut être renoncé à la convocation par écrit, télécopie,
télégramme ou courrier électronique par chaque gérant. Une convocation séparée ne sera pas exigée pour des réunions
individuelles tenues aux heures et lieu décrits dans un échéancier adopté antérieurement par résolution du conseil de gérance

Une réunion du conseil de gérance dûment convoquée aura le quorum nécessaire pour délibérer si la majorité des gérants

est présente ou représentée et si au moins deux (2) des gérants participent à une telle réunion, soit physiquement ou par
procuration, à une telle réunion, au Luxembourg. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l’agrément
de la majorité des gérants de la Société (représentation comprise). Dans le cas où néanmoins l’assemblée générale des
associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) toute résolution
du conseil de gérance ne peut être valablement prise que si approuvée par la majorité des gérants comprenant au moins un
gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions
du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux lesquels seront signés par un gérant de la Société.

Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits

seront émis sous la signature individuelle de tout gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et opérations
relatifs à la Société.

Toutefois, si le ou les associés ont qualifié les gérants de gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B, la Société

ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui un pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de ce pouvoir.

Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la

Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.

Art. 9. Décisions des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au

nombre de parts sociales qu'il possède et peut valablement prendre part aux résolutions écrites et valablement se faire
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la/aux majorité/s prévues dans les présents statuts ou

prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou

87596

L

U X E M B O U R G

lors d'assemblées y compris des assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres
moyens de communication permettant à tous les associés prenant part à l’assemblée de s'entendre les uns les autres et de
communiquer ensemble. La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
assemblée. Toute assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par
la loi le cas échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par le conseil de gérance par une convocation adressée par lettre recommandée

aux associés à l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d’une
telle assemblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions
prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet
à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans
convocation préalable.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises (i) qu'à la majorité des

associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés

sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au 31 mai de chaque année à 12.00 heures.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant.

Art. 11. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale le conseil de gérance établit les comptes annuels.

Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 14. Distribution. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant

ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission (si présent) peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des

associés. L’assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré les

parts sociales suivantes:

Associé

Nombre

de parts
sociales

Capital

souscrit

(Euro)

CF Stefano Holdings LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

12.500 EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

12.500 EUR

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ mille cinq cents euros 1.500,-.

87597

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique, représenté comme ci-avant indiqué, représentant l'intégralité du capital social souscrit a pris immé-

diatement les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée sous réserve

des statuts de la Société:

- Monsieur Constantine Dakolias, gérant, né le 20 juin 1966 à Washington DC, Etats-Unis d’Amérique, avec adresse

professionnelle à 1345 Avenue of the Americas, 46 

ème

 Etage, New York, NY 10105;

- Monsieur Marc Furstein, gérant, né le 11 février 1968 à New York, Etats-Unis d’Amérique, avec adresse profession-

nelle à 1 Market Street, Spear Tower, 42 

ème

 Etage, San Franscisco, CA 94105.

Les personnes suivantes sont nommées gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des

statuts de la Société:

- Monsieur Tomas Lichy, gérant, né le 25 novembre 1972 à Ostrava, République Tchèque, avec adresse professionnelle

à 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg; et

- Madame Fulvia Bizzozero, gérant, née le 3 juin 1968 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle à 2-4, rue Beck,

L-1222 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'à la demande de la comparante en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. GIROTTO, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15649. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015078347/360.
(150090262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Windmill Lux Subco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EPF Acquisition Co 30 S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 193.232.

In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of May.
Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

EPF Acquisition Co 31 S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 44, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of EUR 12,500 and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 193.262,

duly represented by Mrs Rachida El Farhane, employee, having her professional address in Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg, by virtue of a proxy given on May 12 

th

 , 2015.

The proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholders and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing person, represented as above, as requested the notary to state the following:
The appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of EPF Acquisition Co 30 S.à r.l., a société à

responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 44, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
193232 (the “Company”), incorporated by deed of the undersigned notary, dated 20 December 2014, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”) under number 236 as at 29 January 2015.

The Sole Shareholder then reviewed the following agenda (the “Agenda”):

87598

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Change of name of the Company to "Windmill Lux Subco S.à r.l.”; and
2. Subsequent amendment of article 1 of the Company's articles of association.
Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, representing the entire share

capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company to "Windmill Lux Subco S.à r.l.".

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Company's articles

of association in order to read as follows:

“ Art. 1. Name. The name of the company is “Windmill Lux Subco S.à r.l.” (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation

(the Articles)”.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On express request of the same appearing
person, and in case any divergences would arise between the French and the English text, the English text will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said

person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le quinze mai.
Par-devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

EPF Acquisition Co 31 S.à r.l., une société constituée et existante sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant

son siège social au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 193.262, dûment représentée par Madame Rachida El Farhane, salariée, ayant son adresse
professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 12 mai
2015.

La procuration, signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être

soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter comme suit:
La partie comparante est l’Associé unique («Associé Unique») de la société EPF Acquisition Co 30 S.à r.l., une société

constituée et existante sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193232
(la «Société»), constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 20 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») numéro 236 du 29 janvier 2015.

La partie comparante a ensuite considéré l'ordre du jour suivant (l’«ordre du jour»):

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en «Windmill Lux Subco S.à r.l.»; et
4. Modification corrélative de l’article 1 des statuts de la Société.
Après considération des différents points à l'ordre du jour, l’Associé unique, représentant l'intégralité du capital social

de la Société, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société en «Windmill Lux Subco S.à r.l.».

<i>Deuxième résolution

Suite  à  la  résolution  précédente,  l’Associé  unique  décide  de  modifier  l’article  1  des  statuts  de  la  Société,  qui  aura

désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Windmill Lux Subco S.à r.l." (la Société). La Société est une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»

87599

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande du comparant le présent acte est dressé en

langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.

Et après lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire

instrumentant par ses noms, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: El Farhane, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15463. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 28 mai 2015.

Référence de publication: 2015079357/89.

(150090408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

international quiding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Dierkirch, 3, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 171.851.

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite aux conventions de cession de parts sociales sous seing privé, signées par les cédants et le cessionnaire en date du

22 Mai 2015 et acceptées par les gérants au nom de la société, il en résulte que le capital social de la société «international
quiding S.à r.l.» est désormais réparti comme suit:

AUHOLD S.à r.l., avec siège social à L-9237 Diekirch, 3, Place Guillaume, Luxembourg
et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro: B 179 268 . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

RIHOLD S.à r.l., avec siège social à L-9237 Diekirch, 3, Place Guillaume, Luxembourg
et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro: B 179 269 . . . . . . . . . . . . . . .

50.000

Alkimia Advisors Ltd., avec siège social à Dixcart House, Fort Charles, Charlestown, Nevis,
St.KittsandNevis et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro: C 42062 . . .

1.000

Monsieur Antonio GARCIA BRITES, né le 29/05/1967 à Lugo (ESP) et demeurant
à Carrer de la Constitució, Edif. Salita Parc S/N, 2n 1a, AD700 Escaldes, Andorra. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000

Grup Companyia Comercial de Desenvolupament Industrial, SA, avec siège social à
Avinguda Sant Antoni, Casa Forat, número 24, 1r pis, 2a, AD400 Porta La Massana,
Andorra, inscrite auprès du Andorra Publique Registre sous le numéro: 1508. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000

NSFO, SA, avec siege social à Carrer De Roca Corba Núm. 28, Urbanització Can Diumenge,
Escaldes-Engordany, Andorra, inscrite auprès du Andorra Publique Registre sous le numéro: 14738. . . . .

9.000

Madam Neus MORO PUENTE, né le 31/08/1966 à Andorra la Vella (Andorra) et
demeurant à c/ La Solana, 31, AD700 Escaldes-Engordany, Andorra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Monsieur Jaume FORTÓ NOGUEIRA, né le 01/03/1957 à Escaldes-Engordany (Andorra)
et demeurant à Camille Del Roc, casa pasturé, AD700 Escaldes-Engordany, Andorra. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

ORGELIA INVESTMENTS, SLU, avec siège social à Carretera Dels Vilars, Urbanització
Sant Romà, Casa Núm. 9, AD700 Escaldes-Engordany, Andorra, inscrite auprès du
Andorra Publique Registre sous le numéro: 15425. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

Total: cent mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000

Diekirch, le 22 Mai 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Les associés
Oncke Kipperman / Frank B.C.M. Nabuurs
<i>Director / Director

Référence de publication: 2015076444/37.

(150088287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

87600


Document Outline

Alpenland Holding S.A.

AltaFund Invest IV S.à r.l.

Carrée S.A.

CBRE S.A.

CF Stefano S.à r.l.

Colian S.A.

Compagnie Luxembourgeoise de Financement de Commerces

Consolidated Energy Finance S.A.

Constellation Software Luxembourg

Corporation Distribution S.à r.l.

Cozen s.à r.l.

DAH Real Estates S.à r.l.

Danyl S.A., SPF

D Ebco S.à r.l.

Decision Advantage Science S.à r.l.

DesignU S.à r.l.

DK Lux TT SA

Doman (SPF) S.A.

Do Way S.à r.l.

DxO S.A.

Earl Place (Luxembourg) Holding SA

ECommerce Holding II S.à r.l.

Edmond de Rothschild Assurances et Conseil (Europe)

Edmond de Rothschild Europportunities II S.C.A., SICAR

Elisana S.à r.l.

EMC S.A.

EPF Acquisition Co 30 S.à r.l.

Eurofins Discovery Services LUX Holding

Eurofins Hygiène Alimentaire France LUX Holding

Hipoteca VIII Lux S.à r.l.

international quiding S.à r.l.

Leverlake S.àr.l.

Longbow Investment N°3 S.à r.l.

LuxeHeat

Luxembourg Irtysh Petroleum Sàrl

Luxinva S.A.

Meridian Hotel Holdings S.à r.l.

Nouvelle Financière Bi-Sam S.à r.l.

Ragof Heusenstamm S.à r.l.

Sanichaufer S. à r.l.

VPB-Finance S.A.

Windmill Lux Subco S.à r.l.