logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1809

21 juillet 2015

SOMMAIRE

ArcelorMittal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86791

Axiteam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86807

Bonativo Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86811

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86790

Caisse Raiffeisen Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . .

86791

Capacity Allocation Service Company.eu S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86832

DAH Real Estates S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

86790

DE Investment Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

86790

Denlux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86790

DKV Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86791

DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86791

E.EX, Européenne d'Exportation S.A.  . . . . . .

86792

Electro Nord S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86789

Eterlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86792

Eurofins Analyses Environnementales pour les

Industriels France LUX Holding  . . . . . . . . . .

86790

Eurofins Environment Testing LUX Holding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86791

Eurofins Hydrologie France LUX Holding . . .

86792

Fahrenheit SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86792

Fany S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86807

Fiducenter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86792

Fiduciaire Alpha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86793

Imprimerie Fr. Faber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86788

Initio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86788

Interalliance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86789

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86788

IPA Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86789

Ixxo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86789

JCSS Mike S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86830

Lux International Cleaning Enterprise S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86787

Noe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86787

Nostos Holdings Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86786

NRRG Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86786

OCM Debtco S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86807

OCM Luxembourg OPPS VI Blocker S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86787

OCM Luxembourg OPPS VII Blocker S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86787

Op der Gänn SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86786

Pascatti Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

86786

Pole Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86787

Pol Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86786

Société Européenne de Banque  . . . . . . . . . . . .

86832

SOF-9 Rome Investments Lux S.à r.l.  . . . . . . .

86795

SPF 2 Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86799

Tribel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86806

Triton Luxembourg GP Efeu Pooling S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86804

86785

L

U X E M B O U R G

Op der Gänn SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3918 Mondercange, 1, route d'Ehlerange.

R.C.S. Luxembourg B 80.513.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015078730/9.
(150090304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Nostos Holdings Co S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 103.658.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2015.

Référence de publication: 2015078709/10.
(150090335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

NRRG Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 181.064.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29/4/2015.

Signature.

Référence de publication: 2015078712/10.
(150089923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Pascatti Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 163.568.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PASCATTI LUXEMBOURG S.A.
Frédéric SEINCE

Référence de publication: 2015078748/11.
(150089992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Pol Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 109.701.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26.05.2015.

<i>Pour: POL HOLDING S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015078762/14.
(150090302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

86786

L

U X E M B O U R G

Noe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 65.752.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015078707/9.
(150089761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

OCM Luxembourg OPPS VI Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.132.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2015.

Référence de publication: 2015078717/10.
(150090217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

OCM Luxembourg OPPS VII Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.567.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2015.

Référence de publication: 2015078718/10.
(150090220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Pole Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 109.848.

L'administrateur unique de la Société M. Marc Pirlet a changé d'adresse et réside désormais au 58/2, rue de la gare,

L-3377 Leudelange, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 28 mai 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015078739/12.
(150090042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Lux International Cleaning Enterprise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 9.411.

Les comptes sociaux au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2015.

<i>Pour les gérants
Par mandat
Claude GEIBEN

Référence de publication: 2015080588/13.

(150091858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

86787

L

U X E M B O U R G

Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 44.318.

Les comptes consolidés au 31 Décembre 2014 de Intesa Sanpaolo Spa en tant que maison mère de Intesa Sanpaolo

Holding International S.a, sur le dossier de Intesa Sanpaolo Holding International S.A., en vertu de l'art 314(1) de la loi du
10 août 1915 telle que modifiée par la suite, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2015078557/14.
(150090289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Imprimerie Fr. Faber, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 22.529.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 1985,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 72 du 9 mars 1985.

- Dernière modification des statuts par acte notarié de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 150 du 5 février 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 19 mai 2015 que Monsieur Carlo Steimetz,

demeurant à L-6555 BOLLENDORF-PONT 26, Gruusswiss a été coopté Administrateur avec effet au 19 mai 2015.

Mersch, le 26 mai 2015.

Référence de publication: 2015078565/14.
(150089778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Initio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 87.830.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires prises en date du 17 avril 2015

L'Assemblée a délibéré et pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
1. L'Assemblée accepte la démission d'un Administrateur de la société:
- Madame Aline Englebert
1 L'Assemblée nomme comme administrateur:
- La société Athena Group S.A., avec siège social à 89B, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, inscrite au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 87 831.

L'Assemblée constate qu'à dater du 17 avril 2015, la composition du Conseil d'Administration est la suivante:
- Monsieur Eric Bonnel
Administrateur
- Monsieur Jérôme Boucheron
Administrateur
- Athena Group S.A.
Administrateur
Leurs mandats viendront à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant à statuer sur les comptes 2019 de

la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Marc Dame
<i>Délégué à la gestion journalière

Référence de publication: 2015078570/26.
(150089654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

86788

L

U X E M B O U R G

IPA Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 182.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015078574/9.
(150089666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Interalliance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 132.355.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INTERALLIANCE S.à r.l.

Référence de publication: 2015078573/10.
(150089839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Electro Nord S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen, 25, Z.A.E.R. Op der Héi.

R.C.S. Luxembourg B 94.381.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 01/06/2015.

<i>Pour la société
C.F.N GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P. 80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015080361/17.

(150092175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Ixxo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 150.823.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 20.05.2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a dissous

et déclaré en état de liquidation la société anonyme IXXO SA, établie et ayant son siège social à L-9710 Clervaux, 17
Grand-Rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 150823.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles PETRY et liquidateur Me Claude Speicher, avocat à

la Cour, à Diekirch.

Les déclarations de créance sont à déposer au greffe du Tribunal de commerce de Diekirch endéans les 3 semaines de

la présente publication.

Pour extrait conforme
Me Claude SPEICHER
<i>Le liquidateur / Avocat à la Cour

Référence de publication: 2015078584/18.
(150089685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

86789

L

U X E M B O U R G

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, Société Anonyme.

Siège social: L-9214 Diekirch, 1, rue de la Brasserie.

R.C.S. Luxembourg B 96.275.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015075818/9.
(150086392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

DE Investment Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 74.341.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 97.015.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2015.

Référence de publication: 2015080313/10.
(150092372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

DAH Real Estates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 126.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2015.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015080307/11.
(150092151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Eurofins Analyses Environnementales pour les Industriels France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.680.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 165.609.

Les comptes annuels pour la période du 1 

er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015080340/11.
(150092691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Denlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 123.942.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Gérante

Référence de publication: 2015080316/12.
(150092070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

86790

L

U X E M B O U R G

Caisse Raiffeisen Mersch, Société Coopérative.

Siège social: L-7535 Mersch, 13, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 20.416.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015075849/9.
(150086349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

DONNER &amp; REUSCHEL Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.375.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 88.481.

Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2015.

Rolf Brandes / Maunu Römpötti.

Référence de publication: 2015080326/10.

(150092293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

ArcelorMittal, Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 82.454.

Les comptes annuels consolidés du groupe ArcelorMittal au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015078194/10.
(150089589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Eurofins Environment Testing LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.200.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 122.860.

Les comptes annuels pour la période du 1 

er

 janvier au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015080342/11.

(150092684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

DKV Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 45.762.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DKV Luxembourg S.A.
Stefan Pelger
<i>CEO

Référence de publication: 2015080322/12.

(150092567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

86791

L

U X E M B O U R G

Fiducenter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 62.780.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015080397/9.
(150092100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Eterlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 29.029.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marie-Jeanne KIEFFER.

Référence de publication: 2015080372/10.
(150092095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Fahrenheit SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 139.848.

Les comptes annuels de la société Fahrenheit SICAV-SIF au 31 December 2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015080383/10.
(150092602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

Eurofins Hydrologie France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 165.611.

Les comptes annuels pour la période du 1 

er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015080343/11.
(150092690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

E.EX, Européenne d'Exportation S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1134 Luxembourg, 48, rue Charles Arendt.

R.C.S. Luxembourg B 82.919.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2015.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015080333/14.
(150091835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2015.

86792

L

U X E M B O U R G

Fiduciaire Alpha, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7521 Mersch, 55, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 196.989.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le huit mai.
Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Edward KOSTKA, réviseur d’entreprises agréé, demeurant à L-7521 Mersch, 55, rue des Champs.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a déclaré

constituer comme suit:

Art. 1 

er

 .  La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «FIDUCIAIRE ALPHA».

Art. 2. Le siège est établi à Mersch.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la localité. Le siège social

pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’associé ou des associés réunis en assemblée générale.

Art. 3. La société a pour objet l’exécution de toutes missions se rattachant directement ou indirectement à l’exercice, à

titre indépendant, des professions d’expert-comptable, de réviseur d’entreprises et de réviseur d’entreprises agréé, tel que
notamment défini dans la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.

Elle peut effectuer toutes opérations à caractère fiduciaire et, plus généralement, entreprendre toutes autres activités

susceptibles de favoriser cet objet, à l’exclusion de toutes activités commerciales.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter,
participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de
prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits s'attachant à ces brevets ou
pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires
et  brevets.  Elle  pourra  emprunter  et  accorder  aux  sociétés  auxquelles  elle  s'intéresse  tous  concours,  prêts,  avances  ou
garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, com-

merciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Elle  peut  entreprendre  et  réaliser  toutes  opérations  et  entreprises  mobilières  ou  immobilières,  industrielles,  civiles,

commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui
sont de nature à favoriser ou à développer l’activité de la société.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500.-) EUROS, représenté par CINQ CENTS

(500) parts sociales, d’une valeur nominale de VINGT-CINQ (25.-) EUROS chacune.

La société pourra acquérir ses propres parts, à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 6. Lorsque la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l’entend.
Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés, sous réserve d’un droit

de préemption pour chaque associé au prorata de sa participation dans le capital.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que de l'accord des associés représentant au moins les trois

quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires ou au conjoint

survivant.

Dans l’hypothèse d’une transmission de parts sociales pour cause de mort à un non-associé qui n’aurait pas été agréé

par l’assemblée générale des associés, ces derniers seront alors tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification
de leur refus, de faire acquérir les parts sociales dont la cession est projetée dans l’ordre de priorité suivant:

86793

L

U X E M B O U R G

- soit par les associés restants, qui possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital

social restant, étant précisé que le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement
aux autres associés;

- soit par un tiers agréé par eux;
- soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l’acquisition par une société de ses propres

titres.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues par

l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé qui a fait
l’avance et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale à une majorité des deux tiers. Ces
intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme ci-avant déterminée ne sont pas à considérer comme un apport

supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les héritiers et créanciers de l'associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son
administration.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'associé ou par les associés

avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.

Art. 11. L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de sa/leur nomination.

Art. 12. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obligation

personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 14. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice

net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre d'amortissement
et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale.
Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par

l'associé ou par l'un des associés désigné d'un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts l'associé ou les associés se réfèrent et se soumettent

aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’autori-

sation préalable des autorités compétentes.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant a déclaré souscrire la totalité des CINQ CENTS (500) parts

sociales.

Ces  dernières  ont  été  entièrement  libérées  en  espèces,  de  sorte  que  la  somme  de  DOUZE  MILLE  CINQ  CENTS

(12.500.-) EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentaire, qui le constate expressément.

<i>Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à MILLE DEUX CENTS

(1.200.-) EUROS.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2015.

86794

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée générale extraordinaire.

Et à l'instant, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, et agissant en lieu et place de l’assemblée

générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

1.- Il se nomme gérant pour une durée indéterminée, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances

par sa seule signature.

2.- Il déclare que l’adresse de la société est fixée à L-7521 Mersch, 55, rue des Champs.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Kostka, THOLL.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 15 mai 2015. Relation: 2LAC/2015/10692. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Mersch, le 22 mai 2015.

Référence de publication: 2015076856/121.
(150087580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

SOF-9 Rome Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.099,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 170.551.

In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of the month of May.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1) SOF-9 Rome Holdings Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registrar (Registre
de commerce et des Sociétés) under number B170546 and with registered office is at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy under private seal given in May 2015;

2) Mr. James BURRELL, a United Kingdom national, residing at 22 Leadhall Lane, Harrogate, HG2 9PE, United

Kingdom, here represented by Mrs Isabel DIAS , prenamed, by virtue of a proxy under private seal given in May 2015;

3) Mr. lan CONDER, a United Kingdom national, residing at 20 Firwood Avenue, St Albans AL4 OTF, United Kingdom,

here represented by Mrs Isabel DIAS , prenamed , by virtue of a proxy under private seal given in May 2015;

4) Mr. Alan CORLETT, a United Kingdom national, residing at Brook Farm House 49, Brook Street, Hartshorne,

Derbyshire DE11 7AH, United Kingdom, here represented by Mrs Isabel DIAS , prenamed , by virtue of a proxy under
private seal given in May 2015;

5)  Mrs.  Geraldine  GALLAGHER,  a  United  Kingdom  national,  residing  at  Risplith  House,  Risplith,  Ripon,  North

Yorkshire, HG4 3EP, United Kingdom, here represented by Mrs Isabel DIAS , prenamed , by virtue of a proxy under
private seal given in May 2015;

6) Mrs. Gail HUNTER, a United Kingdom national, residing at Welbourne House, Scarah Lane, Burton Leonard, North

Yorkshire HG3 3RS, United Kingdom, here represented by Mrs Isabel DIAS , prenamed , by virtue of a proxy under private
seal given in May 2015;

7) Mrs. Joanne MONK, a United Kingdom national, residing at Pilgrims Cottage, 5 Raven Lane, Ludlow, Shropshire

SY8 1BW, United Kingdom, here represented by Mrs Isabel DIAS , prenamed , by virtue of a proxy under private seal
given in May 2015;

8) Mrs. Laurie NICOL DONALDSON, a United Kingdom national, residing at 79, Garscadden Road, Glasgow, G15

6UH, United Kingdom, here represented by Mrs Isabel DIAS , prenamed , by virtue of a proxy under private seal given in
May 2015;

9) Mr. Adrian OSINSKI, a United Kingdom national, residing at 4 Weiss Road, London SW15 1DH, United Kingdom,

here represented by Mrs Isabel DIAS , prenamed , by virtue of a proxy under private seal given in May 2015; and

10)  Mr.  Anthony  Gerrard  TROY,  a  United  Kingdom  national,  residing  at  Fountains  Bert,  Darley  Road,  Birstwith,

Harrogate, HG3 2PN, United Kingdom, here represented by Mrs Isabel DIAS , prenamed , by virtue of a proxy under
private seal given in May 2015;

(the appearing parties being altogether referred as to the “Shareholders”).

86795

L

U X E M B O U R G

The proxies signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed

for the purpose of registration.

The Shareholders have requested the undersigned notary to document the following:
I. They are the shareholders of “SOF-9 Rome Investments Lux S.à r.l.”, a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of thirteen thousand
ninety-two British Pounds and seventy pence (£13,092.70), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under  number  B170551  and  with  registered  office  at  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882  Luxembourg  (the  “Company”),
incorporated by a deed received by the undersigned notary on July 24, 2012 and published in the Luxembourg Official
Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2193 of September 4, 2013. The Company's articles
of association have last been amended by a deed received by the undersigned notary on July 18, 2014 and published in the
Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2646 of September 30, 2014.

II. They recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda, which is

known to the Shareholders:

<i>Agenda:

1. To increase the Company's share capital by an amount of six British Pounds and thirty pence (£6.30) so as to raise it

from its current amount of thirteen thousand ninety-two British Pounds and seventy pence (£13,092.70) to thirteen thousand
ninety-nine British Pounds (£13,099).

2. To create and issue sixty-three (63) new B shares, each at a nominal value of ten pence (British Pounds Sterling)

(£0.10) together with an aggregate share premium of one thousand nine hundred ninety-three British Pounds and seventy
pence (£1,993.70).

3. To accept the subscription for the sixty-three (63) new B shares by David Taylor, and to allot all such new B shares

against payment in full for such new B shares.

4. To amend article 5 (Capital) of the Company's articles of association in order to reflect the above items.
5. Miscellaneous.
III. The Shareholders then passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to increase the Company's share capital by an amount of six British Pounds and thirty pence

(£6.30)  so  as  to  raise  it  from  its  present  amount  of  thirteen  thousand  ninety-two  British  Pounds  and  seventy  pence
(£13,092.70) to thirteen thousand ninety-nine British Pounds (£13,099).

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to create and issue sixty-three (63) new B shares, each at a nominal value of ten pence (British

Pounds Sterling) (£0.10) together with an aggregate share premium of one thousand nine hundred ninety-three British
Pounds and seventy pence (£1,993.70), having the rights and privileges set out by the articles of association of the Company.

<i>Subscription - Payment

There now appeared Mrs Isabel DIAS, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Mr. David

TAYLOR, a United Kingdom national, residing at 26 Hainthorne Road, London, SE27 OPH, by virtue of a proxy under
private seal given in May 2015.

The proxy signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary will remain annexed to the present deed

for the purpose of registration (the “Subscriber”).

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber to the sixty-three (63) new B

shares newly issued by the Company, each such new share being issued at a nominal value of ten pence (British Pounds
Sterling) (£0.10) together with a share premium of one thousand nine hundred ninety-three British Pounds and seventy
pence (£1,993.70).

The sixty-three (63) newly issued B shares have all been subscribed in exchange for a contribution in cash of six British

Pounds and thirty pence (£6.30) together with an aggregate share premium of one thousand nine hundred ninety-three
British Pounds and seventy pence (£1,993.70).

Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary and the undersigned notary formally

acknowledges the availability of the aggregate amount of two thousand British Pounds (£2,000).

Thereupon, the Shareholders, each having waived any pre-emptive right or other subscription preferential right in any

kind or form that he, she or it can have, resolved to accept the said subscription by the Subscriber, the payment of the new
B shares as well as the allotment of the sixty-three (63) new B shares to the Subscriber as stated above, and to acknowledge
the effectiveness of the capital increase.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the shareholders of the Company resolved to amend article 5.1 (Capital)

of the Company's articles of association which shall forthwith read as follows:

86796

L

U X E M B O U R G

“ Art. 5. Capital.
5.1. The Company's issued share capital is set at thirteen thousand ninety-nine British Pounds (£13,099), divided into

two classes as follows:

5.1.1 one hundred thirty thousand (130,000) A Shares, with a nominal value of ten pence (British Pounds Sterling)

(£0.10) each; and

5.1.2 nine hundred ninety (990) B Shares with a nominal value of ten pence (British Pounds Sterling) (£0.10) each,
with such rights and obligations as are set out in these Articles.”
Articles 5.2 and 5.3 of the Company's articles of association shall remain unchanged.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English, stated herewith that the present deed is worded in English

followed by a French version at the request of the appearing person and in case of discrepancies between the two versions,
the English version will control.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le huitième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1) SOF-9 Rome Holdings Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B170546 et avec siège social au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement au L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé
donnée en mai 2014;

2) M. James BURRELL, ressortissant britannique, résidant à 22 Leadhall Lane, Harrogate, HG2 9PE, Royaume-Uni,

ici représenté par Madame Isabel DIAS, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en mai 2015;

3) M. Ian CONDER, ressortissant britannique, résidant au 20 Firwood Avenue, St Albans, Hertfordshire, AL4 0TF,

Royaume-Uni, ici représenté par Madame Isabel DIAS, prénommée,en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en
mai 2015;

4) M. Alan CORLETT, ressortissant britannique, résidant à Brickhouse Farm, Hartshorne, Staffordshire, DE11 7AH,

Royaume-Uni, ici représenté par Madame Isabel DIAS, prénommée,en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en
mai 2015;

5) Mme Geraldine GALLAGHER, ressortissante britannique, résidant à Risplith House, Risplith, Ripon, North Yorks-

hire, HG4 3EP, Royaume-Uni, ici représenté par Madame Isabel DIAS, prénommée,en vertu d'une procuration sous seing
privé donnée en mai 2015;

6) Mme Gail HUNTER, ressortissante britannique, résidant à Welbourne House, Scarah Lane, Burton Leonard, North

Yorkshire, HG3 3RS, Royaume-Uni, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en mai 2015;

7) Mme Joanne MONK, ressortissante britannique, résidant au 5 Raven Lane, Ludlow, Shrosphire, SY8 1BW, Royaume-

Uni, ici représenté par Madame Isabel DIAS, prénommée,en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en mai 2015;

8) Mme Laurie NICOL DONALDSON, ressortissante britannique, résidant au 79, Garscadden Road, Glasgow, La-

narkshire, G15 6UH, Royaume-Uni, ici représenté par Madame Isabel DIAS, prénommée,en vertu d'une procuration donnée
en mai 2015;

9) M. Adrian OSINSKI, ressortissant britannique, résidant au 4 Weiss Road, London, SW15 1DH, Royaume-Uni, en

vertu d'une procuration sous seing privé donnée en mai 2015; et

10) M. Anthony Gerrard TROY, ressortissant britannique, résidant au Fountains Bert, Darley Road, Birstwith, Harrogate,

HG3 2PN, Royaume-Uni, ici représenté par Madame Isabel DIAS, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé
donnée en mai 2015,

(les parties comparantes collectivement désignées comme les «Associés»).
Les procurations signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte

pour être enregistrées avec lui.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

86797

L

U X E M B O U R G

I. Qu'ils sont ensemble les associés de «SOF-9 Rome Investments Lux S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie

par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de treize mille quatre-vingt-douze livres sterling et
soixante-dix pence (£13.092,70), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B170551
et avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 24 juillet 2012 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
2193 du 4 septembre 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 18 juillet 2014 et publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2646 du
30 septembre 2014.

II. Les Associés ont reconnu avoir été entièrement informés des résolutions à prendre sur la base de l'ordre du jour

suivant, connu des Associés:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant total de six livres sterling et trente pence

(£6,30) afin de porter le montant actuel de son capital social de treize mille quatre-vingt-douze livres sterling et soixante-
dix pence (£13.092,70) à un montant de treize mille quatre-vingt-dix-neuf livres sterling (£13.099).

2. Création et émission de soixante-trois (63) nouvelles parts sociales B, chacune ayant une valeur nominale de dix

pence (livres sterling) (£0,10) avec une prime d'émission d'un montant de mille neuf cent quatre-vingt-treize livres sterling
et soixante-dix pence (£1.993,70).

3. Acceptation de la souscription des soixante-trois (63) nouvelles parts sociales B par M. David TAYLOR et l'allocation

de la totalité des nouvelles parts sociales B en contrepartie du paiement intégral pour ces nouvelles parts sociales B.

4. Modification de l'article 5 (Capital) des statuts de la Société pour l'application des résolutions ci-dessus.
5. Divers.
III. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant total de six livres sterling

et trente pence (£6,30) afin de porter le montant actuel de son capital social de treize mille quatre-vingt-douze livres sterling
et soixante-dix pence (£13.092,70) à un montant de treize mille quatre-vingt-dix-neuf livres sterling (£13.099).

<i>Deuxième résolution

Les Associés ont décidé de créer et d'émettre soixante-trois (63) nouvelles parts sociales B, chacune ayant une valeur

nominale de dix pence (livres sterling) (£0,10) avec une prime d'émission d'un montant de mille neuf cent quatre-vingt-
treize livres sterling et soixante-dix pence (£1.993,70), avec les droits et privilèges attachés tels que prévus dans les statuts
de la Société.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite a comparu Madame Isabel DIAS, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de M. David

TAYLOR, ressortissant britannique, résidant au 26 Hainthorne Road, Londres, SE27 OPH.

Ladite procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte

aux fins d'enregistrement (le «Souscripteur»).

La partie comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte du Souscripteur, les soixante-trois (63) parts sociales

B nouvellement émises par la Société, chacune des nouvelles parts sociales émises ayant une valeur nominale de dix pence
(livres sterling) (£0,10) avec une prime d'émission de mille neuf cent quatre-vingt-treize livres sterling soixante-dix pence
(£1.993,70).

Les soixante-trois (63) parts sociales B nouvellement émises ont été souscrites en contrepartie d'un apport en numéraire

d'un montant total de six livres sterling et trente pence (£6,30) avec une prime d'émission d'un montant total de de mille
neuf cent quatre-vingt-treize livres sterling soixante-dix pence (£1.993,70).

La preuve du tel paiement a été donnée au notaire instrumentant et le notaire instrumentant reconnaît formellement la

disponibilité du montant total de deux mille livres sterling (£2.000).

Ensuite, les Associés, chacun ayant renoncé à tout droit de préemption ou tout autre droit préférentiel de souscription

de tout genre ou forme qu'il ou elle aurait, ont décidé d'accepter ladite souscription par le Souscripteur, le paiement pour
ses parts sociales B ainsi que d'attribuer les soixante-trois (63) parts sociales B nouvelles au Souscripteur de la manière
décrite ci-dessus, et d'acter l'effectivité de l'augmentation de capital.

<i>Troisième résolution

En conséquence des précédents résolutions, les associés ont décidé de modifier l'article 5.1 (Capital) des statuts de la

Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à treize mille quatre-vingt-dix-neuf livres sterling (£13.099), représenté par

deux catégories de parts sociales comme suit:

86798

L

U X E M B O U R G

5.1.1 cent trente mille (130.000) Parts Sociales A, ayant une valeur nominale de dix pence (livres sterling) (£0,10)

chacune; et

5.1.2 neuf cent quatre-vingt-dix (990) Parts Sociales B, ayant une valeur nominale de dix pence (livres sterling) (£0,10)

chacune,

avec les droits et obligations comme décrits dans les présents Statuts.»
Les articles 5.2 et 5.3 des statuts de la Société demeurent inchangés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges de toute sorte, qui incombent à la Société de la présente augmentation de

capital, s'élèvent approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400.-).

<i>Déclarations

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare, à la demande de la partie comparante, que le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version
anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite du présent acte au mandataire des parties comparantes à Luxembourg, qui est connu du notaire

par son nom, prénom, résidence, état civil et résidence, et a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 mai 2015. Relation: 2LAC/2015/10743. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 26 mai 2015.

Référence de publication: 2015077376/228.
(150088391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

SPF 2 Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.260.018,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.720.

In the year two thousand fifteen, on the second day of April.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Shopping Property Fund 2 Feeder SA SICAV-SIF, a public limited liability company (société anonyme) qualifying as

an investment company with variable share capital (SICAV) and established as a specialised investment fund (SIF), in-
corporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 190.678,

here represented by Mrs Sophie Cumani, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg, on 1 

st

 April 2015.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the «Sole Shareholder»), representing the entire share capital of SPF 2

Holdco S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 44, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’
register under number B 190.720 incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg on 10 September 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 3331 on 11 November 2014 (hereinafter the «Company»).

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, declared having waived any prior declaration and notice

requirement and deliberated on the following agenda:

<i>Agenda

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of sixty nine thousand and fifty euros (EUR 69,050.00)

in order to reduce it from its present amount of six million three hundred twenty-nine thousand and sixty-eight euro (EUR

86799

L

U X E M B O U R G

6,329,068.-) represented by one hundred twenty-six thousand five hundred eighty-one (126,581) ordinary shares with a
nominal value of one euro (EUR 1) each and six million two hundred two thousand four hundred eighty-seven (6,202,487)
mandatory redeemable preferred shares each with a par value of one euro (EUR 1) each, by cancellation of one thousand
three hundred eighty-one (1,381) ordinary shares and sixty-seven thousand six hundred sixty-nine (67,669) mandatory
redeemable preferred shares.

2. Amendment of article 5.1 of the Company’s articles of association,
3. Deletion of article 6.1.3 of the Company’s articles of association and renumbering accordingly,
4. Amendment of article 6.1.5 (of the current numbering) of the Company’s articles of association, and
5. Miscellaneous.
The Sole Shareholder required the undersigned notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of sixty nine thousand and fifty

euros (EUR 69,050.00) in order to reduce it from its present amount of six million three hundred twenty-nine thousand and
sixty-eight euro (EUR 6,329,068.-) represented by one hundred twenty-six thousand five hundred eighty-one (126,581)
ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each and six million two hundred two thousand four hundred
eighty-seven (6,202,487) mandatory redeemable preferred shares each with a par value of one euro (EUR 1) each, by
cancellation of one thousand three hundred eighty-one (1,381) ordinary shares and sixty-seven thousand six hundred sixty-
nine (67,669) mandatory redeemable preferred shares, already redeemed by the Company.

As a consequence of the redemption and cancellation of the ordinary shares, the Sole Shareholder shall receive an amount

of one thousand three hundred eighty-one euro (EUR 1,381) corresponding to the nominal value of the ordinary shares
which the Sole Shareholder held.

The Sole Shareholder acknowledges that sixty-seven thousand six hundred sixty-nine (67,669) mandatory redeemable

preferred shares hereby cancelled were redeemed pursuant to a decision of the board of managers of the Company and that
the Sole Shareholder already received a payment sixty-seven thousand six hundred sixty-nine euro (EUR 67,669) corres-
ponding to the nominal value of the mandatory redeemable preferred shares so redeemed.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decided to amend article 5.1 of the articles of

association of the Company which shall henceforth read as follows:

5.1. The Company's share capital is set at six million two hundred sixty thousand and eighteen euro (EUR 6,260,018.-),

represented by one hundred twenty-five thousand two hundred (125,200) ordinary shares (the «Ordinary Shares») with a
nominal value of one euro (EUR 1) each and six million one hundred thirty-four thousand eight hundred and eighteen
(6,134,818) mandatory redeemable preferred shares (the «MRPS», together with the Ordinary Shares hereinafter the «Sha-
res»), with a par value of one euro (EUR 1) each.»

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to delete article 6.1.3 of the articles of association of the Company which stipulates that

«the redemption of MRPS can only be made if followed by a cancellation of the MRPS so redeemed». As a consequence
article 6 of the articles of association of the Company shall henceforth be renumbered as follows:

« Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into Ordinary Shares and MRPS, each of them having the same nominal

value.

6.1.1 Each MRPS will give right to a preferential and cumulative dividend at the annual rate of 5 % of the nominal value

of said MRPS, which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year (the "Preferred Dividend"). In case the
approved annual accounts relating to a given financial year show a loss with regard to such financial year, no Preferred
Dividend may be actually paid during the financial year following the financial year the loss has been recorded.

Holders of MRPS have no right to any other dividends distributed. Distributions regarding Ordinary Shares shall be

made to the holders of Ordinary Shares in proportion to the shares they hold in the Company.

6.1.2 Except as otherwise provided herein (or in any written agreement which may be entered into among the shareholders

of the Company), all subscribed MRPS shall be redeemable (a) upon request of the Company, and (b) in any case, after
ten (10) years as from the date of issuance of the MRPS (the "Mandatory Redemption Date"). The redemption shall take
place pursuant to a decision of the board of managers.

6.1.3 Except as provided otherwise in these articles (or by a written agreement which may be entered into between the

Company and the shareholders), the redemption price of each MRPS shall be equal to (a) (i) the aggregated nominal value
of all the MRPS plus the portion of the balance of the related share premium account, if any, attached to the MRPS, (ii)
plus accrued and unpaid Preferred Dividend on redeemed MRPS, if any (b) divided by the number of outstanding MRPS
at the time of the redemption (the "Redemption Value").

86800

L

U X E M B O U R G

6.1.4 The MRPS may only be partially or entirely redeemed by the Company to the extent that (a) the Company is not

insolvent or will not be insolvent after making such payment, i.e. that the Company can no longer pay its debts as they fall
due and there is no possibility of obtaining further credit, (b) the redemption will not have the effect of reducing the aggregate
net assets below the minimum subscribed capital plus the reserves which may not be distributed and (c) the Company has
sufficient available resources for such redemption in accordance with the Law.

If the Company is not permitted by Law to redeem all MRPS on their Mandatory Redemption Date, the Company shall

redeem the maximum number of MRPS which the Company is then permitted to redeem. Such redemption will be made
on a pro rata basis from each MRPS holder.

6.1.5 The Company may redeem its Ordinary Shares within the limits set forth by Law. However, the redemption of the

Ordinary Shares is subject to the prior redemption of all the MRPS.

6.1.6 Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the shareholders of the

Company, at least fifteen (15) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail or interna-
tionally recognized overnight courier to each registered shareholder of the MRPS to be redeemed, at his or her address last
shown in the shareholders register of the Company, notifying such holder of the number of MRPS so to be redeemed,
specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the MRPS to the Company for
redemption and the valuation of the redemption price, as provided for in this section 6.2. The redemption price of such
MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the
bank account.

6.1.7 The MRPS are subordinated to all type of creditors but senior to the Ordinary Shares or other type of Shares. In

case of liquidation of the Company, each MRPS holder is entitled to the Redemption Value attributable to the MRPS held
by him under the conditions set forth in these articles of incorporation.

6.1.8 After payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of the necessary funds to that effect,

each MRPS holder will have a preferential right to payment and be entitled to the Redemption Value attributable to the
MRPS held by him. If the Company cannot pay such amounts in full to all the MRPS holders, payment will be made on a
pro rata basis to each MRPS and to each holder of MRPS. A holder of MRPS shall participate in the liquidation surplus.

6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.»

<i>Fourth resolution

The  Sole  Shareholder  resolves  to  amend  article  6.1.5  (old  numbering),  i.e.  article  6.1.4  (new  numbering)  of  the

Company’s articles of association in order to replace the word «insolvent» by «bankrupt», so that the article shall henceforth
be read as follows:

« 6.1.4. The MRPS may only be partially or entirely redeemed by the Company to the extent that (a) the Company is

not bankrupt or will not be bankrupt after making such payment, i.e. that the Company can no longer pay its debts as they
fall due and there is no possibility of obtaining further credit, (b) the redemption will not have the effect of reducing the
aggregate net assets below the minimum subscribed capital plus the reserves which may not be distributed and (c) the
Company has sufficient available resources for such redemption in accordance with the Law.

If the Company is not permitted by Law to redeem all MRPS on their Mandatory Redemption Date, the Company shall

redeem the maximum number of MRPS which the Company is then permitted to redeem. Such redemption will be made
on a pro rata basis from each MRPS holder.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at EUR 2,000.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le deux avril.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

86801

L

U X E M B O U R G

Shopping Property Fund 2 Feeder SA SICAV-SIF, une société d'investissement à capital variable (SICAV) prenant la

forme d'une société anonyme (SA) qualifiant comme fonds d'investissement spécialise (FIS), constituée et régie selon les
lois du Luxembourg, dont le siège social se situe à 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 190.678,

ici représentée par Madame Sophie Cumani, employée, ayant son domicile professionnel à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à Luxembourg, le 1 

er

 avril 2015.

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La comparante est l’associé unique («l’Associé Unique»), représentant l’intégralité du capital social de SPF 2 Holdco

S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 190.720 constituée
selon acte reçu par le notaire soussigné, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 10
septembre 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3331 en date du 11 novembre 2014 (ci-
après la «Société»).

L’Associé Unique, représentant l’intégralité du capital social, ayant déclaré avoir renoncé à toute déclaration préalable

et formalité de convocation a délibéré sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de soixante-neuf mille cinquante euros (EUR 69.050,-) afin

de  le  réduire  de  son  montant  actuel  de  six  millions  trois  cent  vingt-neuf  mille  soixante-huit  euros  (EUR  6.329.068,-)
représenté par cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt et une (126.581) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale
d’un euro (EUR 1) chacune et six millions deux cent deux mille quatre cent quatre-vingt-sept (6.202.487) parts sociales
préférentielles obligatoirement rachetables, chacune ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1), par l’annulation de
mille trois cent quatre-vingt et une (1.381) parts sociales ordinaires et soixante-sept mille six cent soixante-neuf (67.669)
parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables;

2. Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société;

3. Suppression de l’article 6.1.3 des statuts de la Société et renumérotation en conséquence;

4. Modification de l’article 6.1.5 (de la numérotation actuelle) des statuts de la Société; et

5. Divers

L’Associé Unique requiert le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de soixante-neuf mille cinquante euros

(EUR 69.050,-) afin de le réduire de son montant actuel de six millions trois cent vingt-neuf mille soixante-huit euros (EUR
6.329.068,-) représenté par cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt et une (126.581) parts sociales ordinaires d’une
valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune et six millions deux cent deux mille quatre cent quatre-vingt-sept (6.202.487)
parts  sociales  préférentielles  obligatoirement  rachetables,  chacune  ayant  une  valeur  nominale  d’un  euro  (EUR  1),  par
l’annulation de mille trois cent quatre-vingt et une (1.381) parts sociales ordinaires et soixante-sept mille six cent soixante-
neuf (67.669) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables et ayant déjà été rachetées par la Société.

En conséquence du rachat et de l’annulation des parts sociales ordinaires, l’Associé Unique recevra un montant de mille

trois cent quatre-vingt et une euros (EUR 1.381) correspondant à la valeur nominale des parts sociales ordinaires que
l’Associé Unique détenait.

L’Associé Unique reconnaît que soixante-sept mille six cent soixante-neuf (67.669) parts sociales préférentielles obli-

gatoirement rachetables annulées par le présent acte ont été rachetées conformément à une décision du conseil de gérance
de la Société et que l’Associé Unique a déjà reçu un paiement de soixante-sept mille six cent soixante-neuf euros (EUR
67.669) correspondant à la valeur nominale des parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables ayant été rache-
tées.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société

qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à six millions deux cent soixante mille dix-huit euros (EUR 6.260.018,-),

représenté par cent vingt-cinq mille deux cent (125.200) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») ayant
une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune et six millions cent trente-quatre mille huit cent dix-huit (6.134.818) parts
sociales préférentielles obligatoirement rachetables (les «APOR», ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires, les «Parts
Sociales»), ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.»

86802

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de supprimer l’article 6.1.3 des statuts de la Société qui précise que «le rachat des APOR ne

peut être fait que s'il est suivi par une annulation des APOR ainsi rachetées». En conséquence l’article 6 des statuts de la
Société devra être renuméroté de la manière suivante:

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en Parts Sociales Ordinaires et en APOR ayant chacune la même valeur

nominale.

6.1.1 Chaque APOR donnera droit à un dividende préférentiel et cumulatif au taux annuel de 5 % de la valeur nominale

desdites APOR, qui augmente quotidiennement et sera calculé en supposant une année de 365 jours (le «Dividende Prio-
ritaire»). Dans le cas où les comptes annuels approuvés relatifs à un exercice font apparaître une perte à l’égard de cet
exercice social, aucun Dividende Prioritaire ne pourra être effectivement versé au cours de l’exercice suivant l’exercice au
cours duquel la perte a été enregistrée.

Les détenteurs d'APOR n'ont pas le droit à d'autres dividendes distribués. Les distributions concernant les Parts Sociales

Ordinaires seront faites pour les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en proportion des parts sociales qu'ils détiennent
dans la Société.

6.1.2 Sauf disposition contraire dans ces statuts (ou dans tout accord écrit qui serait conclu entre les associés de la

Société), toutes les APOR souscrites sont rachetables

(a) à la demande de la Société, et (b) en tout cas, après dix (10) ans à compter de la date d'émission des APOR (la «Date

De Rachat Obligatoire»). Le rachat aura lieu conformément à une décision du conseil de gérance.

6.1.3 Sauf disposition contraire dans ces statuts (ou par un accord écrit qui serait conclu entre la Société et les associés),

le prix de rachat de chaque APOR est égal à (a) (i) la valeur nominale cumulée de toutes les APOR plus la partie du solde
du compte de prime d'émission relatif, le cas échéant, attaché aux APOR, (ii) plus les Dividendes Privilégiés courus et non
rémunérés sur les APOR rachetées, le cas échéant, (b) divisée par le nombre d'APOR au moment du rachat (la «Valeur De
Rachat»).

6.1.4 Les APOR ne pourront être partiellement ou entièrement rachetées par la Société que dans la mesure où (a) la

Société n'est pas insolvable ou ne sera pas insolvable après avoir fait ce paiement, à savoir que la Société ne peut plus payer
ses dettes à leur échéance et qu'il n'y a aucune possibilité d'obtenir un crédit supplémentaire, (b) le rachat n'aura pas pour
effet de réduire l’actif net cumulé en dessous du capital souscrit minimum augmenté des réserves non distribuables et (c)
la Société dispose de ressources suffisantes pour ce rachat, conformément à la Loi.

Si la Société n'est pas autorisée par la Loi à racheter toutes les APOR à leur Date De Rachat Obligatoire, la Société

rachètera le nombre maximum d’APOR que la Société est autorisée à racheter ensuite. Ce rachat sera effectué au prorata
de chaque détenteur d'APOR.

6.1.5 La Société peut racheter ses Parts Sociales Ordinaires dans les limites fixées par la Loi. Toutefois, le rachat des

Parts Sociales Ordinaires est soumis au rachat préalable de toutes les APOR.

6.1.6 Sauf dispositions contraires dans un accord écrit qui pourrait être conclu entre les associés de la Société, au moins

quinze (15) jours avant la date de rachat, un avis écrit doit être envoyé par courrier recommandé ou courrier international
reconnu à chaque associé nominatif des APOR à racheter, à sa dernière adresse indiquée dans le registre des associés de
la Société, indiquant à ce détenteur le nombre d’APOR à racheter, en précisant la date de rachat, le prix de rachat, les
procédures nécessaires pour soumettre les APOR à la Société pour le rachat et l’évaluation du prix de rachat, tel que prévu
dans le présent article 6.1.3. Le prix de rachat de ces APOR doit être libellé à l’ordre de la personne dont le nom figure sur
le registre des associés comme étant le détenteur du compte bancaire.

6.1.7 Les APOR sont subordonnées à tous les types de créanciers, mais supérieur aux Parts Sociales Ordinaires ou

d’autres types d'actions. En cas de liquidation de la Société, chaque détenteur d’APOR a droit à la Valeur De Rachat
attribuable aux APOR détenues par lui dans les conditions énoncées dans les présents statuts.

6.1.8 Après paiement de toutes les dettes et obligations de la Société vis-à-vis de tiers ou de dépôt des fonds nécessaires

à cet effet, chaque détenteur d’APOR aura un droit préférentiel de paiement et a droit à la Valeur De Rachat attribuable
aux APOR détenues par lui. Si la Société ne peut pas payer ces montants en entier à tous les détenteurs d'APOR, le paiement
sera effectué sur une base pro rata à chaque APOR et à chaque détenteur d’APOR. Le détenteur d'APOR participe au boni
de liquidation.

6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre

évènement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 6.1.5 (de l’ancienne numérotation), à savoir l’article 6.1.4 (de la nouvelle

numérotation) des statuts de la Société afin de remplacer le terme «insolvable» par «en état de faillite», de telle manière à
ce que cet article ait la teneur suivante:

86803

L

U X E M B O U R G

6.1.4. Les APOR ne pourront être partiellement ou entièrement rachetées par la Société que dans la mesure où (a) la

Société n'est pas en état de faillite ou ne sera pas en état de faillite après avoir fait ce paiement, à savoir que la Société ne
peut plus payer ses dettes à leur échéance et qu'il n'y a aucune possibilité d'obtenir un crédit supplémentaire, (b) le rachat
n'aura pas pour effet de réduire l’actif net cumulé en dessous du capital souscrit minimum augmenté des réserves non
distribuables et

(c) la Société dispose de ressources suffisantes pour ce rachat, conformément à la Loi.
Si la Société n'est pas autorisée par la Loi à racheter toutes les APOR à leur Date De Rachat Obligatoire, la Société

rachètera le nombre maximum d’APOR que la Société est autorisée à racheter ensuite. Ce rachat sera effectué au prorata
de chaque détenteur d'APOR.

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est

évalué à EUR 2.000,-.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction en français; et qu’à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. CUMANI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 9 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/11092. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 mai 2015.

Référence de publication: 2015077386/274.
(150087909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Triton Luxembourg GP Efeu Pooling S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 174.200.

In the year two thousand fifteen, on the twenty-first day of April,
Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Maître Nirida Nhouyvanisvong, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
acting as special attorney in fact of the board of managers Triton Luxembourg GP, a société à responsabilité limitée

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro
(EUR 12,500.-), with registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 158788 (the “Manager”),
acting in its capacity as manager of Triton Luxembourg GP Efeu Pooling S.C.A., a société en commandite par actions
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 21 December
2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 447 of 22 February 2013 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 1742000 (the "Company"). The articles of
incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of 20 October 2014,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3,630 of 29 November 2014,

by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted by the board of managers of the Manager acting in

its capacity as manager of the Company on 7 April 2015.

The said appearing person has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:
I. That the share capital of the Company is presently set at one hundred fifty-seven thousand eight hundred eleven euro

and forty cents (EUR 157,811.40) divided into one hundred sixty-six thousand six hundred sixty-seven (166,667) class A1
shares (the "Class A1 Shares"), one million four hundred eleven thousand three hundred forty-seven (1,411,347) class A2
shares (the "Class A2 Shares") and hundred (100) class B shares (the "Class B Shares"), each having a nominal value of
ten euro cents (EUR 0.10) and fully paid up.

II. That pursuant to article 7 of the Company's articles of incorporation, the authorised capital of the Company has been

fixed at one hundred sixty-six thousand six hundred seventy-six euro and seventy cents (EUR 166,676.70), divided into

86804

L

U X E M B O U R G

one  sixty-six  thousand  six  hundred  and  sixty-seven  (166,667)  Class  A1  Shares,  one  million  five  hundred  thousand
(1,500,000) Class A2 Shares and one hundred (100) Class B Shares, each with a nominal value of ten euro cents (EUR
0.10).

III. That the board of managers of Triton Luxembourg GP, a société à responsabilité limitée governed by the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with
registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 158788 (the “Manager”), acting in its capacity as
manager of the Company, in its meeting of 7 April 2015 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to
the Company's articles of incorporation, has decided to issue fifty-six thousand nine hundred ninety one (56,991) new Class
A2 Shares, together with a share premium in an aggregate amount of sixty three thousand fifty euro and ninety cents (EUR
63,050.90), and to cancel the preferential subscription rights of the Company's existing shareholders to subscribe for the
new shares.

IV. That Mr Thomas Sonnenberg, acting in his capacity as manager of the Manager, acting in its capacity as manager

of the Company, and according to the authority granted to him pursuant to the resolutions of the board of managers of the
Manager, acting in its capacity as manager of the Company, dated 7 April 2015, has acknowledged and confirmed, in a
confirmation dated 8 April 2015, a copy of which shall remain attached to the present deed, that the capital has been
increased by an amount of five thousand six hundred ninety-nine euro and ten cents (EUR 5,699.10) by the issuance of
fifty-six thousand nine hundred ninety one (56,991) new Class A2 Shares.

V. That as a consequence of the above mentioned issue of shares, with effect as of 7 April 2015, paragraph one of Article

5 of the Articles of Incorporation is therefore amended and shall read as follows:

Art. 5. Share Capital. The issued capital of the Company is set at one hundred sixty-three thousand five hundred ten

euro and fifty cents (EUR 163,510.50), divided into one hundred sixty-six thousand six hundred sixty-seven (166,667)
class A1 shares (the “Class A1 Shares”) and one million four hundred sixty-eight thousand three hundred thirty-eight
(1,468,338) class A2 shares (the “Class A2 Shares”), which shall be held by the limited shareholder(s) (actionnaire(s)
commanditaire(s)) and hundred (100) class B shares (the “Class B Shares”), which shall be held by the unlimited partner
(associé commandité), in representation of its unlimited partnership interest in the Company. Each issued share of each
class has a nominal value of ten euro cent (EUR 0.1) and is fully paid up”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at two thousand euro (EUR 2,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first

name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt et unième jour du mois d'avril,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Maître Nirida Nhouyvanisvong, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant comme mandataire spécial du conseil de gérance de Triton Luxembourg GP, une société à responsabilité régie

par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), avec siège social au
2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158788 (le «Gérant»), agissant en sa qualité de gérant de Triton Luxem-
bourg GP Efeu Pooling S.C.A., une société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire
soussigné en date du 21 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 447
du 22 février 2013, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174200 (la
«Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant du 20 octobre 2014, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3.630 du 29 Novembre 2014.

en vertu d'une procuration qui lui a été conférée par résolutions adoptées par le conseil de gérance du Gérant, agissant

en sa qualité de gérant de la Société en date du 7 avril 2015.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les déclarations et constatations suivantes:
I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à cent cinquante-sept mille huit cent onze euros et quarante

centimes (EUR 157.811,40), divisé en cent soixante-six mille six cents soixante-sept (166.667) actions de catégorie A1
(les «Actions de Catégorie A1»), un million quatre cent onze mille trois cent quarante-sept (1.411.347) actions de catégorie

86805

L

U X E M B O U R G

A2 (les «Actions de Catégorie A2») et cent (100) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), ayant chacune
une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) et entièrement libérées.

II. Qu'en vertu de l'article 7 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à cent soixante-six mille

six cent soixante-seize euros et soixante-dix centimes (EUR 166.676.70), divisé en cent soixante-six mille six cent soixante-
sept (166.667) Actions de Catégorie A1, un million cinq cent mille (1.500.000) Actions de Catégorie A2 et cent (100)
Actions de Catégorie B, ayant chacune une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) et entièrement libéré.

III. Que le conseil de gérance de Triton Luxembourg GP, une société à responsabilité régie par le droit luxembourgeois,

ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), avec siège social au 2C, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 158788 (le «Gérant»), agissant en sa qualité de gérant de la Société, lors de sa réunion en date
du 7 avril 2015 et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé d'émettre
cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-onze (56.991) nouvelles Actions de Catégorie A2, ensemble avec un prime
d'émission d'un montant total de soixante-trois mille cinquante euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 63.050,90), et de
supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société pour la souscription des nouvelles
actions.

IV. Que M. Thomas Sonnenberg, agissant en sa qualité de gérant du Gérant, agissant en sa qualité de gérant de la Société

et conformément au pouvoir qui lui a été conféré par résolutions du conseil de gérance du Gérant, agissant en sa qualité de
gérant de la Société, du 7 avril 2015, a constaté et confirmé, dans une confirmation en date du 8 avril 2015, dont une copie
restera annexée au présent acte, l'augmentation du capital social d'un montant de cinq mille six cent quatre-vingt-dix-neuf
euros et dix centimes (EUR 5.699,10), par l'émission de cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-onze (56.991) nouvelles
Actions de Catégorie A2.

V. Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit avec effet au 7 avril 2015, le premier alinéa

de l'article 5 des statuts est modifié en conséquence et sera désormais rédigé comme suit:

« Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à cent soixante-trois mille cinq cent dix euros et cinquante centimes

(EUR 163.510,50), représenté par cent soixante-six mille six cents soixante-sept (166.667) actions de catégorie A1 (les
«Actions  de  Catégorie  A1»)  et  un  million  quatre  cent  soixante-huit  mille  trois  cent  trente  huit  (1,468,338)  actions  de
catégorie A2 (les «Actions de Catégorie A2»), qui doivent être détenues par les actionnaires-commanditaires et cent (100)
actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B») qui seront détenues par l'associé-commandité, en représentation de
son engagement indéfini dans la Société. Chaque action a une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10), et
chaque action est entièrement libérée.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges toute nature payable par la Société suite en raison du présent acte sont

estimés à deux mille euros (EUR 2.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses noms, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: N. Nhouyvanisvong, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 mai 2015. GAC/2015/3831. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 22 mai 2015.

Référence de publication: 2015077421/133.
(150087947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Tribel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.793.

Je suis au regret de vous annoncer ma démission de ma fonction d'administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 02 mars 2015.

Marine SCHRUB.

Référence de publication: 2015078072/9.
(150088862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

86806

L

U X E M B O U R G

Axiteam, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.

R.C.S. Luxembourg B 174.629.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015075805/9.
(150086431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

OCM Debtco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 192.716.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 17 avril 2015

Il résulte des dites résolutions que:
OCM OPPS IX Group Debt Holdings S.à r.l., avec siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et

enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 193217, associé unique de la Société, a transféré
1,000,000 parts à OCM Gaudi Topco S.à r.l., avec siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et enregistré
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 196815.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2015.

Jabir Chakib
<i>Gérant

Référence de publication: 2015077187/17.
(150088486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Fany S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 197.019.

STATUTS

L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE TREIZE MAI.
Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- Madame Ginette Léa FONTINOY, née le 4 mai 1944 à Lessines, résidant au 9, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen,

Luxembourg,

- Monsieur Michel Félicien FONTINOY, né le 18 juillet 1949 à Durnal, résidant au 9, rue de la Chapelle, L-8017

Strassen, Luxembourg,

tous deux ici représentés par Monsieur Gérald VINTER, employé, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations signées sous seing privé en date du 13 mai 2015, lesquelles procurations resteront annexées

au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d’une société de gestion de

patrimoine familial (en abrégé SPF) sous forme d’une société anonyme qu'ils déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des actions ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une Société de gestion de Patrimoine Familial (en abrégé SPF) sous la forme d'une société anonyme,
qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, la loi du 11 mai 2007
sur la Société de gestion de Patrimoine Familial («Loi sur les SPF»), telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la société n'a qu'un actionnaire unique, elle

peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la société.

La société prend la dénomination de «FANY S.A. SPF».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

86807

L

U X E M B O U R G

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette
mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs constitués d’ins-

truments financiers (au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) et d’espèces et avoirs de quelque
nature que ce soit détenus en compte.

Elle pourra détenir des participations dans des sociétés sans toutefois s’immiscer dans la gestion de celles-ci.
Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine privé d’une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l’objet d’un placement public ou être admis à la cotation d’une bourse de

valeurs.

Elle  prendra  toutes  mesures  pour  sauvegarder  ses  droits  et  fera  toutes  opérations  généralement  quelconques  qui  se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»), telle que modifiée.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) représenté par vingt mille (20.000) actions

d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions seront émises sous forme nominative uniquement.
En cas de démembrement de la propriété des actions, il est expressément prévu que la titularité de chaque action repré-

sentative du capital social souscrit peut être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé
«usufruitier» et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Pour toute assemblée décidant la fusion, la scission, la dissolution ou la liquidation de la société, et plus généralement,

pour toute résolution ayant comme effet la dissolution de la société, l’accord préalable de nu-propriétaire sera requis.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit

commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la Société.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie par inscription dans le registre

des actionnaires:

- en regard du nom de l’usufruitier, de la mention usufruit,
- en regard du nom du nu-propriétaire, de la mention nue-propriété.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. En cas de pluralité des
administrateurs, l’assemblée générale peut nommer les administrateurs de catégorie A et de catégorie B.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-

més ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à
l'élection définitive.

Tant que la société a un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique seulement.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un représentant

permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

86808

L

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le

mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre ou téléfax, ces trois derniers

étant à confirmer par écrit.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconfé-

rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct et (iv)
les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil d'admi-
nistration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant comporter

obligatoirement, le cas échéant, le vote d'un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d'un adminis-
trateur investi des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est
prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des

tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

Art. 12. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature

unique de son administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs, dont obligatoirement, si l’assemblée a nommé les administrateurs de catégories A et B, une signature de la
catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites
de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre

et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Tout actionnaire de la société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et parler
avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent
valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication équivaudra
à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le premier lundi du mois de juin à dix-sept heures (17h00).

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par

l’administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires repré-
sentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. En cas de démembrement de la propriété des actions, le droit de vote est

exercé conformément à l’article 5 des présents statuts.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

86809

L

U X E M B O U R G

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire

au(x) commissaire(s).

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital

sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la Société de

gestion de Patrimoine Familial et leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
La première assemblée générale annuelle se réunira en 2016.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par  dérogation  à  l'article  7  des  statuts,  le  premier  président  du  conseil  d'administration  est  désigné  par  l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription - Libération

L’intégralité des vingt mille (20.000) actions, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, a été

souscrite par les comparants prénommés, représentés comme dit ci-avant, comme suit:

Madame Ginette Léa FONTINOY, prénommée, souscrit à vingt mille (20.000) actions en nue-propriété;
Monsieur Michel Félicien FONTINOY, prénommé, souscrit à vingt mille (20.000) actions en usufruit.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions

d’euros (EUR 2.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire
instrumentant.

<i>Vérification

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six (26) de la loi du 10 août 1915,

telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 3.100,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale ex-

traordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs de catégorie A:
- Madame Ginette Léa FONTINOY, née le 4 mai 1944 à Lessines, résidant au 9, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen,

Luxembourg,

- Monsieur Michel Félicien FONTINOY, né le 18 juillet 1949 à Durnal, résidant au 9, rue de la Chapelle, L-8017

Strassen, Luxembourg, président du conseil d’administration.

3. A été appelé à la fonction d’administrateur de catégorie B:
- Monsieur Marc AMBROISIEN, né le 8 mars 1962 à Thionville, demeurant professionnellement au 20, boulevard

Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

4. Les mandats des administrateurs se termineront lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2020.

86810

L

U X E M B O U R G

5. La société Fidu-Concept S.à r.l., ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36 avenue Marie Thérèse (R.C.S.

Luxembourg B 0038136) est désignée comme Commissaire aux Comptes en charge de la révision des comptes de la société.
Le mandat du réviseur se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2020.

6. Le siège de la société est fixé au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. VINTER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15257. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015076847/205.
(150088405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Bonativo Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.606.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of April,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet SE, a a European Company (Societas Europaea) with its statutory seat in Berlin, Germany, registered

with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany,
under no. HRB 165662 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany, (hereinafter “Rocket”),

being the holder of twelve thousand five hundred (12,500) common shares and being the holder of six hundred twenty-

five (625) series A1 shares,

here represented by Ms. Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal;

2. TEC Global Invest XII GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws

of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local  court  of  Duisburg  (Amtsgericht  Duisburg),  Germany,  under  no.  HRB  24728,  having  its  business  address  at
Wissollstra.e 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany,

being the holder of two thousand eighty-three (2,083) series A1 shares,
here represented by Ms. Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 191.426 (he-
reinafter “Holtzbrinck”),

being the holder of one thousand forty-two (1,042) series A2 shares and becoming the holder of one thousand forty-one

(1,041) series A2 shares,

here represented by Ms. Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties under 1., 2. and 3. (the “Shareholders”) are the shareholders of Bonativo Global S.à r.l. (the “Company”),

a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 188.606 and incorporated pursuant to a deed of the notary Henri
Hellinckx, residing in Luxembourg, on 1 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 2575 dated 23 September 2014. The articles of association have been amended pursuant to a deed of notary Cosita
Delvaux dated 13 February 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement. The meeting of the Sha-

reholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

86811

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Increase of the Company’s share capital by an amount of one thousand forty-one euros (EUR 1,041) so as to raise it

from its current amount of sixteen thousand two hundred fifty euros (EUR 16,250.00) up to an amount of seventeen thousand
two hundred ninety-one euros (EUR 17,291.00) by issuing one thousand forty-one (1,041) series A2 Shares with a nominal
value of one euro (EUR 1.00) each.

2. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read

as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at seventeen thousand two hundred ninety-one euros (EUR 17,291.00), repre-

sented by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 two thousand seven hundred and eight (2,708) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A1 Shares”), and

5.1.3 two thousand eighty-three (2,083) series A2 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each (hereinafter

"Series A2 Shares"; the Series A1 Shares and the Series A2 Shares jointly also the "Series A Shares")

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association."

3. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

"A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Bonativo Global

S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may

be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

86812

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at seventeen thousand two hundred ninety-one euros (EUR 17,291.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 two thousand seven hundred and eight (2,708) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

(hereinafter "Series A1 Shares"), and

5.1.3  two  thousand  and  eighty-three  (2,083)  series  A2  shares,  with  a  nominal  value  of  one  euro  (EUR  1.00)  each

(hereinafter "Series A2 Shares"; the Series A1 Shares and the Series A2 Shares jointly also the "Series A Shares")

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a "Super Majority") and subject to the provisions of
any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet SE ("Roc-

ket"), the shareholder TEC Global Invest XII GmbH ("TEC") and the shareholder HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS
("Holtzbrinck", jointly with Rocket and TEC the "Investors" and each also an "Investor") to a company affiliated to such
Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct
or indirect shareholders of the respective Investor (each a "Controlled Company"), whereas "Control" or "Controlled" or
"Controlling" shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing
shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a con-
tractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies
of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one
or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation proce-

dures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company,
if the shareholders of the Company hold more than 50% in any surviving legal entity after such transformation procedure.

7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of

first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

86813

L

U X E M B O U R G

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased
shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is

rejected for lack of assets;

8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such

enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration of
redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its share
register and to proceed with the relevant filings required by law.

8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one person;

independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way through
one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.

8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).

Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date

is the date before the redemption resolution.

9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding amounts

including interest.

9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert arbitrator
shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the Company. The
decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company and the
requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the redemption price and
the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption
price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a person

named  by  the  Company  (including  another  shareholder  of  the  Company),  including  also  partial  redemption  or  partial
assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.

11.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also

be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a

86814

L

U X E M B O U R G

shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of
managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

11.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must
state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must
be sent to each shareholder in writing without undue delay.

11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.

Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be

specified in the respective convening notices of meeting.

12.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or registered

letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of notice of
at  least  four  (4)  weeks  for  ordinary  shareholders'  meetings  and  at  least  two  (2)  weeks  for  extraordinary  shareholders'
meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders' meeting is not
counted in the calculation of the period of notice.

12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another shareholder

authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.

12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders'
resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders' meeting (for
purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.

Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders are
only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is no
quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with Article
12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this was
pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.

Art. 16. Shareholders' resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of shareholders

(ii) who also constitute a Super Majority:

16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company; and

16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq. German

Stock Corporation Act (AktG));

16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation in
the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective

86815

L

U X E M B O U R G

status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners;

16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases; and
16.2.4 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and

transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.

16.3 Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold all
the issued shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the "sole manager".

17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or
by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 19 Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-
ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

86816

L

U X E M B O U R G

21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.

21.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board (as defined below) for the legal transactions and

measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and
have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board (as defined below):

21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

21.8.2 future transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other trans-

actions with derivative financial instruments;

21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

21.8.6 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party, excluding,

however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;

21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or
indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent
requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business of
the Company and is at arm's length;

21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options) outside

the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders' agreement, if
any.

21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also required

for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further transactions
and measures requiring the consent of the Advisory Board (as defined below). The Advisory Board (as defined below) may
give its consent also in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

21.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in the
future.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).

22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and
class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and

86817

L

U X E M B O U R G

one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board ("Advisory Board"). It shall consist of four (4) voting members. The

shareholders may by way of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members of the
Advisory Board.

24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous

shareholders' consent.

24.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's respective

appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

24.3.1 two (2) voting members of the Advisory Board, each having two (2) votes, shall be nominated by Rocket in its

sole discretion;

24.3.2  one  (1)  voting  member  of  the  Advisory  Board,  having  one  (1)  vote,  shall  be  nominated  by  TEC  in  its  sole

discretion; and

24.3.3 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by Holtzbrinck in its sole

discretion.

24.4 Each member of the Advisory Board may be represented by another member of the Advisory Board or any other

representative of the respective party. In this case a written proxy must be presented at the respective Advisory Board
meeting. For this purpose, Rocket, TEC and Holtzbrinck are entitled to appoint one substitute member for each Advisory
Board member.

24.5 The Advisory Board may have non-voting members of the Advisory Board as observers.
24.6 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall

be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board, if any, may provide for further
provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with
the simple majority of votes cast. The Advisory Board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar
quarter.

24.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree(s))

in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
of the share capital of the Company.

27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

27.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

86818

L

U X E M B O U R G

27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities
of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with the
provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent per-
mitted by Luxembourg law.

30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

4. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, as well as Mr Rüdiger Trox, regardless of his category,

each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders’ register of the Company.

5. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of Shareholders unanimously takes, and requires

the undersigned notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of Shareholders decides to increase the Company’s share capital by an amount of one thousand

forty-one euros (EUR 1,041) so as to raise it from its current amount of sixteen thousand two hundred fifty euros (EUR
16,250.00) up to an amount of seventeen thousand two hundred ninety-one euros (EUR 17,291.00) by issuing one thousand
forty-one (1,041) Series A2 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

<i>Subscription

The one thousand forty-one (1,041) Series A2 Shares have been duly subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, for

the price of one thousand forty-one euros (EUR 1,041.00).

<i>Payment

The one thousand forty-one (1,041) Series A2 Shares subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, have been entirely

paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand forty-one euros (EUR 1,041.00).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of one thousand forty-one euros (EUR 1,041.00) is entirely allocated to the share capital.

<i>Second resolution

The general meeting of Shareholders resolves to amend article five (5) of the articles of association of the Company so

that it shall now henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at seventeen thousand two hundred ninety-one euros (EUR 17,291.00), repre-

sented by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 two thousand seven hundred and eight (2,708) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A1 Shares”), and

5.1.3  two  thousand  and  eighty-three  (2,083)  series  A2  shares,  with  a  nominal  value  of  one  euro  (EUR  1.00)  each

(hereinafter “Series A2 Shares”; the Series A1 Shares and the Series A2 Shares jointly also the “Series A Shares”).

86819

L

U X E M B O U R G

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

<i>Third resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the Shareholders decide to fully restate the articles of association of the Company

which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Fourth resolution

The general meeting of Shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well

as Mr Rüdiger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders register
of the Company.

<i>Costs and expenses

The  expenses,  costs,  remunerations  or  charges  in  any  form  whatsoever  which  shall  be  borne  by  the  Company  are

estimated at approximately one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and in
case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizigsten April,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet SE, eine europäische Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin,

Deutschland,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts  Charlottenburg,  Deutschland,  unter  der  Nummer  HRB
165662 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),

Inhaberin von zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen und von sechshundertfünfundzwanzig (625) Anteilen

der Serie A1,

hier vertreten durch Fr. Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatrechtlichen Voll-

macht;

2. TEC Global Invest XII GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmä-

ßigem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB
24728, mit Sitz in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland,

Inhaberin von zweitausenddreiundachtzig (2.083) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Fr. Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatrechtlichen Voll-

macht;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend

unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter
der Nummer B 191.426 („Holtzbrinck“), Inhaberin von eintausendzweiundvierzig (1.042) Anteilen der Serie A2 und zu-
künftige

Inhaberin von eintausendeinundvierzig (1.041) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Fr. Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatrechtlichen Voll-

macht.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien unter 1., 2. und 3. (die „Gesellschafter“) sind die Gesellschafter der Bonativo Global S.à r.l. (die „Gesell-

schaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188.606, gegründet am 1. Juli 2014 gemäß einer Urkunde des
Notars Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 23. September 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 2575, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde am 13. Februar 2015 gemäß

86820

L

U X E M B O U R G

einer Urkunde der Notarin Cosita Delvaux geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
veröffentlicht wurde.

Die Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet.

Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende Tages-
ordnung verhandeln:

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von sechzehntausendzweihun-

dertfünfzig Euro (EUR 16.250,00) um einen Betrag von eintausendeinundvierzig Euro (EUR 1.041,00) auf einen Betrag
von siebzehntausendzweihunderteinundneunzig Euro (EUR 17.291,00) durch die Ausgabe von eintausendeinundvierzig
(1.041) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

2. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  siebzehntausendzweihunderteinundneunzig  Euro  (EUR

17.291,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 zweitausendsiebenhundertacht (2.708) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.3 zweitausenddreiundachtzig (2.083) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A2“; die Anteile der Serie A1 und die Anteile der Serie A2 gemeinsam auch die „Anteile der Serie
A“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch

das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

3. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Bonativo Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1  Zweck  der  Gesellschaft  ist  das  Halten  von  Beteiligungen  jeglicher  Art  an  luxemburgischen  und  ausländischen

Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch  Aufnahme  von  Darlehen  in  jeglicher  Form  oder  mittels  Ausgabe  aller  Arten  von  Anleihen,  Wertpapieren  und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sons-
tige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

86821

L

U X E M B O U R G

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  durch  Beschluss  des  Rates  der  Geschäftsführer  im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  siebzehntausendzweihunderteinundneunzig  Euro  (EUR

17.291,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 zweitausendsiebenhundertacht (2.708) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.3 zweitausenddreiundachtzig (2.083) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A2“; die Anteile der Serie A1 und die Anteile der Serie A2 gemeinsam auch die „Anteile der Serie
A“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch

das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten

darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-

gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechtenoder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern
übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung von An-
teilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter

Rocket Internet SE („Rocket“), den Gesellschafter TEC Global Invest XII GmbH („TEC“) und den Gesellschafter HV
Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS („Holtzbrinck“, gemeinschaftlich mit Rocket und TEC die „Investoren“ und jeweils
einzeln ein „Investor“) an eine mit einem solchen Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG);

86822

L

U X E M B O U R G

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen

Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder
indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von diesem
Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert
Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a) die Leitung der
Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten
der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder
indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberech-
tigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere
Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten, welcher

Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen
Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Umwand-

lungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmel-
zung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als
fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikeln 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten

gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters
für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an
Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen
Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile ent-

spricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines

86823

L

U X E M B O U R G

Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.

10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschrif-

ten des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschaf-
terversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der

entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

12.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

12.4  Jeder  Gesellschafter  ist  dazu  berechtigt,  bei  einer  Gesellschafterversammlung  von  einem  anderen  durch  eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mit
einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen  wurden  notariell  beurkundet.  Die  Niederschrift  ist  von  allen  bei  der  Gesellschafterver-

86824

L

U X E M B O U R G

sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals

vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
12.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 15. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.

Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit

der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:

16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft; und 16.1.2 Beschluss hinsichtlich der
Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.

16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;

16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen; und 16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesell-

schaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.

16.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1  Die  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer  geleitet.  Falls  die  Gesellschaft  mehrere  Ge-

schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.

17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1  Der  bzw.  die  Geschäftsführer  werden  durch  die  Gesellschafterversammlung  ernannt,  welche  ihre  Bezüge  und

Amtszeit festlegt.

18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-

86825

L

U X E M B O U R G

sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

19.2  Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem  Amt  ausscheidet,  muss  die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

20.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-

punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der
Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-

ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-

führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der für die
Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

21.2  Sitzungen  des  Rates  der  Geschäftsführer  werden,  falls  vorhanden,  durch  den  Vorsitzenden  des  Rates  der  Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (wie unten definiert) für die unten genannten Rechts-

geschäfte und Maßnahmen im Einklang mit Artikel 24.5. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechts-
geschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des
Beirats (wie unten definiert) genehmigt wurden:

21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transak-

tionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

86826

L

U X E M B O U R G

21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streitwert

von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft

an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen. Als

solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt 15
der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheitsbe-
teiligung  halten.  Die  Zustimmung  gemäß  dieses  Artikels  21.8.7  ist  nicht  erforderlich,  wenn  die  Transaktion  zum
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteilsoder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.

21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,

so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beirats (wie unten definiert) erfordern. Der Beirat (wie unten definiert) kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen
und Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art.  22.  Protokoll  von  Sitzungen  des  Rates  der  Geschäftsführer;  Protokoll  der  Entscheidungen  des  alleinigen  Ge-

schäftsführers.

22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Ver-
treter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine
Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat („Beirat“). Dieser besteht aus vier (4) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-

sellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Beirats erhöhen oder herabsetzen.

24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-

schafter festlegen und/oder verändern.

24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

24.3.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats mit je zwei (2) Stimmen werden von Rocket nach eigenem

Ermessen ernannt;

86827

L

U X E M B O U R G

24.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von TEC nach eigenem Ermessen

ernannt; und 24.3.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von Holtzbrinck nach eigenem
Ermessen ernannt.

24.4 Jedes Mitglied des Beirats kann von jedem anderen Mitglieds des Beirats oder einem Vertreter der jeweiligen Partei

vertreten werden. In diesem Fall muss bei der jeweiligen Sitzung des Beirats eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden.
Zu diesem Zweck sind Rocket, TEC und Holtzbrinck berechtigt, ein Ersatzmitglied für jedes Beiratsmitglied zu ernennen.

24.5 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimmbe-

rechtigtes  Mitglied  ist  der  Vorsitzende  des  Beirats.  Die  Geschäftsordnung  des  Beirats  kann  weitere  Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.

24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der

Gesellschaft.

25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.

25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-

sellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-

klang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

27.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-

falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare  Rücklagen,  beziehungsweise  vermindert  durch  vorgetragene  Verluste  und  Summen,  die  einer  Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

86828

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die

Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Andwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

4. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie

Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit unein-
geschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

5. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag

von sechzehntausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 16.250,00) um einen Betrag von eintausendeinundvierzig Euro (EUR
1.041,00) auf einen Betrag von siebzehntausendzweihunderteinundneunzig Euro (EUR 17.291,00) durch die Ausgabe von
eintausendeinundvierzig (1.041) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die eintausendeinundvierzig (1.041) Anteile der Serie A2 wurden ordnungsgemäß von Holtzbrinck, vorbenannt, zum

Preis von eintausendeinundvierzig Euro (EUR 1.041,00) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Holtzbrinck, vorbenannt, gezeichneten eintausendeinundvierzig (1.041) Anteile der Serie A2 wurden vollstän-

dig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendeinundvierzig Euro (EUR 1.041,00).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde der unterzeichnenden Notarin

erbracht.

Die  Einlage  in  Höhe  von  eintausendeinundvierzig  Euro  (EUR  1.041,00)  wird  vollständig  dem  Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr

wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  siebzehntausendzweihunderteinundneunzig  Euro  (EUR

17.291,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 zweitausendsiebenhundertacht (2.708) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.3 zweitausenddreiundachtzig (2.083) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A2“; die Anteile der Serie A1 und die Anteile der Serie A2 gemeinsam auch die „Anteile der Serie
A“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch

das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

86829

L

U X E M B O U R G

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der

Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-

tegorie, sowie Herrn Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die  Kosten,  Auslagen,  Honorare  und  Gebühren  jeglicher  Art,  die  von  der  Gesellschaft  zu  tragen  sind,  werden  auf

ungefähr eintausendsechshundert Euro (EUR 1.600) geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.

Gezeichnet: X. TANG, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 04 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/13824. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Mai 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015075817/1069.
(150087289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

JCSS Mike S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 196.394.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of April,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

JCSS Super 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of

twelve thousand five hundred one euro (EUR 12,501.-), with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 185115 (the “Shareholder”),

hereby represented by Me Alexandre Koch, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 24 April 2015.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of JCSS

Mike S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed of 22 April 2014, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations and under process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To amend article 10.2 of the articles of association of the Company to allow the taking of written resolutions by the

board of managers of the Company.

86830

L

U X E M B O U R G

2 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to amend article 10.2 of the articles of association of the Company by adding a sixth paragraph

in order to allow the taking of written resolutions by the board of managers of the Company. Said paragraph will read as
follows:

“(vi) A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or
in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois d'avril,
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

JCSS Super 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de

douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-), dont le siège social est au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous le
numéro B 185115 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Maître Alexandre Koch, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 24 avril 2015.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de JCSS Mike S.à r.l., une

société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-), dont le siège social est au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
constituée suivant acte notarié en date du 22 avril 2014, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations et en cours d'immatriculation auprès du Registre du commerce et des Sociétés de Luxembourg (la «Société»). Les
statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Modification de l'article 10.2 des statuts de la Société, afin de permettre la prise de résolutions circulaires par le conseil

de gérance de la Société.

2 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a décidé de modifier l'article 10.2 des statuts de la Société pour y ajouter un sixième paragraphe afin de

permettre la prise de résolutions circulaires par le conseil de gérance de la Société. Ledit paragraphe sera rédigé comme
suit:

"(vi) Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été

adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans
un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants."

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille cent euros (EUR 1.100,-).

86831

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même com-
parante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: A. Koch, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 28 avril 2015. GAC/2015/3606. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 22 mai 2015.

Référence de publication: 2015077006/93.
(150087976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

CASC.EU S.A., Capacity Allocation Service Company.eu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 2, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 142.282.

<i>Extrait de résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 14 avril 2015

<i>Résolution 4

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de reconduire les mandats de tous les administrateurs de la société jusqu'à

l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de l'année 2015.

<i>Résolution 5

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de nommer KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John

F. Kennedy L-1855 Luxembourg comme réviseurs d'entreprises agrée de la société jusqu'à l'assemblée générale qui ap-
prouvera les comptes annuels de l'année 2015.

Pour extrait
<i>Pour la société
M. Corné Meeuwis
<i>Directeur Général

Référence de publication: 2015075851/19.
(150087006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

Société Européenne de Banque, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 13.859.

<i>Dépôt rectificatif du Dépôt n° L150046308 déposé le 12/03/2015.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue le 16 février 2015

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Angelo Caloia donnée en date du 09.12.14, en

qualité de Président du Conseil d'Administration et de la démission de Monsieur Marco Elio Rottigni donnée en date du
31.12.2014, en qualité d'Administrateur. Le Conseil d'Administration décide de nommer en remplacement des adminis-
trateurs démissionnaires, les administrateurs suivants:

- Monsieur Paul HELMINGER, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 55 rue Michel Rodange L-2430,

Président;

- Monsieur Andréa FARAGALLI ZENOBI, employé privé au Piazza della Scalla, 6 - 20121 Milan Italie, Administrateur
Les mandats ainsi conférés expireront à l'assemblée qui approuvera les comptes clôturés au 31.12.2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPENNE DE BANQUE
Société Anonyme

Référence de publication: 2015077371/20.
(150088716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

86832


Document Outline

ArcelorMittal

Axiteam

Bonativo Global S.à r.l.

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch

Caisse Raiffeisen Mersch

Capacity Allocation Service Company.eu S.A.

DAH Real Estates S.à r.l.

DE Investment Group S.à r.l.

Denlux S.à r.l.

DKV Luxembourg S.A.

DONNER &amp; REUSCHEL Luxemburg S.A.

E.EX, Européenne d'Exportation S.A.

Electro Nord S.à.r.l.

Eterlux S.A.

Eurofins Analyses Environnementales pour les Industriels France LUX Holding

Eurofins Environment Testing LUX Holding

Eurofins Hydrologie France LUX Holding

Fahrenheit SICAV-SIF

Fany S.A. SPF

Fiducenter S.A.

Fiduciaire Alpha

Imprimerie Fr. Faber

Initio S.A.

Interalliance S.à r.l.

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

IPA Holding S.A.

Ixxo S.A.

JCSS Mike S.à r.l.

Lux International Cleaning Enterprise S.à r.l.

Noe S.A.

Nostos Holdings Co S.A.

NRRG Invest S.à r.l.

OCM Debtco S.à.r.l.

OCM Luxembourg OPPS VI Blocker S.à r.l.

OCM Luxembourg OPPS VII Blocker S.à r.l.

Op der Gänn SA

Pascatti Luxembourg S.A.

Pole Invest S.A.

Pol Holding S.A.

Société Européenne de Banque

SOF-9 Rome Investments Lux S.à r.l.

SPF 2 Holdco S.à r.l.

Tribel S.A.

Triton Luxembourg GP Efeu Pooling S.C.A.