logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1793

20 juillet 2015

SOMMAIRE

1 Day International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

86061

31 Holding - Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

86062

ADLG S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86025

Alphabet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86024

BE Aerospace Investments Holdings II S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86026

Bio & Bio Licensing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86040

CSCP Credit Acquisition Holdings Luxco Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86019

Donard Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86018

Donard Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86018

ESCE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86018

Eurofoil Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

86018

European Financial Group EFG-S.A.  . . . . . . .

86019

Fürstenberger Siedlung 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

86018

Henkel Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86021

Holly Tree Immobilier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

86021

Horizont Marine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86021

Innovation Arch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86019

Intendance of International Consultants S.à

r.l., intentionally known as the Consultancy,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86020

Investment Opportunities S.à r.l. . . . . . . . . . . .

86020

IPSE Dixit Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86020

Lune Holdings SPF SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86019

Medacta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86023

Mediplan G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86023

Megatouch Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

86019

Mineral5 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86024

Mineral5 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86024

Mineral5 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86025

MIV Greeneden LP Holding SCA  . . . . . . . . . .

86025

Nord Europe Life Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

86025

Quant S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86022

QVC France Holdings, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

86022

RE ENERGY Management S.à r.l.  . . . . . . . . .

86024

R-Holdings 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86022

Rollibo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86051

Royal Body Concept S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

86021

Scylla Conseil S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86050

SEDCO Capital Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

86022

Shine France Pledgeco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

86053

Shire Sweden Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

86023

S.L.Z.A. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86023

Starwood International Licensing Company

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86061

Verizon Business Security Solutions Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86064

Whitecourt S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86051

86017

L

U X E M B O U R G

ESCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3933 Mondercange, 14, rue Kiemel.

R.C.S. Luxembourg B 21.614.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015077716/9.
(150088835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

Donard Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 119.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 26 mai 2015.

Référence de publication: 2015077682/10.
(150088756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

Donard Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 119.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 26 mai 2015.

Référence de publication: 2015077683/10.
(150088757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

Fürstenberger Siedlung 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 182.993.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Fürstenberger Siedlung 3 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015077739/11.
(150089259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

Eurofoil Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R.C.S. Luxembourg B 19.358.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la société Eurofoil Luxembourg S.A. tenue le 24 avril 2015

<i>4 

<i>ème

<i> résolution

L'assemblée décide de réélire à la fonction de commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire

qui se tiendra en 2016:

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator 2182 Luxembourg

Luxembourg, le 24 Avril 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015077702/14.
(150089326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

86018

L

U X E M B O U R G

European Financial Group EFG-S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 51.432.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015077720/9.
(150089243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

Innovation Arch, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 181.642.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015077778/10.
(150088983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

Megatouch Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1131 Luxembourg, 20, rue Antoine.

R.C.S. Luxembourg B 111.112.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015077874/10.
(150088979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

CSCP Credit Acquisition Holdings Luxco Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 151.142.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015078363/12.
(150090309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Lune Holdings SPF SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 161.964.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société tenue le 5 juin 2014 que le

commissaire aux comptes, Monsieur Tamas Mark, a été remplacé par Madame Emmanuelle Bauer résidant profession-
nellement au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, avec effet à partir du 24 juillet 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2015.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015078614/13.
(150089967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

86019

L

U X E M B O U R G

IPSE Dixit Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.346.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 29 avril 2015 il a été décidé:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 20 rue de la Poste L-2346 Luxembourg au 2-8

Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IPSE DIXIT HOLDING S.A.
Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2015078575/14.
(150090341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Investment Opportunities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 196.396.

<i>Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises le 27 mai 2015

L'associé unique de la Société a décidé de nommer la personne suivante:
- Monsieur Rohan Maxwell, né le 11 novembre 1977 à Oldham, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 5,

Via  Nassa,  6900  Lugano,  Suisse,  en  qualité  de  Gérant  de  la  Société  avec  effet  au  26  mai  2015  et  ce  pour  une  durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2015078558/16.
(150089687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Intendance of International Consultants S.à r.l., intentionally known as the Consultancy,, Société à responsabilité

limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 9.632.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 21 mai 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation de la société:

INTENDANCE OF INTERNATIONAL CONSULTANTS S.àr.l, intentionally known as the Consultancy, avec siège

social à L-2324 Luxembourg, 6, Avenue Jean-Pierre Pescatore, de fait inconnue à cette adresse, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.9.632,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg, et a désigné comme liquidateur Maître Karim MAADI, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal invite les créanciers à produire leurs déclarations de créances au greffe Tribunal de commerce avant le 11

juin 2015.

Luxembourg, le 27 mai 2015.

Pour extrait conforme
Maître Karim MAADI
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015078572/24.
(150089796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

86020

L

U X E M B O U R G

Horizont Marine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 89.808.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015078539/9.
(150089701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Holly Tree Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 118.578.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015078538/10.
(150089598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Royal Body Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 193.040.

AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll des Verwaltungsrates vom 02. Januar 2015 hervor dass:
Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von FIDU-CONCEPT Sàrl, mit Sitz in L-2132 Luxemburg, 36, avenue Marie-

Thérèse, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 38136, als
Rechnungskommissar der Gesellschaft Royal Body Concept S.A. an.

Der Verwaltungsrat beschliesst BCB &amp; PARTNERS S.A. mit Sitz zu L-2320 Luxemburg, 68-70, boulevard de la Pé-

trusse, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B83095 als neuer Rechnungskommissar der
Gesellschaft Royal Body Concept S.A. zu ernennen.

Das Mandat läuft bei der ordnungsgemässen Hauptversammlung in 2017 aus.

Für gleichlautenden Auszug

Référence de publication: 2015077276/17.
(150088673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Henkel Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 50.690.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 12 mai 2015

L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs suivants:
- Wolfgang KNAUF,
- Lambert SCHROEDER,
- Ludger STEIN
Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.
L'Assemblée décide de nommer en tant que Réviseur Indépendant de la société KPMG Luxembourg, 39 avenue John

F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2015.

<i>Pour la société HENKEL RE S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2015078527/18.
(150089760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

86021

L

U X E M B O U R G

Quant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 136.613.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour QUANT S.A

Référence de publication: 2015077257/10.
(150087702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

R-Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 158.543.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015077261/10.
(150088245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

QVC France Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 182.351.

En date du 13 mai 2015 l'associé unique de la Société a pris la décision suivante:
- Acceptation de la démission du Monsieur Michael A. George, de ses fonctions de gérant A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

QVC Frange Holdings, S.à r.l.
Jacob Mudde
<i>Gérant B

Référence de publication: 2015077258/14.
(150087969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

SEDCO Capital Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 168.695.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique de la Société que Monsieur Bernard Caralp a été nommé administrateur

de la Société avec effet au 13 octobre 2014 en remplacement de Monsieur Paul Touloumbadjian pour une durée se terminant
à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

Le conseil d'administration est composé dès lors comme suit pour une durée se terminant à l'assemblée générale annuelle

qui se tiendra en 2015:

- Hasan S. Aljabri
- Bernard Caralp, Membre du conseil d'administration, Al Hajarayn Compound, Al Shati District, Jeddah 21573, Arabie

Saoudite

- Yaser S. Binmahfouz.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015076345/20.
(150087151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

86022

L

U X E M B O U R G

Mediplan G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 30.738.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015076188/9.
(150087061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

Medacta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 62.571.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2015.

Référence de publication: 2015076187/10.
(150086905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

S.L.Z.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 182.850.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 20 mai 2015 que le siège social de

la société a été transféré de son ancienne adresse au 10, rue Antoine Jans à L-1820 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2015.

Référence de publication: 2015076312/12.
(150087228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

Shire Sweden Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 175.029.

EXTRAIT

Par résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société en date du 1 

er

 mai 2015:

L'associé a pris connaissance de la démission de Mattias Bankel, demeurant 11D Svärdvägen, SE-18233 Danderyd,

Suède, a de son mandat de gérant de la Société avec effet au 1 

er

 mai 2015.

L'associé a approuvé la nomination de Paul Blanchfield, né le 22 mai 1980 à Danbury, Connecticut aux Etats-Unis

d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 11D Svärdvägen, SE-18233 Danderyd, Suède, est nommé avec effet au

er

 mai 2015, en tant que gérant de la Société, pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est dès lors composé des gérants suivants pour une durée indéterminée:
- M. Richard Lucas;
- M. Fearghas Carruthers; et
- M. Paul Blanchfield.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2015.

<i>Pour la Société
Jonathan Celler

Référence de publication: 2015076320/23.
(150087021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

86023

L

U X E M B O U R G

Mineral5 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 140.758.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015076195/10.
(150086562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

Mineral5 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 140.758.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015076196/10.
(150086937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

RE ENERGY Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.025.

<i>Dépôt rectificatif du dépôt L130218582 déposé en date du 20/12/2013

Veuillez noter qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'orthographe de la dénomination de l'associé Heliopolis Energia

Srl détenant 9.375 parts sociales et qu'il y a lieu de lire et prendre compte l'orthographe suivante:

Luxembourg, le 22 mai 2015.

Heliopolis Energia S.p.A.

Référence de publication: 2015076295/12.
(150087447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

Alphabet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.414.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 27 avril 2015

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à

l'adresse suivante avec effet au 20 mars 2015:

44, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Par ailleurs, le Conseil d'Administration informe que l'adresse de deux de ces administrateurs a également changé avec

effet au 20 mars 2015:

JALYNE S.A., 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par Monsieur Jacques Bonnier, 44, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

PACBO EUROPE Administration et Conseil, 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par Monsieur

Patrice Crochet, 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour copie conforme à l'original
- / JALYNE S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015076518/22.
(150088322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

86024

L

U X E M B O U R G

Mineral5 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 140.758.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015076197/10.
(150086996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

MIV Greeneden LP Holding SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 170.526.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2015.

Référence de publication: 2015076200/10.
(150086752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

Nord Europe Life Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1468 Luxembourg-Kirchberg, 13, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 59.361.

Nous vous informons que Monsieur BERNARD Hervé, Directeur agréé de Nord Europe Life Luxembourg SA, a trans-

féré depuis le 16 janvier 2013 sa résidence principale venant de 5310 Eghezée, Rue du Collège, 14 (Belgique), dans la ville
de 5101 Namur (Erpent) à l'adresse suivante:

Clos des Angéliques des Prés, 7

Luxembourg, le 22 mai 2015.

Nord Europe Life Luxembourg
Hervé BERNARD

Référence de publication: 2015076217/14.
(150086979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

ADLG S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 130.097.

En date du 21 mai 2015, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Michaël Goosse, Gérant, avec effet au 21 mai 2015;
2. Acceptation de la démission de Christophe Gammal, Gérant, avec effet au 21 mai 2015;
3. Nomination de Séverine Lesgardeur, née le 26 juillet 1979 à Libramont, Belgique, dont l'adresse professionnelle se

situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que Gérant, avec effet au 21 mai 2015 et pour une période
illimitée.

Depuis le 21 mai 2015, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- David Harvey, et
- Séverine Lesgardeur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2015.

Certifié conforme et sincère

Référence de publication: 2015076502/20.
(150087887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

86025

L

U X E M B O U R G

BE Aerospace Investments Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 198.443.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen on the thirtieth day of June.
Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

BE Aerospace (UK) Europe Holdings Limited, a limited company incorporated and existing under the laws of England

and Wales, having its registered office at One Silk Street, London, United Kingdom, EC2Y 8HQ, registered with Companies
House under number 06469453 (the «Shareholder»),

here represented by Me Laurence Ouverleaux, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg,

by virtue of a resolution of the directors of the Shareholder taken on June 29, 2015.
The appearing person, represented as stated above, has requested the notary to record that:
I. The Shareholder is the sole shareholder of BE Aerospace Investments Holdings II Ltd., an exempted company in-

corporated with limited liability and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at 190 Elgin
Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands, registered under number 282184, and in the process
of de-registration in the Cayman Islands (the "Company").

II. The issued share capital of the Company is currently fixed at fifty thousand US Dollars (USD 50,000) represented

by five million (5,000,000) shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each, entirely paid-in.

III. The Shareholder, represented as mentioned above, has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken

on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 Acknowledgement of the written resolutions taken by the board of directors of the Company on 29 June 2015 and of

the written resolutions of the Shareholder of the Company taken on 29 June 2015 regarding the transfer of the domicile,
registered office and central administrative seat of the Company without any dissolution from Grand Cayman, Cayman
Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with effect as at the date of the present extraordinary general meeting.

2 Transfer of the domicile, registered office and central administrative seat of the Company without dissolution from

Grand Cayman, Cayman Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as at the date of the present
extraordinary general meeting.

3 Adoption of the Luxembourg nationality and submission of the Company to Luxembourg laws, adoption of the legal

form of a “société à responsabilité limitée” and change of the Company’s name to “BE Aerospace Investments Holdings
II S.à r.l.”.

4 Complete restatement of the Company’s articles of association in order to bring them in conformity with Luxembourg

laws.

5 Confirmation of the closing date of the current financial year of the Company under the laws of the Cayman Island

and of the opening date of the first financial year of the Company under Luxembourg law.

6 Approval of an opening balance sheet of the Company as at 31 May 2015, and of a director’s certificate with respect

to this balance sheet.

7 Acknowledgement that the value of the Company’s assets and liabilities corresponds at least to the Company’s issued

share capital of fifty thousand US Dollars (USD 50,000) represented by five million (5,000,000) shares with a nominal
value of one cent (USD 0.01) each, and subsequently that the Company complies with the Luxembourg statutory require-
ments of the minimum share capital applicable for a société privée à responsabilité limitée.

8 Determination of the address of the registered office in Luxembourg.
9 Setting of the number of Managers of the Company at four (4) and appointment of the following Managers of the

Company for an unlimited duration:

- Mr. Marcus Jacobus DIJKERMAN, born on 5 November 1962 in Schiedam, Netherlands, with professional address

at 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, as Class B Manager; and

- Mr. Joost Anton MEES, born on 27 September 1978 in Delft, Netherlands, with professional address at 48, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg; as Class B Manager.

As a consequence, the Board of Managers of the Company will be composed as follows:
- Mr. James L. BOMAR, born on 8 January 1968 in Miami, Florida, USA with professional address at 1400 Corporate

Center Way, Wellington, Florida 33414, USA, Class A Manager;

86026

L

U X E M B O U R G

- Mr. Werner LIEBERHERR, born on 15 March 1960 in Switzerland with professional address at 1400 Corporate Center

Way, Wellington, Florida 33414, USA, Class A Manager;

- Mr. Marcus Jacobus DIJKERMAN, pre-named, Class B Manager;
- Mr Joost MEES, pre-named, Class B Manager;
10 Setting at one (1) the number of statutory auditor and appointment for a period ending at the annual general meeting

approving the annual accounts of the financial year ending on 31 December 2015:

- Deloitte Audit S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered under number B 067.895.

11 To delegate powers.
IV. The Shareholder, represented as above mentioned, requested the notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to acknowledge the written resolutions of the Shareholder of the Company taken on 29 June

2015 and the written resolutions taken by the board of directors of the Company on 29 June 2015 resolving on the transfer
of the domicile, registered office and central administrative seat of the Company without dissolution from Grand Cayman,
Cayman Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Consequently, the Company will become a Luxembourg domiciled company falling under Luxembourg laws.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to transfer the domicile, registered office and central administrative seat of the Company

without any dissolution from the Cayman Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as at the date
of the present extraordinary general meeting.

<i>Third resolution

The Shareholder resolved that as a consequence of the above transfer, the Company shall adopt the Luxembourg na-

tionality, shall be submitted to the Luxembourg laws and shall adopt the legal form of a “société à responsabilité limitée”.

The Shareholder further resolved that the Company will change its name to “BE Aerospace Investments Holdings II S.à

r.l.”.

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to proceed with a complete restatement of the Company’s articles of association in order to

comply with Luxembourg laws in this respect and that the articles of association of the Company shall henceforth read as
follows:

“Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of In-
corporation”).

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of “BE Aerospace Investments Holdings II S.à r.l.”.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager

(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the

Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of com-
munications  with  such  office  or  between  such  office  and  persons  abroad,  the  Company  may  temporarily  transfer  the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by
the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in

foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

86027

L

U X E M B O U R G

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well

as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by

the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at fifty thousand US Dollars (USD 50,000) represented

by five million (5,000,000) shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles

of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make dis-
tributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst

them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but

the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three
quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several

times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles
of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,

suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the “Manager(s)”).

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).
The  Managers  will  be  appointed  by  the  shareholder(s),  who  will  determine  their  number  and  the  duration  of  their

mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or

class B Managers (the “Class B Managers”).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or

useful for accomplishing the Company’s object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

86028

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or proxies,

or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The  Company  will  be  bound  towards  third  parties  by  the  individual  signature  of  the  sole  Manager  or  by  the  joint

signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom

special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Managers (the “Secretary”).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present
or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days’ written

notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent
of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers

may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding

office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such
quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of

communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary

(if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed

by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the pursuit
of the Company’s corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager,  associate,  member,  shareholder,  officer  or  employee  of  such  other  company  or  firm.  Any  person  related  as

86029

L

U X E M B O U R G

described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers’ Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,

heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company
is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or wilful misconduct. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors
who need not be shareholders themselves.

The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the

number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at
any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory
auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the

Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of
shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders must be held within six (6) months

following the end of the previous financial year. If the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the annual
general meeting of shareholders will be held on 31 May at 11 am. If such day is a day on which banks are not generally
open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five

(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders
are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed
resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the
transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the
general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement
of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a

general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or
the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders repre-
senting more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and,
if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of sha-

reholders.

86030

L

U X E M B O U R G

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as
a proxy holder.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over (i) by the Chairman or, (ii) by a person

designated by the Manager(s) or, (iii) by a person designated by the general meeting of shareholders in case such person
has not been designated by the Manager(s).

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending

the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing
more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the
shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number
of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the

purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to
the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall
be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting

of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2)
Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January of each year and ends on the

last day of December of each year.

Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If

the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half

of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may

be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compen-
sation.

After  payment  of  all  the  debts  of  and  charges  against  the  Company,  including  the  expenses  of  liquidation,  the  net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

86031

L

U X E M B O U R G

Chapter VII. Applicable law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.”

<i>Fifth resolution

The Shareholder resolved that the current financial year of the Company under the laws of the Cayman Islands has ended

on 29 June 2015.

The Shareholder further resolved that the first financial year of the Company under Luxembourg law shall start as at

the date of the present extraordinary general meeting and shall terminate on 31 December 2015, and that any subsequent
financial year shall start on 1 January and end on 31 December of each year.

<i>Sixth resolution

The Shareholder resolved to approve an opening balance sheet of the Company as at 31 May 2015, and a director’s

certificate dated 29 June 2015 with respect to this interim opening balance sheet.

<i>Seventh resolution

The Shareholder resolved to acknowledge that pursuant to the above opening balance sheet and the director’s certificate,

the value of the Company’s assets and liabilities corresponds at least to the Company’s issued share capital of fifty thousand
US Dollars (USD 50,000) represented by five million (5,000,000) shares with a nominal value of one cent (USD 0.01)
each.

<i>Eighth resolution

The Shareholder resolved to fix the address of the registered office of the Company at 48, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Ninth resolution

The Shareholder resolved to set the number of Managers of the Company at four (4) and appointment of the following

Managers of the Company for an unlimited duration:

- Mr. Marcus Jacobus DIJKERMAN, born on 5 November 1962 in Schiedam, Netherlands, with professional address

at 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, as Class B Manager; and

- Mr. Joost Anton MEES, born on 27 September 1978 in Delft, Netherlands, with professional address at 48, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg; as Class B Manager.

As a consequence, the Board of Managers of the Company will be composed as follows:
- Mr. James L. BOMAR, born on 8 January 1968 in Miami, Florida, USA with professional address at 1400 Corporate

Center Way, Wellington, Florida 33414, USA, Class A Manager;

- Mr. Werner LIEBERHERR, born on 15 March 1960 in Switzerland with professional address at 1400 Corporate Center

Way, Wellington, Florida 33414, USA, Class A Manager;

- Mr. Marcus Jacobus DIJKERMAN, pre-named, Class B Manager; and
- Mr. Joost MEES, pre-named, Class B Manager;

<i>Tenth resolution

The Shareholder resolved to set at one (1) the number of statutory auditor and further resolved to appoint the following

for a period ending at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts of the financial year ending
on 31 December 2015:

Deloitte Audit S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 67.895.

<i>Eleventh resolution

The Shareholder resolved to delegate to any manager of the Company, any lawyer at the law firm Walkers, the Cayman

Islands and any lawyer at the law firm Linklaters LLP, Luxembourg, each of them acting individually, all powers to perform
all the formalities and to effect all the registrations and publications in the Cayman Islands and in Luxembourg, for the
purpose of transferring of the domicile, registered office and the central administrative seat of the Company from the
Cayman Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000).

86032

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the proxyholder of the appearing party,

the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder and in case
of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by

his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le trente juin.
Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

BE Aerospace (UK) Europe Holdings Limited, une limited liability company, constituée et existant selon les lois d’An-

gleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au One Silk Street, Londres, Royaume-Unis, EC2Y 8HQ et immatriculée
sous le numéro 06469453 (l’«Associé»),

ici représentée par Maître Laurence Ouverleaux, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes

d'une résolution prise par les directeurs de l’Associé en date du 29 juin 2015.

La personne qui comparaît, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’enregistrer que:
I. L’Associé est le seul et unique associé de BE Aerospace Investments Holdings II Ltd., une société enregistrée et régie

par les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social au 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Iles
Caïmans, enregistrée sous le numéro 282184, et en processus de radiation aux Iles Caïmans (la «Société»).

II. Le capital émis de la Société est actuellement fixé à cinquante mille dollars américains (USD 50.000) représenté par

cinq millions (5.000.000) d’actions d’une valeur nominale d’un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune, entiè-
rement libérées.

III. L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaît avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Constatation des résolutions prises par le conseil d’administration de la Société le 29 juin 2015 et des résolutions de

l’Associé de la Société prises le 29 juin 2015 concernant le transfert du domicile, du siège social et de l’administration
centrale de la Société sans dissolution, de Grand Cayman, Iles Caïmans au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
avec effet à la date de la présente assemblée générale des associés.

2 Transfert du domicile, de siège social et de l’administration centrale de la Société sans dissolution, de Grand Cayman,

Iles Caïmans au Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, avec effet à la date de la présente assemblée générale des
associés.

3 Adoption de la nationalité luxembourgeoise et soumission de la Société aux lois luxembourgeoises, adoption de la

forme légale d’une société à responsabilité limitée et changement du nom de la Société en «BE Aerospace Investments
Holdings II S.à r.l.».

4 Refonte complète des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

5 Confirmation de la date de clôture de l’année financière en cours de la Société sous les lois des Iles Caïmans et de la

date d’ouverture de la première année financière de la Société sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

6 Approbation d’un bilan intermédiaire de la Société en date du 31 mai 2015, et d’un certificat d’administrateur con-

cernant ce bilan.

7 Constatation du fait que la valeur de l’actif et du passif de la Société correspond au moins au capital social émis de la

Société, à savoir cinquante mille dollars américains (USD 50.000) représenté par cinq millions (5.000.000) de parts sociales
d’une valeur nominale d’un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune, et par conséquent, que la Société est en
conformité avec les exigences réglementaires du Luxembourg concernant le capital social minimum applicable à une société
à responsabilité limitée.

8 Fixation de l’adresse du siège social de la Société au Luxembourg.
9 Fixation du nombre de Gérants de la Société à quatre (4) et nomination des Gérants de la Société suivant pour une

durée illimitée:

- Monsieur Marcus Jacobus DIJKERMAN, né le 5 novembre 1962 à Schiedam, Pays-Bas, ayant son adresse profes-

sionnelle  au  48,  Boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  L-1330  Luxembourg,  Grand-Duché  du  Luxembourg  comme
Gérant de Catégorie B; et

- Monsieur Joost Anton MEES, né le 27 septembre 1978 à Delft, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 48,

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg comme Gérant de Catégorie
B.

86033

L

U X E M B O U R G

Le Conseil de Gérance se compose, par conséquent comme suit:
- Monsieur James L. BOMAR, né le 8 janvier 1968 à Miami, Floride, Etats-Unis ayant son adresse professionnelle au

1400 Corporate Center Way, Wellington, Floride 33414, Etats-Unis d’Amérique, Gérant de Catégorie A;

- Monsieur Werner LIEBERHERR né le 15 mars 1960 en Suisse ayant son adresse professionnelle au 1400 Corporate

Center Way, Wellington, Floride 33414, Etats-Unis d’Amérique, Gérant de Catégorie A;

- Monsieur Marcus Jacobus DIJKERMAN, précité, Gérant de Catégorie B; et
- Monsieur Joost Anton MEES, précité. Gérant de Catégorie B.
10 Fixation à un (1) du nombre d’auditeur statutaire et nomination pour une période se terminant à l’assemblée générale

annuelle approuvant les comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2015:

- Deloitte Audit S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, avant

son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée sous le numéro
B 67.895.

11 Délégation de pouvoirs.
IV. L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé a décidé de constater les résolutions de l’Associé de la Société prises le 29 juin 2015 et les résolutions prises

par le conseil d’administration de la Société le 29 juin 2015 qui prévoient de transférer le domicile, le siège social et de
l’administration centrale de la Société sans dissolution, de Grand Cayman, Iles Caïmans au Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg.

Par conséquent, la Société sera une société domiciliée au Luxembourg, régie par les lois du Grand-Duché du Luxem-

bourg.

<i>Deuxième résolution

L’Associé a décidé de transférer le domicile, le siège social et de l’administration centrale de la Société sans dissolution,

de Grand Cayman, Iles Caïmans au Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, avec effet à la date de la présente as-
semblée générale des associés.

<i>Troisième résolution

L’Associé a décidé, qu’en conséquence du transfert ci-dessus, la Société adopte la nationalité luxembourgeoise, se

soumet aux lois luxembourgeoises et adopte la forme légale d’une société à responsabilité limitée.

L’Associé a ensuite décidé que la Société changera son nom en «BE Aerospace Investments Holdings II S.à r.l.».

<i>Quatrième résolution

L’Associé a décidé de procéder à une refonte totale des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec le

droit luxembourgeois.

L’Associé a décidé que les statuts de la Société seront dorénavant rédigés comme suit:

«Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la

limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «BE Aerospace Investments Holdings II S.à r.l.».

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des  succursales  ou  d’autres  bureaux  peuvent  être  établis  soit  au  Grand-Duché  de  Luxembourg  ou  à  l’étranger  par

décision des Gérants.

Dans l’hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social

sont de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures pro-
visoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera
régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et

entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

86034

L

U X E M B O U R G

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés

sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d’entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société
fait partie.

La Société peut également investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier

ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission privée d’obligations, de billets à

ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d’actions.

D’une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu’elle estime

utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l’article 29 des Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à cinquante mille dollars américains (USD 50.000) représenté

par cinq millions (5.000.000) de parts sociales d’une valeur nominale d’un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune,
celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d’émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d’émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou

non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu’un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales

ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.

La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n’est

opposable à la Société ou aux tiers qu’après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à
l’article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d’une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement

adoptées par les associés.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou

plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou,
le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Décès, Suspension des droits civils, Faillite ou Insolvabilité d’un Associé. L’incapacité, le décès, la

suspension des droits civils, la faillite, l’insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un associé n’entraîne pas
la mise en liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérants, Commissaires

Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin d’être associés (les

«Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants

peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou Gérants

de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

Les associés ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société.

86035

L

U X E M B O U R G

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la

compétence des Gérants.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des

mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe

de deux Gérants si plus d’un Gérant a été nommé.

Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne

sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l’hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes

s’appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un

secrétaire qui n’a pas besoin d’être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de
Gérance (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée

si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera

un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation écrite devra

être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit. La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu
de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un
accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise
pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de
Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra

déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout

moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant
peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est

présente ou représentée, sous réserve que dans l’hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie B
ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont
présents ou représentés.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre

moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée

à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire

(s’il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,

pourront être signés par le Gérant unique ou par deux (2) Gérants agissant conjointement si plus d’un Gérant a été nommé.

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l’approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une ré-

munération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu’ils auront exposées
en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l’objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d’Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de

la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote
sur une telle transaction.

Dans l’hypothèse d’un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

86036

L

U X E M B O U R G

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l’opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le

simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la
manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d'affaires,  ne  devra  pas  en  raison  de  cette  affiliation  à  cette  société  ou  entreprise,  être  automatiquement  empêchée  de
délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,

dans l’exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l’accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs,

leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu’ils ont à payer et tous frais
raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des
procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant(s),
de fondé de pouvoir ou d’employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur
responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion intentionnelle. En cas d'arrangement transactionnel,
l’indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la
Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’est pas coupable de négligence
grave ou mauvaise gestion intentionnelle. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d’autres droits auxquels les personnes
susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

Art. 17. Commissaires. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la

Société doivent être vérifiés par un réviseur d’entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en
particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs
commissaires qui n’ont pas besoin d’être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d’entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermi-

neront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d’entreprises agréé peut seulement, par
dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d’un commun accord.

Chapitre IV. Des associés

Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la

Société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l’assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des associés.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés doit se tenir dans les

six (6) mois suivant la clôture de l’année financière. Au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, l’assemblée
générale annuelle des associés aura lieu le 31 mai à 11 heures. Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable
à Luxembourg, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,

les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou
plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont
été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze (15)
jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d’exprimer leur vote par écrit en le retournant à
la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit. Les exigences de quorum et de
majorité imposées pour l’adoption de résolutions par l’assemblée générale s’applique mutatis mutandis à l’adoption de
résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social

de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l’étranger, chaque fois que des
circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent aussi

se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire (s’il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la
moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale ainsi que l’ordre du

jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des associés. L’ordre du jour d’une assemblée générale
d’associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.

86037

L

U X E M B O U R G

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s’ils déclarent avoir été dûment

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée

générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte

écrit, un mandataire qui n’a pas besoin d’être lui-même associé.

Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par (i) le Président ou, (ii) par une personne

désignée par le ou les Gérants, ou, (iii) par une personne désignée par l’assemblée générale des associés dans le cas où une
telle personne n’a pas été désignée par le ou les Gérants.

Le Président de l’assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l’assemblée générale des

associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale.

Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu’une assemblée générale convoquée en vue de la

modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et
de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus
de la moitié (1/2) du capital social.

Si cette majorité n’est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau

convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts
sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modi-

fication des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de
majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Art. 25. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et

peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d’associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l’associé unique seront établies par écrit et signées par l’associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées

générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant con-
jointement dès lors que plus d’un Gérant aura été nommé.

Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 26. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et s’achève le dernier

jour de décembre de chaque année.

Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants

dressent l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si

la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires
qui précèdent l’assemblée générale annuelle des associés.

Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%)

qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils

peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau
ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d’émission, aux associés, chaque
part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions (s’il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants

peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que
la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant

les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une

personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

86038

L

U X E M B O U R G

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation

sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les
règles relatives à la distribution de dividendes.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois,

en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Cinquième résolution

L’Associé a décidé que l’année sociale en cours de la Société sous les lois des Iles Caïmans se termine le 29 juin 2015.
L’Associé a décidé que la première année sociale de la Société sous les lois Luxembourgeoises, débutera à la date de

la présente assemblée générale des associés et se terminera le 31 décembre 2015 et que toute année sociale suivante débutera
le 1 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

<i>Sixième résolution

L’Associé a décidé d’approuver un bilan intermédiaire de la Société au 31 mai 2015, et un certificat d’administrateur

en date du 29 juin 2015 concernant ce bilan.

<i>Septième résolution

L’Associé a constaté qu’en vertu du bilan intermédiaire et du certificat d’administrateur susmentionnés, la valeur de

l’actif et du passif de la Société correspond au moins au capital social émis de la Société d’un montant de cinquante mille
dollars américains (USD 50.000) représenté par cinq millions (5.000.000) de parts sociales d’une valeur nominale d’un
centime de dollar américain (USD 0,01) chacune, et par conséqu00ent, que la Société est en conformité avec les exigences
réglementaires du Luxembourg concernant le capital social minimum applicable à une société à responsabilité limitée.

<i>Huitième résolution

L’Associé a décidé de fixer l’adresse du siège social de la Société au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330

Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Neuvième résolution

L’Associé a décidé de fixer le nombre de gérants de la Société à quatre (4) et nomination des Gérants de la Société

suivant pour une durée illimitée:

- Monsieur Marcus Jacobus DIJKERMAN, né le 5 novembre 1962 à Schiedam, Pays-Bas, ayant son adresse profes-

sionnelle au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg comme Gérant
de Catégorie B; et

- Monsieur Joost Anton MEES, né le 27 septembre 1978 à Delft, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 48,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg comme Gérant de Catégorie
B.

Le Conseil de Gérance se compose, par conséquent comme suit:
- Monsieur James L. BOMAR, né le 8 janvier 1968 à Miami, Floride, Etats-Unis ayant son adresse professionnelle au

1400 Corporate Center Way, Wellington, Floride 33414, Etats-Unis d’Amérique, Gérant de Catégorie A;

- Monsieur Werner LIEBERHERR, né le 15 mars 1960 en Suisse ayant son adresse professionnelle au 1400 Corporate

Center Way, Wellington, Floride 33414, Etats-Unis d’Amérique, Gérant de Catégorie A;

- Monsieur Marcus Jacobus DIJKERMAN, précité, Gérant de Catégorie B; et
- Monsieur Joost Anton MEES, précité, Gérant de Catégorie B.

<i>Dixième résolution

L’Associé a décidé de fixer à un (1) le nombre de commissaire et de nommer le commissaire suivant pour une période

se terminant à l’approbation lors de l’assemblée générale des actionnaires des comptes annuels de l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2015:

Deloitte Audit, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège

social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895.

<i>Onzième résolution

L’Associé a décidé de déléguer à tout gérant de la Société, à tout avocat du cabinet Walkers, Iles Caïmans et à n’importe

quel avocat du cabinet Linklaters LLP, Luxembourg, chacun agissant individuellement, tout pouvoir pour procéder à toutes
les formalités et pour effectuer toutes les enregistrements et publications aux Iles Caïmans ou au Luxembourg, dans le but
de transférer le domicile, le siège social et l’administration centrale de la Société des Iles Caïmans au Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg.

86039

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à sept mille euros (EUR 7.000).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire

de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande
du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: L. Ouverleaux, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 7 juillet 2015. GAC/2015/5726. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 15 juillet 2015.

Référence de publication: 2015117776/776.
(150127525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Bio &amp; Bio Licensing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 77.323.

Dépôt complémentaire au dépôt référence L150124367 du 15 juillet 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Zur Vorlage gemäß § 148 (Paragraph einhundertachtundvier-zig) Absatz 1 (eins) Aktiengesetz an das Handelsgericht

Wien.

Beurkundung
Ich bestätige, daß bei dem vorstehenden Wortlaut der Satzung der Bio-Products &amp; Bio-Engineering Aktiengesellschaft

mit dem Sitz in Wien die geänderten Bestimmungen derselben mit dem vom öffentlichen Notar Doktor Georg Weißmann
mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt zur Geschäftszahl: 18.239 beurkundeten Beschluß über die Änderung der Satzung
und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt beim Firmenbuch eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung
übereinstimmen.

Wien, am 16. (sechzehnten) September 1997 (neunzehnhundert-siebenundneunzig).

Dr. Christoph Bieber / Dr. Georg Weißmann
<i>Als Substitut des öffentlichen Notars / Mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt

Aide Nr

Schulzrecht Land

Inhaberwortlaut

Kutzlitel

5208

PAT

EP

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208AT

PAT

AT

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208BE

PAT

BE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208CH

PAT

CH

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208DE

DE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208DK

PAT

DK

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208ES

PAT

ES

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208FI

PAT

FI

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208FR

PAT

FR

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208GB

PAT

GB

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208IT

PAT

IT

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208NL

PAT

NL

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5208SE

PAT

SE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5209

PAT

CA

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicament for topical application

5210

PAT

HU

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5212

PAT

MX

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicament for topical application

5213

PAT

NO

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicament for topical application

5581

PAT

EP

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

7616

PAT

EP

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

86040

L

U X E M B O U R G

7817

PAT

RS

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7816

PAT

US

Bio &amp; Bio Licensing SA

Pharmaceutically active substance preparations

7821

PAT

US

Bio &amp; Bio Licensing SA

Pharmaceutical prepartations and medicines

8220

PAT

EP

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabilies therapeutisches Fibrinogen

8221

PAT

US

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stable Therapeutic Preinins

13289

PAT

EP

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products for the Treatment of Blood

7816DK

PAT

DK

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7816AT

PAT

AT

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7816CH

PAT

CH

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7816CZ

PAT

CZ

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7916DE

PAT

DE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7816ES

PAT

ES

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7816FI

PAT

FI

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7818FR

PAT

FR

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenererfahige und thrombinhällige

7818GB

PAT

GB

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7818HU

PAT

HU

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7818IE

PAT

IE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

T818IT

PAT

IT

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7816NL

PAT

NL

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

7616BE

PAT

BE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Thrombingenerlerfahige und thrombinhallige

8220AT

PAT

AT

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

8220BE

PAT

BE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

8220CH

PAT

CH

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

B220CZ

PAT

CZ

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

8220DE

PAT

DE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

6220DK

PAT

DK

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

6220ES

PAT

ES

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

8220FI

PAT

FI

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

8220FR

PAT

FR

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

8220GB

PAT

GB

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

8220HU

PAT

HU

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

8220IT

PAT

IT

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

8220NL

PAT

NL

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

B220SE

PAT

SE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Stabiles therapeutisches Fibrinogen

14774

PAT

CA

Bio &amp; Bio Licensing SA

Storage-slable fibrinogen

14775

PAT

EP

Bio &amp; Bio Licensing SA

Storage-slablo fibrinogen

14776

PAT

US

Bio &amp; Bio Licensing SA

Storage-slablo fibrinogen

5581FI

PAT

FI

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5581FR

PAT

FR

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5581GB

PAT

GB

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5581AT

PAT

AT

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5581DE

PAT

DE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5581DK

PAT

DK

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5581ES

PAT

ES

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5581IT

PAT

IT

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

15259A

PAT

US

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254A

PAT

EP

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254AT

PAT

AT

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

I5254BE

PAT

BE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254CH

PAT

CH

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254CZ

PAT

CZ

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254DE

PAT

DE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254DK

PAT

DK

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254ES

PAT

ES

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254FR

PAT

FR

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

86041

L

U X E M B O U R G

15254GB

PAT

GB

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

152S4HR

PAT

HR

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254HU

PAT

HU

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254IE

PAT

IE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254IT

PAT

IT

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254LU

PAT

LU

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15259

PAT

US

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15252

PAT

AU

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15253

PAT

CA

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254

PAT

EP

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15258

PAT

MX

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15257

PAT

RU

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

55818BE

PAT

BE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5581CH

PAT

CH

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5581NL

PAT

NL

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

5581SE

PAT

SE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Arzneimittel zur lokalen Anwendung

15254FI

PAT

FI

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254SE

PAT

SE

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254NL

PAT

NL

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

15254TR

PAT

TR

Bio &amp; Bio Licensing SA

Medicinal Products tor the Treatment of Blood

Anmalde-Nr.

Anmalde-Nr

Schutzrecht-Nr.

Datum Erteilung

Zustand

00938524.8

19.05.2000

1 183 043

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

E 283575

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

1 183 043

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

1 183 043

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

500 05 999.3-08

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

1 183 043

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

1 183 043

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

1 183.043

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

1 183 043

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

1 183.043

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

27305BE/2004

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

1 183 043

07.04.2004

E

00938524.8

19.05.2000

1 183 043

07.04.2004

E

2.372.929

19.05.2000

2.372.929

15.11.2011

E

P 02 00858

19.05.2000

228 018

24.01.2008

E

PA/A/2001/011859

19.05.2000

226485

14.08.2005

E

20015510

19.05.2000

329232

20.09.2010

E

020158812

19.05.2000

1 275 397

08.08.2014

E

03770983.9

21.07.2003

1 528 030

15.04.2009

E

P.0052/05

21.07.2003

52080

07.03.2012

E

11/040.891

21.07.2003

7.371.722

13.05.2008

E

11/041.165

23.07.2003

7.494.971

24.02.2009

E

03781990.1

18.12.2003

1 572 229

30.04.2014

E

11/155.418

18.12.2003

7,795,399

14.09.2010

E

09450173.1

16.09.2009

S

03770083.9

21.07.2003

1 526.930

15.04.2009

E

03770983.9

21.07.2003

E 4284 40

15.04.2009

E

03770983.8

21.07.2003

1 528 930

15.04.2009

E

03770983.9

21.07.2003

1 528 930

15.04.2009

E

03770983.9

21.07.2003

503114227-08

15.04.2009

E

03770983.9

21.07.2003

1 528 830

15.04.2009

E

03770083.9

21.07.2003

1 528.930

15.04.2009

E

03770983.5

21.07.2003

1 528 930

15.04.2009

E

03770983.9

21.07.2003

1 528 930

15.04.2009

E

86042

L

U X E M B O U R G

03770983.9

21.07.2003

E008470

16.04.2008

E

03770983.9

21.07.2003

1 528 930

15.04.2009

E

03770983.9

21.07.2003

258788E/2009

15.04.2009

E

03770963.9

21.07.2003

1 528 030

15.04.2009

E

03770983.9

21.07.2003

1 528 930

15.04.2009

E

03781990.1

18.12.2003

E 684943

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

1 572 229

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

1 572 229

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

1572229

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

3 0315 039 8

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

1 572 229

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

1 572 229

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

1 572 229

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

1 572 229

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

1 572 229

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

E020983

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

2523585/2014

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

1 572 229

30.04.2014

E

03781990.1

18.12.2003

1 572 229

30.04.2014

E

2.728.358

22.06.2009

S

09768601.6

22.06.2009

S

13/000,934

22.06.2009

8.741.846

06.08.2014

E

02015881.2

19.05.2000

1.275.397

06.08.2014

E

02015881.2

19.05.2000

1 275 397

06.08.2014

E

02015881.2

19.05.2000

1 275.397

06.08.2014

E

02015881.2

19.05.2000

E 660863

06.08.2014

E

02015881.2

19.05.2000

500 16 3820

06.06.2014

E

02015881.2

19.05.2000

1 275 387

08.08.2014

E

02015881.2

19.05.2000

1 275 397

06.08.2014

E

02015881.2

19.05.2000

28003BE/2014

06.08.2014

E

14/336.906

16.09.2010

S

14191080.2

16.09.2010

S

10759797.3

16.09.2010

E703988

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

2 348 527

31.12.2014

E

10759797.3

16.092010

2 348 527

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

2 346 527

31.12.2014

E

10759797.3

16.08.2010

60 2010 021 457.5

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

2 348 527

31.12.2014

E

10759797.3

16 09.2010

2 346 527

31.12.2014

E

10759797.3

16.08.2010

2 346 527

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

2 346 527

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

P20150161

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

2.346 527

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

2 346.527

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

2.346 527

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

2 346 527

31.12.2014

E

13/254.451

16.09.2010

8.889.624

18.11.2014

E

2010295217

18.09.2010

S

2.748.115

16.09.2010

S

10759797.3

18.09.2010

2 348 527

31.12.2014

E

Mx/a/2011/005789

16.09.2010

310044

30.05.2013

E

2011121681

16.09.2010

S

02015881.2

19.05.2000

1 275 397

06.08.2014

E

02015661.2

19.05.2000

1 275 397

06.08.2014

E

02015881.2

19.05.2000

1 275 397

06.08.2014

E

86043

L

U X E M B O U R G

02015861.2

19.05.2000

1 275 397

06.08.2014

E

10759797.3

16.09.2010

2 348.527

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

2 346 527

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

2 346 527

31.12.2014

E

10759797.3

16.09.2010

TR 2015 00444 T4

31.12.2014

E

<i>Comptes annuels aux 31 décembre 2014 et 2013

<i>Bilans au 31 décembre 2014 et 2013

<i>(Montants exprimés en EUR)

ACTIF

31/12/2014

31/12/2013

ACTIF IMMOBILISE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.673.772,94 31.563.233,17
Immobilisations incoporelles (Note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.673.772,94 31.563.233,17
ACTIF CIRCULANT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.669,22

40.777,71

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.061,59

19.029,27

Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.061,59

19.029,27

Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.607,63

21.748,44

COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.345,21

3.345,21

TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.717.787,37 31.607.356,09
PASSIF
CAPITAUX PROPRES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7.002.417,49) (5.630.585,22)
Capital souscrit (Note 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.000,00

4.000.000,00

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9.630.585,22) (8.430.325,12)
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.371.832,27) (1.200.260,10)
DETTES NON SUBORDONNEES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.720.204,86 37.237.941,31
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366.084,62

155.490,00

dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.354.120,24 37.082.451,31
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.717.787,37 31.607.356,09

<i>Comptes de profits et pertes pour la période se terminant au 31 décembre 2014

<i>(montants exprimés en EUR)

CHARGES:

2014

2013

Charges brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.690,32

45.027,21

Intérêts et autres charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.455.861,08 1.337.194,94
Autres intérêts et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.455.861,08 1.337.194,94
Impôts sur le résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.400,00

21.400,00

Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62,00

62,00

1.556.013,40 1.403.684,15

PRODUITS:
Autres intérêts et produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184.181,13

203.424,05

Autres intérêts et produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184.181,13

203.424,05

Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.371.832,27 1.200.260,10

1.556.013,40 1.403.684,15

Annexe aux 31 décembre 2014 et 2013

(Montants exprimés en EUR)

Note 1. Généralités. BIO &amp; BIO LICENSING S.A. (la Société) a été constituée en date du 10 août 2000 pour une durée

illimitée. La Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés B No 77.323 et son siège est établi à
Luxembourg.

La Société a pour objet toutes les opérations se rapportent directement ou indirectement à la prise de participations sous

quelque forme que ce soit dans toutes entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur

86044

L

U X E M B O U R G

ces affaires et brevets, assurer la gestion d'un portefeuille brevets et de droits de propriété intellectuelle (copyrights, tra-
demarkts, etc..) au niveau national et international par la concession de licences ou de sous-licences, accorder aux sociétés
auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se

rattachent à son objet ou qui te favorisent

La Société tient ses comptes en Euro et son exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Note 2. Principes, Règles et principales méthodes comptables.
a) Règles d'évaluation
Les comptes sont établis suivant les principes généraux d'évaluation prévus aux articles 51 et 52 de la loi modifiée du

19 décembre 2002, à savoir.

- la société est présumée continuer ses activités;
- les modes d'évaluation ne sont pas modifiés d'un exercice à l'autre;
- le principe de prudence est respecté, c'est-à-dire:
* seuls les bénéfices réalisés sont pris en considération,
* il est tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance avant la date de clôture

de l'exercice,

* ii est tenu compte de toutes les dépréciations indépendamment du résultat,
- tous les produite et charges se rapportant à l'exercice sont enregistrés;
- les différents éléments des postes d'actif et de passif sont évalués séparément;
- te bilan d'ouverture correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent;
- l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels est basée sur le principe du prix d'acquisition ou du coût de

revient

b) Immobilisations Incorporelles
La société comptabilise ses immobilisations incorporelles au coût d'acquisition. Les brevets ainsi que les acomptes versés

sont portés à l'actif du bilan. Les corrections de valeur sont effectuées lorsque les brevets sont enregistrés et lorsqu'ils ont
obtenus toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir les utiliser. Les corrections de valeur sont pratiquées sur la durée
usuelle d'utilisation des brevets.

c) Créances
Les créances de l'actif circulant sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur estimée à la date de clôture est

inférieure à la valeur nominale, une correction de valeur est pratiquée.

d) Conversion des comptes en devisas étrangères
Les transactions effectuées durant l'année dans une devise autre que la devise du bilan sont converties dans la devise du

bilan aux cours de change en vigueur à la date de transaction.

A la date de clôture du bilan:
- le prix d'acquisition des titres de participation inclus dans les immobilisations financières et les valeurs mobilières

exprimé dans une autre devise que la devise du bilan, reste converti au cours de change historique;

- les avoirs et dettes bancaires, exprimés dans une autre devise que celle du bilan, sont valorisés au cours de change en

vigueur à la date de clôture du bilan; tous les autres postes de l'actif, exprimés dans une autre devise que la devise du bilan,
sont évalués individuellement au plus bas de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur
base du cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan;

- tous les autres postes de passif, exprimés dans une autre devise que la devise du bilan, sont évalués individuellement

au plus haut de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en
vigueur à la date de clôture du bilan.

Ainsi seuls sont comptabilisés dans les comptes de profits et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et les pertes

de change non réalisées.

Note 3. Immobilisations incorporelles. Durant l'exercice l'évolution des immobilisations incorporelles a été comme suit:

31.12.2014

(EUR)

31.12.2013

(EUR)

a) Brevets
Prix d'acquisition au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.563.233,17 27.534.600.44
Entrées au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.110.539,77

4.028.632,73

Sorties au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0.00

Prix d'acquisition à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.673.772,94 31.563.233,17
b) Corrections de valeur sur brevets
Corrections de valeur au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

86045

L

U X E M B O U R G

Dotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Reprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Corrections de valeur à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Valeur nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.673.772,94 31.563.233,17

Note 4. Capital souscrit. Au 31 décembre 2014, le capital souscrit s'élève à EUR 4.000.000 et est représenté par 40.000

actions de valeur nominale EUR 100 chacune entièrement libérées.

Note 53. Emprunts obligataires non convertibles. Au 31 décembre 2005 la société a émis deux emprunts obligataires

non convertibles entièrements souscrits :

a) CHF 1.000.000 à 4,5% jusqu'au 31 décembre 2015
b) EUR 9.000.000 à 5% jusqu'au 31 décembre 2015
Le 16 octobre 2006 la société a émis un emprunt obligataire non convertible entièrement souscrit pour EUR 2.650.000

à 5% à échéance au 17 octobre 2016.

Le 31 juillet 2008 la société a émis un emprunt obligataire non convertible entièrement souscrit pour EUR 2.055.000 à

5% à échéance au 1 

er

 août 2018.

Le 30 juillet 2009 la société a émis un emprunt obligataire non convertible entièrement souscrit pour EUR 3.450.000 à

5% à échéance au 1 

er

 août 2019.

Le 3 juillet 2010 la société a émis un emprunt obligataire non convertible entièrement souscrit pour EUR 2.530.000 à

3,75% à échéance au 2 juillet 2020.

Le 21 décembre 2011 la société a émis un emprunt obligataire non convertible entièrement souscrit pour EUR 2.600.000

à 3,00% à échéance au 20 décembre 2021.

Le 12 septembre 2012 la société a émis un emprunt obligataire non convertible entièrement souscrit pour EUR 1.600.000

à 3,00% à échéance au 11 septembre 2022.

Le 29 mai 2013 la société a émis un emprunt obligataire non convertible entièrement souscrit pour EUR 2.300.000 à

2,00% à échéance au 28 mai 2023.

Le 30 septembre 2013 la société a émis un emprunt obligataire non convertible entièrement souscrit pour EUR 3.000.000

à 2,00% à échéance au 29 septembre 2023.

Le 31 mars 2014 la société a émis un emprunt obligataire non convertible entièrement souscrit pour EUR 3.000.000 à

2,00% à échéance au 30 mars 2024.

Note 6. Réserve légale. Conformément à la loi luxembourgeoise, 5% du bénéfice de l'exercice doivent être affectés à

une réserve légale jusqu'au moment où cette réserve atteint 10% du capital. Cette réserve n'est pas disponible pour des
distributions de dividendes.

<i>Actif au 31 décembre 2014

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Brevets
Arzneimittel zur lokalen Anwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.294.286,93
Thrombin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.157.229,12
Stabile Therapeutische Proteine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.111.445,24
Lagerstabiles funktionell intaktes fibrinogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.600.368,50
Intrinsinc Pathway Activator Complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.510.443,15
Multi Staphylokokken antigen Impfstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000,00 34.673.772,94

ACTIF CIRCULANT

Créances dont la durée résiduelle est Inférieure ou égale à an an
TVA à récupérer 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.061,59

Avoirs en banques
Ubi Banca International EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.521,54

Ubi Banca International CHF 103,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86,09

37.607,63

Comptes de régularisation
DS Corporation N° 14-08/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.824,66

DS Corporation N° 14-08/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.520,55

3.345,21

<i>Passif au 31 décembre 2014

DETTES NON SUBORDONNEES

Dont la dorée résiduelle est inférieure ou égale à un an

86046

L

U X E M B O U R G

Dette sur achats et prestations de services
Schwarz &amp; Partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.634,62

Honoraires DS Corporation -cion supplémentaire 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000,00

DS corporation - mise en conformité avec la loi du 28/07/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.150,00

Honoraires de comptabilité 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.300,00

36.084,62

Dettes envers des entreprises liées
Dettes diverses (Bio-products and Bio-engineering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.000,00

Dettes diverses (Bio-products and Bio-engineering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260.000,00

330.000,00
366.084,62

DETTES NON SUBORDONNEES

Dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Emprunts obligataires non convertibles
Emprunt obligataire 4,5% CHF 1.000.000 ech 30/12/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

831.693,51

Emprunt obligataire 5% EUR échéance 30/12/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000.000,00
Emprunt obligataire 5% EUR échéance 17/10/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.650.000,00
Emprunt obligataire 5% EUR échéance 01/08/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.055.000,00
Emprunt obligataire 5% EUR échéance 01/08/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.450.000,00
Emprunt obligataire 3,75% EUR échéance 02/07/2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.530.000,00
Emprunt obligataire 3,00% EUR échéance 20/12/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600.000,00
Emprunt obligataire 3,00% EUR échéance 11/09/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000,00
Emprunt obligataire 2,00% EUR échéance 28/05/2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300.000,00
Emprunt obligataire 2,00% EUR échéance 29/09/2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000,00
Emprunt obligataire 2,00% EUR échéance 30/03/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000.00 33.016.693,51
Intérêts sur emprunt obligataires
Intérêts sur emprunt obligataire CHF 486.097,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

404.284,23

Intérêts sur emprunt obligataire EUR

7.658.053,11

Intérêts prorata sur EO du 17/10/14 au 31/12/14
2.650.000*5%*75/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.226,03

Intérêts prorata sur EO du 01/08/14 au 31/12/14
2.055.000*5%*155/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.633,56

Intérêts prorata sur EO du 02/07/14 au 31/12/14
3.450.000*5%*155/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.253,42

Intérêts prorata sur EO du 03/07/14 au 31/12/14
2.530.000*3,75%* 181/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.047,60

Intérêts prorata sur EO du 21/12/14 au 31/12/14
2.600.000*3,00%*10/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.136,99

Intérêts prorata sur EO du 12/09/14 au 31/12/14
2.600.000*3,00%*110/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.465,75

Intérêts prorata sur EO du 29/05/14 au 31/12/14
2.300.000*2,00%*216/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.221,92

Intérêts prorata sur EO du 30/09/14 au 31/12/14
3.000.000*2,00%*92/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.123,29

Intérêts prorata sur EO du 31/03/14 au 31/12/14
750.000*2,00%*275/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.301,37

Intérêts prorata sur EO du 16/06/14 au 31/12/14
700.000*2,00%*198/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.594,52

Intérêts prorata sur EO du 18/06/14 au 31/12/14
50.000*2,00%*!96/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

536,99

Intérêts prorata sur EO du 09/09/14 au 31/12/14
750.000*2,00%* 113/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.643,84

Intérêts prorata sur EO du 09/12/14 au 31/12/14
750.000*2,00%*22/365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

904,11

8.337.426,73

41.354.120,24

86047

L

U X E M B O U R G

<i>Charges au 31 décembre 2014

Charges brutes

TVA

Honoraires de comptabilité 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prov

3.300,00

Honoraires de domiciliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375,00

2.500,00

Honoraires de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

525,00

3.500,00

Honoraires DS Corporation -cion supplémentaire 2013 . . . . . . . . . . . . . .

1.462,50

9.750,00

Honoraires DS Corporation -cion supplémentaire 2014 . . . . . . . . . . . . . .

prov

30.000,00

Honoraires DS Corporation - Contrôle des comptes 2013 . . . . . . . . . . . . .

75,00

500,00

DS corporation - mise en conformité avec la loi du 28/07/14 . . . . . . . . . .

1.150,00

Vulpes International (Suisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.619,73

Publications légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129,09

1.643,48

voyages et déplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.092,95

Cotisation Chambre de Commerce 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140,00

Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.494,16

Tva sur provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495,00

0,00

78.690,32

3.061,59

Intérêts et autres charges financières
Autres intérêts et charges
Intérêts sur emprunt obligataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.247.032,04

Perte de change réalisée sur CHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,12

Perte de change non réalisée sur CHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208.816,92 1.455.861,08

Impôts sur le résultat
IRC 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.400,00

Autres impôts
Impôt sur la fortune 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62,00

<i>Produits au 31 décembre 2014

Autres intérêts et autres produits financiers
Autres intérêts et produits financiers
Gain de change réalisé sur CHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,26

Gain de change non réalisé sur CHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.179.S7 184.181,13

Compte

Montants en

devise

Cours

change

contreval.

EUR

comptab.

avant aj'ust

plus / moins

values

en CHF

163011 Emprunt obligataire . . . . . .

(1.000.000,00) 1,202366

(831.693,51)

(673.306,13)

(158.387,38)

451511 Bio-Prod. &amp; Bio-Eng. I  . . .

(486.097,61) 1,202366

(404.284,23

(353.854,71)

(50.429,52)

512011 Ubi-Banca International  . .

103,51 1,202366

86,09

86,11

(0.02)

(1.485.994,10)

(1.235.891.65) (1.027.074,73)

(208.816.92)

<i>Intérêts sur emprunts obligataires au 31 décembre 2014

EO 4.5% CHF 1.000.000 échéance 30 décembre 2015

devise

montant

taux

intérêts

devise

cours devise intérêts EUR

CHF

1.000.000,00 4,50% 45.000,00

1,202366

37.426,21

661102/

/451511/

37.426,21

37.426,21

EO 5% EUR 9.000.000 échéance 30 décembre 2015

devise

montant

taux

intérêts

devise

cours devise intérêts EUR

EUR

9.000.000,00 5,00% 450.000,00

1

450.000,00

661101/

/451501/

450.000,00 450.000,00

EO 5% EUR 2.650.000 échéance 17 octobre 2016

a) intérêts 2013/2014

86048

L

U X E M B O U R G

devise

montant

taux

intérêts

devise

cours devise intérêts EUR

EUR

2.650.000,00

5,00%

132.500,00

1

132.500,00

486000/
661101/

/451501/

27.226,03

105.273,97

132.500,00

b) intérêts 2014/2015 (du 17 octobre au 31 décembre)

((( EUR 2.650.000 x 5% ) / 365 ) x 75) =

27.226,03

661101/ /486000/

27.226,03

27.226,03

EO 5% EUR 2.055.000 échéance 1 

er

 août 2018

a) intérêts 2013/2014

devise

montant

taux

intérêts

devise

cours devise intérêts EUR

EUR

2.055.000.00 5,00% 102.750,00

1

102.750,00

486000/
661101/

/451501/

43.633,56
59.116,44

102.750,00

b) intérêts 2014/2015 (du 1 

er

 août au 31 décembre)

((( EUR 2.055.000 x 5% ) / 365 ) X 155) =

43.633,56

661101/ /486000/

43.633,56

43.633,56

EO 5% EUR 3.450.000 échéance 1 

er

 août 2019

a) intérêts 2013/2014

devise

montant

taux

intérêts

devise

cours devise intérêts EUR

EUR

3.450.000,00 5,00% 172.500,00

1

172.500,00

486000/
661101/

/451501/

73.253,42
99.246,58

172.500,00

b) intérêts 2014/2015 (du 1 

er

 août au 31 décembre)

((( EUR 3.450.000 X 5% ) / 365 ) X 155) =

73.253,42

661101/ /486000/

73.253,42

73.253,42

EO 3.75% EUR 2.530.000 échéance 2 juillet 2020
a) intérêts 2013/2014

devise

montant

taux

intérêts

devise

cours devise intérêts EUR

EUR

2.530.000,00 3,75% 94.875,00

1

94.875,00

486000/
661101/

/451501/

47.047,60
47.827,40

94.875,00

a) intérêts 2014/2015 (du 3 juillet au 31 décembre)

((( EUR 2.530.000 x 3,75% ) / 365 ) x 181) =

47.047,60

661101/ /486000/

47.047.60

47.047,60

EO 3.00% EUR 2.600.000 échéance 20 décembre 2021
a) intérêts 2013/2014

devise

montant

taux

intérêts

devise

cours devise intérêts EUR

EUR

2.600.000,00 3,00% 78.000,00

1

78.000,00

486000/
661101/

/451501/

2.136,99

75.863,01

78.000,00

b) intérêts 2014/2015 (du 21 décembre au 31 décembre)

((( EUR 2.600.000 x 3,00% ) / 365 ) X 10) =

2.136,99

661101/ /486000/

2.136,99

2.136,99

EO 3.00% EUR 1.600.000 échéance 11 septembre 2022
a) intérêts 2013/2014

devise

montant

taux

intérêts

devise

cours devise intérêts EUR

EUR

1.600.000,00 3,00% 48.000,00

1

48.000,00

486000/
661101/

/451501/

14.465.75
33.534,25

48.000,00

b) intérêts 2014/2015 (du 12 septembre au 31 décembre)

((( EUR 1.600.000 x 3,00% )/365 ) x110) =

14.465,75

661101/ /486000/

14.465.75

14.465.75

EO 2.00% EUR 2.300.000 échéance 28 mai 2023
a) intérêts 2013/2014

86049

L

U X E M B O U R G

devise

montant

taux

intérêts

devise

cours devise intérêts EUR

EUR

2.300.000,00 2,00% 46.000,00

1

46.000,00

486000/
661101/

/451501/

27.221,92
18.778.08

46.000,00

b) intérêts 2014/2015 (du 29 mai au 31 décembre)

((( EUR 2.300.000 x 2,00% ) / 365 ) x 216) =

27.221,92

661101/ /486000/

27.221.92

27.221,92

EO 2,00% CUR 3.000.000 Échéance 29 septembre 2023
a) intérêts 2013/2014

devise

montant

taux

intérêts

devise

cours devise intérêts EUR

EUR

3.000.000,00 2,00% 60.000,00

1

60.000,00

486000/
661101/

/451501/

10.438,35
44.876,71

55.315,06

b) intérêts 2014/2015 (du 30 septembre au 31 décembre)

((( EUR 3.000.000 x 2,00% ) / 365 ) x 92) =

15.123,29

661101/ /486000/

15.123,29 15.123,29

EO 2.00% EUR 3.000.000 échéance 30 mars 2024
a) intérêts 2014/2015 (du 31 mars au 31 décembre)

((( EUR 3.000.000 x 2,00% ) / 365 ) x 92) =

11.301,37

661101/ /486000/

11.301,37 11.301,37

b) intérêts 2014/2015 (du 16 juin au 31 décembre)

((( EUR 700.000 x 2,00% ) / 365 ) x 198) =

7.594,52

661101/ /486000/

7.594,52

7.594,52

c) intérêts 2014/2015 (du 18 juin au 31 décembre)

((( EUR 50.000 x 2,00% ) / 365 ) x 196) =

536,99

661101/ /486000/

536,99

536,99

d) intérêts 2014/2015 (du 9 septembre au 31 décembre)

((( EUR 750.000 x 2,00% ) / 365 ) x 113) =

4.643,84

661101/ /486000/

4.643,84

4.643,84

e) intérêts 2014/2015 (du 9 décembre au 31 décembre)

((( EUR 750.000 x 2,00% ) / 365 ) x 22) =

904,11

661101/ /486000/

904,11

904,11

<i>Notes explicatives aux comptes de Bio &amp; Bio Licensing S.A. au 31 décembre 2014

1) Actif immobilisé:
a) Brevet Arzneimittel : ce poste a augmenté de EUR 38.924,63 du fait de l'imputation d'une partie des factures
Schwarz &amp; Partner payées par la société en 2014.
b) Brevet Thrombin : ce poste a augmenté de EUR 13.015,66 du fait de l'imputation d'une partie des factures
Schwarz &amp; Partner payées par la société en 2014.
C) Brevet Stabile Therapeutische : ce poste a augmenté de EUR 47.787,83 du fait de l'imputation d'une partie des factures
Schwarz &amp; Partner payées par la société en 2014.
d) Brevet Fribrinogen : ce poste a augmenté de EUR 366,50 du fait de l'imputation d'une partie des factures
Schwarz &amp; Partner payées par la société en 2014.
e) Brevet INPAC : ce poste a augmenté de EUR 10.443,15 du fait de l'imputation d'une partie des factures
Schwarz &amp; Partner payées par la société en 2014.
d) Brevet MSAI ; ce poste a été créé en 2013. Le prix d'achat est de 10.000.000
dont 4.000.000 ont été payé en 2013 et 3.000.000,00 en 2014.
Référence de publication: 2015117792/565.
(150127142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Scylla Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142, rue Unden.

R.C.S. Luxembourg B 178.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015075624/9.
(150085582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2015.

86050

L

U X E M B O U R G

Rollibo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 122.034.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2015.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015075589/14.
(150085835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2015.

Whitecourt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 328.900,00.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 173.600.

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of May,
Before Maître Danielle KOLBACH, Notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED

Stichting Administratiekantoor Whitecourt, a fondation incorporated under the laws of The Netherlands, having its

registered office at 2243 AE Wassenaar, The Netherlands, Backershagenlaan 62, registered under the number 41141645,
duly represented by Geert DIRKX, companies director, born on 10 October 1970 in Maaseik (Belgium) and professionally
residing at 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, by virtue of a proxy given privately to him on 05 March 2015 (the
Appearing Party ),

the aforesaid proxy, after being signed ne varietur by the proxyholder and the officiating notary will remain attached to

the present deed to be registered together with it;

who declares being the sole Shareholder of the Société à responsabilité limitée WHITECOURT S.à r.l. (the Company)

having its principal place of business, its place of effective management and the center of its main interests at L-2561
Luxembourg, 31 rue de Strasbourg, registered in Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under the number
B 173600, incorporated pursuant to a notarial deed enacted by Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxem-
bourg on 10 December 2012, published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 253 on 01
February 2013.

The Articles of Association have not been amended until now.
The representative of the Appearing Party requests the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to transfer the principal place of business of the Company, the place of effective mana-

gement of the Company and the center of its main interests from its current location to establish them at 11, rue de l’Industrie,
L-8399 Windhof, Municipality of Koerich.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolves to amend article 2 of the Articles of Association

as follows:

« Art. 2.
2.1 The registered office of the Company is established in Wassenaar. The Company has its central administration and

effective place of management and centre of its main interest in the municipality of Koerich, Grand-Duchy of Luxembourg.
The principal establishment may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single
manager, or as the case may be, by the Board of Managers of the Company. The principal establishment may further be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the
general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately nine hundred euros (EUR 900.-).

86051

L

U X E M B O U R G

WHEREOF, the present deed was drawn up in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the representative of the person appearing, who is known to the notary by its surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mil quinze, le dix-huitième jour de mai,
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

Stichting Administratiekantoor Whitecourt, une fondation constituée sous la loi néerlandaise, ayant son siège social au

2243 AE Wassenaar, Pays-Bas, Backershagenlaan 62, numéro du registre 41141645, dument représentée par Geert DIRKX,
administrateur de sociétés, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique) et demeurant professionnellement au 31 rue de
Strasbourg, L-2561 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 05 mars 2015 (la Partie Compa-
rante), laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement,

qui déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée WHITECOURT S.à r.l. (la «Société») ayant son

établissement principal, son siège de direction effective et le centre de ses intérêts principaux à L-2561 Luxembourg, 31
rue de Strasbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 173600, constituée par acte reçu par
Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 10 décembre 2012, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 253 du 01 février 2013.

Les statuts n’ont pas été changés jusqu'à ce jour.
La Partie Comparante prie le notaire instrumentant de prendre acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer l’établissement principal, le siège de direction effective et le centre des intérêts

principaux de la Société de son adresse actuelle au 11 rue de l’Industrie, L-8399 Windhof, Commune de Koerich.

<i>Seconde résolution

Afin de refléter la résolution prise ci-avant, l’associé unique décide de modifier le premier point du deuxième article

comme suit:

« Art. 2.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Wassenaar. La Société a son établissement principal, son siège de direction

effective et le centre de ses intérêts principaux dans la commune de Koerich, Grand-Duché de Luxembourg. L'établissement
principal peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance. L'établissement principal peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés adoptée selon les modalités
requises pour la modification des Statuts.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à neuf cents euros (EUR 900,-).

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, Grand-Duché du Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état

et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. DIRKX, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 21 mai 2015. Relation: DAC/2015/8398. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 26 mai 2015.

Référence de publication: 2015078096/94.
(150089025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

86052

L

U X E M B O U R G

Shine France Pledgeco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 196.933.

STATUTES

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN,
ON THE FOURTH DAY OF THE MONTH OF MAY.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Shine France Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having
a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500),

incorporated by deed of the undersigned notary dated 4 May 2015 not yet published and in the course of being registered

with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,

represented by Maître Flora Verrecchia, maître en droit, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy

dated 04 May 2015 which proxy shall be registered together with the present deed.

The appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary to draw up the articles of in-

corporation of a limited liability company Shine France Pledgeco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Shine France Pled-

geco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in

which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance

money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

86053

L

U X E M B O U R G

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case

may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500)

represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its own shares
upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be

shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business

of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to

act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,

by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

86054

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the

board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal

to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in

the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in  the  register  of  shareholders  held  by  the  Company  at  least  eight  (8)  days  before  the  proposed  effective  date  of  the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions  (or  subject  to  the  satisfaction  of  the  majority  requirements,  on  the  date  set  out  therein).  Unanimous  written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

86055

L

U X E M B O U R G

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies;

in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December 2015.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscriber

Number

of shares

Subscription

price (EUR)

Shine France Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12,500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12,500

All the shares have been entirely paid up by contribution in cash, so that the company has now at its disposal the sum

of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,400.-.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles

of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:

- BRE/Management 8 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at

35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under number B 195.140.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above

appearing party the present deed is worded in English followed by and German translation. On request of the same appearing
party and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its name, first name,

civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

IM JAHRE ZWEITAUSENDFÜNFZEHN,
AM VIERTEN TAG DES MONATS MAI,
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

86056

L

U X E M B O U R G

ist erschienen,

Shine France Topco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgi-

schen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12,500) beträgt, gegründet durch eine Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 4. Mai 2015, welche noch
nicht  veröffentlicht  wurde  und  die  dabei  ist,  beim  Handels-  und  Gesellschaftsregister  von  Luxemburg  eingetragen  zu
werden,

hier vertreten durch Maître Flora Verrecchia, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-

schriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 04. Mai 2015, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der
Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Shine France Pledgeco S.à r.l." wie folgt zu
beurkunden.

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

"Shine France Pledgeco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,

Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen

die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Ge-
sellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-

geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder - Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-

denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und

Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,

durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-

schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-

liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende

86057

L

U X E M B O U R G

solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-

hundert Euro (EUR 12,500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung

vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine eigenen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht

anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die

keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-

gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse

um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und

abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der

Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung

mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,

von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig

abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen

Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder
einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

86058

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich

haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder

leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen

unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-

schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder

von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das

Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern  und  Verwaltern  einer  solchen  Person  dienen.  Nichts  hierin  Enthaltenes  berührt  die  Rechte  zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder

Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl

seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-

schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage

vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses

mindestens  acht  (8)  Tage  bevor  der  Beschluss  wirksam  werden  soll,  an  alle  Gesellschafter  an  ihre  im  Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-

schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen

Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

86059

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember

eines jeden Jahres.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die

Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich

vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die  Gesellschafter  können  auf  der  Grundlage  eines  von  dem  alleinigen  Geschäftsführer,  beziehungsweise  der  Ge-

schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet

werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-

datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179

(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich

nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2015 enden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt

eingezahlt und gezeichnet:

Einzahler

Zahl der

Geschäftsanteile

Einzahlungspreis

(EUR)

Shine France Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12.500

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12.500

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 1.400,-.

<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der

Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:

- BRE/Management 8 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue

Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer
B 195.140.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

86060

L

U X E M B O U R G

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit dass auf Anfrage der erschienenen

Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im
Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

Und  nach  Vorlesung  und  Erklärung  alles  Vorstehenden  an  den  Vollmachtnehmer  der  erschienenen  Partei  der  dem

amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat derselbe zusammen mit dem Notar die
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. VERRECCHIA, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 08 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/14366. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21. Mai 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015075596/460.
(150086213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2015.

1 Day International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 189.104.

EXTRAIT

En date du 8 mai 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- La nomination de Madame Wioletta Ciesielska, née le 26 novembre 1973 en Skieriewice, Pologne, avec adresse

professionnelle au ul. Krucza 24/26, 00-526 Varsovie, Pologne, est élue nouveau gérant de classe A de la Société avec effet
au 8 mai 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- La nomination de Monsieur Mariusz Wisniewski, né le 17 novembre 1982 en Polczyn-Zdroj, Pologne avec adresse

professionnelle au ul. Krucza 24/26, 00-526 Varsovie, Pologne, est élu nouveau gérant de classe A de la Société avec effet
au 8 mai 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- La résignation de société Travis Management S.A., avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, gérant de classe B de la Société, avec effet au 8 mai 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- La nomination de Madame Zuzanna Zielinska-Rousseau, née le 13 août 1977 en Chojnice, Pologne avec adresse

professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouveau gérant de classe B de la Société avec
effet au 8 mai 2015 et ce pour une durée indéterminée; et

- La nomination de Monsieur Igor Ismagilov, né le 27 juin 1987 en Leningrad, Russe avec adresse professionnelle au

15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouveau gérant de classe B de la Société avec effet au 8 mai 2015
et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 8 mai 2015.

Référence de publication: 2015075717/26.
(150086502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2015.

Starwood International Licensing Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.018.706,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 133.098.

EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique:
1. La démission de Monsieur Philip Patrick Mc Aveety, de son mandat de gérant de catégorie B de la Société, a été

acceptée avec effet au 31 mars 2015;

2. La personne suivante a été nommée en tant que nouveau gérant de catégorie B de la société, avec effet au 15 mai

2015 et pour une durée indéterminée:

- Monsieur John Wolf PEYTON, né le 19 mars 1967 à Livingston, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse

au Starwood Hotels &amp; Resorts Worldwide, Inc. One Starpoint Stamford, CT 06903, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

86061

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 19 mai 2015.

Référence de publication: 2015075609/18.
(150085823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2015.

31 Holding - Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.635,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 174.660.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of the month of May;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

The limited company governed by the laws of the British Virgin Islands Global 31 Holding Limited, having its registered

office at VG1110 Tortola, Road Town Wickhams Cay, registered with the Registrar of Corporate Affairs under number
1742243,

here represented by Mr. Fabrice GEIMER, private employee, residing professionally at L-1420 Luxembourg, 5, Avenue

Gaston Diderich, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the
proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
1) That the private limited company 31 Holding - Luxembourg, established and having its registered office in L-1420

Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B,
under number 174660, (the “Company”), has been originally incorporated under the name Manra Investments S.à r.l.,
pursuant to a deed of the officiating notary, on the 28 

th

 of December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, number 617 of the 13 

th

 of March 2013,

and that the articles of association have been amended pursuant to a deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing

in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on the 23 

rd

 of May 2013, published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, number 1655 of the 11 

th

 of July 2013, containing, among other things, the adoption by the

Company of its current denomination and a complete restate of the articles of association.

2) That the corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand six hundred and thirty-five Euro (12.635.-

EUR) represented by twelve thousand six hundred and thirty-five (12.635) shares of one hundred Euro (1.- EUR) each.

3) That the appearing party is the sole owner of all the shares of the Company (the “Sole Shareholder”).
4) That the activity of the Company has ceased and that the Sole Shareholder, acting as at an extraordinary Sole Sha-

reholders' meeting amending the articles of the Company, pronounces the advanced dissolution of the Company with
immediate effect and its putting into liquidation.

5) That the Sole Shareholder appoints Mrs. Xuan Wen ZHOU, born in People's Republic of China, on October 13, 1973,

professionally residing at 304, Hudson Street, Suite 800, New York NY 10013, as liquidator of the Company, with full
powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or
useful so to bring into effect the purposes of the present deed.

6) That the Sole Shareholder decides to immediately convene the second and third general meeting of Sole Shareholder

in accordance with article 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies and to immediately hold
these meetings one after the other.

7) That the Sole Shareholder declares having thorough knowledge of the articles of association and of the financial

situation of the Company.

8) That with the approval of debtors, all debts have been taken over by the Sole Shareholder.
9) That the liquidator presents the liquidation report and declares that the Sole Shareholder takes over all the assets of

the Company, and that it will assume any existing debt of the Company.

The liquidation report, after having been signed “ne varietur” by the liquidator and the undersigned notary, shall stay

affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

10) That the Sole Shareholder appoints Mr. Mark KATZ, professionally residing at 304, Hudson Street, Suite 800, New

York NY 10013, as auditor to the liquidation and asked him to establish a report on the liquidation.

Having reviewed the report of the auditor to the liquidation, the Sole Shareholder accepts the findings, approves the

liquidation accounts and grants a total and entire discharge, without reserve or restriction to the said auditor in relation to
the verifications carried out as of the date hereof.

The report of the auditor to the liquidation shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

86062

L

U X E M B O U R G

11) That the Sole Shareholder, in the third general meeting of Sole Shareholder, declares that the liquidation of the

Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be
cancelled.

The Sole Shareholder confirms that the Company has definitely ceased to exist.
12) That discharge is given to the managers of the Company.
13) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at

L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, the registered office of United International Management S.A..

14) That the company United International Management S.A., with registered office at L-1420 Luxembourg, 5, Avenue

Gaston Diderich, is hereby empowered to accomplish all formalities deriving from the liquidation, including but not limited
to the closing of any bank account, the payment of any outstanding taxes and expenses, and the filing of any outstanding
tax returns.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de mai;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

A COMPARU:

La limited company régie par les lois des Iles Vierges Britanniques Global 31 Holding Limited, ayant son siège social

à VG1110 Tortola, Road Town Wickhams Cay, inscrite au Registrar of Corporate Affairs sous le numéeo 1742243,

ici représentée par Monsieur Fabrice GEIMER, employé privé, demeurant professionnellement au L-1420 Luxembourg,

5, Avenue Gaston Diderich, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été
signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée
avec lui

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société à responsabilité limitée 31 Holding - Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxem-

bourg, 7, Avenue Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 174 660, (la “Société”), a été originairement constituée sous la dénomination de Manra Investments S.à r.l., suivant
acte par le notaire instrumentant, le 28 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
617 du 13 mars 2013,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg), le 23 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1655
du 11 juillet 2013, contenant, entre autres, l'adoption par la Société de sa dénomination actuelle et une refonte complète
des statuts.

2) Que le capital social de la Société est fixé à douze mille six cent trente-cinq euros (12.635,- EUR), représenté par

douze mille six cent trente-cinq (12.635) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune.

3) Que le comparant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de la Société (l’“Associé Unique”).
4) Que l'activité de la Société ayant cessé et que l'Associé Unique, siégeant comme en assemblée générale extraordinaire

modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en
liquidation.

5) Que l’Associé Unique se désigne Madame Xuan Wen ZHOU, né en République Populaire de Chine, le 13 octobre

1973, ayant son adresse professionnelle à 304. Hudson Street, Suite 800, New York 10013 comme liquidateur de la Société,
avec les pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire
tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que l’Associé Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l'article 151

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

7) Que l’Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

86063

L

U X E M B O U R G

8) Que de l'accord des créanciers, toutes les dettes ont été reprises par l’Associé Unique.
9) Que le liquidateur présente le rapport de liquidation et l’Associé Unique déclare reprendre tout l'actif de la Société

et s'engage à régler tout le passif de la Société.

Le rapport sur la liquidation, après avoir été signée “ne varietur” par le liquidateur et le notaire soussigné, restera annexé

au présent acte avec lequel il sera enregistré.

10) Que l’Associé Unique nomme Monsieur Mark KATZ, demeurant professionnellement au 304, Hudson Street, Suite

800, New York NY 10013, comme commissaire à la liquidation et lui confie la mission de faire le rapport sur la gestion.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l’Associé Unique en adopte les conclusions,

approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière audit commissaire pour ses travaux de vérification
effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
11) Que l’Associé Unique, constitué en troisième assemblée, déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que

tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.

Il constate que la Société a définitivement cessé d'exister.
12) Que décharge est donnée aux gérants de la Société.
13) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à L-1420

Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, siège social de United International Management S.A..

14) Que la société United International Management S.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston

Diderich, est habilitée à accomplir toutes les formalités découlant de la liquidation, y compris mais non limité à la clôture
de tout compte bancaire, le paiement de tout impôt impayé et de tous frais, le dépôt de toute déclaration fiscale en cours.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par

son nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: F. GEIMER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 19 mai 2015. 2LAC/2015/10862. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 27 mai 2015.

Référence de publication: 2015078128/144.
(150089659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

Verizon Business Security Solutions Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 4A/B, rue de l'Etang.

R.C.S. Luxembourg B 62.274.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 22 avril 2015, il a été décidé:
- d'approuver la démission avec effet au 22 avril 2015 de Monsieur Gavan Patrick Egan, demeurant 1, Foxrock Mount,

Foxrock, Dublin 18, Irlande, en tant qu'administrateur de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2015.

<i>Pour Verizon Business Security Solutions Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2015075687/15.
(150086078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

86064


Document Outline

1 Day International S.à r.l.

31 Holding - Luxembourg

ADLG S.à r.l.

Alphabet S.A.

BE Aerospace Investments Holdings II S.à r.l.

Bio &amp; Bio Licensing S.A.

CSCP Credit Acquisition Holdings Luxco Sàrl

Donard Holdings S.à r.l.

Donard Holdings S.à r.l.

ESCE S.A.

Eurofoil Luxembourg S.A.

European Financial Group EFG-S.A.

Fürstenberger Siedlung 3 S.à r.l.

Henkel Re S.A.

Holly Tree Immobilier S.A.

Horizont Marine S.A.

Innovation Arch

Intendance of International Consultants S.à r.l., intentionally known as the Consultancy,

Investment Opportunities S.à r.l.

IPSE Dixit Holding S.A.

Lune Holdings SPF SA

Medacta S.A.

Mediplan G.m.b.H.

Megatouch Luxembourg S.à r.l.

Mineral5 SA

Mineral5 SA

Mineral5 SA

MIV Greeneden LP Holding SCA

Nord Europe Life Luxembourg

Quant S.A.

QVC France Holdings, S.à r.l.

RE ENERGY Management S.à r.l.

R-Holdings 2 S.à r.l.

Rollibo S.A.

Royal Body Concept S.A.

Scylla Conseil S.à r.l.

SEDCO Capital Luxembourg S.A.

Shine France Pledgeco S.à r.l.

Shire Sweden Holdings S.à r.l.

S.L.Z.A. S.A.

Starwood International Licensing Company S.à r.l.

Verizon Business Security Solutions Luxembourg

Whitecourt S.à r.l.