logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1724

13 juillet 2015

SOMMAIRE

AAC Capital 2005 Lux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

82751

ACI LUXEMBOURG the Financial Markets

Association  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82752

Acis Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82752

Actech Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82752

Algim S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82752

Barclays Aegis Investments S.à r.l.  . . . . . . . . .

82742

Baskland Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82752

d'Amico International Shipping S.A.  . . . . . . .

82751

FSI Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82742

Fusion Orientale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82738

Helpling Group Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

82706

Ideal-Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82740

(in)cube s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82751

INGBE Beteiligung S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

82747

La Varenne Gastronomie Holding . . . . . . . . . .

82733

Pacase S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82750

Schuler Romain S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82740

Selkea S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82744

Setas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82741

SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82747

Sinal Capital SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82735

Solar Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82737

SOLIT Information Security S.à r.l.  . . . . . . . .

82738

Somuchmore GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82737

SPC Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82738

T.E.A. Oriental Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82740

Tishman Speyer Point Partners S.à r.l.  . . . . . .

82743

Toiture Miller Frères, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

82743

TPL Neckarsulm S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82743

TPL Vilshofen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82744

TPL Wittenberge S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82746

Traxys S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82743

TR Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82746

Tur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82746

Vermalito S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82748

Vero S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82749

Vireos Investment Fund S.A., SICAV-SIF  . . .

82749

Vitco & Partners SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82746

Wedco One (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

82751

Wedco Two (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . .

82751

White Ice Ventures Limited  . . . . . . . . . . . . . . .

82747

82705

L

U X E M B O U R G

Helpling Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 34.246,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 184.677.

In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of April,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet SE (formerly: Rocket Internet AG), a European Company (Societas Europaea) with its statutory seat

in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amts-
gericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 165662 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany,

being the holder of ten thousand (10,000) common shares of the Company and one thousand five hundred eighty-seven

(1,587) series B1 shares of the Company,

here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-

chränkt)) existing under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial
register at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under number HRB 126893 B, having
its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of two thousand five hundred (2,500) common shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

3. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of

the Netherlands with its registered office in Schiphol, the Netherlands, registered with the commercial register of the Dutch
Trade Register, under no. 60628022, having its business address at Schiphol Boulevard 127, 1118 BG Schiphol, The
Netherlands,

being the holder of four hundred seventeen (417) series A1 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing

under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 176.544, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000.00),

being the holder of one thousand two hundred fifty (1,250) series A1 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

5. JP Ventures UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt))

existing under the laws of Germany with its statutory seat in Wehingen, Germany, registered with the commercial register
(Handelsregister)  at  the  local  court  of  Stuttgart  (Amtsgericht  Stuttgart),  Germany,  under  no.  HRB  733673,  having  its
business address at Gosheimer Straße 48, 78564 Wehingen, Germany,

being the holder of forty-two (42) series A1 shares of the Company and ten (10) series B1 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

6. Kaltroco Limited, a company incorporated in Jersey with registered no. 60595, having its business address at Floor

One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3AS,

being the holder of two thousand five hundred (2,500) series A2 shares of the Company and three hundred eighteen

(318) series B1 shares of the Company,

here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

7. Phenomen Ventures LP, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, registration no. OG - 66003,

having its registered office at 89, Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands,

being the holder of two thousand eighty-four (2,084) series A3 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

82706

L

U X E M B O U R G

8. Mangrove IV Investments S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 189.521, having its registered office at 20, boulevard Emmanuel
Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

being the holder of three thousand three hundred thirty-four (3,334) series A4 shares of the Company and five hundred

thirty (530) series B1 shares of the Company, and becoming the holder of six hundred thirty-five (635) newly created series
B3 shares of the Company,

here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

9. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda with its statutory

seat in Hamilton, Bermuda, having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11,

being the holder of four hundred seventeen (417) series A5 shares of the Company and ninety-five (95) series B1 shares

of the Company, and becoming the holder of fifty-two (52) newly created series B3 shares of the Company,

here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

10. David W. Zalaznick, born on 16 April 1954, resident at 9 West 57 

th

 Street - 33 

rd

 Floor, New York, NY 10019,

United States of America,

being the holder of four hundred seventeen (417) series A5 shares of the Company and ninety-five (95) series B2 shares

of the Company, and becoming the holder of fifty-two (52) newly created series B3 shares of the Company,

here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

11. Luktev GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of Germany with

its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Char-
lottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 119212 B, having its business address at Mohrenstraße
60, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of four hundred seventeen (417) series A5 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

12. Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws of

Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local
court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRA 45915 B, having its business address at
Jägerstraße 65, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of three hundred eighty-one (381) series A5 shares of the Company and eighty-seven (87) series B1

shares of the Company,

here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

13. Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws of Germany

with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of
Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRA 45911 B, having its business address at Jägerstraße
65, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of thirty-six (36) series A5 shares of the Company and seven (7) series B1 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

14. L’Arche B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws

of the Netherlands, registered with the Dutch trade register of the Chambers of Commerce under no. 59430982, having its
business address at Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam, The Netherlands,

being the holder of one thousand five hundred eighty-seven (1,587) series B1 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

15. Mercura Capital GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of

Germany with its statutory seat in Starnberg, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local  court  of  Munich  (Amtsgericht  München),  Germany,  under  no.  HRB  200948,  having  its  business  address  at
Schießstättstraße 22, 82319 Starnberg, Germany,

being the holder of seven hundred ninety-four (794) series B1 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

16. SHCO 57 S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg with its statutory seat in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg

82707

L

U X E M B O U R G

Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 183.425, having its registered office
at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

being the holder of four hundred seventy-six (476) series B1 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

17. Team Europe Ventures Ltd., a limited liability company under the laws of England and Wales with its statutory seat

at 69 Great Hampton Street, Birmingham, B18 6EW, United Kingdom, registered with the Companies House Cardiff under
no. 05831082, with a branch office (Zweigniederlassung) at Mohrenstraße 60, 10117 Berlin, Germany, registered with the
commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under
no. HRB 115038 B,

being the holder of one thousand five hundred eighty-seven (1,587) series B2 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

18. Lakestar I LP, a Limited Partnership, registered number 55408, having its business address at PO Box 656, East

Wing Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3PP, Channel Islands, participating and voting only for
purposes of agenda points 4 et seq.,

becoming the holder of one thousand five hundred eighty-seven (1,587) newly created series B3 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy;

19. Finvasco Capital Investments Ltd., a limited liability company under the laws of Cyprus, registered with the De-

partment of Registrar of Companies and Official Receiver under no. HE 341867, having its registered office at 67 Kennedy
Avenue, Athienitis Kennedy Park, 4 

th

 Floor, Office 401, 1076 Nicosia, Cyprus, participating and voting only for purposes

of agenda points 4 et seq.,

becoming the holder of nine hundred fifty-two (952) newly created series B3 shares of the Company,
here represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. and 17. (the “Existing Shareholders”) are all the

shareholders  of  Helpling  Group  Holding  S.à  r.l.  (the  “Company”),  a  société  à  responsabilité  limitée  incorporated  and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  (Registre  de
Commerce et des Sociétés) under no. B 184.677 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 7 February
2014, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1074 dated 28 April 2014. The articles
of association were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Cosita Delvaux on 27 February 2015, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement, and the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the parties
18 and 19 (the “New Investors”) participate and vote for the purpose of agenda points 4 et seq. only:

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) new series of shares in the share capital of the Company, namely the series B3 shares, so

that the Company will hence have nine (9) series of shares, being the common shares (hereinafter “Common Shares”), the
series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), the series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”), the series A3
shares (hereinafter the “Series A3 Shares”), the series A4 shares (hereinafter the “Series A4 Shares”), the series A5 shares
(hereinafter the “Series A5 Shares”), the series B1 shares (hereinafter the “Series B1 Shares”), the series B2 shares (he-
reinafter the “Series B2 Shares”) and the series B3 shares (hereinafter the “Series B3 Shares”).

2. Acceptance of Lakestar I LP and Finvasco Capital Investments Ltd., each aforementioned, as new shareholders of

the Company.

3. Increase of the Company’s share capital by an amount of three thousand two hundred seventy-eight euros (EUR

3,278.00) so as to raise it from its current amount of thirty thousand nine hundred sixty-eight euros (EUR 30,968.00) up
to thirty-four thousand two hundred forty-six euros (EUR 34,246.00) by issuing three thousand two hundred seventy-eight
(3,278) Series B3 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

4. Restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the capital increase as per the third

resolution as well as to reflect several amendments to the articles of association following the entry into the capital of the
Company by the New Investors.

5. Miscellaneous.
The general meeting of shareholders acknowledges that, for the purposes of the above agenda, all Existing Shareholders

have unanimously waived the investors’ consent requirement for the amendment of the articles of association of the Com-

82708

L

U X E M B O U R G

pany set forth by Article 16 of the articles of association of the Company and any preferential subscription right they may
have - unless exercised - according to Article 5.3 of the articles of association of the Company.

Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) new series of shares in the share capital of the Company,

namely the Series B3 Shares, so that the Company will hence have nine (9) series of shares, being the Common Shares,
the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 Shares, the Series A4 Shares, the Series A5 Shares, the Series
B1 Shares, the Series B2 Shares and the Series B3 Shares.

<i>Second resolution

The  general  meeting  of  shareholders  decides  to  accept  Lakestar  I  LP  and  Finvasco  Capital  Investments  Ltd.,  each

aforementioned, as new shareholders of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three thousand

two hundred seventy-eight euros (EUR 3,278.00) so as to raise it from its current amount of thirty thousand nine hundred
sixty-eight euros (EUR 30,968.00) up to thirty-four thousand two hundred forty-six euros (EUR 34,246.00) by issuing three
thousand two hundred seventy-eight (3,278) Series B3 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

<i>Subscription

The three thousand two hundred seventy-eight (3,278) Series B3 Shares have been duly subscribed as follows:
- one thousand five hundred eighty-seven (1,587) Series B3 Shares have been duly subscribed by Lakestar I LP, afore-

mentioned;

-  nine  hundred  fifty-two  (952)  Series  B3  Shares  have  been  duly  subscribed  by  Finvasco  Capital  Investments  Ltd.,

aforementioned;

- six hundred thirty-five (635) Series B3 Shares have been duly subscribed by Mangrove IV Investments S.à r.l., afo-

rementioned;

- fifty-two (52) Series B3 Shares have been duly subscribed by TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., afore-

mentioned;

- fifty-two (52) Series B3 Shares have been duly subscribed by Mr. David W. Zalaznick, aforementioned.

<i>Payment

The three thousand two hundred seventy-eight (3,278) Series B3 Shares have been entirely paid up as follows:
- the one thousand five hundred eighty-seven (1,587) Series B3 Shares subscribed by Lakestar I LP, aforementioned,

have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand five hundred eighty-seven euros
(EUR 1,587.00);

- the nine hundred fifty-two (952) Series B3 Shares subscribed by Finvasco Capital Investments Ltd., aforementioned,

have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of nine hundred fifty-two euros (EUR 952.00);

- the six hundred thirty-five (635) Series B3 Shares subscribed by Mangrove IV Investments S.à r.l., aforementioned,

have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of six hundred thirty-five euros (EUR 635.00);

- the fifty-two (52) Series B3 Shares subscribed by TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., aforementioned, have

been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of fifty-two euros (EUR 52.00);

- the fifty-two (52) Series B3 Shares subscribed by Mr. David W. Zalaznick, aforementioned, have been entirely paid

up through a contribution in cash in an amount of fifty-two euros (EUR 52.00).

The proof of the existence and of the value of the above contributions has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of three thousand two hundred seventy-eight euros (EUR 3,278.00) is entirely allocated

to the share capital.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to proceed to a complete restatement of the articles of association of the

Company in order to reflect the capital increase as per the third resolution as well as to reflect several amendments to the
articles of association following the entry into the capital of the Company by the New Investors.

The articles of association of the Company shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Helpling Group

Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

82709

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may

be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-four thousand two hundred forty-six euros (EUR 34,246.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), each with a nominal value

of one euro (EUR 1.00),

5.1.2 one thousand seven hundred nine (1,709) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), each with a nominal

value of one euro (EUR 1.00),

5.1.3 two thousand five hundred (2,500) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”), each with a nominal value

of one euro (EUR 1.00),

5.1.4 two thousand eighty-four (2,084) series A3 shares (hereinafter “Series A3 Shares”), each with a nominal value of

one euro (EUR 1.00),

5.1.5 three thousand three hundred thirty-four (3,334) series A4 shares (hereinafter “Series A4 Shares”), each with a

nominal value of one euro (EUR 1.00),

5.1.6 one thousand six hundred sixty-eight (1,668) series A5 shares (hereinafter “Series A5 Shares”), each with a nominal

value of one euro (EUR 1.00), and jointly with the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 Shares and the
Series A4 Shares the “Series A Shares”,

5.1.7 five thousand four hundred ninety-one (5,491) series B1 shares (hereinafter “Series B1 Shares”), each with a

nominal value of one euro (EUR 1.00),

5.1.8 one thousand six hundred eighty-two (1,682) series B2 shares (hereinafter “Series B2 Shares”), each with a nominal

value of one euro (EUR 1.00), and

5.1.9 three thousand two hundred seventy-eight (3,278) series B3 shares, each with a nominal value of one euro (EUR

1.00) (hereinafter “Series B3 Shares”; the Series B1 Shares, the Series B2 Shares and the Series B3 Shares hereinafter also
referred to as the “Series B Shares”; the Series A Shares and the Series B Shares hereinafter jointly referred to as the
“Preferred Shares”).

82710

L

U X E M B O U R G

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association, any shareholders’ agreement or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of the shareholders Rocket Internet SE (“Rocket”), Netris B.V. (“Eiffel”), Aismare Lux Holdings S.à r.l.

(“Aismare”), JP Ventures UG (haftungsbeschränkt) (“JP Ventures”), Kaltroco Limited (“Kaltroco”), Phenomen Ventures
LP (“Phenomen”), Mangrove IV Investments S.à r.l. (“Mangrove”), TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”),
David W. Zalaznick (“DZ”), Luktev GmbH (“Luktev”), Team Europe Ventures Ltd. (“Team Europe Ventures”, jointly
with Luktev “Team Europe”), Point Nine Capital Fund II GmbH &amp; Co. KG (“Point Nine Capital”), Point Nine Co-Invest
II GmbH &amp; Co. KG (“Point Nine Co-Invest”, jointly with Point Nine Capital “Point Nine”), L’Arche B.V. (“L’Arche”),
SHCO 57 S.à r.l. (“SHCO”), Mercura Capital GmbH (“Mercura”), Lakestar I LP (“Lakestar”) and Finvasco Capital In-
vestments Ltd. (“Finvasco”; Finvasco jointly with Rocket, Eiffel, Aismare, Kaltroco, Phenomen, Mangrove, TJT, DZ,
Team Europe, Point Nine, L’Arche, SHCO, Mercura and Lakestar the “Investors” and each also an “Investor”) shall be
entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an
investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning
of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)) (a “Third Party Investor”) which has been approved with
an Advisory Board Majority (as defined in Article 25.5 below) (such investment being a “Third Party Investment”) -
irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to
its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the
Third Party Investment is based on. The respective Investor or other entitled shareholder pursuant to this Article 5.3 shall
inform the Company by binding declaration within three (3) weeks whether it intends to exercise its right pursuant to the
foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors or other
shareholders (or a company affiliated to an Investor or other shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German
Stock Corporation Act (AktG)) subscribe for further shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders, subject to the provisions of any shareholders’ agreement

between the shareholders of the Company, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along
rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders of the Company.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

a majority vote of seventy five per cent (75%) of the votes of all shareholders of the Company (such majority being a “Super
Majority”) and subject to the provisions of any shareholders’ agreement between the shareholders of the Company, if any,
in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any
shareholders’ agreement between the shareholders of the Company. To the extent that such approval has been granted, an
additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a Transfer (as defined in Article 8.1 below) or any other disposal of shares by any Investor to a

company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a Transfer or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is directly or indirectly

Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct or indirect share-
holders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Controlled” or “Controlling”
shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing shareholder,
(b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a contractual voting pool, or (d)
the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies of a person, whether
through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders
of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

82711

L

U X E M B O U R G

7.4.3 in any case of a disposal of shares by Lakestar to any bona fide fund which has been nominated and which is

advised and/or managed by the entity managing Lakestar;

7.4.4 in case of a Transfer or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under the simplified employee

participation agreed upon between the shareholders of the Company in a shareholders’ agreement, if any or (ii) to the
Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme implemented pursuant to such simplified
employee participation;

7.4.5 in case of any Transfer or any other disposal of shares within the framework of transformation procedures pursuant

to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company, if the shareholders
of the Company hold more than fifty per cent (50%) in any surviving legal entity after such transformation procedure.

7.5 In the cases provided for in Articles 7.4.1 through 7.4.5 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of

first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any Transfer or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third parties through

the notification of the Transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the Transfer, assignment or
any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased
shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any Transfer of at least fifty per cent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of

the Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) Transfer of at least 50% of the Company’s Assets or business of the Company, in a single or more related
transactions or (iii) Transfer of a material part of the Company’s Intellectual Property Rights in a single or more related
transactions or (iv) of the liquidation or de facto liquidation of the Company (in particular following an asset deal) or (v)
of any sale or Transfer of shares in the Company either to third parties or other shareholders that would result in either
more than fifty per cent (50%) of the registered share capital or more than fifty per cent (50%) of the voting rights being
owned by the acquiring party/ parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the events
described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to
Article 8.2 below - will be distributed in accordance with Article 8.3 to the shareholders pro rata to (i) in case of an asset
Transfer, their shareholding in the registered share capital of the Company or (ii) in case of a share Transfer, the number
of shares sold in the Liquidity Event (as applicable).

“Transfer” means, with respect to any asset (including without limitation, shares and Intellectual Property Rights), any

transfer, assignment, sale, pledge, hypothecation, Encumbrance or other disposition of that asset or of any rights or obli-
gations associated with that asset, whether voluntary or involuntary, including an option to do any of the forgoing.

“Encumbrance”/“Encumbered” means any encumbrance whatsoever, including a mortgage, charge, debenture, pledge,

hypothecation, lien, security interest, title retention, option, right to acquire or purchase, restriction upon sale or transfer,
right of first refusal, right of pre-emption, third party right or interest, claims, trust arrangement, agreement to confer
security, other encumbrance or security interest of any kind or other type of preferential arrangement or any equity or other
restriction or limitation of any nature whatsoever (including, without limitation, a title transfer or retention arrangement,
any preliminary agreement or other arrangement to create any of the above) having similar effect.

8.2 On a first preferred level (“First Preferred Level”), each holder of Series B Shares shall receive an amount equal to

its respective total investment made to acquire its respective Series B Shares held by it (consisting of the nominal amount
of the Series B Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid
by the respective holder to the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the First
Preferred Level, the Exit Proceeds shall be allocated to each holder of Series B Shares pro rata to the amounts that would
have been allocated to that holder on the First Preferred Level if the Exit Proceeds had been sufficient.

8.3 On a second preferred level (“Second Preferred Level”), each holder of Series A Shares shall receive an amount

equal to its respective investment made to acquire its respective Series A Shares held by it (i.e. the respective series A
nominal amount and the respective series A additional payment). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to
be made on the Second Preferred Level, the Exit Proceeds shall be allocated to each holder of Series A Shares pro rata to
the amounts that would have been allocated to that holder on the Second Preferred Level if the Exit Proceeds had been
sufficient.

8.4 After the payments on the First Preferred Level and the Second Preferred Level have been made, the remaining Exit

Proceeds shall be allocated on a common level (“Common Level”) to all selling shareholders pro rata to the respective
shares disposed of in connection with the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on a Preferred Level
shall reduce the amount to be allocated to such shareholder on the Common Level; provided that no shareholder shall be
obliged to repay any amount received on the First Preferred Level and/or the Second Preferred Level. Any Exit Proceeds
remaining unallocated after allocation under this Article 8.4 shall also be allocated in accordance with this Article 8.4 by
applying Article 8.4 repeatedly until all Exit Proceeds have been allocated to the shareholders. Irrespective of whether or

82712

L

U X E M B O U R G

not the sale of shares is made in one or more transactions, no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and
repay any exceeding amount to the other shareholder) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit
Proceeds pro rata to the Shares sold or (ii) the amount of its investment in the Company (payment of purchase price for
shelf company, payment of share capital, including premium, if any, and payments into account 115 of the standard chart
of accountants “apport en capitaux propres non rémunérés par des titres” under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
(additional amounts)) in respect of the shares sold. If shares in the Company are sold in more than one transaction, no
shareholder shall receive less proceeds than it would have received if the shares in the Company were sold in one transaction.

8.5 The preferred allocation on the First Preferred Level and the Second Preferred Level applies for the benefit of the

respective shareholder so long as the respective shareholder (including any sales prior to a Liquidity Event) has not yet
received the full amount that is to be allocated to such shareholder according to the First Preferred Level and/or the Second
Preferred Level.

Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is

rejected for lack of assets;

9.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such

enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration of
redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its share
register and to proceed with the relevant filings required by law.

9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one person;

independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way through
one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.

9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).

Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date

is the date before the redemption resolution.

10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable compensation for redemption, such compensation is

to be determined by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is
reached, the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a share-
holder or of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be
borne by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off
with the compensation for redemption and the compensation for redemption shall be reduced accordingly. The shareholder
shall bear the remaining costs in case the compensation for redemption does not cover the costs allocated to the shareholder
for the expert opinion.

Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a person

named  by  the  Company  (including  another  shareholder  of  the  Company),  including  also  partial  redemption  or  partial
assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

82713

L

U X E M B O U R G

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.

12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also

be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a
shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of
managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence, the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must
state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must
be sent to each shareholder in writing without undue delay.

12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.

Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be

specified in the respective convening notices of meeting.

13.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or regis-

tered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of
notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary share-
holders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’ meeting
is not counted in the calculation of the period of notice.

13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another shareholder

authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.

13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders’
resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’ meeting (for
purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.

Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.

Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If there is no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance
with Article 13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if
this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority, provided that it includes the consent
of all of the Investors. Any amendment of these articles of association that materially or adversely affects the rights of the
holders of Preferred Shares require the consent of all of the holders of those Preferred Shares.

Art. 17. Shareholders’ Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders’ resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and require the

consent of the Advisory Board:

17.1.1 conclusion, amendment and termination of intra-group affiliation agreements (Unternehmensverträge within the

meaning of sections 291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG));

82714

L

U X E M B O U R G

17.1.2 conclusion or amendment of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal

of shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a
participation in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does
not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a
prospective  status  as  shareholder  or  employee,  as  well  as  agreements  with  third  parties  within  the  ordinary  course  of
business, e.g. agreements between the Company and advertising partners.

17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the consent of all

of the Investors:

17.2.1 material changes to the business object of the Company or any material modification of the fields of business of

the Company or the termination of existing and commencement of new fields of business;

17.2.2 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.3 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and

transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association;

17.2.4 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

17.2.5 merger, separation and transformation of the Company.
17.3. Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares, the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold all
the issued shares of that class.

D. Board of managers

Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.

18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-
ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

82715

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means

of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event, however, the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.

22.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board for the legal transactions and measures specified

below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance
been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:

22.8.1 approval of the annual plan including the budget plan for each following year;
22.8.2 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros

(EUR 200,000.00) in the individual case;

22.8.3 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

22.8.4 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.5 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

22.8.6 institution and termination of legal disputes, including arbitration proceedings, involving a judicial amount in

controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

22.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals;
22.8.8 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party outside the

ordinary course of business;

22.8.9 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such profits

to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;

22.8.10 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options) other

than the establishment of any simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the Company in
a shareholders’ agreement, if any.

22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also required

for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further transactions
and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also in advance for
certain groups and kinds of transactions and measures.

22.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in the
future.

Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts

82716

L

U X E M B O U R G

of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and
class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company has set up an advisory board (the “Advisory Board”). It consists of ten (10) voting members, each

having the number of votes as set forth in this Article 25. The shareholders may by way of unanimous shareholders’ consent
increase or decrease (i) the number of voting members of the Advisory Board and/or (ii) the number of the respective votes.

25.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of unanimous

shareholders’ consent.

25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s respective

appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

25.3.1 two (2) voting members of the Advisory Board, one having three (3) votes and the other having two (2) votes,

shall be nominated by the Investor Rocket (“Rocket Members”) in its sole discretion;

25.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Aismare

(“Aismare Member”) in its sole discretion;

25.3.3 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Phenomen

(“Phenomen Member”) in its sole discretion;

25.3.4 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Mangrove

(“Mangrove Member”) in its sole discretion;

25.3.5 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor L’Arche

(“L’Arche Member”) in its sole discretion;

25.3.6 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Mercura

(“Mercura Member”) in its sole discretion;

25.3.7 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor SHCO

(“SHCO Member”) in its sole discretion;

25.3.8 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Team

Europe (“Team Europe Member”) in its sole discretion; and

25.3.9 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Lakestar

(“Lakestar Member”) in its sole discretion.

25.4 Each Investor other than those entitled to appoint a voting member of the Advisory Board pursuant to Article 25.3

shall be entitled to appoint a non-voting member to the Advisory Board as an observer.

25.5 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman yet none of them shall have a casting vote and/

or any additional right and/or authority differing from the other members of the Advisory Board. One of the Rocket Members
shall  be  the  chairman  of  the  Advisory  Board.  The  rules  of  procedure  of  the  Advisory  Board  may  provide  for  further
provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. Subject to any consents or approvals otherwise
required under these Articles and/or any shareholders’ agreement with respect to the Company, if any, the Advisory Board
shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast (the “Advisory Board Majority”). In addition, for certain
measures required under a shareholders’ agreement with respect to the Company, the Advisory Board shall adopt resolutions
with the simple majority of votes cast, provided that it includes the affirmative vote of three (3) out of the Aismare Member
and/or the Phenomen Member and/or the Mangrove Member and/or the L’Arche Member and/or the Mercura Member
and/or the SHCO Member and/or the Team Europe Member and/or the Lakestar Member and/or any further member of
the Advisory Board nominated after the date hereof (the “Qualified Advisory Board Majority”). The Advisory Board shall
hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.

25.6 In addition to any consents or approvals otherwise required under these Articles and/or any shareholders’ agreement

with respect to the Company, if any, the Advisory Board has a consultative function and will not interfere in the management
of the Company.

25.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

82717

L

U X E M B O U R G

E. Audit and supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))

in accordance with Article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution
of internal auditor(s) is suppressed.

26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold

in the Company.

Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable - in accordance with the provisions of Article 8 - and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities
of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders’ agreement with respect to the Company which may be entered into from time to time between the shareholders
and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these
articles conflicts with the provisions of any shareholders’ agreement with respect to the Company, such shareholders’
agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.

31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

82718

L

U X E M B O U R G

<i>Costs and expenses

The  expenses,  costs,  remunerations  or  charges  in  any  form  whatsoever  which  shall  be  borne  by  the  Company  are

estimated at approximately EUR 1,800.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünfzehnten April,
vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg:

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), eine europäische Gesellschaft (Societas Europea) bestehend unter

deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 165662 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland,

Inhaber von zehntausend (10.000) Stammanteilen der Gesellschaft und eintausendfünfhundertsiebenundachtzig (1.587)

Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter

deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von zweitausendfünfhundert (2.500) Stammanteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
3.  Netris  B.V.,  eine  Gesellschaft  (Besloten  Vennootschap)  nach  dem  Recht  der  Niederlande,  mit  Sitz  in  Schiphol,

Niederlande, eingetragen im Handelsregister des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz in
Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, Niederlande,

Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société a responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesellschafts-
register  unter  der  Nummer  B  176.544,  mit  Sitz  in  6C,  rue  Gabriel  Lippmann,  L-5365  Munsbach,  Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000,00),

Inhaber von eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie A1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
5. JP Ventures UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter deutsch-

em Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Wehingen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart,
Deutschland, unter der Nummer HRB 733673, mit Geschäftssitz in Gosheimer Straße 48, 78564 Wehingen, Deutschland,

Inhaber  von  zweiundvierzig  (42)  Anteilen  der  Serie  A1  der  Gesellschaft  und  zehn  (10)  Anteilen  der  Serie  B1  der

Gesellschaft,

hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

25. Februar 2015;

6. Kaltroco Limited, eine Gesellschaft gegründet in Jersey, eingetragen unter der Nummer 60595, mit Geschäftssitz in

Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3AS,

Inhaber von zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A2 der Gesellschaft und dreihundertachtzehn (318)

Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
7. Phenomen Ventures LP, eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht der Kaimaninseln, Eintragungsnummer OG -

66003, mit Sitz in 89, Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Kaimaninseln,

Inhaber von zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteilen der Serie A3 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

24. Februar 2015;

8.  Mangrove  IV  Investments  S.à  r.l.,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  a  responsabilité  limitée),

gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund

82719

L

U X E M B O U R G

Gesellschaftsregister unter der Nummer B 189.521, mit Sitz in 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg,

Inhaber von dreitausenddreihundertvierunddreißig (3.334) Anteilen der Serie A4 der Gesellschaft und fünfhundertd-

reißig (530) Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft und zukünftiger Inhaber von sechshundertfünfunddreißig (635) Anteilen
der neu geschaffenen Serie B3 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
9. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft nach dem Recht der Bermuda-Inseln mit satzungs-

mäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda-Inseln, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda-
Inseln HM11,

Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A5 der Gesellschaft und fünfundneunzig (95) Anteilen der

Serie B1 der Gesellschaft und zukünftiger Inhaber von zweiundfünfzig (52) Anteilen der neu geschaffenen Serie B3 der
Gesellschaft,

hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
10. David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954, ansässig in 9 West 57 

th

 Street, 33 

rd

 Floor, New York, NY 10019,

Vereinigte Staaten von Amerika,

Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A5 der Gesellschaft und fünfundneunzig (95) Anteilen der

Serie B2 der Gesellschaft und zukünftiger Inhaber von zweiundfünfzig (52) Anteilen der neu geschaffenen Serie B3 der
Gesellschaft,

hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
11. Luktev GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in

Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 119212 B, mit Geschäftssitz in Mohrenstraße 60, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A5 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
12. Point Nine Capital Fund II GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmä-

ßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRA 45915 B, mit Geschäftssitz in Jägerstraße 65, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von dreihunderteinundachtzig (381) Anteilen der Serie A5 der Gesellschaft und siebenundachtzig (87) Anteilen

der Serie B1 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
13. Point Nine Co-Invest II GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem

Sitz  in  Berlin,  Deutschland,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts  Charlottenburg,  Deutschland,  unter  der
Nummer HRA 45911 B, mit Geschäftssitz in Jägerstraße 65, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von sechsunddreißig (36) Anteilen der Serie A5 der Gesellschaft und sieben (7) Anteilen der Serie B1 der

Gesellschaft,

hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
14. L’Arche B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

nach dem Recht der Niederlande, eingetragen im niederländischen Handelsregister der Handelskammern, unter der Num-
mer 59430982, mit Geschäftssitz in Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam, Niederlande,

Inhaber von eintausendfünfhundertsiebenundachtzig (1.587) Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
15. Mercura Capital GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem

Sitz in Starnberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Num-
mer HRB 200948, mit Geschäftssitz in Schießstättstraße 22, 82319 Starnberg, Deutschland,

Inhaber von siebenhundertvierundneunzig (794) Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
16.  SHCO  57  S.à  r.l.,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  a  responsabilité  limitée),  gegründet  und

bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register unter der Nummer B 183.425, mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Inhaber von vierhundertsechsundsiebzig (476) Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
17. Team Europe Ventures Ltd., eine Gesellschaft nach dem Recht von England und Wales mit satzungsmäßigem Sitz

in 69 Great Hampton Street, Birmingham, B18 6EW, Vereinigtes Königreich, eingetragen im Gesellschaftsregister von
Cardiff unter der Nummer 05831082, mit einer Zweigniederlassung in Mohrenstraße 60, 10117 Berlin, Germany, einge-
tragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 115038 B,

Inhaber von eintausendfünfhundertsiebenundachtzig (1.587) Anteilen der Serie B2 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;

82720

L

U X E M B O U R G

18. Lakestar I LP, eine Gesellschaft mit Eintragungsnummer OG - 55408, mit Geschäftssitz in PO Box 656, East Wing

Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3PP, Kaimaninseln, ausschließlich für die Punkte 4 ff. der
Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhalber von eintausendfünfhundertsiebenundachtzig (1.587) Anteile der neu geschaffenen Serie B3 der

Gesellschaft,

hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
19. Finvasco Capital Investments Ltd., eine Gesellschaft nach dem Recht von Zipern, eingetragen im Department of

Registrar of Companies and Official Receiver unter der Nummer HE 341867, mit Sitz im 67 Kennedy Avenue, Athienitis
Kennedy Park, 4 

th

 Floor, Office 401, 1076 Nicosia, Zipern, ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme-

und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhalber von neunhundertzweiundfünfzig (952) Anteile der neu geschaffenen Serie B3 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur paraphiert

wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. und 17. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind

alle Gesellschafter der Helpling Group Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in
5,  Heienhaff,  L-1736  Senningerberg,  Großherzogtum  Luxemburg,  eingetragen  im  Luxemburger  Handels-  und  Gesell-
schaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.677, gegründet am 7. Februar 2014 gemäß
einer Urkunde des unterzeichnenden Notars, welche am 28. April 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 1074 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt geändert am 27. February 2015
gemäß einer Urkunde von Maître Cosita Delvaux, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
veröffentlicht wurde.

Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet, und die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die fol-
gende Tagesordnung verhandeln, wobei die Parteien 18. und 19. (die „Neuen Investoren“) ausschließlich für die Punkte 4
ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) neuen Serie von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, und

zwar der Anteile der Serie B3, sodass die Gesellschaft nunmehr neun (9) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen
(die „Stammanteile“), Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie
A2“), Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“), Anteilen der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“), Anteilen der
Serie A5 (die „Anteile der Serie A5“), Anteilen der Serie B1 (die „Anteile der Serie B1“), Anteilen der Serie B2 (die
„Anteile der Serie B2“) und Anteilen der Serie B3 (die „Anteile der Serie B3“).

2. Aufnahme von Lakestar I LP und Finvasco Capital Investments Ltd., vorbenannt, als neue Gesellschafter der Ge-

sellschaft.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von dreißigtausendneunhunder-

tachtundsechzig Euro (EUR 30.968,00) um einen Betrag von dreitausendzweihundertachtundsiebzig Euro (EUR 3.278,00)
auf einen Betrag von vierunddreißigtausendzweihundertsechsundvierzig Euro (EUR 34.246,00) durch die Ausgabe von
dreitausendzweihundertachtundsiebzig (3.278) Anteilen der Serie B3 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00).

4.  Neufassung  der  Satzung  der  Gesellschaft,  um  die  Kapitalerhöhung  gemäß  dem  dritten  Beschluss,  sowie  weitere

Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage durch die Neuen Investoren wiederzugeben.

5. Verschiedenes.
Die Gesellschafterversammlung erkennt an, dass alle Bestehenden Gesellschafter zum Zwecke der vorstehenden Ta-

gesordnung auf die Verpflichtung der Zustimmung der Investoren zur Veränderung der Satzung der Gesellschaft gemäß
Artikel 16 der Satzung und auf Vorzugsrechte - außer wenn ausgeübt -, welche ihnen gemäß Artikel 5.3 der Satzung
zustehen könnten, einstimmig verzichtet haben.

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) neue Serie von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft

zu schaffen, und zwar die Anteile der Serie B3, sodass die Gesellschaft nunmehr neun (9) Anteilsklassen hat, bestehend
aus Stammanteilen, Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2, Anteilen der Serie A3, Anteilen der Serie A4, Anteilen
der Serie A5, Anteilen der Serie B1, Anteilen der Serie B2 und Anteilen der Serie B3.

82721

L

U X E M B O U R G

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Lakestar I LP und Finvasco Capital Investments Ltd., vorbenannt, als neue

Gesellschafter der Gesellschaft anzunehmen.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag

von dreißigtausendneunhundertachtundsechzig Euro (EUR 30.968,00) um einen Betrag von dreitausendzweihundertach-
tundsiebzig Euro (EUR 3.278,00) auf einen Betrag von vierunddreißigtausendzweihundertsechsundvierzig Euro (EUR
34.246,00) durch die Ausgabe von dreitausendzweihundertachtundsiebzig (3.278,00) Anteilen der Serie B3 mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die dreitausendzweihundertachtundsiebzig (3.278) Anteile der Serie B3 wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:
- eintausendfünfhundertsiebenundachtzig (1.587) Anteile der Serie B3 wurden ordnungsgemäß von Lakestar I LP, vor-

benannt, gezeichnet;

- neunhundertzweiundfünfzig (952) Anteile der Serie B3 wurden ordnungsgemäß von Finvasco Capital Investments

Ltd., vorbenannt, gezeichnet;

- sechshundertfünfunddreißig (635) Anteile der Serie B3 wurden ordnungsgemäß von Mangrove IV Investments S.à

r.l., vorbenannt, gezeichnet;

- zweiundfünfzig (52) Anteile der Serie B3 wurden ordnungsgemäß von TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd.,

vorbenannt, gezeichnet;

- zweiundfünfzig (52) Anteile der Serie B3 wurden ordnungsgemäß von Herrn David W. Zalaznick, vorbenannt, ge-

zeichnet.

<i>Zahlung

Die dreitausendzweihundertachtundsiebzig (3.278) Anteile der Serie B3 wurden vollständig wie folgt eingezahlt:
- die von Lakestar I LP, vorbenannt, gezeichneten eintausendfünfhundertsiebenundachtzig (1.587) Anteile der Serie B3

wurden vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendfünfhundertsiebenundachtzig Euro (EUR 1.587,00) ein-
gezahlt;

- die von Finvasco Capital Investments Ltd., vorbenannt, gezeichneten neunhundertzweiundfünfzig (952) Anteile der

Serie B3 wurden vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von neunhundertzweiundfünfzig Euro (EUR 952,00) einge-
zahlt;

- die von Mangrove IV Investments S.à r.l., vorbenannt, gezeichneten sechshundertfünfunddreißig (635) Anteile der

Serie B3 wurden vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von sechshundertfünfunddreißig Euro (EUR 635,00) einge-
zahlt;

- die von Finvasco Capital Investments Ltd., vorbenannt, gezeichneten zweiundfünfzig (52) Anteile der Serie B3 wurden

vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von zweiundfünfzig Euro (EUR 52,00) eingezahlt;

- die von Herrn David W. Zalaznick, vorbenannt, gezeichneten zweiundfünfzig (52) Anteile der Serie B3 wurden voll-

ständig durch eine Bareinlage in Höhe von zweiundfünfzig Euro (EUR 52,00) eingezahlt.

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlagen wurde dem unterzeichnenden Notar

erbracht.

Die Einlage in Höhe von dreitausendzweihundertachtundsiebzig Euro (EUR 3.278,00) wird vollständig dem Gesell-

schaftskapital zugeführt.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt eine vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um die Kapi-

talerhöhung gemäß dem dritten Beschluss, sowie weitere Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage durch die Neuen
Investoren wiederzugeben.

Die Satzung der Gesellschaft lautet nunmehr wie folgt:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Helpling Group Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1  Zweck  der  Gesellschaft  ist  das  Halten  von  Beteiligungen  jeglicher  Art  an  luxemburgischen  und  ausländischen

Gesellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

82722

L

U X E M B O U R G

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch  Aufnahme  von  Darlehen  in  jeglicher  Form  oder  mittels  Ausgabe  aller  Arten  von  Anleihen,  Wertpapieren  und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  durch  Beschluss  des  Rates  der  Geschäftsführer  im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt vierunddreißigtausendzweihundertsechsundvierzig Euro (EUR

34.246,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00),

5.1.2 eintausendsiebenhundertneun (1.709) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1,00),

5.1.3 zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“) mit einem Nominalwert von

je einem Euro (EUR 1,00),

5.1.4 zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1,00),

5.1.5 dreitausenddreihundertvierunddreißig (3.334) Anteilen der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) mit einem No-

minalwert von je einem Euro (EUR 1,00),

5.1.6 eintausendsechshundertachtundsechzig (1.668) Anteilen der Serie A5 (die „Anteile der Serie A5“) mit einem

Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), gemeinsam mit den Anteilen der Serie A1, den Anteilen der Serie A2, den
Anteilen der Serie A3 und den Anteilen der Serie A4 die „Anteile der Serie A“,

5.1.7 fünftausendvierhunderteinundneunzig (5.491) Anteilen der Serie B1 (die „Anteile der Serie B1“) mit einem No-

minalwert von je einem Euro (EUR 1,00),

5.1.8 eintausendsechshundertzweiundachtzig (1.682) Anteilen der Serie B2, mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B2“), und

5.1.9 dreitausendzweihundertachtundsiebzig (3.278) Anteile der Serie B3, mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B3“; die Anteile der Serie B1 gemeinsam mit den Anteilen der Serie B2 und den Anteilen
der Serie B3 im Folgenden auch die „Anteile der Serie B“; die Anteile der Serie A gemeinsam mit den Anteilen der Serie
B im Folgenden die „Vorzugsanteile“).

82723

L

U X E M B O U R G

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung, in einer

Gesellschaftervereinbarung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jeder der Gesellschafter Rocket Internet SE („Rocket“), Netris B.V. („Eiffel“), Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Ais-

mare“), JP Ventures UG (haftungsbeschränkt) („JP Ventures“), Kaltroco Limited („Kaltroco“), Phenomen Ventures LP
(„Phenomen“), Mangrove IV Investments S.à r.l. („Mangrove“), TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. („TJT“),
David W. Zalaznick („DZ“), Luktev GmbH („Luktev“), Team Europe Ventures Ltd. („Team Europe Ventures“, gemein-
schaftlich mit Luktev „Team Europe“), Point Nine Capital Fund II GmbH &amp; Co. KG („Point Nine Capital“), Point Nine
Co-Invest II GmbH &amp; Co. KG („Point Nine Co-Invest“, gemeinschaftlich mit Point Nine Capital „Point Nine“), L’Arche
B.V. („L’Arche“), SHCO 57 S.à r.l. („SHCO“), Mercura Capital GmbH („Mercura“), Lakestar I LP („Lakestar“) und
Finvasco Capital Investments Ltd. („Finvasco“; Finvasco gemeinschaftlich mit Rocket, Eiffel, Aismare, Kaltroco, Pheno-
men, Mangrove, TJT, DZ, Team Europe, Point Nine, L’Arche, SHCO, Mercura und Lakestar die „Investoren“ und jeweils
ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wo-
durch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine
mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drit-
tinvestor“) handelt), der mit einer Mehrheit des Beirats (wie in Artikel 25.5 definiert) zugestimmt wurde (wobei eine solche
Investition als „Investition eines Dritten“ bezeichnet wird) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem
oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft
vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines
Dritten. Der jeweilige Investor oder der bezugsberechtigte Gesellschafter gemäß diesem Artikel 5.3 hat die Gesellschaft
durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß dem
vorstehenden Satz dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren oder
anderen Gesellschafter (oder eine mit einem Investor oder einem anderen Gesellschafter im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) verbundene Gesellschaft) weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten

darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-

venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar, vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaf-

tervereinbarungen  zwischen  den  Gesellschaftern  der  Gesellschaft,  sofern  vorhanden,  insbesondere  vorbehaltlich  Vor-
kaufsrechten,  Bezugsrechten  oder  Mitverkaufsrechten-  oder  Pflichten  aus  Gesellschaftervereinbarungen  zwischen  den
Gesellschaftern der Gesellschaft übertragen werden.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung einer Mehrheit von fünf-

undsiebzig Prozent (75%) der Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft (wobei eine solche Mehrheit als „Qualifizierte
Mehrheit“ bezeichnet wird) und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Ge-
sellschaftern der Gesellschaft, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mit-
verkaufsrechten-  oder  Pflichten  aus  Gesellschaftervereinbarungen  zwischen  den  Gesellschaftern  der  Gesellschaft
übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Übertragung von An-
teilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung (wie in Artikel 8.1 definiert) oder jeglichen anderen Veräußerung durch einen Investor an

eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung durch einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche

direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden

82724

L

U X E M B O U R G

Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsa-
men Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte
oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnet, durch (a) die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender
Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine
vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung
und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu be-
einflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte
oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3 bei einer Veräußerung durch Lakestar I an einen bona fide Fond, der benannt wurde und der durch die Führungs-

gesellschaft von Lakestar I beraten und/oder verwaltet ist.

7.4.4 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung (i) an einen Dritten, welcher Anteile unter einer, sofern

von den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung beschlossen, vereinfachten Mitarbeiterbe-
teiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusam-
menhang mit einer Vesting-Regelung, die gemäß einer solchen vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung eingeführt wurde;

7.4.5 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung im Rahmen von Umwandlungsvorgängen gemäß des

Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmelzung der Gesellschaft, sofern
die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer
überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.5 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung oder jegliche andere Veräußerung wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel

1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung in
Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn einer solchen Übertragung mit einer Qualifizierten Mehrheit zugestimmt wird (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die
Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des
verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) einer Übertragung von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines

Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren verbun-
denen Transaktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) einer Übertragung von mindestens 50% des Vermögens
oder der Geschäfte der Gesellschaft in einer oder mehreren verbundenen Transaktionen oder (iii) einer Übertragung eines
wesentlichen Teils der Rechte des geistigen Eigentums der Gesellschaft in einer oder mehreren verbundenen Transaktionen
oder (iv) der Liquidation oder der de facto-Liquidation der Gesellschaft (insbesondere nach einem Asset Deal) oder (v)
eines Verkaufs oder einer Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter,
was dazu führen würde, dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des eingetragenen Gesellschaftskapitals oder mehr
als fünfzig Prozent (50%) der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als
Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im
Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) - vorbehaltlich des Artikels 8.2 -
im Einklang mit Artikel 8.3 auf einer pro rata-Basis (i) entsprechend ihrer Beteiligung am eingetragenen Gesellschaftska-
pital der Gesellschaft im Falle einer Vermögensübertragung, oder (ii) entsprechend der Anzahl der im Liquiditätsereignis
verkauften Anteile (soweit anwendbar) im Falle einer Anteilsübertragung an die Gesellschafter verteilt.

„Übertragung“ meint, im Hinblick auf Vermögenswerte (einschließlich, ohne Beschränkung, Anteile und Rechte des

geistigen Eigentums), eine Übertragung, eine Abtretung, einen Verkauf, eine Verpfändung (pledge), eine Beleihung (hy-
pothecation),  eine  Belastung  oder  andere  Veräußerung  dieses  Vermögenswertes  oder  damit  verbundener  Rechte  und
Pflichten, ob absichtlich oder unabsichtlich, einschließlich einer Option hinsichtlich jeder der vorgenannten Handlungen.

„Belastung“/„Belastet“ meint Belastungen jedweder Art, einschließlich Hypotheken, Belastungen (charge), Obligatio-

nen,  Verpfändungen,  Beleihungen,  Pfandrechte,  Sicherungsrechte,  Eigentumsvorbehalte,  Optionsrechte,  Erwerbsoder
Bezugsrechte, Verkaufs- oder Übertragungsbeschränkungen, Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Rechte oder Interessen eines
Dritten, Forderungen, Trust-Arrangements, Verträge bezüglich der Übertragung von Wertpapieren, anderer Belastungen
oder anderer Sicherungsrechte jeder Art oder anderer Vorzugsvereinbarungen oder Eigenkapital oder anderer Einschrän-
kungen oder Beschränkungen jedweder Art (einschließlich, ohne Beschränkung, Übertragungsabkommen von Titeln oder
Vorbehaltsvereinbarungen, Vorverträge oder andere Vereinbarungen bezüglich einer der vorgenannten Handlungen) mit
ähnlicher Wirkung;

8.2 Auf einer ersten Vorzugsebene („Erste Vorzugsebene”) erhält jeder Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag,

welcher dem Betrag seiner jeweiligen Gesamtinvestition entspricht, die er getätigt hat, um seine jeweiligen von ihm ge-
haltenen Anteile der Serie B zu erwerben (bestehend aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile
der Serie B und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Konten-
plans), die von dem jeweiligen Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht ausreichend Exiterlöse für die

82725

L

U X E M B O U R G

Zahlungen auf der Ersten Vorzugsebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an jeden Inhaber der Anteile der Serie B auf
einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an diesen Inhaber auf der Ersten Vorzugsebene verteilt worden wären,
wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.

8.3 Auf einer zweiten Vorzugsebene („Zweite Vorzugsebene”) erhält jeder Inhaber von Anteilen der Serie A einen

Betrag, welcher dem Betrag seiner jeweiligen Investition entspricht, die er zum Erwerb seiner jeweiligen von ihm gehalt-
enen  Anteile  der  Serie  A  getätigt  hat  (d.h.  den  jeweiligen  Nominalbetrag  der  Anteile  der  Serie  A  und  die  jeweilige
zusätzliche Einzahlung). Sind nicht ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der Zweiten Vorzugsebene vorhanden,
so werden die Exiterlöse an jeden Inhaber der Anteile der Serie A auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an
diesen Inhaber auf der Zweiten Vorzugsebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen
wären.

8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Vorzugsebene und der Zweiten Vorzugsebene geleistet wurden, werden die

übrigen Exiterlöse auf einer gemeinsamen Ebene („Gemeinsame Ebene“) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer
pro rata-Basis entsprechend den jeweiligen Anteilen, die im Zusammenhang mit dem Liquiditätsereignis veräußert wurden,
verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf einer Vorzugsebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesell-
schafter zu erhaltenden Betrag auf der Gemeinsamen Ebene; mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung
eines auf der Ersten Vorzugsebene und/oder der Zweiten Vorzugsebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Exiterlöse,
welche nach der Verteilung gemäß dieses Artikels 8.4 nicht zugeteilt wurden, werden auch im Einklang mit diesem Artikel
8.4 durch die wiederholte Anwendung des Artikels 8.4 verteilt, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden.
Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Ge-
sellschafter  für  den  Verkauf  all  seiner  Anteile  einen  Betrag  zu  erhalten  (und  übersteigende  Beträge  an  die  anderen
Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse auf einer pro rata-Basis
zu den verkauften Anteilen, oder (ii) als der Betrag seiner Investition in die Gesellschaft (Zahlung des Kaufpreises für eine
eventuelle Vorratsgesellschaft, Einzahlung des Gesellschaftskapitals, einschließlich ggf. des Agios, und Einzahlungen auf
Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans „apport en capitaux propres non rémunérés par des titres“
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (zusätzliche Beträge)) in Bezug auf die verkauften Anteile. Werden
Anteile der Gesellschaft in mehr als einer Transaktion verkauft, so hat kein Gesellschafter weniger Erlöse zu erhalten, als
er erhalten hätte, wenn die Anteile der Gesellschaft in einer Transaktion verkauft worden wären.

8.5 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten Vorzugsebene und der Zweiten Vorzugsebene gilt zugunsten des ent-

sprechenden Investors solange, wie dieser (einschließlich von Verkäufen vor einem Liquiditätsereignis) den vollständigen
Betrag, der an diesen Gesellschafter gemäß der Ersten Vorzugsebene und/oder der Zweiten Vorzugsebene zu verteilen ist,
noch nicht erhalten hat.

Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.

82726

L

U X E M B O U R G

10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist diese Aus-

gleichszahlung von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemein-
schaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser
auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondisse-
ment)  bestimmt.  Die  Entscheidung  des  Schiedsgutachters  ist  bindend.  Die  Kosten  für  das  Gutachten  werden  von  der
Gesellschaft und dem betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende
Teil mit der Ausgleichszahlung für den Rückkauf verrechnet und die Ausgleichszahlung für den Rückkauf dementspre-
chend  herabgesetzt  wird.  Der  Gesellschafter  hat  die  übrigen  Kosten  zu  tragen,  sofern  die  Ausgleichszahlung  für  den
Rückkauf die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.

11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschrif-

ten  des  Abschnitts  XII  des  Gesetzes  von  1915  und  dieser  Satzung  aus.  In  diesem  Fall  ist  jede  Bezugnahme  auf  die
„Gesellschafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusam-
menhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleinge-
sellschafter ausgeübt.

Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche in

der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

13.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

82727

L

U X E M B O U R G

13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine schrift-

liche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer unter der
Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung  anwesenden  oder  vertretenen  Gesellschaftern  zu  unterzeichnen  (als  Nachweis,  nicht  als  Voraussetzung  für  die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Ge-

sellschaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres  Mehrheitsverhältnis  vorsehen,  bedürfen  gemeinsame  Entscheidungen  der  Gesellschafter  der  Zustimmung  von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich
im  Einklang  mit  Artikel  13.2  eine  neue  Gesellschafterversammlung  mit  derselben  Tagesordnung  einzuberufen.  Diese
Gesellschafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf
in der die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen gefasst.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen, die die Zustimmung aller In-

vestoren vorausgesetzt. Änderungen dieser Satzung, durch welche die Rechte der Inhaber der Vorzugsanteile erheblich
oder nachteilig beeinflusst werden, bedürfen der Zustimmung aller Inhaber dieser Vorzugsanteile.

Art. 17. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und

zudem die Zustimmung des Beirats:

17.1.1 Abschluss, Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Ak-

tiengesetzes (AktG));

17.1.2 Abschluss oder Änderung von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräu-

ßerung von Anteilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere
Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der
Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich
Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wur-
den, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und
Werbepartnern.

17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte
Mehrheit und zudem die Zustimmung aller Investoren:
17.2.1 wesentliche Änderungen des Geschäftszwecks der Gesellschaft oder jegliche wesentliche Modifikation der Ge-

schäftsfelder der Gesellschaft oder die Aufgabe bestehender und die Aufnahme neuer Geschäftsfelder;

17.2.2 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.3 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung;

17.2.4 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

17.2.5 Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
17.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer

Art. 18. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1  Die  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer  geleitet.  Falls  die  Gesellschaft  mehrere  Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

82728

L

U X E M B O U R G

18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und ihre

Amtszeit festlegt.

19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschluss festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterver-
sammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige
Ernennung entscheidet.

20.2  Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem  Amt  ausscheidet,  muss  die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des

Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-

punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-

ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-

führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

22.2  Sitzungen  des  Rates  der  Geschäftsführer  werden,  falls  vorhanden,  durch  den  Vorsitzenden  des  Rates  der  Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikations-
mittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

82729

L

U X E M B O U R G

22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, oder per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maß-

nahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im
Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:

22.8.1 Genehmigung des Jahresplans, einschließlich des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr;
22.8.2 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Betrag von zweihundert-

tausend Euro (EUR 200.000,00) übersteigen;

22.8.3 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transak-

tionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.4 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungverpflichtungen jeglicher Art;
22.8.5 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

22.8.6 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streitwert

von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

22.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen;
22.8.8 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder dokumentiertem Wissen durch die Gesellschaft an einen

Dritten, die außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs liegt;

22.8.9 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag solcher

Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln;

22.8.10 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Aktienoptionen) mit Ausnahme der Schaffung einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den Ge-
sellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.

22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,

so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und Maßnah-
men auch im Voraus erteilen.

22.10 Die Gesellschafter können durcheinenGesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des Alleinigen Ge-

schäftsführers.

23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden),
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B),
bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter).

23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer  hat,  durch  die  gemeinsamen  Unterschriften  zwei  (2)  beliebiger  Geschäftsführer  wirksam  verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder

82730

L

U X E M B O U R G

deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat gebildet (der „Beirat“). Dieser besteht aus zehn (10) stimmberechtigten Mitglie-

dern, jeweils mit der in diesem Artikel 25 angegebenen Anzahl an Stimmen. Die Gesellschafter können durch einstimmige
Zustimmung der Gesellschafter (i) die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats erhöhen oder herabsetzen und/
oder (ii) die jeweilige Anzahl der Stimmen erhöhen oder herabsetzen.

25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-

schafter festlegen und/oder verändern.

25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

25.3.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats, von denen eines über drei (3) Stimmen und eines über zwei

(2) Stimmen verfügt, werden von dem Investor Rocket nach eigenem Ermessen ernannt (die „Rocket-Mitglieder“);

25.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor Aismare

nach eigenem Ermessen ernannt (das „Aismare-Mitglied“);

25.3.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor Phe-

nomen nach eigenem Ermessen ernannt (das „Phenomen-Mitglied“);

25.3.4 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor Mang-

rove nach eigenem Ermessen ernannt (das „Mangrove-Mitglied“);

25.3.5 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor L‘Arche

nach eigenem Ermessen ernannt (das „L‘Arche-Mitglied“);

25.3.6 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor Mercura

nach eigenem Ermessen ernannt (das „Mercura-Mitglied“);

25.3.7 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor SHCO

nach eigenem Ermessen ernannt (das „SHCO-Mitglied“);

25.3.8 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor Team

Europe nach eigenem Ermessen ernannt (das „Team Europe-Mitglied“);

25.3.9 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor Lakestar

nach eigenem Ermessen ernannt (das „Lakestar-Mitglied“).

25.4 Jeder Investor, der nicht zur Ernennung eines stimmberechtigten Mitglieds des Beirats gemäß Artikel 25.3 be-

rechtigt ist, darf ein nichtstimmberechtigtes Mitglied des Beirats als Beobachter ernennen.

25.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, wobei keiner von beiden eine ent-

scheidende Stimme und/oder zusätzliche Rechte und/oder Befugnisse hat, die sich von denen der anderen Mitglieder des
Beirats unterscheiden. Eines der Rocket-Mitglieder ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats hat
weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten. Vorbehaltlich anderer
Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarungen bezüglich
der Gesellschaft, sofern vorhanden, fasst der Beirat Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen (die
„Mehrheit des Beirats“). Darüber hinaus fasst der Beirat für bestimmte Maßnahmen, die sich aus einer Gesellschafterver-
einbarung ergeben, Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern die Ja-Stimmen von zumindest
drei  (3)  der  folgenden  Mitglieder  abgegeben  worden  sind:  Aismare-Mitglied  und/oder  Phenomen-Mitglied  und/oder
Mangrove-Mitglied und/oder L’Arche-Mitglied und/oder Mercura-Mitglied und/oder SHCO-Mitglied und/oder Team Eu-
rope-Mitglied  und/oder  Lakestar-Mitglied  und/oder  jedem  anderen  Mitglied  des  Beirats,  das  nach  dem  Datum  dieser
Satzung ernannt wird (die „Qualifizierte Mehrheit des Beirats“). Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens
einmal pro Kalenderquartal.

25.6 Vorbehaltlich anderer Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesell-

schaftervereinbarungen bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, hat der Beirat eine beratende Funktion und wird
nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

26.2 Ein Rechnungsprüferkann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüferhaben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

82731

L

U X E M B O U R G

26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.

26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-

sellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-

klang  mit  den  gesetzlichen  Anforderungen  ein  Inventar  der  Aktiva  und  Passiva,  eine  Bilanz  und  eine  Gewinn-  und
Verlustrechnung.

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3 Durch einen GesellschaftererbrachteEinlagenin Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-

falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-

mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-

stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls - im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 -
verteilt und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenen-
falls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene
Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die

Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der
Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft
eingehen und durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung
mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft in Widerspruch stehen, so ist die
Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

<i>Kosten und Auslagen

Die  Kosten,  Auslagen,  Honorare  und  Gebühren  jeglicher  Art,  die  von  der  Gesellschaft  zu  tragen  sind,  werden  auf

ungefähr EUR 1.800,-geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

82732

L

U X E M B O U R G

Der  unterzeichnende  Notar,  der  die  englische  Sprache  beherrscht  und  spricht,  erklärt  hiermit,  dass  die  vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/12337. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Mai 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015073225/1539.
(150083272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

La Varenne Gastronomie Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.

R.C.S. Luxembourg B 174.846.

L'an deux mille quinze, le vingt-et-un avril.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg),

ONT COMPARU:

1.- G. Willems Holding B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, avec siège social à NL-1412DD

Naarden,  Vincent  van  Goghlaan  4,  inscrite  à  la  Chambre  de  Commerce  de  Gooi-,  Eem-et  Flevoland  sous  le  numéro
34224292,

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé lui délivrée.

2.- Tacking B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, avec siège social à NL-3743HK Baarn, de

Genestetlaan 8, inscrite à la Chambre de Commerce de Gooi-, Eem-et Flevoland sous le numéro 32171719,

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé lui délivrée.

3.-  STICHTING  VAN  HÖVELL  TOT  WESTERFLIER,  une  fondation  de  droit  néerlandais,  avec  siège  social  à

NL-3744MA Baarn, Amsterdamsestraatweg 39B, inscrite à la Chambre de Commerce de Gooi-, Eem-et Flevoland sous
le numéro 56956231,

ici  représentée  Monsieur  Henri  DA  CRUZ,  employé,  demeurant  professionnellement  à  Junglinster,  en  vertu  d’une

procuration donnée sous seing privé lui délivrée.

Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le notaire et le mandataire, resteront annexées au

présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter:
- que les comparantes sont les seules et uniques associeés actuelles de la société à responsabilité limitée «La Varenne

Gastronomie Holding S.à r.l.», (la «Société»), établie et ayant son siège social à L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale
1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 174.846, constituée suivant acte
reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 31 décembre 2012, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 701 du 22 mars 2013, et que les statuts n’ont pas été modifiés
depuis.

- qu'en leur qualité d’associées, représentant l’intégralité du capital social de la société, elles se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’annuler la valeur nominale des mille (1.000) parts sociales existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant de sept cent soixante-dix-

neuf mille cent euros (EUR 779.100,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions quatre cent vingt-deux mille
euros (EUR 3.422.000,-) à un montant de quatre millions deux cent et un mille cent euros (EUR 4.201.100,-) sans création
de nouvelles parts sociales.

82733

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription - Libération

Le montant de sept cent soixante-dix-neuf mille cent euros (EUR 779.100,-) est libéré comme suit:
- par l’apport en nature de trois mille (3.000) parts sociales de la société MARTINO S.à r.l., avec siège social à L-6776

Grevenmacher, 2, route Nationale 1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
182.464 appartenant à G. Willems Holding B.V., précitée et représentée comme dit ci-avant, évaluées à EUR 233.730.

- par l’apport en nature de trois mille (3.000) parts sociales de la société MARTINO S.à r.l., avec siège social à L-6776

Grevenmacher, 2, route Nationale 1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
182.464 appartenant à Tacking B.V., précitée et représentée comme dit ci-avant, évaluées à EUR 233.730.

- par l’apport en nature de trois mille (4.000) parts sociales de la société MARTINO S.à r.l., avec siège social à L-6776

Grevenmacher, 2, route Nationale 1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
182.464 appartenant à STICHTING VAN HÖVELL TOT WESTERFLIER, précitée, évalués à EUR 311.640.

<i>Évaluation

La valeur dudit apport a été fixée à sept cent soixante-dix-neuf mille cent euros (EUR 779.100,-) et a été évaluée par

les souscripteurs.

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Mise en oeuvre effective de l’apport

Les souscripteurs ici présents, déclarent expressément que:
(i) les souscripteurs sont les seuls propriétaires de tous les parts sociales précitées;
(ii) les parts sociales sont libres de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iii) les parts sociales apportées ne font l’objet d’aucune contestation ou action en justice;
(iv) les parts sociales apportées sont librement transférables, avec tous les droits y attachés;
(v) «MARTINO S.à r.l.» est dûment constituée et existe valablement;
(vi)  à  leur  connaissance,  «MARTINO  S.à  r.l.»  ne  fait  l’objet  d’aucune  procédure  judiciaire  de  faillite,  liquidation,

dissolution ou de transfert d’actifs à ses créanciers, et il n’existe aucun fait ni aucune circonstance à la date des présentes
qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires;

(vii) pour autant que de besoin, tous les actes ou formalités ont été accomplis et tous les consentements et approbations

nécessaires ont été obtenus afin d’autoriser le transfert des Actions; et

(viii)  l’ensemble  des  formalités  subséquentes  au  transfert  des  Actions  requise  en  vertu  de  toute  loi  applicable  sera

accompli afin que l’apport des Actifs soit valable en tout lieu et à l’égard de tout tiers.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de remplacer les mille (1.000) parts sociales existantes par dix mille (10.000) parts sociales

de sorte que la nouvelle répartition des parts sociales est comme suit:

G. Willems Holding B.V., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

Tacking B.V., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

STICHTING VAN HÖVELL TOT WESTERFLIER, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.020

Total: dix mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social d’un montant de six cent vingt-cinq mille euros (EUR 625.000,-),

pour le porter de son montant actuel de quatre millions deux-cent-et-un mille cent euros (EUR 4.201.100,-) à trois millions
cinq cent soixante-seize mille cent euros (EUR 3.576.100,-) par remboursement aux associés et avec annulation de quatre
mille (4.000) parts sociales comme suit:

- soixante-et-un mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 61.875,-) seront remboursés à G. Willems Holding B.V.

précitée, avec annulation de trois cent quatre-vingt-seize (396) parts sociales;

- soixante-et-un mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 61.875,-) seront remboursés à Tacking B.V., précitée, avec

annulation de trois cent quatre-vingt-seize (396) parts sociales;

- cinq cent un mille deux cent cinquante euros (EUR 501.250,-) seront remboursés à STICHTING VAN HÖVELL TOT

WESTERFLIER, précitée, avec annulation de trois mille deux cent huit (3.208) parts sociales.

Les quatre mille (4.000) parts sociales ont une valeur de marché de six cent vingt-cinq mille euros (EUR 625.000).

<i>Cinquième résolution

L'assemblée  générale  décide  d'augmenter  le  capital  social  d'un  montant  de  cent  soixante-quinze  mille  euros  (EUR

175.000,-), pour le porter de son montant actuel de trois millions cinq cent soixante-seize mille cent euros (EUR 3.576.100,-)
à trois millions sept cent cinquante-et-un mille cent euros (EUR 3.751.100,-), sans création de nouvelles parts sociales.

82734

L

U X E M B O U R G

Le montant de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,-) a été libéré par un apport en nature d’une créance

existant au profit de

- G. Willems Holding B.V., précitée, d’un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-) et
- Tacking B.V., précitée, d’un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-),
et en annulation de cette même créance à due concurrence.
La justification de l'existence de ladite créance a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables

(rapport d’évaluation).

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide, en conséquence de ce qui précède de modifier l’article 6.1 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

Version anglaise:

“ Art. 6.1. The Company's share capital is fixed at three million seven hundred fifty-one thousand one hundred Euro

(EUR 3,751,100.-) represented by six thousand (6,000) shares ("parts sociales") (hereafter, the "Shares"), without a nominal
value, all fully subscribed and entirely paid-up.”

Version française:

«  Art. 6.1.  Le  capital  social  est  fixé  à  trois  millions  sept  cent  cinquante-et-un  mille  cent  euros  (EUR  3.751.100,-),

représenté par six mille (6.000) parts sociales sans valeur nominale, toutes entièrement souscrites et libérées.»

DONT ACTE, fait et passé Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 avril 2015. Relation GAC/2015/3573. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015073280/118.
(150083404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Sinal Capital SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 163.296.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of April,
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg (herei-

nafter referred to as the “Notary”).

THERE APPEARED

MR. SERGEY DRUGOV, a citizen of Russian Federation, born on 29 May 1965 in Tver region, USSR and residing at

11/2, Letchika Babushkina street, building 2, apt 135, Moscow, Russian Federation,

(hereinafter referred to as the "Appearing Party").
here represented by Mr Max MAYER, employee, professionally residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg

by virtue of a proxy given on 16 February 2015 (hereinafter referred to as the “Proxyholder”),

Such Appearing Party is the sole shareholder of SINAL CAPITAL SPF S.A., a Luxembourg public limited liability

company (société anonyme), duly incorporated and existing under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and being registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (hereinafter referred to as the “R.C.S.”) under number B
163.296 and whose articles of incorporation (hereinafter referred to as the “Articles”) have been published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter referred to as “Mémorial C”) under number 2133, page 102338 on 13

th

 September 2011 and have not been amended since that time (hereinafter referred to as the “Company”).

The Appearing Party representing the whole corporate capital require the Notary to act the following declarations and

statements:

1. That the share capital of the Company currently amounts to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented

by thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

2. That pursuant to the shareholders register of the Company, the Appearing Party is the sole shareholder of the Company.

82735

L

U X E M B O U R G

3. That the latest annual accounts of the Company have been approved by the Appearing Party and duly submitted to

R.C.S. for the purposes of publication.

4. That the Appearing Party, acting in its capacity of the sole shareholder, declares the anticipated dissolution of the

Company with immediate effect followed by its liquidation.

5. That the Appearing Party declares that it has full knowledge of the Articles of the Company and that it is fully aware

of the financial situation of the Company.

6. That the Appearing Party, acting in its capacity of the sole shareholder, appoints itself liquidator of the Company and

declares that the activity of the Company has ceased.

7. That in that capacity, the Appearing Party requests the Notary to record that it has realised all of the Company's assets

and has settled all liabilities and debts of the Company by way of payment or fully provided for of all of the known liabilities
of the Company.

8. That the Appearing Party is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume

liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to the sole
shareholder.

9. That consequently, the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed.
10. That the full and complete discharge is granted to the sole director of the Company for the execution of its mandate

up to this day.

11. That it is expedient to proceed with the cancellation of the shareholders register.
12. That the books and records of the Company shall be kept for at least five years at the former registered office of the

dissolved Company being 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by

reason of the present deed are assessed at EUR 1,785.-.

Whereof, the present deed is drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned Notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the Appearing Party and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.

The document having been read to the Proxyholder of the Appearing Party known to the Notary by her name, first name,

civil status and residence, the Proxyholder of the Appearing Party signed together with the Notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-huit avril,
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire, de résidence au Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné (ci-

après le «Notaire»).

A COMPARU

M. SERGEY DRUGOV, le citoyen de la Fédération de Russie, né le 29 mai 1965 à la région de Tver, URSS et résidant

à 11/2, Letchika Babushkina street, building 2, app. 135, Moscou, Fédération de Russie,

(ci-après la "Personne Comparante").
ici-représenté par Monsieur Max MAYER, emlpoyé, résidant professionnellement à Junglinster, Grand Duché de Lu-

xembourg en vertu du mandat octroyé le 16 février 2015 (ci-après le «Mandataire»),

Telle Personne Comparante est l'actionnaire unique de SINAL CAPITAL SPF S.A., une société anonyme luxembour-

geoise, dûment constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg (ci-après le "R.C.S.") sous le numéro B 163.296, dont les statuts (ci-après les "Statuts") ont
été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après le "Mémorial C") le 13 septembre 2011, sous
numéro 2133, page 102338 et n'ont été modifiés depuis cette date (ci-après la "Société").

La Personne Comparante représentant la totalité du capital social demande le Notaire d'acter les déclarations et cons-

tatations suivantes:

1. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente-une mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente-

une mille (31,000) actions ayant la valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

2. Que selon le registre des actionnaires de la Société la Personne Comparante est l'actionnaire unique de la Société.
3. Que les derniers comptes annuels de la Société ont été approuvés par la Personne Comparante et dûment déposés

auprès du R.C.S. à des fins de la publication.

4. Que la Personne Comparante, en tant que l'actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec

effet immédiat et sa mise en liquidation.

82736

L

U X E M B O U R G

5. Que la Personne Comparante déclare avoir pleine connaissance des Statuts de la Société et est pleinement consciente

de la situation financière de la Société.

6. Que la Personne Comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne liquidatrice de la Société et déclare que l'activité

de la Société est cessée.

7. Qu'en cette qualité, la Personne Comparante requiert le Notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réalisé tous

les actifs de la Société et avoir réglé tout le passif de la Société par payement ou entière approvisionnement des dettes
connues de la Société.

8. Que la Personne Comparante, étant investie de tous les avoirs, déclare expressément prendre à sa charge et assumer

toute responsabilité pour tout passif connu mais impayé et pour toutes dettes encore inconnues de la Société avant tout
paiement à l'actionnaire unique.

9. Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme ayant été effectuée et terminée.
10. Que décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur unique de la Société pour l'exécution de son mandat

jusqu'à ce jour.

11. Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des actionnaires.
12. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à son ancien siège

social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Coûts et frais

Les coûts, frais, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en

conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement 1.785,- EUR.

Sur quoi le présent acte a été établi à Junglinster, à la date mentionnée au début du présent acte.
Le Notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que le présent acte est dressé en langue anglaise

suivi d'une traduction française; à la demande de la Personne Comparante et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Après que lecture de l'acte a été faite au Mandataire de la Personne Comparante, connu du Notaire par son nom, prénom,

statut marital et lieu de résidence, ledit Mandataire de la Personne Comparante a signé ensemble avec le Notaire le présent
acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 06 mai 2015. Relation GAC/2015/3867. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015073435/113.
(150083586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Solar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 154.316.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015073446/9.
(150083679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Somuchmore GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.469.

Die koordinierte Satzung vom 23/04/2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18/05/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notar

Référence de publication: 2015073449/12.
(150083329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

82737

L

U X E M B O U R G

SOLIT Information Security S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6841 Machtum, 59, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 143.625.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015073478/9.
(150083457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

SPC Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 33.235.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015073480/9.
(150083223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Fusion Orientale, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3515 Dudelange, 210, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg F 10.396.

STATUTS

- Candice Mayembo, de nationalité Française, employée secteur privé, 24 avenue de Luxembourg, B-6700 Arlon, Bel-

gique

- Jonathan Walter, de nationalité Française, employé secteur privé, 24 avenue de Luxembourg, B-6700 Arlon, Belgique
- Charlotte Gresset, de nationalité Française, podologue, 16, rue Garibaldi F-54190 Villerupt, France
Déclarent constituer entre eux une association sans but lucratif, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les

associations et fondations sans but lucratif.

1. Dénomination sociale, durée, siège et objet social

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination «FUSION ORIENTALE» Association sans but lucratif.

Art. 2. L'Association est constituée pour une durée illimitée

Art. 3. Le siège social de l’Association est établi au 210 Route de Luxembourg, L-3515 à Dudelange. Il pourra être

transféré à tout autre tout autre lieu au Grand Duché du Luxembourg par simple décision de Conseil d'Administration.

Art. 4. L’Association a pour objet:
En premier lieu, de promouvoir la pratique des danses orientales et tribales fusion
D’organiser ou de participer à des manifestations de tous genres se rapportant de près ou de loin aux danses orientales

et tribales fusion.

Cette énumération se veut indicative et non limitative.

2. Membres, admissions, démissions, exclusions, cotisations

Art. 5. Les membres sont admis à la suite d’une demande écrite. Le conseil d’administration se réserve le droit de refuser

l’admission d’un membre.

Art. 6. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite au

conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 1 mois à compter du jour de l’échéance tout membre
qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 7. Les membres peut être exclus de l’association, si d’une manière quelconque, ils portent atteinte aux intérêts de

l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu'à la décision définitive
de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion est envisagée est suspendu
de plein droit de ses fonctions sociales.

3. Droits et devoirs des membres

Art. 8. Les membres sont obligés de:
- d’assister à l’assemblée générale

82738

L

U X E M B O U R G

- de payer régulièrement la cotisation annuelle, semestrielle ou trimestrielle selon le cas
- Suivre les dispositions des présents statuts et des décisions prises par l'Assemblée générale

Art. 9. Les membres sont autorisés à:
- participer aux élections et à toutes décisions prises lors de l'Assemblée générale.
- participer à toutes les manifestations sous conditions fixées par le Conseil d'administration.

Art. 10. La cotisation est proposée par le conseil d’administration et approuvée par l'assemblée générale. Elle ne peut

pas être supérieure à 200 Euros par trimestre.

4. Organes administratifs

Art. 11. L'assemblée est administrée par les organes suivants:
- L'assemblée générale
- Le conseil d'administration

Art. 12. L'assemblée générale représente l'ensemble des membres, elle décide définitivement sur tous les points qui ne

sont pas prévus dans les présents statuts et toutes les décisions prises conforment aux présents statuts sont juridiquement
obligatoires pour tous les membres de l'association. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration
une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent.

Art. 13. La convocation se fait par voie écrite ou orale au moins cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée générale.

La convocation indique l'ordre du jour.

Art. 14. Sauf ceux lui attribués par les articles des présents statuts, les compétences sont en principal les suivantes
- la modification des statuts;
- la nomination et la révocation des administrateurs;
- l’approbation des budgets et des comptes;
- la dissolution de la société.
L'assemblée générale est présidée par le président ou par son remplaçant. Ses décisions sont prises à la majorité des

voix.

Art. 15. Les décisions de L'assemblée générale sont prises à la majorité des voix à l'exception des modifications aux

présents statuts. Pour la modification des statuts ou pour la dissolution de l'association, la présence de 2/3 des membres est
requise et une majorité de 2/3 des membres présents.

Art. 16. L'association est gérée par un conseil d'administration qui se compose d'un président, d'un secrétaire et d'un

trésorier.

Art. 17. Le conseil d'administration représente l'association dans toutes les affaires commerciales, gère le patrimoine en

observation des dispositions statutaires et légales. Il prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage des voix,
celle du président ou de son remplaçant, est prépondérante.

5. Comptes et Bilans

Art. 18. L'exercice commence au 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

6. Dissolution de l'association

Art. 19. En cas de dissolution de l'association, les biens liquides seront transférés à une autre association.

7. Divers

Art. 20. Pour ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la législation en vigueur respectivement au

règlement interne.

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication de modifications qui se sont produites et ce

au 31 décembre.

Art. 22. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale les comptes de l'exer-

cice écoulé et le budget du prochain exercice.

Les présents statuts de l'association sont arrêtés, approuvés et signés à Dudelange, le 6 mars 2015.
Référence de publication: 2015073814/81.
(150084092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

82739

L

U X E M B O U R G

Ideal-Lux, Société à responsabilité limitée,

(anc. T.E.A. Oriental Sàrl).

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 2, route de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 135.313.

L'an deux mille quinze,
Le trente avril,
Pardevant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange, soussigné,

Ont comparu:

1. Monsieur Habib ABID, chef de chantier, né à Créhange (France), le 18 janvier 1960, demeurant à L-4025 Esch-sur-

Alzette, 2, rue de Belvaux,

2. Monsieur Olivier TULLII, commercial, né à Villerupt (France), le 22 novembre 1972, demeurant à F-54190 Villerupt,

47, rue Paul Nicou,

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Les comparants, prénommés, sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "T.E.A. ORIENTAL S.à r.l.",

ayant son siège social à L-4025 Esch-sur-Alzette, 2, rue de Belvaux, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 135 313,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank MOLITOR, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du 21 décembre

2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 349 du 11 février 2008.

Lesquels comparants agissant en lieu et place de l'assemblée générale, ont pris la résolution unique suivante:

<i>Unique résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la Société en «IDEAL-LUX» et de modifier par conséquent l'article

premier (1 

er

 ) des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de «IDEALLUX».»

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de cette assemblée générale à environ sept cent cinquante

euros (750.-€).

DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentaire par

noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. ABID, O. TULLII, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 mai 2015. Relation: EAC/2015/10518. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 12 mai 2015.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2015074185/40.
(150084437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

Schuler Romain S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 48-52, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 84.969.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le treize mai.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Romain SCHULER, gérant d'immeubles, né à Esch-sur-Alzette le 2 mars 1957, demeurant à L-3733 Rume-

lange, 3, Cité Kiichbierg,

agissant en son nom personnel, en ses qualités d'associé et gérant unique de la société ci-après spécifiée.

82740

L

U X E M B O U R G

Lequel comparant, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit

les déclarations et constatations suivantes:

I.- Que la société à responsabilité limitée "SCHULER ROMAIN S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-4050

Esch-sur-Alzette, 48-52, Rue du Canal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 84969 a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 3 décembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 521 du 4 avril 2002.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "SCHULER ROMAIN S.à r.l.", préqualifiée, s'élève

actuellement à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur
nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune, entièrement libérées.

III.- Que le comparant en sa qualité d'associé déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière

de la susdite société "SCHULER ROMAIN S.à r.l.".

IV.- Le comparant déclare que l’activité de la société a cessé au 30 avril 2015.
Un bilan de clôture a été arrêté au 30 avril 2015.
V.- Que le comparant est propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé il déclare

expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

VI.- Que le comparant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée
sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société dissoute pour l’exécution de son mandat jusqu'à

ce jour.

VIII.- Qu’il a été procédé à l’annulation des parts sociales, le tout en présence du notaire instrumentant.
IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-3733 Rumelange, 3, Cité

Kiichbierg.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en ses dites qualités, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: SCHULER, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15/05/2015. Relation: EAC/2015/10881. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 18/05/2015.

Référence de publication: 2015073462/46.
(150083807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Setas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.499.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 9 décembre 2014

- Il est pris acte de la démission de Monsieur Christian FRANCOIS de son mandat d'Administrateur avec effet ce jour.
- Madame Ariane VIGNERON, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Christian FRANCOIS, démissionnaire,
avec effet ce jour, et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de
l'Assemblée générale statutaire de l'an 2015.

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Certifié sincère et conforme
F. DARCHE / P-S GUHLET
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015073469/17.
(150083717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

82741

L

U X E M B O U R G

FSI Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, maison 38, Z.A.R.E. Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 108.048.

L'an deux mille quinze, le premier avril.
Par-devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Frédéric FLAUSS, informaticien, demeurant au 7, rue de la Gare, F-57800 Betting,
ici représenté par Madame Suet Sum WONG, juriste, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg,

en vertu d’une procuration, donnée sous seing privé le 31 mars 2015.
La prédite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'acter les faits suivants:
- Qu'il est l’associé unique de la société à responsabilité limitée FSI CONSULTING S.à r.l., avec siège social au 30, rue

Edmond Reuter, L-5326 Contern, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le
numéro 108.048, ci-après la «Société»;

- Que la Société a été constituée le 28 avril 2005 suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence

à Niederanven, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1049 du 17 octobre 2005;

- Que les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu en date du 17 février 2012 suivant acte reçu par Maître

Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 852
du 31 mars 2012;

- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par

cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Tout ceci ayant été déclaré, le comparant, représenté comme dit ci-avant, détenant cent pour cent (100%) du capital de

la Société, a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social du 30, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern vers la Z.A.R.E. Ouest,

Bâtiment 38, L-4384 Ehlerange, et de modifier par conséquent la première phrase de l’article 2 des statuts pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:

« Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Sanem.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont évalués à environ mille cent euros (EUR 1.100).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation du présent acte donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instru-

mentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: S.S. Wong, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 8 avril 2015. GAC/2015/2988. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 19 mai 2015.

Référence de publication: 2015073835/45.
(150084487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

Barclays Aegis Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 25.106,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 116.153.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

82742

L

U X E M B O U R G

Fait à Luxembourg, le 23 mars 2015.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
Greger McMillan
<i>Gérant

Référence de publication: 2015073656/14.
(150084344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

Tishman Speyer Point Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 181.665.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2014 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 13 mai 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2015073500/17.
(150083265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Traxys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 90.829.

<i>Extrait de la résolution de l'associé unique du 9 avril 2015 statuant sur l'exercice 2014

ad 8) L'Assemblée générale décide de nommer Deloitte Audit comme réviseur d'entreprises pour l'exercice 2015.

Pour extrait conforme
Bernard de Busscher
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015073502/12.
(150083576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Toiture Miller Frères, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4930 Bascharage, 124A, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 29.966.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015073505/9.
(150083647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

TPL Neckarsulm S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.750.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

82743

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015073510/12.
(150083381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

TPL Vilshofen S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.789.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015073511/12.
(150083375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Selkea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 12, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 196.800.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le sixième jour du mois de mai,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Virgile RABY, employé privé, né le 15 octobre 1982 à Evreux (France), demeurant professionnellement à

L-8824 Perlé, 12, rue Neuve.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il

déclare constituer par les présentes:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour

compte de tiers, la sauvegarde externalisées, le traitement de dématérialisation, l'échange, le cryptage et décryptage de
toutes  données  informatiques  auprès  de  clients  personnes  privées  ou  publiques,  ainsi  que  la  vente  de  tout  matériel  se
rattachant au traitement des données informatiques, l’audit, le conseil, la maintenance, la téléphonie et VoIP. L'hébergement
de tout système de communication informatique, la création et l'hébergement de site internet, l'installation, la maintenance.
L'hébergement de tout système de virtualisation ainsi que tout outil de connexion à distance, la location d'espace disque
ainsi que tout élément technique et matériel permettant la vente de produit en ligne incluant les produits finis. Toutes
opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. Toutes opérations industrielles et commerciales se rap-
portant à la création ou l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées ci-dessus. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant lesdites activités, la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe. Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de "SELKEA S.à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Perlé.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l’associé unique ou

de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision
du gérant unique ou du conseil de gérance.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (EUR 125,00) chacune.

Art. 7. Lorsque la société compte plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après

avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

82744

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est
toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 10. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle

fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de son objet social.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants,

la société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) signature(s) de
toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le ou les gérant(s).

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Si et aussi longtemps que la société sera unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi

ou les présents statuts à l'Assemblée Générale.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18.  L'excédent  favorable  du  bilan,  déduction  faite  des  charges  sociales,  amortissements  et  moins-values  jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévus dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales.

<i>Souscription et libération

L'intégralité des cents (100) parts sociales est souscrite par Monsieur Virgile RABY, pré qualifié.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille quinze.

<i>Décisions de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant unique pour une durée illimitée:
Monsieur Virgile RABY, employé privé, né le 15 octobre 1982 à Evreux (France), demeurant professionnellement à

L-8824 Perlé, 12, rue Neuve.

2. Le siège social est fixé à L-8824 Perlé, 12, rue Neuve.

<i>Avertissement

Le notaire soussigné a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société doit obtenir une autorisation d'établissement

de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité
commerciale, avertissement que le comparant reconnaît avoir reçu.

82745

L

U X E M B O U R G

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Raby, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 8 mai 2015. GAC/2015/3977. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 18 mai 2015.

Référence de publication: 2015073468/100.
(150083696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

TPL Wittenberge S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.746.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015073512/12.
(150083382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

TR Investment, Société Anonyme.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 193.482.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

C.W. Karsten
<i>Gérante

Référence de publication: 2015073513/12.
(150083421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Tur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1530 Luxembourg, 70, rue Anatole France.

R.C.S. Luxembourg B 47.443.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015073517/9.
(150083366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Vitco &amp; Partners SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 121.633.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015073524/9.
(150083591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

82746

L

U X E M B O U R G

White Ice Ventures Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 193.622.

<i>Rectificatif du dépôt L150011039 du 19/01/2015

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015073539/12.
(150083476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

INGBE Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 165.834.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am vierten Tag im Monat Mai.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Paul BETTINGEN, mit Amtssitz in Senningerberg, Großherzogtum Luxem-

burg,

IST ERSCHIENEN:

INGBE Stiftung, eine Stiftung nach liechtensteiner Recht mit Sitz in 6, Heiligkreuz, Li-9490 Vaduz, eingetragen im

Handelsregister der Stadt Vaduz unter der Nummer FL-0002.485.176-0, hier vertreten durch Herrn Jean-Pierre Dias, Pri-
vatbeamten, geschäftsansässig in Senningerberg, aufgrund einer am 10. April 2015 in Vaduz privatschriftlich erteilten
Vollmacht.

Die besagte Vollmacht, welche „ne varietur“ von dem Vertreter der erschienenen Partei und dem vorgenannten Notar

unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei, wie oben erklärt vertreten, ist die Alleingesellschafterin der SIGNA Prime Luxembourg Betei-

ligung S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in
5, rue Heienhaff, L-1736 Sennigerberg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer
B 165.834 (die „Gesellschaft“).

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 9. Dezember 2011, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations“, am 10. Februar 2012 unter Nummer 365. Die Satzung wurde abgeändert durch den unterzeichnenden Notar,
am 31. Januar 2013, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“, am 16. April 2013 unter Nummer
894.

Die erschienene Partei, die das gesamte Kapital der Gesellschaft vertritt, hat auf jegliche Einberufungsformalitäten

verzichtet und den unterzeichnenden Notar ersucht, folgenden Beschluss zu beurkunden:

Die Gesellschafterversammlung fasst folgenden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Gesellschaft in „INGBE Beteiligung S.à r.l.“ umzubenennen und de-

mentsprechend Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

Art. 1. Form - Name. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „INGBE Beteiligung S.à r.l." (nachs-

tehend die "Gesellschaft") untersteht dem luxemburgischen Recht, das für eine solche juristische Person gilt, insbesondere
dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das "Gesetz") und
der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").

<i>Voraussichtliche Kosten

Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Gebühren, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Ge-

sellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden auf circa TAUSENDEINHUNDERT Euro (1.100 EUR)
geschätzt.

82747

L

U X E M B O U R G

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Um  Vorgenanntes  zu  beurkunden,  wurde  diese  notarielle  Urkunde  zum  eingangs  erwähnten  Tag  in  Senningerberg

aufgenommen.

Nachdem die vorliegende Urkunde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welcher dem Notar

mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, wurde diese von dem Vertreter der erschienenen Person und dem vor-
genannten Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A. C1., le 5 mai 2015. 1LAC / 2015 / 14053. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 18. Mai 2015.

Référence de publication: 2015073471/55.
(150083705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Vermalito S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3812 Schifflange, 4, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 195.677.

L'an deux mil quinze, le vingt avril.
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

Monsieur Marcel VERHASSELT, conseiller économique, né le 5 septembre 1953 à Uccle (Belgique), demeurant à

L-3812 Schifflange, 4, rue des Artisans,

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- qu’il est le seul et unique associé de la société VERMALITO S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège

social à L-3812 Schifflange, 4, rue des Artisans, constituée en date du 4 mars 2015 suivant acte du notaire instrumentant,
en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

<i>I. - Cession de parts sociales

Monsieur Marcel VERHASSELT, prénommé, «le Cédant»,
déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour,
soixante (60) parts sociales de la société VERMALITO S.à r l., à Madame Linda MACOY, née le 10 juillet 1968 à

Tongeren (Belgique), demeurant à L-3812 Schifflange, 4, rue des Artisans, dénommée également «le Cessionnaire», in-
tervenant et ce acceptant.

La présente cession de parts sociales est consentie et acceptée moyennant le montant de UN EURO (1,- EUR), lequel

prix a été payé avant les présentes et en dehors de la présence du notaire, par le Cessionnaire au Cédant, qui lui en donne
bonne et valable quittance.

Il est convenu entre les parties que:
- les parts cédées ne sont représentées par aucun titre;
- l’entrée en jouissance des parts ainsi cédées aura lieu à compter de ce jour, de sorte que le cessionnaire sera subrogé

dans tous les droits et obligations attachés aux parts lui étant respectivement cédées.

En conséquence, le cédant met et subroge le cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts sociales

présentement cédées.

<i>II. - Assemblée générale extraordinaire

<i>Première résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les associés déclarent que la répartition des parts sociales de la société

VERMALITO S.à r.l., est dorénavant la suivante:

1.- Monsieur Marcel VERHASSELT, précité,
soixante cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

2.- Madame Linda MACOY, précitée,
soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

82748

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’article 4 des statuts et lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet
- la mise en service de toutes prestations de services administratifs et de secrétariat pour personnes physiques et sociétés,
- la Coordination de la gestion administrative avec différents professionnels nationaux et internationaux,
- l’organisation de présentations et de conférences,
- les recherches et choix des sources documentaires,
- la consultation de banques de données,
- la constitution, organisation, actualisation et gestion de documentation, et
- divers travaux administratifs.
Elle pourra accomplir tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, tous actes, toutes opérations financières,

industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et
permettant d’en faciliter la réalisation. Elle pourra notamment emprunter, et donner en garantie ou consentir des hypothè-
ques.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à huit cent soixante-cinq euros (865,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. VERHASSELT, L. MACOY, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/12755. Reçu soixante-quinze euros

75,00 EUR.

<i>Le Receveur (signé): T. BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2015.

Référence de publication: 2015073527/66.
(150083654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Vero S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1530 Luxembourg, 70, rue Anatole France.

R.C.S. Luxembourg B 72.797.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015073528/9.
(150083364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Vireos Investment Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.353.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 24 avril 2015 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée a reconduit les mandats d'administrateurs de:
- M. Christoph Wehr
- M. Alexander Kotb
- M. Marc Wenda
pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2016.
2. L'Assemblée a reconduit le mandat de BDO (Luxembourg) en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé pour une durée

d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2016.

Référence de publication: 2015073529/17.
(150083205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

82749

L

U X E M B O U R G

Pacase S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-3322 Bivange, 12, rue de la Forge.

R.C.S. Luxembourg B 156.788.

L'an deux mille quinze, le six mai.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, Société de Gestion de Patrimoine Familial

«PACASE S.A., SPF», ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.788, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné,
en date du 12 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2807 du 22 décembre
2010, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Rachida EL FAHRANE, salariée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien PHILIPPI, salarié demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions

possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux for-
malités d'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social, qui est fixé à cent quatre-vingt-trois mille euros (EUR 183.000,-) et divisé en cent

quatre-vingt-trois (183) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune, étant présente ou représentée
à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy à L-3322 Bivange, 12, rue de la Forge;
2. Modification de l'article 1 

er

 alinéa 2 des statuts de la société prénommée, pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi dans la commune de Roeser.»
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l'assemblée générale prend, à l'una-

nimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle L-1940 Luxembourg, 282,

route de Longwy à l'adresse suivante: L-3322 Bivange, 12, rue de la Forge, commune de Roeser.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 1 

er

 alinéa 2 des statuts de la

Société pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi dans la commune de Roeser.»

<i>Frais

Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison du présent

acte sont évalués approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Nezar, El Farhane, Philippi, GRETHEN.

82750

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/14599. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 18 mai 2015.

Référence de publication: 2015074078/60.
(150084631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

Wedco One (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 145.187.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015073536/9.
(150083751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Wedco Two (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 145.216.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015073537/9.
(150083754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

(in)cube s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 147.432.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015073571/9.
(150084604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

d'Amico International Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 124.790.

Les comptes annuels consolidés au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015073572/9.
(150084297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

AAC Capital 2005 Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.888.166,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 141.032.

Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015073605/13.
(150084073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

82751

L

U X E M B O U R G

ACI LUXEMBOURG the Financial Markets Association, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg F 1.969.

Les statuts coordonnés au 23 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2015.

Référence de publication: 2015073608/10.
(150084261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

Acis Holding S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 53.881.

Le Bilan arrête au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015073609/10.
(150084699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

Actech Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7373 Lorentzweiler, 80, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 156.809.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2015.

Référence de publication: 2015073611/10.
(150084109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

Algim S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9163 Kehmen, 6, Uesperwee.

R.C.S. Luxembourg B 96.299.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kehmen, le 18 mai 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015073624/10.
(150084335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

Baskland Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 142.263.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18.05.2015

BASKLAND CAPITAL S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015073669/12.
(150083977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

82752


Document Outline

AAC Capital 2005 Lux Sàrl

ACI LUXEMBOURG the Financial Markets Association

Acis Holding S.A.

Actech Consulting S.A.

Algim S.à.r.l.

Barclays Aegis Investments S.à r.l.

Baskland Capital S.A.

d'Amico International Shipping S.A.

FSI Consulting S.à r.l.

Fusion Orientale

Helpling Group Holding S.à r.l.

Ideal-Lux

(in)cube s.à r.l.

INGBE Beteiligung S.à r.l.

La Varenne Gastronomie Holding

Pacase S.A., SPF

Schuler Romain S.à.r.l.

Selkea S.à r.l.

Setas S.A.

SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung S.à r.l.

Sinal Capital SPF S.A.

Solar Holdings S.à r.l.

SOLIT Information Security S.à r.l.

Somuchmore GP S.à r.l.

SPC Holding S.A.

T.E.A. Oriental Sàrl

Tishman Speyer Point Partners S.à r.l.

Toiture Miller Frères, S.à r.l.

TPL Neckarsulm S.à r.l.

TPL Vilshofen S.à r.l.

TPL Wittenberge S.à r.l.

Traxys S.à r.l.

TR Investment

Tur S.A.

Vermalito S.à r.l.

Vero S.A.

Vireos Investment Fund S.A., SICAV-SIF

Vitco &amp; Partners SA

Wedco One (Luxembourg) S.à r.l.

Wedco Two (Luxembourg) S.à r.l.

White Ice Ventures Limited