logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1700

10 juillet 2015

SOMMAIRE

Alken Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81600

Alscot Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81598

BA Financial Trading (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81596

Cube Infrastructure Fund  . . . . . . . . . . . . . . . .

81554

D4S Designer 4 Sport S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

81594

Delta Partners Luxembourg SV Coop S.A.  . .

81599

Firkin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81600

Gate Gourmet Luxembourg III A S.à r.l.  . . . .

81592

Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l.  . . . .

81593

Gigaplex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81591

Grohe Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81585

Letterone Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81578

Luxinvest Investment Advisors S.A.  . . . . . . . .

81574

Lux. Ouvrage d'Art S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

81574

Malabar Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81574

Marim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81575

Mishte Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81574

Nalys Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81575

Next Code Health Corporation S.à r.l.  . . . . . .

81579

Nitteler Hof Event & Traiteur  . . . . . . . . . . . . .

81581

OAKS Estate Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .

81589

Orange 3 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81578

«Ouestia Intermediate S.à r.l  . . . . . . . . . . . . . .

81578

Parc Merveilleux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81595

Parquet Bembé S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81589

Parquet Bembé S.à r.l. & Cie  . . . . . . . . . . . . . .

81590

Pars Transaction S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81595

Pasta Point Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81596

PAX S.A. S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81596

Peinture Dany S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81596

Pentavest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81591

Perennity Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

81597

Permotio International Learning S.à r.l. . . . . .

81592

Pixel.Lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81597

Pixel.Lu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81598

Plock S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81593

Pneu Consult Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81598

Prime Corvette S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81598

Principia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81595

Prisma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81599

Prodilux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81595

Queensgate Carry Partner GP Coop S.A. . . . .

81599

Queensgate Investments I HoldCo S.à r.l.  . . .

81599

Rendac - C.E.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81600

Resolution IV Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

81600

Rib Elec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81600

R.P. Constructions Rainer Parmentier Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81599

Shiplux III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81575

Timelux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81577

WW¤studio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81571

81553

L

U X E M B O U R G

Cube Infrastructure Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.234.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of the month of June.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Cube Infrastructure Fund (hereafter referred to as

the "Company"), a société anonyme constituée sous la forme de société d’investissement à capital variable - fonds d’in-
vestissement spécialisé, with its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated under Luxembourg
law by a deed of Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on February 6

th

 , 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 265 on February

28 

th

 , 2007.

The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been amended for the last time pursuant to a deed

of  Maître  Paul  DECKER,  notary  residing  in  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  on  December  30 

th

  ,  2010,

published in the Mémorial number 433 on March 7 

th

 , 2011.

The Meeting was presided over by Mrs Marie BERNOT, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Lisa SOLD, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr Maxime WUNDERLICH, private employee, professionally residing in Luxem-

bourg.

The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list which is signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the members of the
bureau. This list and the proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau will be attached to the present deed
to be filed with the registration authorities.

II. All the shares being registered shares, the Meeting was convened by notice containing the agenda sent to the share-

holders of the Company by registered mail on June 11 

th

 , 2015.

The related copies of the said convocations are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
III. As it appears from the attendance list, out of 971,631,898.917 shares currently in issue, 1 (one) Class A shares and

554.818.166,876 Class B shares (57,10%) are duly represented at the Meeting.

IV. The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

Restatement of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") in order inter alia to comply with the

requirements of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers, as follows:

(i) Amendment of article 3 of the Articles to reflect the submission of the Company to the Luxembourg law of 13

February 2007 on specialised investment funds (the "2007 Law") by adding a third paragraph to be read as follows: "The
Company is subject to the provisions of the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds,
as amended (the "2007 Law") and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purpose to the fullest extent permitted by the Law."

(ii) Amendment of article 7 of the Articles in order to remove the possibility for the Company to issue shares in bearer

form.

(iii) Amendment of article 9 of the Articles to mainly:
- remove reference to NATIXIS Environnement &amp; Infrastructures Luxembourg S.A. (NATIXIS EIL) so as to refer more

broadly to the alternative investment fund manager (the "AIFM") of the Company;

- clarify that the Company may invest through Subsidiaries which may not be necessarily wholly owned subsidiaries;

and

- suppress the right for the Company to proceed to the compulsory redemption of "A" Shares in case a "A" Shareholder

has attempted to or intends to transfer its activities to entities not affiliated to NATIXIS or wholly owned affiliates of
NATIXIS EIL.

(iv) Amendment of article 13 of the Articles to:
- refer to the "redemption price" of the shares in this article, and
- indicate that the definition of a "US Person" will be given in the sales documents of the Company.
(v) Amendment of article 14 of the Articles to:
- clarify the calculation of the net asset value of the Company by inserting two new paragraphs to this effect after the

first paragraph to be read as follows:

81554

L

U X E M B O U R G

"The net asset value of the Company will be equal to its total assets minus its liabilities as of any date of determination.

The net asset value of the Company will be the aggregate net asset values of the classes of shares of the Company as of the
Valuation Date, calculated as provided in the following sentence. The net asset value of each class is generally determined
by starting with the net asset value of the class at the beginning of an accounting period and increasing or decreasing that
amount by allocating (i) the aggregate subscription price of any shares of such class issued during such period as an increase
in the net asset value of such class, (ii) the aggregate amount of dividends, distributions or other payments made with
respect to such class during such period as a decrease in the net asset value of such class, (iii) any Profit (as an increase in
the net asset value) or Loss (as a decrease in the net asset value) of the Company for the period of calculation among each
class  pro  rata  in  portion  to  the  net  asset  values  of  the  classes  at  the  beginning  of  such  period,  and  (vi)  Special  Items
attributable to each class only as an increase or decrease to the net asset value of that class. Upon determining the net asset
value of a class, the net asset value per share of such class is calculated by dividing the net asset value of such class by the
number of shares issued and in circulation in such class.

For the purpose of calculating net asset value: "Profit" means all items of income, revenue or gain of the Company

excluding any Special Items; "Loss" means any item of deduction, expense or other charge of the Company, excluding any
Special Items; and "Special Items" means items of Management Fee and Incentive Fee expense or deduction, and any other
items that may either positively or negatively impact the net asset value per class that the board of directors reasonably
determines to be attributable, in whole or special portion, to one or more classes of shares." in replacement of the previous
corresponding paragraph and removal of paragraph 7 of the Articles,

and
- deletion of the two paragraphs related to the capitalisation shares as no capitalisation shares have been issued by Cube.
(vi) Amendment of article 18 of the Articles to remove the obligation to circulate the minutes of the board of directors

meetings within a prescribed timeframe.

(vii) Amendment of article 24 of the Articles mainly to:
- delete paragraphs 9 and 10 relating to the publication requirements as a result of the removal of the possibility to issue

bearer shares, and

- add a new paragraph 13 (old numbering) to allow for the possibility to calculate the quorum and the majority applicable

to a general meeting by reference to the Shares issued and in circulation as of a certain date prior to this general meeting
to be referred to as the "Record Date".

(viii) Amendment of article 26 of the Articles to add a last paragraph relating to the applicable accounting standards to

be used to draw the accounts of the Company.

(ix) Introduction of a new article relating to the depositary agreement to be numbered article 28, and to the right of the

depositary to discharge itself of its liability, provided that certain conditions are met and that information regarding such
discharge of liability are disclosed or made available to investors and subsequent renumbering of articles 28 to 35 of the
Articles.

(x)  Amendment  of  article  30  to  clarify  the  quorum  and  majority  requirements  applicable  to  shareholders  meetings

resolving on the winding up/liquidation of the Company, depending on the circumstances.

(xi) Insertion of a new article 33 of the Articles relating to investors' information means and to shareholders' preferential

treatment, to reflect the requirements imposed by the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the
"AIFM Law").

(xii) Amendment of article 35 of the Articles to add the definitions of the AIFM, the Manager and the Articles and to

update other definitions.

(xiii) Amendments of various articles of the Articles mainly to:
- update the references to the various articles due to their renumbering;
- reflect the new defined terms used across the Articles as a result of the revised definitions provided in article 13;
- reflect the fact that only registered share certificates will be issued; and
- proceed with minor typographical corrections or update of legal references.
(xiv) Deletion of the French translation of the articles of association.
V. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the sole item

of the agenda.

After deliberation, the Meeting, by 100% votes for, 0 votes against and 0 abstentions, takes the following resolution:

<i>Sole resolution

The Meeting resolves to fully restate the articles of incorporation of the Company which shall therefore read as follows:

“Chapter I - Form, Term, Object, Registered office

Art. 1. Name and form. There exists among the existing shareholders and those who may become owners of shares in

the future, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital
("société d'investissement à capital variable") under the name of "Cube Infrastructure Fund" (hereinafter the "Company").

81555

L

U X E M B O U R G

The Company has a stand alone structure and hence, the board of directors may not create any sub-funds within the

Company.

Art. 2. Duration. The Company is formed for a period of time expiring twelve (12) years after the first Closing Date

(i.e. on 21 December 2019) subject to up to three (3) consecutive additional one (1) year extensions as decided by the board
of directors in accordance with the procedure stated in the offering memorandum of the Company.

Art. 3. Purpose. The Company's sole object shall be to invest its assets in transferable securities, money market instru-

ments of all kinds and in other permissible assets, in each case in the infrastructure market and with a view to spreading
investment risks and enabling its shareholders to benefit from the results of its management.

The Company may invest more than 20% of its net assets in (i) securities and instruments that are not admitted to or

dealt in on a regulated market, (ii) securities and instruments that are not dealt in on another market in a Member State of
the European Union which is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public.

Further, the Company may borrow for investment purpose.
The Company is subject to the provisions of the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment

funds, as amended (the "2007 Law") and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purpose to the fullest extent permitted by the Law.

Art. 4. Registered office. The Company's registered office shall be in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg). If

the board of directors considers that extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to compromise
the registered office's normal activity or easy communications between this office and abroad, have occurred or are im-
minent, it may temporarily transfer the registered office abroad until such time as these abnormal circumstances have ceased
completely; this temporary measure shall not, however, have any effect on the Company's nationality, which, notwiths-
tanding a temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

decision of the board of directors.

Chapter II - Capital

Art. 5. Share capital. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time

be equal to the total value of the net assets of the Company. The minimum capital of the Company cannot be lower than
the level provided for by law with respect to undertakings for collective investment. Such minimum capital must be reached
within a period of six months after the date on which the Company has been authorized as an undertaking for collective
investment under Luxembourg law.

For the purposes of the consolidation of the accounts the base currency of the Company shall be Euro (EUR). The

Company's share capital shall be denominated in Euro (EUR).

Art. 6. Capital variation. The Company's share capital shall vary, without any amendment of the articles of incorporation,

as a result of the Company issuing new shares or redeeming its shares.

Chapter III - Shares

Art. 7. Form of shares. The Company will issue shares in registered form only.
All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by

the Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of
each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered
shares held by him and the amounts paid.

The  inscription  of  the  shareholder's  name  in  the  register  of  shareholders  evidences  his  right  of  ownership  on  such

registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder
or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

Upon the written request of a shareholder, registered share certificate(s) recording the entry of such shareholder in the

register of shareholders may be issued in such denominations as the board of directors shall prescribe. The certificates so
issued shall be in such form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be determined by the
board of directors. Such certificates shall be signed manually or by facsimile by two directors or by the delegate of the
board of directors. Lost, stolen or mutilated certificates will be replaced by the Company upon such evidence. The Company
may, at its election, charge to the shareholder the costs and all reasonable expenses incurred by the Company in connection
with such replacement.

Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices and

announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered

into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company,
or at such other address as may be so entered into the register of shareholders by the Company from time to time, until
another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address

81556

L

U X E M B O U R G

as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at
such other address as may be set by the Company from time to time.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) must appoint one single attorney to represent such share
(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney shall lead to a suspension of the exercise of all rights attached
to such shares.

The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be

entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis.

Art. 8. Classes of shares. The board of directors may decide to issue one or more classes of shares. These classes may

be reserved to a specific group of investors such as investors from a specific country or eligible investors.

Each class of shares may differ from the other classes with respect to its cost structure, the initial investment required,

or the currency in which the net asset value is expressed or any other feature.

Within each class, there may be a capitalisation share-type and one or more distribution share-types.
Whenever dividends are distributed on distribution shares, the portion of net assets of the class of shares to be allotted

to all distribution the shares shall subsequently be reduced by an amount equal to the amounts of the dividends distributed,
thus leading to a reduction in the percentage of net assets allotted to all distribution the shares, whereas the portion of net
assets allotted to all capitalisation shares shall remain the same.

Art. 9. Specific "A" Share class. There exists one specific share class (the "A" Share Class), issued in registered form

with specific rights and powers and reserved to the legal entity appointed by the Company as its alternative investment
fund manager (the "AIFM" or the "Manager") regulated under chapter 16 of the Luxembourg law dated 17 December 2010
on undertakings for collective investment (the "2010 Law") and authorised as an alternative investment fund manager under
the Luxembourg law dated 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the "2013 Law").

The "A" Shareholder shall (i) be the AIFM of the Company and, as such, perform investment management function and

provide other management services to the Company in accordance with the terms of the alternative investment fund ma-
nagement agreement concluded with the Company, (ii) be in charge of the management (or designate one of its wholly-
owned affiliates to act in such capacity) of each of the Luxembourg Subsidiaries through which the Company’s investments
are held, (iii) propose the appointment of board members, as provided for in article 16 "Administration" hereof and, (iv)
receive a preferential dividend, as provided for in article 27.

Any decision which affects the rights attached to this "A" Share Class, shall require a specific resolution of the general

meeting which must be passed with a presence quorum of fifty percent (50%) of the share capital, and approved by a
majority of at least two thirds of the voting rights present or represented at the meeting, and requires the consent of the "A"
Shareholder.

The board of directors shall make all necessary and useful arrangements in order to ensure that the Luxembourg Sub-

sidiaries incorporated as société en commandite par actions (S.C.A.) through which the Company will invest shall be
managed by the "A" Shareholder (or by one of its wholly-owned affiliates designated by the "A" Shareholder) as unlimited
partner/manager subject to the limitations set forth by the 2013 Law.

Moreover, if the Company decides, for investment purpose, to set up any Luxembourg subsidiary(ies) incorporated

under a form other than that of a société en commandite par actions (S.C.A.) or any foreign subsidiary(ies), the board of
directors of the Company shall make all the necessary arrangements in order to ensure that the "A" Shareholder (or one of
its wholly-owned affiliates designated by the "A" Shareholder) is in charge of the management of any such subsidiary(ies).

"A" Shares are issued as "redeemable shares", i.e. shares which are redeemable at the initiative of the Company, under

the following conditions.

The Company may proceed with the compulsory redemption of all such "A" Shares (and not only some "A" Shares) if

the "A" Shareholder:

(i) ceases for any reason to act as the AIFM of the Company or ceases to act as unlimited partner/manager of any of the

Luxembourg Subsidiaries (or if one of its wholly-owned affiliates has been designated to act as unlimited partner/manager,
such affiliate of the "A" Shareholder ceases for any reason to act as unlimited partner/manager of any Luxembourg Sub-
sidiary and is not promptly replaced in such capacity by the "A" Shareholder or one of its wholly-owned affiliates); or

(ii) has committed (or if one of its wholly-owned affiliates has been designated to act as unlimited partner/manager of

one or more of the Luxembourg Subsidiaries, such affiliate has committed) (a) gross negligence, fraud or wilful misconduct
in performing its obligations in the capacity described in paragraph (i) above, which constitutes a material breach of its
duties as the Manager of the Company or in its capacity as unlimited partner/manager towards any of the Luxembourg
Subsidiaries, and such entity has failed to cure a breach resulting from gross negligence or wilful misconduct within ninety
(90) days of receipt of notice thereof or the Manager or such entity has failed to demonstrate its good faith efforts to effect
such cure within thirty (30) days of receipt of notice thereof; or (b) a breach of (x) any material provision of the Management
Agreement or (y) any material obligation of the Manager or such affiliate under the Offering Memorandum or any material
provision of these articles of incorporation, which breach, in the case of this clause (b), (1) has continued without being
cured for a period of at least thirty (30) days after the date upon which written notice describing such breach has been given
to the Manager and (2) is the primary cause of a material adverse effect on the business of the Company, in each case

81557

L

U X E M B O U R G

described in this clause (b) as finally determined by a court or arbitral tribunal of competent jurisdiction upon entry of a
final, non-appealable judgment; or,

(iii) has become insolvent or unable to pay its debts as they fall due; or
(iv) has gone into liquidation whether voluntarily or compulsorily (except a voluntary liquidation upon terms previously

approved in writing by the Company); or

(v) has had a receiver appointed over all or part of its assets or has received notice of proceedings or proposed proceedings

for its windingup.

Clauses (iii), (iv) and (v) above shall not apply if the insolvency or liquidation or receivership of the "A" Shareholder

results from the failure of the Company or any Luxembourg Subsidiary to pay sums due to the "A" Shareholder in its quality
of unlimited partner/manager of the Luxembourg Subsidiaries or under agreements signed between the Company or any
of its Luxembourg Subsidiaries and the "A" Shareholder.

The terms "material breach", "gross negligence", "fraud" and "wilful misconduct" shall be interpreted in accordance

with Luxembourg laws and case law.

The following redemption procedure shall then be applied:
1. the Company shall send a notice (hereinafter called the "redemption notice") to the "A" Shareholder; the redemption

notice shall specify the redemption price to be paid, and the place where this price shall be payable. The redemption notice
shall be sent to the "A" Shareholder by recorded delivery letter to its last known address. The "A" Shareholder shall be
obliged without delay to deliver to the Company the certificates, if any, representing the "A" Shares as specified in the
redemption notice. From close of business on the day specified in the redemption notice, the "A" Shareholder shall cease
to be the owner of the "A" Shares and the certificate representing this "A" Shares, if any, shall be rendered null and void
in the books of the Company;

2. the price at which "A" Shares shall be redeemed ("the redemption price") shall be equal to their net asset value which

shall be determined on the date of the redemption notice in accordance with article 14 hereof;

3. the payment of the redemption price will be made to the "A" Shareholder in Euros and will be deposited by the

Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to the "A" Share-
holder upon surrender of the "A" Share certificates, if any. Upon payment of such price, the "A" Shareholder shall cease
to have an interest in the "A" Shares.

The Company may also proceed with the compulsory conversion of all "A" Shares (and not only some "A" Shares) if

the "A" Shareholder is removed from its duties as AIFM of the Company by application of the "no fault divorce" procedure
exercised by the board of directors and the shareholders of the Company in accordance with the provisions of the mana-
gement agreement entered into between the Company and the "A" Shareholder.

The following conversion procedure shall then be applied:
1. the Company shall send a notice (hereinafter called the "conversion notice") to the "A" Shareholder; the conversion

notice shall be signed by two members of the board of directors and shall specify that the "no fault divorce" procedure has
been exercised by the board of directors and the shareholders of the Company in accordance with the provisions of the
management agreement; the conversion notice shall also enclose a certified copy of the minutes of the board of directors’
meeting during which the "no fault divorce" procedure has been decided and approved and a certified copy of the written
decision made by the shareholders approving such removal. The conversion notice shall be sent to the "A" Shareholder by
recorded delivery letter to its last known address;

2. simultaneously, the Company shall create and issue a separate class of shares to be held by the Manager (or its

permitted transferees) which shall have identical economic rights as the "A" Shares as exist immediately prior to the exercise
of the "no fault divorce" procedure (including the right to continued receipt of the preferred dividend specified in article
27 ("Distributions"));

3. upon receipt by the Manager of certificates of the new share(s) created by the Company (or other evidences that the

new share(s) have been created and recorded in the name of the Manager in the register of shareholders of the Company),
the Manager shall be obliged without delay to deliver to the Company the certificates, if any, representing the "A" Shares
as specified in the conversion notice.

Any decision which affects the rights attached to the new class of shares created in accordance with the above shall

require a specific resolution of the general meeting which must be passed with a presence quorum of fifty percent (50%)
of the share capital, and approved by a majority of at least two thirds of the voting rights present or represented at the
meeting, and requires the consent of the holder of such new class of shares.

Art. 10. Issue of shares. The board of directors is authorized without limitation to issue an unlimited number of shares

at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares;

the board of directors may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering
periods or at such other periodicity as provided for in the sales documents for the shares of the Company.

Subscriptions to the relevant class of shares shall be made in whole or in part on the date determined by the board of

directors. The modes of payment in relation to such subscriptions shall be determined by the board of directors and more

81558

L

U X E M B O U R G

fully described in the sales documents for the shares of the Company. Subject to and in accordance with the terms of the
offering memorandum of the Company, the board of directors shall determine the terms and conditions upon which shares
are issued and the amounts and times of payment of calls on unpaid share capital.

The board of directors may determine any other subscription conditions such as the minimum amount of commitments,

the minimum amount of the aggregate net asset value of the shares of the Company to be initially subscribed, the minimum
amount of any additional shares to be issued, the application of default interest payments on shares subscribed and unpaid
when due, restrictions on the ownership of shares and the minimum amount of any holding of shares. Such other conditions
shall be disclosed and more fully described in the sales documents for the shares of the Company.

Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be

determined in accordance with the terms and conditions specified in the offering memorandum of the Company.

The net asset value per share shall be determined in accordance with article 14 ("Net asset value") hereof.
The share subscription price may include any premium or fee payable to the Company as well as any sales charge payable

to a distributor or to the Manager.

The price so determined shall be payable within a period determined by the board of directors.
The board of directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorized agent the power to accept

subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them.

The Company may, if a prospective shareholder so requests and the board of directors so agrees, satisfy any application

for subscription of shares which is proposed to be made by way of contribution in kind. The nature and type of assets to
be accepted in any such case shall be determined by the board of directors and must correspond to the investment policy
and restrictions of the Company. A valuation report relating to the contributed assets must be delivered to the board of
directors by the independent auditor of the Company. The costs resulting from such a subscription in kind shall be borne
in equal proportion by the relevant investor(s) and the Company.

Art. 11. Redemption. The Company is a closed-ended company and thus unilateral redemption requests by the share-

holders may not be accepted by the Company.

The Company however may redeem shares whenever the board of directors considers a redemption to be in the best

interests of the Company; provided that no outstanding B shares may be redeemed by the Company, except (i) in connection
with the return of capital resulting in the increase of the "Outstanding Commitment" of a B shareholder in accordance with
the offering memorandum of the Company and any agreement relating to subscription of the shares of the Company to
which such B shareholder is a party, (ii) as a consequence of a default by a B shareholder of payment of all or a part of its
commitment to subscribe for shares of the Company, as provided for in the offering memorandum of the Company and
any agreement relating to subscription of the shares of the Company to which such B shareholder is a party, (iii) to the
extent that the board of directors determines that continued ownership of the B shares by any B shareholder (a) will result
in a material violation of law by the Company, (b) will subject the Company to material taxation in any country or (c)
otherwise will have a material adverse effect on the Company and (iv) to the extent that the board of directors determines
that it is in the best interests of the B shareholders that a distribution be effected by way of redemption of B shares from
all holders thereof. For the purposes of subclause (iv) of the preceding sentence, class B shares shall be redeemed pro rata
based upon the ratio that the number of B shares held by each B shareholder bears to the aggregate number of B shares.

Redemptions will be made in accordance with the principles set forth by the board of directors and reflected in the

offering memorandum of the Company and in any other sales documents of the Company.

The payment of any redemption price upon a redemption made under this article 11 shall be deemed to have been a

distribution made in accordance with, and credited to, the order or priority set forth in article 27 hereof.

The  Company  shall  have  the  right,  if  the  board  of  directors  so  determines,  to  satisfy  in  specie  the  payment  of  the

redemption price to any shareholder who agrees by allocating to the shareholder investments from the portfolio of assets
of the Company equal to the value of the shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such
case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of
the Company and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of
any such transfers shall be borne by the transferee.

Art. 12. Conversion. In addition to the compulsory conversion of the class "A" Shares in accordance with article 9

"Specific "A" Share Class", conversion of one class of shares into another class of shares is permitted only (1) in connection
with a change in commitment of any B shareholder to subscribe for shares of the Company, (2) as a consequence of a
default by any B shareholder of payment of all or a part of its commitment to subscribe for shares of the Company, in each
case in accordance with the offering memorandum of the Company or any agreement relating to subscription of the shares
of the Company to which such B shareholder is a party, and (3) for any other conversion of B shares only if effected pro
rata among the B shareholders based upon the ratio that the number of B shares (or the sub-class(es) of B shares being
converted, if limited to a specific sub-class(es)) held by each B shareholder bears to the aggregate number of B shares (or
the subclass(es) of B shares being converted, if limited to a specific subclass(es)).

The price for the conversion of shares shall be computed by reference to the respective net asset values per relevant

share, calculated on the same Valuation Day. If there is no common Valuation Day for any two classes, the conversion will

81559

L

U X E M B O U R G

be made on the basis of the net asset value calculated on the next following Valuation Day of each of the two relevant
classes.

If, as a result of any request for conversion, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any

shareholder of class of shares would fall below such number or such value as determined by the board of directors, then
the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's
holding of shares in such class.

Art. 13. L imitations on the ownership of shares. The board of directors may restrict or block the ownership of shares

in the Company by any natural person or legal entity if the Company considers that this ownership violates the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg or of any other country, or may subject the Company to taxation in any country or may
otherwise be detrimental to the Company.

In such instance, the Company may:
a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of shares if such issue or transfer may result in the

ownership of the shares by a person or legal entity who is not authorised pursuant to the first sentence of this article 13 to
hold shares in the Company; and

b) decline to take into account, during any shareholders meeting, the vote of any person or legal entity who is not

authorised pursuant to the first sentence of this article 13 to hold shares in the Company.

Except as permitted by article 11, the Company may not proceed with the compulsory redemption of all or any of the

shares of any person or legal entity who, either alone or together with other persons or legal entities, is the owner of shares
in the Company. The following procedure shall be applied in connection with any redemption under article 11:

1. the Company shall send a redemption notice to the shareholder(s) holding the shares; the redemption notice shall

specify the shares to be redeemed, the redemption price to be paid, and the place where this price shall be payable. The
redemption notice may be sent to the shareholder(s) by registered mail to their last known address. The shareholder(s) shall
be obliged without delay to deliver to the Company the registered share certificate specified in the redemption notice. From
close of business on the day specified in the redemption notice, the shareholder(s) shall cease to be the owner(s) of the
shares specified in the redemption notice and the registered share certificates shall be rendered null and void;

2. the price at which the shares specified in the redemption notice shall be redeemed ("the redemption price") shall be

equal to the net asset value of the shares of the Company determined in accordance with article 14 hereof on the date of
the redemption notice;

3. the payment of the redemption price will be made available to the former owner of such shares in the reference

currency of the relevant class, except during periods of exchange restrictions and will be deposited for payment by the
Company to such person with a bank account in Luxembourg or abroad (as specified in the redemption notice) upon final
determination of the redemption price following surrender of the share(s) or share certificate(s) specified in such notice
and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the redemption notice as aforesaid such former owner
shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect
thereof, except the right to receive the redemption price (without interest) from such bank following effective surrender of
the share(s) or share certificate(s) as aforesaid;

4. the exercise of the powers conferred by this article to the Company shall not be challenged or invalidated on grounds

that there was insufficient evidence of ownership of shares by a person or that the true ownership of shares was different
to what appeared to the Company at the date of the relevant purchase notice, provided that such powers shall always be
exercised by the Company in good faith, and

c) decline to take into account, during any shareholders meeting, the vote of any person who is not authorised to hold

shares in the Company.

In particular, the Company may restrict or block the ownership of shares in the Company by any "US Person" unless

such ownership is in compliance with the relevant US laws and regulations.

The term "US Person" has the meaning ascribed to that term in the sales documents of the Company.

Art. 14. Net asset value. The net asset value of the Company and the shares in each class, type or sub-type shall be

determined at least every six months and expressed in euros. The board of directors shall decide the days on which the net
asset value will be determined (each referred to as a "Valuation Day") and the appropriate manner to communicate the net
asset value per share to the shareholders in accordance with applicable legislation.

The net asset value of the Company will be equal to its total assets minus its liabilities as of any date of determination.

The net asset value of the Company will be the aggregate net asset values of the classes of shares of the Company as of the
Valuation Date, calculated as provided in the following sentence. The net asset value of each class is generally determined
by starting with the net asset value of the class at the beginning of an accounting period and increasing or decreasing that
amount by allocating (i) the aggregate subscription price of any shares of such class issued during such period as an increase
in the net asset value of such class, (ii) the aggregate amount of dividends, distributions or other payments made with
respect to such class during such period as a decrease in the net asset value of such class, (iii) any Profit (as an increase in
the net asset value) or Loss (as a decrease in the net asset value) of the Company for the period of calculation among each
class  pro  rata  in  portion  to  the  net  asset  values  of  the  classes  at  the  beginning  of  such  period,  and  (vi)  Special  Items
attributable to each class only as an increase or decrease to the net asset value of that class. Upon determining the net asset

81560

L

U X E M B O U R G

value of a class, the net asset value per share of such class is calculated by dividing the net asset value of such class by the
number of shares issued and in circulation in such class.

For the purpose of calculating net asset value: "Profit" means all items of income, revenue or gain of the Company

excluding any Special Items; "Loss" means any item of deduction, expense or other charge of the Company, excluding any
Special Items; and "Special Items" means items of Management Fee and Incentive Fee expense or deduction, and any other
items that may either positively or negatively impact the net asset value per class that the board of directors reasonably
determines to be attributable, in whole or special portion, to one or more classes of shares.

I. The Company's assets shall include:
(i) all cash in hand or on deposit, including any outstanding accrued interest;
(ii) all bills and promissory notes and accounts receivable, including outstanding proceeds of any sale of securities;
(iii) all securities, shares, bonds, time notes, debenture stocks, options or subscription rights, warrants, money market

instruments, and all other investments and transferable securities belonging to the Company;

(iv) all dividends and distributions payable to the Company either in cash or in the form of stocks and shares (the

Company may, however, make adjustments to account for any fluctuations in the market value of transferable securities
resulting from practices such as ex-dividend or ex-claim negotiations);

(v) all outstanding accrued interest on any interest-bearing securities belonging to the Company, unless this interest is

included in the principal amount of such securities;

(vi) the Company's preliminary expenses, to the extent that such expenses have not already been written-off;
(vii) the Company’s other fixed assets, including office buildings, equipment and fixtures;
(viii) all other assets whatever their nature, including the proceeds of swap transactions and advance payments.
II. The Company's liabilities shall include:
(i) all borrowings, bills, promissory notes and accounts payable;
(ii) all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term,

involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the
Company but not yet paid;

(iii) a provision for capital tax and income tax accrued on the Valuation Day and any other provisions authorised or

approved by the board of directors;

(iv) all other liabilities of the Company of any kind except liabilities represented by shares in the Company. In deter-

mining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company including,
but not limited to:

- formation expenses,
- expenses in connection with and fees payable to, its investment manager(s), advisors(s), accountants, custodian and

correspondents, registrar, transfer agents, paying agents, brokers, distributors, permanent representatives in places of re-
gistration and auditors,

- administration, domiciliary, services, promotion, printing, reporting, publishing (including advertising or preparing

and printing of copies of the offering memorandum, explanatory memoranda, registration statements, annual and semi-
annual reports) and other operating expenses,

- the cost of buying and selling assets,
- interest and bank charges, and
- taxes and other governmental charges.
The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated basis

for yearly or other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.

III. The value of the Company’s assets shall be determined as follows:
(i) the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid

expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be equal to the entire
amount thereof, unless the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined
after making such discount as the board of directors may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;

(ii) the value of all portfolio securities and money market instruments or derivatives that are listed on an official stock

exchange or traded on any other regulated market will be based on the last available price on the principal market on which
such securities, money market instruments or derivatives are traded, as supplied by a recognised pricing service approved
by the board of directors. If such prices are not representative of the fair value, such securities, money market instruments
or derivatives as well as other permitted assets may be valued at a fair value at which it is expected that they may be resold,
as determined in good faith by and under the direction of the board of directors;

(iii) the value of securities and money market instruments which are not quoted or traded on a regulated market will be

valued at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined in good faith by and under the direction
of the board of directors;

81561

L

U X E M B O U R G

(iv) the amortised cost method of valuation for short-term transferable debt securities in the Company may be used. This

method involves valuing a security at its cost and thereafter assuming a constant amortization to maturity of any discount
or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the security. While this method
provides certainty in valuation, it may result during certain periods in values which are higher or lower than the price which
the  Company  would  receive  if  it  sold  the  securities.  For  certain  short  term  transferable  debt  securities,  the  yield  to  a
shareholder may differ somewhat from that which could be obtained from a similar fund which marks its portfolio securities
to market each day.

(v) the value of the participations in investment funds shall be based on the last available valuation. Generally, partici-

pations in investment funds will be valued in accordance with the methods provided by the instruments governing such
investment funds. These valuations shall normally be provided by the fund administrator or valuation agent of an investment
fund. To ensure consistency within the valuation of the Company, if the time at which the valuation of an investment fund
was calculated does not coincide with the valuation time of the Company, and such valuation is determined to have changed
materially since it was calculated, then the net asset value may be adjusted to reflect the change as determined in good faith
by and under the direction of the board of directors.

(vi) the valuation of swaps will be based on their market value, which itself depends on various factors (e.g. level and

volatility of the underlying asset, market interest rates, residual term of the swap). Any adjustments required as a result of
issues and redemptions are carried out by means of an increase or decrease in the nominal of the swaps, traded at their
market value.

(vii) the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded

on exchanges or on other recognised markets, will be based on their net liquidating value determined, pursuant to the
policies  established  by  the  board  of  directors,  on  a  basis  consistently  applied  for  each  category  of  contracts.  The  net
liquidating value of a derivative position is to be understood as being equal to the net unrealised profit/loss with respect to
the relevant position. The valuation applied should be calculated based on a model commonly used in the market.

(viii) the valuation rule which will generally be applied to calculate the fair value of an infrastructure asset shall be the

discounted cash flow method. The discount rate used for such purpose shall be equal to the risk free rate of the country
where the asset is located plus a risk premium reflecting the specific risks of such asset.

(ix) the value of other assets will be determined prudently and in good faith by and under the direction of the board of

directors in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.

The board of directors, at its discretion, may authorize the use of other methods of valuation if it considers that such

methods would enable the fair value of any asset of the Company to be determined more accurately.

Where necessary, the fair value of an asset is determined by the board of directors, or by a committee appointed by the

board of directors, or by a designee of the board of directors. This may especially be the case for unlisted securities and
instruments.

The valuation of the Company's assets and liabilities expressed in foreign currencies shall be converted into euros, based

on the latest known exchange rates.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted ac-

counting principles.

Adequate provisions will be made for expenses incurred by the Company and due account will be taken of any off-

balance sheet liabilities in accordance with fair and prudent criteria.

Any share that is in the process of being redeemed shall be regarded as a share that has been issued and is in existence

until after the close of the Valuation Day applicable to the redemption of this share. Thereafter, and until it will have been
paid for, it shall be accounted for as a liability of the Company.

Any shares to be issued by the Company, in accordance with subscription applications received, shall be treated as being

issued on the close of the Valuation Day on which their issue price is determined. Thereafter, this price shall be treated as
an amount payable to the Company until it will have effectively been paid to the Company.

Any purchase or sale of transferable securities entered into by the Company shall, as far as possible, be effected on a

Valuation Day.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision to determine the net asset value taken by

the board of directors or by any bank, company or other organization which the board of directors may appoint for such
purpose, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

Art. 15. Suspension of the determination of the net asset value. The Company may suspend the determination of the net

asset value of shares and/or the conversion of shares, in the following cases:

(i) a stock exchange or another regulated and recognised market (that is a market which is operating regularly and is

open to the public), which is a source of pricing information for a significant part of the assets of the Company, is closed
for a period other than normal holidays, or in the event that transactions on such a market are suspended, or are subject to
restrictions, or are impossible to execute in volumes allowing the determination of fair prices;

(ii) the information or calculation sources normally used to determine the value of the Company's assets are unavailable,

or if the value of the Company's investment cannot be determined with the required speed and accuracy for any reason
whatsoever;

81562

L

U X E M B O U R G

(iii) exchange or capital transfer restrictions prevent the execution of transactions of the Company or if purchase or sale

transactions of the Company cannot be executed at normal exchange rates;

(iv) the political, economic, military or monetary environment, or an event of force majeure, prevent the Company from

being able to manage normally its assets or its liabilities and prevent the determination of their value in a reasonable manner;

(v) the decision has been taken to dissolve the Company;
(vi) the market of a currency in which a significant part of the Company's assets is denominated is closed for a period

other than normal holidays, or if transactions on such a market are either suspended or subject to restrictions.

(vii) the Company is in the process of establishing exchange parities in the context of a merger, a contribution of assets,

an asset or share split or any other restructuring transaction.

In addition, the board of directors is authorised to suspend temporarily conversions of shares when the stock exchange

(s) or market(s) which are a source of pricing information for a significant part of the assets of the Company are closed.

In the event of exceptional circumstances which could adversely affect the interest of the shareholders or insufficient

market liquidity, the board of directors reserves its right to determine the net asset value of the shares only after it shall
have completed the necessary purchases and sales of securities, financial instruments or other assets on the Company's
behalf.

The suspension of the calculation of the net asset value, of the conversion of shares, shall be notified through all means

reasonably available to the Company and in particular by a publication in the press, unless the board of directors is of the
opinion that a notification is not necessary considering the short period of the suspension.

Such a suspension decision shall be notified to all the shareholders requesting the conversion of their shares.

Chapter IV - Administration and management of the company

Art. 16. Administration. The Company shall be managed by a board of directors composed of an uneven number of

persons, of not less than five (5) members and not more than thirteen (13) members, and who do not need to be shareholders
of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders. Directors shall be elected by the

majority of the votes. The general meeting of shareholders shall further determine the number of directors, their remune-
ration and the term of their office.

From the first Closing Date, the board shall be composed by a majority of Independent Directors (as defined in article

35 "Definitions" below).

The "A" Shareholder shall be entitled to propose to the general meeting of shareholders a list containing the name of

nominees for the position of directors of the Company (the "List of Nominees"). The directors must be appointed by the
shareholders from the List of Nominees.

The List of Nominees must be presented by the "A" Shareholder to the Company in writing at least two (2) weeks prior

to the date of such general meeting.

The general meeting of shareholders shall choose and appoint as directors candidates from the List of Nominees.
If the "A" Shareholder fails to submit the List of Nominees, the general meeting of shareholders shall elect instead

candidates of its choice.

Any director may be removed with or without cause at any time by a resolution adopted by the general meeting of

shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director appointed by a general meeting of shareholders, the other directors

may appoint a new director to temporarily fill such vacancy; the shareholders shall take a final decision regarding such
nomination at their next general meeting.

Art. 17. Operation and meetings. The board of directors shall choose a chairman and may elect one or more vicechairmen

among its members. It shall also appoint a secretary, who does not need to be a director and who shall write and keep the
minutes of board of directors and shareholders meetings.

The board of directors shall meet when convened by the chairman or any two directors, at the place indicated in the

notice of the meeting. It shall meet in the Grand-Duchy of Luxembourg at least twice a year and also before any general
meeting of shareholders of any of the Company’s Luxembourg Subsidiaries (as defined in article 35 "Definitions" below).

Written notice of any board meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours prior to the time set

for the meeting, except in the event of an emergency, in which case the nature of this emergency shall be stated in the
convening notice of the meeting. This notice requirement may be disregarded following the agreement in writing or by
facsimile or e-mail transmission from each director. A special notice shall not be required for a meeting of the board of
directors being held at a time and a place determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

The chairman shall preside at the meetings of the directors and of the shareholders. In his absence, the shareholders or

the board members shall decide by a majority vote that another director, or in case of a shareholders' meeting, that any
other person shall be in the chair of such meetings.

Any director may arrange to be represented at board meetings by appointing another director to act as a proxy for him,

either in writing or by facsimile or e-mail. A director may represent more than one director.

81563

L

U X E M B O U R G

The board of directors may only deliberate and act if two thirds (2/3) of its members are present or represented. If the

quorum is not satisfied, a second meeting shall be convened. Such second meeting shall validly deliberate without quorum
requirement.

Decisions shall as a rule be taken by a majority vote of the directors present or represented. Amendments of the offering

memorandum of the Company shall require a resolution adopted by a specific majority of two thirds (2/3) of the votes of
the  directors  present  or  represented,  except  when  such  amendments  are  required  by  law  or  requested  by  a  regulatory
authority competent to request such amendments. In the latter case, amendments shall be decided by a majority vote of the
directors present or represented.

Any director or all directors may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means

of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a
meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors'

meetings; each director shall approve such resolution in writing, or by facsimile or e-mail or any other similar means of
communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves that such
decision has been taken.

Art. 18. Minutes. The minutes of board meetings shall be drafted by the secretary of the board of directors. Minutes of

a board of directors' meeting shall be approved at the following board of directors' meeting and, once approved, shall be
signed by the chairman or whoever has assumed the chairmanship in his absence and by another director.

Notwithstanding the above, the minutes of any meeting held in an emergency shall be immediately prepared by the

secretary of the board of directors and signed by the chairman or whoever has assumed the chairmanship in his absence
and by another director having participated in such meeting. Such minutes shall be deemed to be approved by the other
directors.

Any copies of or extracts from the minutes, which are to be used for legal or other purposes, shall be signed by the

chairman or by the secretary or by two directors.

Art. 19. Powers of the board of directors. The board of directors, applying the principle of risk spreading, shall determine

the investment policies and strategies of the Company and the course of conduct of the management and business affairs
of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws
and regulations.

The Company is authorized to employ techniques and instruments to the fullest extent permitted by law for the purpose

of efficient portfolio management.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within

the Company's purpose.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation to the general meeting of shareholders

fall to the board of directors.

Art. 20. Corporate signature. Towards third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two (2)

directors or by the joint or single signature of any officer(s) of the Company or of any other person(s) to whom authority
has been delegated by the board of directors.

Art. 21. Delegation of power. The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily

management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers
to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities,
which do not need to be members of the board, who shall have the powers determined by the board of directors and who
may, if the board of directors so authorizes, sub-delegate their powers.

The board of directors may appoint any officers, including a general manager and any possible assistant general managers

as well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such
appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers do not need to be directors or shareholders
of the Company. Any decision regarding the appointment or removal of such officers shall be taken by an unanimous vote
of the directors present or represented. Unless otherwise stipulated by these articles of incorporation, the officers shall have
the rights and duties conferred upon them by the board of directors.

Art. 22. Conflicts of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

For the avoidance of doubt, any director, executive or authorised representative who is a director, executive, authorised

representative or employee of a company or firm with which the Company places contracts or is otherwise engaged in
business relations, shall not be denied the right to deliberate, vote and act with regard to matters related to such contracts
or business dealings.

81564

L

U X E M B O U R G

If any director, executive or authorised representative has a personal interest in some part of the Company's business,

he shall inform the board of directors thereof. He shall not deliberate or take part in voting on this matter. The matter shall
be reported to the next shareholders' meeting. The term "personal interest" such as it is used above, shall not include any
relationship or interest of any kind that may exist in any capacity or in any connection with the "A" Shareholder, its parent
companies, its subsidiaries and affiliated or associated companies or with any other company or legal entity that the board
may determine at its discretion.

Art. 23. Indemnification. The Company may indemnify any director, officer, executive or authorised representative,

together with his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director, officer,
executive or authorised representative of the Company or, for being or having been, at the Company's request, a director,
officer, executive or authorised representative of any other company in which the Company is a shareholder or of which
it is a creditor and for which he would not be indemnified, except in relation to matters for which he is finally adjudged in
such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or wilful misconduct; in the event of an out-of-court
settlement, indemnification shall be provided only in connection with those matters covered by the settlement and provided
the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing
right of indemnification shall not exclude other rights to which such person may be entitled.

Chapter V - General meetings

Art. 24. General meetings of the company. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg,

either at the Company's registered office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting,
at 3 PM on the fourth Thursday of April. If this day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting shall
be held on the next banking day. The annual general meeting may be held abroad if the board of directors, acting with
sovereign powers, decides that this is warranted by exceptional circumstances.

Other general meetings of shareholders may be held at the place and on the date specified in the notice of meeting.
The requirements for participation, the quorum and the majority at each general meeting (as described below) are those

outlined in articles 67 and 67-1 of the law of Luxembourg of August 10 

th

 1915 on commercial companies, as amended.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of

the shareholders present or represented.

In accordance with article 68 of the law of Luxembourg of August 10, 1915 on commercial companies, as amended,

any resolution of the general meeting of shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of shares of class
or type vis-à-vis the rights of the holders of shares of any other class or classes, type or types shall be subject to a resolution
of the general meeting of shareholders of such class or classes, type or types. The resolutions, in order to be valid, must be
adopted in compliance with the quorum and majority requirements referred to in article 32 hereof, with respect to each
class or classes, type or types concerned.

The general meeting of shareholders shall be convened by the board of directors.
It may also be convened upon the request of shareholders representing at least one tenth (1/10) of the share capital.
The notice from the board of directors shall set forth the agenda, and shall be sent by registered mail at least eight (8)

days prior to the due date of the meeting, to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of
shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall
be prepared by the board of directors except if the meeting is called on the written demand of the shareholders in which
instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any

meeting of shareholders.

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting

of shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by
reference to the Shares issued and in circulation at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record
Date"), whereas the right of as shareholder to participate at a general meeting of shareholders and to exercise the voting
rights attached to his/its/her shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record
Date.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which

shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share, whatever its value, shall confer one vote. Fractions of shares do not give their holders any voting right.
Shareholders may take part in meetings by designating in writing or by facsimile other persons to act as their proxy.

Art. 25. General meetings with respect to a class of shares. The shareholders of the class or classes of shares may hold,

at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such class of shares.

The provisions of article 24 shall apply mutatis mutandis to such general meetings.

81565

L

U X E M B O U R G

Each share confers one vote in compliance with Luxembourg law and these articles of incorporation. Shareholders may

act either in person or by giving a written proxy to another person who need not be a shareholder and may be a director of
the Company. Fractions of shares do not confer any voting rights upon their holders.

Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a class of

shares are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

Chapter VI - Annual accounts

Art. 26. Financial year. The financial year starts on the 1 

st

 of January each year and ends on the 31 

st

 of December of

the same year.

The Company shall publish an annual report and a half-yearly report in accordance with the legislation in force. These

reports shall include financial information relative to the Company, and the composition and progress of its assets. The
Company shall also provide periodic financial statements to the shareholders, in accordance with the offering memorandum
of the Company.

The accounts of the Company shall be prepared in accordance with any permitted accounting standards accepted in

Luxembourg and considered by the board of directors to be the most appropriate for the Company.

Art. 27. Distributions. The general meeting (of all the shareholders or of the shareholders of the class or classes, as the

case may be) shall, upon proposal from the board of directors and within the limits provided by law, determine how the
results of the Company shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorise the board of directors to
declare, distributions of dividends.

The dividends shall initially be apportioned among the separate classes of B shares in proportion to their respective

Class Distribution Percentages then applicable.

For any class of shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in accordance

with the provisions of the offering memorandum of the Company and in compliance with the conditions set forth by law.

Dividends shall generally be distributed to the shareholders by the Company in the order of priority (including for interim

dividends) set out below, with respect to amounts available for distribution attributable to Investments (excluding Bridge
Financing, temporary investments and any income thereon) (for the avoidance of doubt, any proceeds representing the
redemption price paid by the Company upon a redemption made under article 11 shall be deemed to have been a dividend
distribution received by the affected B shareholders for purposes of the priority rules set forth in this article 27).

Dividends apportioned to a class of B Shares shall be allocated among the shareholders of such class of B shares and

the class "A" Shareholder for distribution in the following order of priority:

I. With respect to either of "class B-1" or "class B-2" shares, taken separately for this purpose:
(a) first, 100% to the holders of such class of shares (i.e., classes B-1 or B-2), pro rata among such shareholders based

upon shares of such class held, until the cumulative distributions to such shareholders equal the aggregate of the following:

(i) such shareholders’ aggregate capital contributions to the Company used to acquire all realized Investments (as defined

in article 35 "Definitions"), plus such shareholders’ proportionate share (based upon the aggregate Net Asset Value attri-
butable to the applicable class) of the amount (if any) by which the total capital contributions used to acquire the unrealized
Investments of the Company exceeds the net asset value of all unrealized Investments of the Company (calculated in
accordance with article 14) as of that time; and

(ii) such shareholders’ aggregate capital contributions to the Company used to pay organizational expenses and other

expenses of the Company, including the management fees of the manager of the Company (as such expenses and fees are
specified in the offering memorandum of the Company), allocated to the realized or written-off Investments of the Company,
as reasonably determined by the board of directors;

(b) second, 100% among the B-1 or B-2 shareholders, as the case may be, pro rata based upon their shares held, until

the cumulative distributions to such class of shareholders pursuant to this clause I.(b) of article 27 equal a preferred return
on their aggregate capital contributions to the Company (excluding any capital contributions attributable to any Bridge
Financing and temporary investments), calculated at the rate of 6% per annum, compounded annually (computed separately
for each capital contribution of such shareholders from the due date specified in the applicable Capital Call through to but
excluding the earlier of (1) the applicable dividend distribution date pursuant to this clause I.(b) of article 27 and (2) the
date of the distribution of such capital contribution pursuant to the clause I.(a) of article 27 above); and

(c) third, any remaining amounts to be distributed following the satisfaction of preferred return under clause I.(b) of

article 27 shall be allocated (i) 80% among the class B-1 or B-2 shareholders, as the case may be, pro rata based upon their
shares held; and (ii) 20% to the "A" Shares (or to the new shares created upon conversion of the "A" Shares in accordance
with the provisions of article 9 above); provided that it is specified that the amount otherwise payable under this clause I.
(c)(ii) of article 27 by the Company to the "A" Shareholder will be reduced by way of credit of any amount attributable
directly or indirectly to the capital contributions of the class B-1 or B-2 shareholders, as the case may be, distributed or
paid to the "A" Shareholder (and/or, if applicable, any of its wholly-owned Affiliate(s)) in its capacity as unlimited partner/
manager of any Luxembourg Subsidiary (excluding any return of or on capital invested by the "A" Shareholder and/or, if
applicable, any of its whollyowned Affiliate(s) in a Luxembourg Subsidiary).

II. With respect to class "B-2 Premium" shares:

81566

L

U X E M B O U R G

(a) first, 100% to the holders of B-2 Premium shares, pro rata among such shareholders based upon shares held, until

the cumulative distributions to such shareholders equal the aggregate of the following:

(i) B-2 Premium shareholders’ aggregate capital contributions to the Company used to acquire all realized Investments

(as defined in article 35 "Definitions"), plus such shareholders’ proportionate share (based upon the aggregate Net Asset
Value of the class B-2 Premium) of the amount (if any) by which the total capital contributions used to acquire the unrealized
Investments of the Company exceeds the net asset value of all unrealized Investments of the Company (calculated in
accordance with article 14) as of that time; and

(ii) B-2 Premium shareholders’ aggregate capital contributions to the Company used to pay organizational expenses and

other expenses of the Company, including the management fees of the manager of the Company (as such expenses and
fees are specified in the offering memorandum of the Company), allocated to the realized or written-off Investments of the
Company, as reasonably determined by the board of directors;

(b) second, 100% among the B-2 Premium shareholders, pro rata based upon their shares held, until the cumulative

distributions to the B-2 Premium shareholders pursuant to this clause II.(b) of article 27 equal a preferred return on their
aggregate capital contributions to the Company (excluding any capital contributions attributable to any Bridge Financing
and temporary investments) calculated at the rate of 7% per annum, compounded annually (computed separately for each
capital contribution of such B-2 Premium shareholder from the due date specified in the applicable Capital Call through
to but excluding the earlier of (1) the applicable dividend distribution date pursuant to this clause II.(b) of article 27 and
(2) the date of the distribution of such capital contribution pursuant to the clause II.(a) of article 27 above); and

(c) third, any remaining amounts to be distributed following the satisfaction of preferred return under clause II.(b) of

article 27 shall be allocated (i) 80% to the B-2 Premium shareholders pro rata based upon their shareholdings; and (ii) 20%
to the "A" Shares (or to the new shares created upon conversion of the "A" Shares in accordance with the provisions of
article 9 above); provided that it is specified that the amount otherwise payable under this clause II.(c)(ii) of article 27 by
the Company to the "A" Shareholder will be reduced by way of credit of any amount attributable directly or indirectly to
the capital contributions of the class B-2 Premium shareholders distributed or paid to the "A" Shareholder (and/or, if
applicable, any of its wholly-owned Affiliate(s)) in its capacity as unlimited partner/manager of any Luxembourg Subsidiary
(excluding any return of or on capital invested by the "A" Shareholder and/or, if applicable, any of its wholly-owned
Affiliate(s) in any Luxembourg Subsidiary).

III. With respect to "class B-3" shares, 100% to the holder of class B-3 shares.
Amounts available for distribution attributable to any Bridge Financing or temporary investments) shall be paid to the

B-1, B-2, B-2 Premium and B-3 shareholders pro rata in proportion to their capital contributions to the investment giving
rise to such available amounts or, in the discretion of the board of directors, in proportion to their Commitments, at such
times and in such amounts as the board of directors determines to be appropriate.

If less than all of an Investment is disposed of by the Company, the portion disposed of and the portion retained shall

be deemed to be separate Investment for purposes of calculating dividends for this article 27. Any capital contributions or
dividends made with respect to such Investment, and any amounts received or expenses paid by the Company prior to such
disposition that are attributable to such Investment, shall be allocated between the portion disposed of and the portion
retained in proportion to their respective acquisition costs.

Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of shareholders.
Distributions may be paid at such time and place as the board of directors shall determine from time to time.
Any distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and reverted to the

class or classes of shares concerned by such distribution.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

Chapter VII - Custody, Transfer and re-use of assets

Art. 28. Depositary agreement. The Company shall enter into a depositary agreement with an entity, which shall satisfy

the requirements of the Luxembourg laws, and in particular the 2013 Law (the "Depositary"). The Depositary shall assume
towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by the applicable law.

The Depositary of the Company may discharge itself of its liability provided that certain conditions are met, including

the condition that, where the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local
entity and there are no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in point (d)(ii) of the second paragraph
of article 19(11) of the 2013 Law, the articles of incorporation expressly allow for such a discharge under the conditions
set out in article 19(14) of the 2013 Law. The Company hereby expressly allows its board of directors to grant such a
discharge and, more generally, allows the board of directors to grant any discharge by the Depositary of its liability that is
not prohibited by any applicable laws and regulations and to be in place in accordance with the conditions set out in the
2013 Law.

Information regarding any discharge by the Depositary of its liability, as well as any material change to this information,

may be disclosed or made available to Investors in, via and/or at any of the Information Means listed in article 33 of these
articles of incorporation; it being understood that availability or disclosure of any information regarding discharge by the
Depositary of its liability may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.

81567

L

U X E M B O U R G

Chapter VIII - Audit

Art. 29. Auditor. The Company shall hold its accounting data in an annual report inspected by an independent audit

firm. The independent audit firm's report issued subsequent to this inspection shall at least testify that this accounting data
provides a true and accurate reflection of the state of the Company's assets and liabilities. The independent audit firm shall
be appointed by the shareholder's general meeting, upon the proposal of the audit committee, which shall also decide its
remuneration. The auditor shall fulfil all duties prescribed by law.

Art. 30. Audit committee. At the Closing Date, the board of directors shall appoint an audit committee composed of

three members chosen amongst the Independent Directors.

The audit committee shall be responsible for (i) controlling the compliance of the activities of the Company with these

articles of incorporation and the offering memorandum of the Company, (ii) proposing to the shareholders general meeting
the appointment and remuneration of and overseeing the Company’s independent audit firm, including the resolution of
disagreements regarding financial reporting between the Company’s management and such independent audit firm, (iii)
ensuring  the  independence  of  the  Company’s  audit  firm  and,  (iv)  approving  the  financial  statements  before  these  are
presented by the board of directors to the general meeting of shareholders.

The audit committee shall choose a chairman from among its members and shall decide on the frequency and formalities

applicable to its meetings. Decisions shall be taken by a majority vote of the members present or represented. If an equal
number of votes is cast for and against a decision at a board meeting, the chairman shall have the casting vote.

Chapter IX - Winding-up - Liquidation

Art. 31. Winding-up/Liquidation. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of

shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in this article 31.

Whenever  the  share  capital  falls  below  two-thirds  (2/3)  of  the  minimum  capital  referred  to  in  article  5  hereof,  the

dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the board of directors.

The general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by a simple majority of the votes cast by the

shareholders present or represented at the meeting.

The dissolution of the Company shall also be referred to the general meeting whenever the share capital falls below one-

fourth (1/4) of the minimum capital referred to in article 5 hereof; in such an event, the general meeting shall be held without
any quorum requirements and the dissolution may be decided by the shareholders holding one fourth (1/4) of the Shares
represented at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascertainment that the net assets

of the Company have fallen below two-thirds (2/3) or one-fourth (1/4) of the legal minimum, as the case may be.

A dissolution of the Company in any other circumstances shall be referred to the general meeting by the board of

directors; in such an event, the dissolution may be decided by the general meeting of shareholders subject to the quorum
and majority requirements referred to in article 32 below.

Liquidation of the Company shall be carried out by the "A" Shareholder. The "A" Shareholder shall be appointed in

such capacity by the general meeting of shareholders and the powers and compensation of the liquidator shall be determined
by this general meeting of shareholders. The duties of the liquidator shall last until all the assets of the Company are sold,
for distribution of the cash proceeds to the shareholders. Such cash proceeds shall be attributed to the shareholders in
accordance with the order of priority set forth in article 27 above, and subject to the provisions of the offering memorandum
of the Company.

Chapter X - General provisions

Art. 32. Amendment of the articles of incorporation. These articles of incorporation may be amended by a shareholders'

general meeting, subject to the quorum and voting conditions (as described below) laid down by article 67-1 of the law of
10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Unless otherwise provided herein, an extraordinary general meeting may amend any provision of the articles of incor-

poration. The general meeting shall not validly deliberate unless at least one half (1/2) of the capital is represented and the
agenda indicates the proposed amendments to the articles of incorporation and, where applicable, the text of those amend-
ments relating to the purpose or the form of the Company. If the quorum requirement is not satisfied, a second meeting
may be convened by means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the
meeting in the Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such convening notices shall reproduce the agenda and
indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the
proportion of the capital represented.

At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be approved by a majority of at least two thirds (2/3) of the

votes cast by the shareholders present or represented. However, the nationality of the Company may be changed and the
commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

Art. 33. Investor's information. Any information or document that the Company or its AIFM must or wishes to disclose

or be made available to some or all of the Investors shall be validly disclosed or made available to any of the concerned
Investors in, via and/or at any of the following information means (each an "Information Means"): (i) the Company's sales

81568

L

U X E M B O U R G

documents, offering or marketing documentation, (ii) subscription, redemption, conversion or transfer form, (iii) contract
note, statement or confirmation in any other form, (iv) letter, telecopy, e-mail or any type of notice or message, (v) publi-
cation in the (electronic or printed) press, (vi) the Company's periodic report, (vii) the Company's, AIFM's or any third
party's registered office, (viii) a third-party, (ix) internet/a website (as the case may be subject to password or other limi-
tations) and (x) any other means or medium to be freely determined from time to time by the Company or its AIFM to the
extent that such means or medium comply and remain consistent with these articles of incorporation and applicable Lu-
xembourg laws and regulations.

The Company or its AIFM may freely determine from to time the specific Information Means to be used to disclose or

make available a specific information or document, provided, however, that at least one current Information Means used
to disclose or make available any specific information or document to be disclosed or made available shall at least be
indicated in either the Company's sales documents or at the Company's or AIFM's registered office.

Certain Information Means (each hereinafter an "Electronic Information Means") used to disclose or make available

certain information or document requires an access to internet and/or to an electronic messaging system. By the sole fact
of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor acknowledges the possible use of Electronic Infor-
mation Means and confirms having access to internet and to an electronic messaging system allowing this Investor to access
the information or document disclosed or made available via an Electronic Information Means.

By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor (i) acknowledges and consents

that the information to be disclosed in accordance with article 13(1) and (2) of the AIFM Law may be provided by means
of a website without being addressed personally thereto and (ii) that the address of the relevant website and the place of
the website where the information may be accessed is indicated in either the Company's sales documents or at the Company's
or AIFM's registered office.

Any prospective or existing shareholder ("Investor") may be accorded a preferential treatment, or a right to obtain a

preferential treatment (a "Preferential Treatment") subject to, and in compliance with the conditions set forth in, applicable
laws and regulations.

A Preferential Treatment may take any form that is not inconsistent (or incompatible) with these articles of incorporation

or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of, the
Company and/or its AIFM and may be assorted with a "most favoured nation" clause in favour of all or certain Investors.
The existence or introduction of a Preferential Treatment or the fact that one or more investors have been accorded a
Preferential Treatment may create a right in favour of any other Investor (the "new Investor") to claim such a Preferential
Treatment for its benefit, if, in relation to this new Investor, all the criteria and features on which is based the relevant
Preferential Treatment are met, and if the situation and features of this new Investor are identical to any of the investors to
whom this Preferential Treatment has been accorded.

Should an Investor obtains a Preferential Treatment, a description of that Preferential Treatment, the type of Investors

who obtain such preferential treatment and, where relevant, their legal or economic links with the Company or its AIFM,
as well as any material change to this information, may be disclosed or made available to Investors in, via and/or at any of
the Information Means listed in this article 33; it being understood that availability or disclosure of any information re-
garding Preferential Treatment may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.

For the avoidance of doubt, any preferential treatment accorded to an Investor not resulting in a disadvantage to the

other investors does not qualify as a Preferential Treatment and hence is not subject to the foregoing conditions applicable
to a Preferential Treatment.

Art. 34. Applicable law. In respect of all matters not governed by these articles of incorporation, the parties shall refer

to the provisions of the law of August 10 

th

 1915 on commercial companies and the amendments thereto, and to the 2007

Law.

Art. 35. Definitions. Whenever used in these articles of incorporation, unless there is something inconsistent in the

subject matter or context, defined terms shall have the following meanings and capitalised terms not defined below shall
have the meaning ascribed to them in the offering memorandum of the Company:

"A" Share Class means a specific share class issued in registered form and reserved to the Manager (also referred to as

"A" Shares);

"A" Shareholder means the Manager;
Affiliate means in respect of any person: (a) any entity which controls (the Controlling Entity), or any entity which is

controlled by (the Controlled Entity), that person (i) either through the direct or indirect ownership of the majority of the
voting rights at the general assembly, or (ii) through the effective exercise of management power within the management
structure of the Controlled Entity, or (iii) through the exercise of a significant influence over the Controlled Entity and
ownership of at least 20% of the share capital of the Controlled Entity, including in both case jointly with other persons
through specific agreements; and (b) any other person having the same Controlling Entity.

AIFM or Manager means any alternative investment fund manager appointed by the Company in accordance with the

2013 Law;

Articles of Incorporation means the present articles of incorporation of the Company as may be amended from time to

time;

81569

L

U X E M B O U R G

Bridge Financing means any interim debt financing made in connection with an Investment and in accordance with the

offering memorandum of the Company.

Closing Date means the day on which a commitment period will terminate, as determined in the offering memorandum

of the Company;

Company means Cube Infrastructure Fund;
Class Distribution Percentages means, with respect to each respective class of B shares (i.e., class B-1 shares, class B-2

shares, class B-2 Premium shares and class B-3 shares) as of each applicable date of determination, a fraction, expressed
as a percentage, the numerator of which is the Net Asset Value of the applicable class of B shares and the denominator of
which is the sum of the Net Asset Value of all classes of B shares.

Independent  Director:  a  director  will  be  considered  independent  if  he  is  not  a  member  of  management  of  the  "A"

Shareholder and if he:

- is not a substantial shareholder of the "A" Shareholder, or of a company holding directly or indirectly more than ten

per cent of the "A" Shareholder's voting stock or an officer of or otherwise associated directly or indirectly with a shareholder
holding more, directly or indirectly, than ten per cent of the "A" Shareholder's voting stock;

- has not within the last three years been employed in an executive capacity by the "A" Shareholder or by an Affiliate

of the "A" Shareholder or been a director after ceasing to hold any such employment;

- is not a principal or employee of a professional adviser to the "A" Shareholder or of an Affiliate of the "A" Shareholder

whose billings exceed five per cent of the adviser's total revenues;

- is not a significant supplier or customer of the "A" Shareholder or of an Affiliate of the "A" Shareholder or an officer

of or otherwise associated directly or indirectly with a significant supplier or customer. A significant supplier is defined as
one whose revenues from the "A" Shareholder and its Affiliates exceed five per cent of supplier's total revenue. A significant
customer is one whose debts to the "A" Shareholder and its Affiliates exceed five per cent of the customer's total operating
costs;

- has no material contractual relationship with the "A" Shareholder or any of its Affiliates other than as a director of the

"A" Shareholder;

- is not a director of any of the "A" Shareholder parent companies' subsidiaries or Affiliates; and
- has no other interest or relationship that could interfere with the director's ability to act in the best interests of the

Company and independently of management.

With good cause, the board of directors of the Company may at its discretion determine that a director is independent

notwithstanding that not all of the above criteria are satisfied. Correspondingly, the board of directors of the Company can,
in appropriate circumstances, determine that a board member has lost his independence.

Investments means any investment made, directly or indirectly in any instrument (including equity, quasi-equity, debt,

corporate guarantees in connection thereto and irrevocable undertakings to invest) by the Company or a Luxembourg
Subsidiary;

Luxembourg Subsidiary(ies) means the one or several subsidiary(ies) incorporated in Luxembourg in the form of a

société en commandite par actions, or any other form of entity, through which the Company may hold its Investments;

Net Asset Value or NAV means the net asset value of the Company as determined in accordance with these articles of

incorporation and the offering memorandum of the Company, or, as the context may require, the portion of such net asset
value of the Company directly attributable to as specified class of shares of the Company.

US Person has the meaning ascribed to that term in Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as amended;
Valuation Day means any valuation day of the shares of the Company;
2007 Law means the law of 13 February 2007 on specialised investment funds;
2010 Law means the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended;
2013 Law means the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers, as may be amended.”
It is further resolved that the French translation of the articles of association be deleted as it is not required anymore

under the 2007 Law.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated

at two thousand euro (EUR 2,000).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, surname, civil status and

residence, signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: M. Bernot, L. Sold, M. Wunderlich et M. Schaeffer.

81570

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 juin 2015. 2LAC/2015/14220. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2015.

Référence de publication: 2015106549/983.
(150117143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2015.

WW¤studio, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 65, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 196.743.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-huit avril.
Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU

1.- Madame Laura MANNELLI, architecte, née le 23 mars 1980 à Luxembourg, demeurant à L-8365 Hagen, 65, Rue

Principale.

2.- Madame Elodie LENOIR, architecte d'intérieur cfai, née le 6 juin 1982 à Paris (France), demeurant à L-2181 Lu-

xembourg, 6, rue G.C.Marshall.

Lesquelles comparantes, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité

limitée, qu'elles déclarent constituer entre elles.

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'un bureau d'architecture, d'architecture d'intérieur et activités connexes

dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles déontologiques de l'Ordre Luxembourgeois des Architectes et des
Ingénieurs-Conseils (l"OAI").

A ce titre, elle peut accomplir tant au Luxembourg qu'à l'étranger toutes opérations et activités se rapportant à l'archi-

tecture, à l'architecture d'intérieur ainsi que toutes prestations consultatives, d'assistance, de contrôle, de coordination,
d'expertise et d'étude dans le domaine de l'architecture, ainsi que toutes activités se rapportant directement ou indirectement,
en tout ou en partie, à l'exercice et aux disciplines de la profession d'architecte et aux disciplines spécialisées dans l'art de
bâtir.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

La Société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance

professionnelle de l'activité libérale d'architecte/ingénieur-conseil et elle s'engage à respecter toutes les dispositions légis-
latives et réglementaires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société est constituée sous le nom de «WW*studio».

Art. 5. Le siège social est établi à Hagen.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société
peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres
pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)

parts sociales, d'une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

81571

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés repré-

sentant les trois quarts du capital social, en conformité avec l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et sous réserve que le cessionnaire remplisse les conditions requises par l'OAI.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non- associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des parts sociales appartenant aux survivants, en conformité avec
l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et sous réserve que le cessionnaire remplisse
les conditions par l'OAI.

En cas de refus de cession, les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs

de l'actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société. Les parts doivent être

détenues au moins à:

a) 75% par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s), inscrite(s) à l'OAI:
i) dont au moins 51 % par un ou plusieurs membre(s) obligatoire(s) de l'OAI, c'est-à-dire exerçant sa (leur) profession

à titre d'indépendant, et

ii) dont au moins 26% des parts et des droits de vote sont détenus par un ou plusieurs membre(s) obligatoire(s) et établi

(s) au Grand-Duché de Luxembourg et disposant de la qualification requise à l'exercice de l'activité mentionnée sur l'au-
torisation d'établissement de la Société;

b) les 25% restants au maximum par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) qui ne risque(nt) pas de

porter atteinte, directement ou indirectement, à L'indépendance professionnelle de la Société.

Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à

la Société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la Société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément
aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés, dont au moins un gérant

technique.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement

révocables à tout moment et sans cause.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants

dont obligatoirement celle du gérant technique, ou par la signature individuelle du gérant administratif pour toute opération
inférieure à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-), ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à
laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, ou par le gérant unique.

Art. 12. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir

parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les

associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la
présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de
chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation  spéciale  ne  sera  pas  requise  pour  une  réunion  du  conseil  de  gérance  se  tenant  à  une  heure  et  un  endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier

électronique ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou d'autres

moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les
autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

81572

L

U X E M B O U R G

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,

par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Art. 18. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés

par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 19. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre

de la même année.

Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un

inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication
au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le conseil
de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont dispo-
nibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par l'assemblée 7 des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription - Libération

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Madame Laura MANNELLI, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 parts sociales

2.- Madame Elodie LENOIR, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 parts sociales

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société

en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille Euros (EUR 1.000,-).

81573

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée générale

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité

des voix ont pris les décisions suivantes:

1- Sont nommées gérantes de la société pour une durée indéterminée:
Madame Laura MANNELLI, préqualifiée, en tant que gérante technique.
Madame Elodie LENOIR, préqualifiée, en tant que gérante administrative.
2- Le siège social de la société est fixé à L-8365 Hagen, 65, Rue Principale.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. MANNELLI, E. LENOIR et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 29 avril 2015. 1LAC / 2015 / 13334. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015072903/168.
(150083078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Lux. Ouvrage d'Art S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4742 Pétange, 81A, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 99.067.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015072585/10.
(150082112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Luxinvest Investment Advisors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 177.668.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015072590/9.
(150083113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Malabar Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 151.891.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2015072596/10.
(150082795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Mishte Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 185.471.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015072601/10.
(150083057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

81574

L

U X E M B O U R G

Shiplux III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 111.971.

<i>Extrait des Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2015

M. Michel JADOT, M. Kristof WUYTACK et M. Jozef ADRIAENS sont renommés administrateurs.
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de la société BDO AUDIT S.A.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016.
M. Kristof Wuytack, administrateur, a comme nouvelle adresse: 3, rue Schiller L-2519 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
Michel Jadot / Jozef Adriaens
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015072793/15.
(150082969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Marim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 51.726.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015072604/9.
(150082135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Nalys Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 189.871.

L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois d'avril,
Par devant Nous, Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale de l'actionnaire unique de Nalys Investment S.A., une société anonyme constituée et organisée

sous le droit luxembourgeois, suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
14 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2995 du 17 octobre 2014 (la Société).
Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Madame Isabel DIAS, employée privée, dont l'adresse professionnelle est à L-1750 Lu-

xembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le président nomme comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, avec la même adresse profes-

sionnelle.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Isabel DIAS, prénommée.
Le bureau ainsi formé, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'actionnaire unique présent ou représenté et le nombre d'actions détenues par celui-ci sont indiqués dans une liste de

présence. Cette liste et la procuration, après avoir été signée par le mandataire de la partie comparante et le notaire, resteront
attachées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

II. Cette liste de présence montre que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital sont présentes ou représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, qui sont connus de l'actionnaire unique.

III. Le capital social de la Société est actuellement fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000) représenté par soixante-

deux  (62)  actions  ordinaires  numérotées  de  1  à  62  (les  Actions  Ordinaires)  et  trente-huit  (38)  actions  préférentielles
numérotées de 63 à 100 (les Actions Préférentielles), ayant une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.

Les Actions Préférentielles se divisent en classes (la/les Classe(s)) comme suit:
a) 11 Actions Préférentielles de Classe A;
b) 3 Actions Préférentielles de Classe B;
c) 3 Actions Préférentielles de Classe C;

81575

L

U X E M B O U R G

d) 3 Actions Préférentielles de Classe D;
e) 3 Actions Préférentielles de Classe E;
f) 3 Actions Préférentielles de Classe F;
g) 3 Actions Préférentielles de Classe G;
h) 3 Actions Préférentielles de Classe H;
i) 3 Actions Préférentielles de Classe I;
j) 3 Actions Préférentielles de Classe J.
IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000) moyennant l'aug-

mentation de la valeur nominale de toutes les actions de la Société de cinq cents euros (EUR 500) à mille euros (EUR
1.000) chacune;

2. Paiement par Wise Services S.à r.l. pour ladite augmentation de la valeur nominale des actions, par un apport en

numéraire de cinquante mille euros (EUR 50.000), qui sera entièrement attribué au capital social de la Société;

3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société, de manière à refléter l'augmentation de capital ci-dessus;
4. Annulation et remplacement des bons au porteur émis en date du 21 août 2014 par l'émission d'un nouveau bon au

porteur représentant les Actions Ordinaires et d'un nouveau bon au porteur représentant les Actions Préférentielles;

5. Divers.
Ces faits ayant été exposés et reconnus comme vrais par l'assemblée, l'assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000) de

manière à l'augmenter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) divisé tel que décrit ci-dessus, d'une
valeur nominale telle que mentionnée ci-dessus, à un montant de cent mille euros (EUR 100.000) par l'augmentation de la
valeur nominale de toutes les actions de la Société de cinq cents euros (EUR 500) à mille euros (EUR 1.000) chacune.

<i>Souscription - Paiement

Par conséquent, l'actionnaire unique Wise Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.823 et ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500),
déclare d'avoir entièrement libéré les actions augmentées en valeur nominale par versement en espèces, de sorte que la
somme de cinquante mille euros (EUR 50.000) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.

Les documents justificatifs du paiement ont été fournis au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui aura

dorénavant la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent mille euros (EUR 100,000) représenté par soixante-deux

(62) actions ordinaires numérotées de 1 à 62 (les Actions Ordinaires) et trente-huit (38) actions préférentielles numérotées
de 63 à 100 (les Actions Préférentielles), ayant une valeur nominale de mille euros (1000 EUR) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.

Les Actions Préférentielles se divisent en classes (la/les Classe(s)) comme suit:
a) 11 Actions Préférentielles de Classe A;
b) 3 Actions Préférentielles de Classe B;
c) 3 Actions Préférentielles de Classe C;
d) 3 Actions Préférentielles de Classe D;
e) 3 Actions Préférentielles de Classe E;
f) 3 Actions Préférentielles de Classe F;
g) 3 Actions Préférentielles de Classe G;
h) 3 Actions Préférentielles de Classe H;
i) 3 Actions Préférentielles de Classe I;
j) 3 Actions Préférentielles de Classe J.
Toute référence faite aux «Actions Préférentielles» ci-après devra être formulée en tant que référence à la Classe d'Ac-

tions Préférentielles A et/ou B et/ou C et/ou D et/ou E et/ou F et/ou G et/ou H et/ou I et/ou J, dépendant du contexte.

Toute référence faite aux «actions» ci-après devra être formulée en tant que référence aux Actions Ordinaires et aux

Actions Préférentielles».

81576

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'annuler et remplacer les deux bons au porteur émis en date du 21 août 2014 par l'émission d'un

nouveau bon au porteur représentant les Actions Ordinaires et un nouveau bon au porteur représentant les Actions Préfé-
rentielles.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques incombant à la Société en raison des pré-

sentes, s'élève approximativement à mille six cents euro (EUR 1.600.-).

<i>Déclaration

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qui figure en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, agissant comme indiqué précédemment, qui est connu du

notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: I. Dias, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 8 mai 2015. 2LAC/2015/10116. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): André Muller.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2015.

Référence de publication: 2015072633/105.
(150082266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Timelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 34.776.

L'an deux mille quinze, le dix avril.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Roger SCHÜTZ, ingénieur-conseil, demeurant à B-6900 Aye (Belgique), 42, rue de Serinchamps,
propriétaire de mille cinq cents (1.500) parts en usufruit,
2.- Madame Anne SCHÜTZ, employée, demeurant à B-6900 Aye (Belgique), 42, rue de Serinchamps,
propriétaire de cinq cents (500) parts en nue-propriété,
3.- Madame Julie SCHÜTZ, employée, demeurant à B-4130 Méry (Belgique), 64/11, avenue d'Esneux,
propriétaire de cinq cents (500) parts en nue-propriété,
4.- Monsieur Cédric SCHÜTZ, employé, demeurant à B-6900 Marche-en-Famenne (Belgique), 32, rue du Commerce,
propriétaire de cinq cents (500) parts en nue-propriété,
tous ici représentés par Monsieur Marcel KRIER, comptable, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg,

9, avenue Guillaume, en vertu de quatre procurations données sous seing privé en date du 31 mars 2015,

Lesquelles procuration resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Les comparants sont les seuls associés de la société "TIMELUX S.à r.l.", établie et ayant son siège à L-4972 Dippach,

39, rue des Trois Cantons, constituée suivant acte du notaire Franck BADEN de Luxembourg en date du 27 août 1990,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 71 du 15 février 1991, dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte du notaire Paul DECKER de Luxembourg en date du 19 mai 2006, publié au dit Mémorial
C, Numéro 1467 du 31 juillet 2006, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
34.776.

Les comparants, représentés comme il est dit ci-dessus, prennent chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les comparants décident de transférer le siège social de Dippach à Luxembourg et par conséquent de modifier le premier

alinéa de l'article 4 des statuts comme suit:

Art. 4. Premier alinéa. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg."

<i>Deuxième résolution

Les comparants fixent l'adresse du siège de la société à L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

81577

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Les comparants constatent le changement d'adresse de Cédric SCHÜTZ au 32, rue du Commerce à B-6900 Marche-en-

Famenne (Belgique) et de Julie SCHÜTZ au 64/11, avenue d'Esneux à B-4130 Méry (Belgique).

Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le mandataire des comparants a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: KRIER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 avril 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 11384. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 13 mai 2015.

Référence de publication: 2015072860/48.
(150082156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Orange 3 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 169.760.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015072652/9.
(150082176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

«Ouestia Intermediate S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 189.412.

Les statuts coordonnés au 15/04/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15/05/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015072658/12.
(150082841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Letterone Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 176.010.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 17 avril 2015 que:
Nigel Robinson a démissionné comme administrateur de classe I avec effet au 27 mars 2015;
Lord Mervyn Davies, né le 21 novembre 1952 à Bangor, Royaume-Uni et domicilié à Devonshire House, 1 Mayfair

Place, Londres W1J 8AJ, Royaume-Uni, a été nommé en tant qu'administrateur de classe I de la Société avec effet au 17
avril 2015 pour une durée se terminant à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de la Société pour
l'exercice social se terminant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

Les administrateurs restants ont été nommés en tant qu'administrateurs et administrateurs de classe I de la Société avec

effet au 17 avril 2015 pour une durée se terminant à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de la
Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

Il en résulte que le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- Mikhail Fridman, administrateur;
- German Khan, administrateur;

81578

L

U X E M B O U R G

- Alexey Kuzmichev, administrateur;
- Petr Aven, administrateur;
- Andrey Kosogov, administrateur;
- Jonathan Muir, administrateur de Classe I;
- Pavel Nazariyan, administrateur de Classe I;
- Mervyn Davies, administrateur de Classe I, et
- David Gould, administrateur de Classe I.
Il résulte également de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 17 avril 2015 que Pricewaterhou-

seCoopers,  société  coopérative,  a  été  nommée  commissaire  aux  comptes  de  la  Société  pour  une  durée  se  terminant  à
l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 dé-
cembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015073286/33.
(150083235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Next Code Health Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 183.689.

In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of May.
Before us Me Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

NEXT CODE HEALTH LUXEMBOURG SARL, a company existing under the Laws of Luxembourg, with registered

office at 128, boulevard de la Pétrusse registered with the trade register of Luxembourg under the number B183646, here
represented by Mrs Sofia AFONSODA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by
virtue of a proxy given in Luxembourg on March 17 

th

 2015;

Which proxy shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity, NEXT CODE HEALTH LUXEMBOURG SARL, is the sole partner of Next Code Health Cor-

poration S.à r.l., organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 128 Boulevard de
la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under
number B 183.689 (the "Company"), incorporated a deed of November 5 

th

 , 2013, published in the Mémorial C, number

716 dated 19 

th

 March 2014.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The sole part holder resolves to change, effective January 1, 2015, the currency of the corporate capital, from Euros into

US Dollars. The corporate capital, actually fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12.500.-), is converted into
US Dollars, at the rate of 1.- EUR = USD 1.21416. The sole part holder resolves to fix the new corporate capital of the
Company at fifteen thousand one hundred seventy seven US Dollars (15.177.- USD) and to fix the nominal value of each
share to zero US Dollars and one cent (USD 0.01) through the conversion of the existing shares into one million five
hundred seventeen thousand seven hundred (1,517,700) shares of zero US Dollars and one cent (USD 0.01) each.

Amendment of article 5 of the Articles of incorporation of the Company in order to reflect this.

<i>Second resolution

The sole partner resolves to amend article 5 of the by-laws of the Company in order to reflect such change of the currency,

which now reads as follows:

Art. 5. “The Company's subscribed share capital is fixed at fifteen thousand one hundred seventy seven US Dollars

(15.177.- USD) represented by one million five hundred seventeen thousand seven hundred (1,517,700) shares having a
par value of zero US Dollars one cent (USD 0,01.-) each.”

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby

grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign any
deed rectifying the present deed.

81579

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person, in case
of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le cinq mai.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch sur Alzette soussigné;

A COMPARU

NEXT CODE HEALTH LUXEMBOURG SARL, une société à responsabilité limité organisée selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 128 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B183.646 représenté
par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, en vertu
d’une procuration donnée le 17 mars 2015.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la personne représentant la partie comparante susnommée

et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée, NEXT CODE HEALTH LUXEMBOURG SARL, est l’associé unique de Next Code Health

Corporation S.à r.l., organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 128 Boulevard de
la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 183.689, constituée par un acte du 5 novembre 2013, publié au Mémorial C, numéro 716
du 13 mars 2014 (la «Société»).

Laquelle personne comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de convertir, avec effet au 1 

er

 janvier 2015, la devise du capital social, de l’Euro vers le Dollar

américain. Le capital social actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12,500) est converti en Dollars américains au
taux de 1 Euro = 1.21416 Dollar américain. L’associé unique décide donc de fixer le nouveau capital social à quinze mille
cent soixante-dix-sept US Dollars (15,177.-USD) et de fixer la valeur nominal des actions à USD 0,01 par la conversion
des parts sociales existantes en un million cinq cent dix-sept mille sept cents (1.517.700) parts sociales de zéro dollars
américains un cent (USD 0,01) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide alors de modifier l’article 5 des statuts de la Société pour refléter la conversion de la devise de

capital, lequel article sera comme suit:

Art. 5. «Le capital social de la Société est fixé quinze mille cent soixante-dix-sept US Dollars (15,177.- USD) représenté

par un million cinq cent dix-sept mille sept cents (1.517.700) parts sociales d'une valeur nominale de zéro dollars américains
un cent (0,01-USD) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à

tous employés de l’Étude du notaire soussigné, à l’effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête e la personne comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et

demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: AFONSO-DA CHAO CONDE, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 mai 2015. Relation: EAC/2015/10193. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch/Alzette, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015072645/91.
(150082750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

81580

L

U X E M B O U R G

Nitteler Hof Event &amp; Traiteur, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-5429 Hettermillen, 15, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 196.718.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreißigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Herr Marco Zandbergen, geboren am 5. Juni 1968 in Ridderkerk, NL, ansässig im Bruchhausenstrasse 12a, 54294

Trier, und

2. Maurits Zandbergen Beheer B.V., eine Gesellschaft niederländischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 34, Burensedijk,

NL 4197 RJ Buurrmalsen, Niederlande und eingetragen im Handelsregister der Niederlande unter Nummer 30237298,

hier vertreten durch Herrn Marco Zandbergen, vorbenannt, auf Grund einer Vollmacht erteilt unter Privatschrift.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung „ne varietur“ durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

In ihrer oben beschriebenen Eigenschaft ersucht die erschienene Partei den unterzeichneten Notar, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

Rechtsform - Name- Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Form, Name. Hiermit wird zwischen vorbenannten Parteien und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter wer-

den, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) (nachstehend die „Gesellschaft“) gemäß
den Bestimmungen des Rechts des Großherzogtums Luxemburg und dieser Satzung gegründet.

Die Gesellschaft kann einen einzigen Gesellschafter als Inhaber aller Anteile oder mehrere Gesellschafter (maximal

jedoch vierzig (40) Gesellschafter) haben.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Nitteler Hof Event &amp; Traiteur“.

Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde von Stadtbredimus. Er kann durch Beschluss der Geschäfts-

führer, die gemeinsam den Geschäftsführerrat der Gesellschaft bilden, an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt
werden.

Zweigniederlassungen können durch Beschluss der Geschäftsführer, die gemeinsam den Geschäftsführerrat der Ge-

sellschaft bilden, in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten und das Betreiben von einer oder mehreren Gaststätten,

sowie die Außer-Haus-Verpflegung (Catering), entweder in eigener Regie oder von verbundenen Unternehmen.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Aktivitäten, die mit ihrem Gesellschaftszweck im Einklang sind, durchführen,

wie das Anbieten von Übernachtungsmöglichkeiten, Hochzeitsplanung und

Außer-Haus-Aktivitäten an anderen Standorten.
Sie kann weiterhin alle kommerziellen, industriellen, finanziellen oder Immobilien betreffende Aktionen durchführen

und dazu noch alle weiteren Aktivitäten, die Ihr ermöglicht den Gesellschaftszweck zu erfüllen und kann diese Aktivitäten
in Luxembourg und anderen Ländern ausführen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann jederzeit mittels Beschluss der Gesellschafter mit Zustimmung der einfachen Mehrheit von Ge-

sellschaftern,  die  insgesamt  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals  halten,  oder  ggf.  durch  Beschluss  des  alleinigen
Gesellschafters aufgelöst werden

Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) aufgeteilt in fünf-

zigtausend (50.000) Anteile mit einem Wert von jeweils einem Euro (EUR 1,-).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch außer in dem nach dem Gesetz oder nach dieser

Satzung bestimmten Umfang.

Art. 6. Anteile, Anteilsübertragungen. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme in ordentlichen und außerordentlichen

Generalversammlungen.

Die Anteile sind im Verhältnis zur Gesellschaft nicht teilbar.
Die Gesellschaft erkennt pro Anteil jeweils nur einen Eigentümer an. Miteigentümer müssen einen einzigen Vertreter

ernennen, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

81581

L

U X E M B O U R G

Die Anteile der Gesellschaft sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter,

können sie nur mit vorheriger Zustimmung der Mehrheit der übrigen Gesellschafter von drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals an neue Gesellschafter übertragen werden.

Geschäftsanteile müssen durch notariellen oder privatschriftlichen Vertrag übertragen werden. Übertragungen von Ge-

schäftsanteilen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst wirksam, nachdem sie der Gesellschaft mitgeteilt oder von
ihr gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuchs (Code Civil) bestätigt worden sind.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zum Zwecke der sofortigen Einziehung erwerben.
Anteilsinhaberschaft impliziert das Einverständnis mit der Geltung der Satzung und der wirksam gefassten Beschlüsse

der Gesellschafter.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit mittels Beschluss der Gesellschafter

mit Zustimmung der einfachen Mehrheit von Gesellschaftern, die insgesamt drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten,
oder ggf. durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 8. Verhinderung eines Gesellschafters. Durch den Tode, die Insolvenz, den Vergleich mit Gläubigern, der Zah-

lungsunfähigkeit oder einer sonstigen Einschränkung der Rechtsposition eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht
aufgelöst.

Geschäftsführung

Art. 9. Geschäftsführer. Die Geschäftsführung der Gesellschaft besteht aus ein oder mehreren Geschäftsführern, die

gemeinsam den Geschäftsführerrat bilden. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung ernannt, welche deren Amtsdauer festsetzt. Die Geschäfts-

führer können jederzeit, ohne Angabe eines rechtfertigenden Grundes (cause légitime) durch die Generalversammlung
abberufen werden.

Art. 10. Befugnisse der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind mit den weitesten, d.h. mit sämtlichen nicht den

Gesellschaftern bzw. der Generalversammlung bzw. den Abschlussprüfern gesetzlich ausdrücklich obliegenden, Befu-
gnissen ausgestattet, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte,
die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen und zu genehmigen.

Art. 11. Delegation, Vertretung der Gesellschaft. Der Geschäftsführerrat kann an eine oder mehrere natürliche oder

juristische Personen bzw. Komitees spezielle Befugnisse bzw. Vertretungsbefugnisse zuweisen, oder diesen bestimmte
permanente oder vorübergehende Funktionen zuweisen. Diese Personen müssen weder Mitglied des Geschäftsführerrates
noch Gesellschafter sein. Ihre Befugnisse und Aufgaben werden seitens des Geschäftsführerrates bestimmt. Sie können
jederzeit durch den Geschäftsführerrat abberufen werden.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, durch (ii) die

gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern falls mehr Geschäftsführer gibt oder durch (iii) die Unterschrift einer
Person verpflichtet, der die Befugnis zur Unterzeichnung durch den Geschäftsführerrat erteilt worden ist. Der Geschäfts-
führerrat kann besondere Vollmachten auf Grund notariell beglaubigter oder privatschriftlicher Urkunde erteilen.

Art. 12. Sitzungen des Geschäftsführerrates. Der Geschäftsführerrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzen-

den. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer zu sein braucht und der für das Führen der Protokolle
der Sitzungen des Geschäftsführerrates und der Generalversammlungen zuständig ist.

Der Geschäftsführerrat tagt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem in dem

Einberufungsschreiben genannten Ort.

Der Vorsitzende leitet alle Geschäftsführerratssitzungen und Generalversammlungen, aber in seiner Abwesenheit kön-

nen die Geschäftsführer mit der Mehrheit der Anwesenden einen anderen vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Geschäftsführerratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem geplanten Sitzungsdatum

ein Einberufungsschreiben erhalten, außer in dringenden Fällen, in denen die Natur der Dringlichkeit im Einberufungss-
chreiben anzugeben ist. Durch schriftliche oder per Fax oder E-Mail gegebene Einwilligung eines jeden Geschäftsführers
kann auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden.

Ein Einberufungsschreiben ist auch für solche Sitzungen nicht erforderlich, bei denen alle Geschäftsführer anwesend

oder  vertreten  sind  und  erklären,  dass  sie  vor  der  Sitzung  von  der  Tagesordnung  Kenntnis  hatten,  sowie  für  einzelne
Sitzungen, die zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden, die vorher durch Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt
wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich an jeder Sitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, den er schriftlich,

auch per Faxschreiben oder, wenn die Herkunft erwiesen ist, per E-Mail, ernannt hat.

Der Geschäftsführerrat ist nur dann beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer

anwesend oder vertreten ist. Entscheidungen werden mit einer Mehrheit der an einer solchen Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmengleichheit fällt dem Vorsitzenden das entscheidende Stimmrecht zu.

81582

L

U X E M B O U R G

Jeder Geschäftsführer kann durch eine Konferenzschaltung oder durch ein ähnliches Kommunikationsmittel an einer

Sitzung teilnehmen unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen und mit diesen kom-
munizieren kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Art. 13. Form der Beschlüsse des Geschäftsführerrates. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates sind schriftlich auf-

zuzeichnen.

Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom vorläu-

figen Vorsitzenden, der dieser Sitzung vorstand, oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge
der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, müssen vom Vorsitzenden, vom Sekretär oder
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet werden.

Der Geschäftsführerrat kann einstimmige Beschlüsse auf einem oder mehreren voneinander getrennten ähnlichen Do-

kumenten durch Rundschreiben fassen, wenn er seine Zustimmung schriftlich, per Fax, per E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel erteilt. Die Gesamtheit solcher Dokumente bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende
Protokoll.

Art. 14. Vergütung der Geschäftsführer. Die Vergütung der jeweiligen Geschäftsführer wird von der Generalversamm-

lung festgelegt. Sie umfasst auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Geschäftsführern in Ausübung ihrer Tätigkeit
entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn, solche wären veranlasst durch
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Geschäftsführers.

Art. 15. Interessenskonflikte. Sofern ein Geschäftsführer der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Geschäftsvor-

fall der Gesellschaft ein persönliches Interesse hat, wird dieser Geschäftsführer dem Geschäftsführerrat dieses persönliche
Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall, vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen,
nicht an den Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen. Dies gilt nicht, wenn das Geschäft zu marktüblichen Bedingungen
eingegangen wird und zum normalen Geschäftsverlauf der Gesellschaft gehört.

Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und Dritten werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb

ungültig, dass ein oder mehrere Geschäftsführer der Gesellschaft in Hinblick auf diesen Dritten ein persönliches Interesse
haben oder dort Geschäftsführer, Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter bzw. leitender oder sonstiger Angestellter sind.
Ein Geschäftsführer der Gesellschaft, der Geschäftsführer, Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder einfacher
Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung ist, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige
Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht
daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzus-
timmen oder in anderer Weise für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 16. Tod oder Rücktritt. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem

Grund dies auch immer sein sollte, nicht aufgelöst.

Art. 17. Haftung. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie im Namen

der Gesellschaft vorschriftsmäßig eingehen bzw. eingegangen sind. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung
ihres Mandates verantwortlich.

Gesellschafter

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter.  Die  Gesellschafter  haben  die  ihnen  nach  dieser  Satzung  sowie  dem  Gesetz

zugewiesenen Befugnisse. Ein etwaiger alleiniger Gesellschafter übt die Befugnisse aus, die der Generalversammlung
gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung
zustehen.

Art. 19. Generalversammlung. Eine wirksam einberufene Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Ge-

sellschafter der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Gesellschafter.

Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Geschäftsführerrates zusammen. Sie kann auch auf Einladung von

Gesellschaftern, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, zusammentreten.

Die Einberufung zu den Generalversammlungen erfolgt per Schreiben an sämtliche Gesellschafter, welches die Tage-

sordnung enthält und wenigstens acht (8) Tage vor der Generalversammlung an jeden Gesellschafter versandt werden muss.
Die Mitteilung muss auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden.

Ungeachtet des vorstehenden, soweit eine jährliche Generalversammlung aufgrund des Vorhandenseins von mehr als

fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern erforderlich ist, findet diese in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem
anderen,  im  Einladungsschreiben  angegebenen  Ort  am  letzten  Montag  im  Juni  um  11.00  Uhr  statt.  Ist  dieser  Tag  ein
gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag, findet die Generalversammlung am letzten vorausgehenden Bankarbeitstag statt.

Andere Generalversammlungen können an denjenigen Orten und zu denjenigen Zeiten abgehalten werden, die in der

entsprechenden Einladung angegeben werden.

Sofern sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über

die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung auch ohne schriftliche Einladung stattfinden.

81583

L

U X E M B O U R G

Jeder Gesellschafter kann an den Generalversammlungen der Gesellschaft teilnehmen und auf diesen sprechen, unab-

hängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Ein Gesellschafter kann sich bei jeder Generalver-
sammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Ge-

neralversammlung durch die einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter gefasst.

Art. 20. Beschlüsse. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.
Die Beschlüsse der Gesellschafter sind, soweit das Gesetz und diese Satzung nichts anderes bestimmt, nur rechtswirk-

sam, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Eine Satzungsänderung erfordert die Zustimmung der einfachen Mehrheit von Gesellschaftern, die insgesamt drei Vier-

tel des Gesellschaftskapitals halten, oder ggf. durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters.

Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31.

Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Konten geschlossen und der/die Geschäftsführer

stellt/stellen eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung auf (gemeinsam der „Jahresabschluss“). Das Ergebnis der
Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Belastungen und Rückstellungen ist
der Nettogewinn der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 23. Dividenden. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn

Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
In Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften kann der Ge-
schäftsführerrat Dividenden und Zwischendividenden ausschütten.

Auflösung - Liquidation

Art. 24. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren

Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt; die Liquidatoren werden durch die Generalversammlung
der Gesellschaft oder durch den etwaigen alleinigen Gesellschafter ernannt, durch die/der die Befugnisse und Vergütungen
der Liquidatoren festgelegt werden. Sofern nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung
des Vermögens und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt, insofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen
getroffen wurden, oder an den etwaigen alleinigen Gesellschafter ausgeschüttet.

Weder eine Fusion noch eine Zusammenführung der Gesellschaft mit einem oder mehreren Rechtsträger(n), noch eine

Fusion oder Zusammenführung einer oder mehrerer Rechtsträger mit der Gesellschaft, noch ein Verkauf, eine Übertragung,
ein Leasing oder Tausch (gegen Geld, Wertpapiere oder anderweitige Gegenleistung) aller oder eines Teils der Aktiva der
Gesellschaft ist eine Liquidation im Sinne dieses Artikels 24, es sei denn, diese Fusion, diese Zusammenführung, dieser
Verkauf, diese Übertragung, dieses Leasing oder dieser Tausch steht in Verbindung mit oder soll ein Plan sein zur völligen
Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft.

Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte werden durch das Recht von Luxemburg,

insbesondere das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung, geregelt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Anteilseigner

Anteile

(Anzahl

Betrag

eingezahlt

(in Euro)

Herr Marco Zandbergen, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.500

27.500,-

Maurits Zandbergen Beheer B.V., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.500

22.500,-

Summe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

50.000,-

Alle Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass vorgenannte Summe von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-),

die vollständig dem Gesellschaftskapital zugewiesen wird, von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dem
unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

81584

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Gebühren und Auslagen werden auf ungefähr

tausendsechshundert Euro (EUR 1.600,-) geschätzt.

<i>Anmerkung

Der amtierende Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft

vor  jeglicher  geschäftlicher  Aktivität,  im  Besitz  einer  formgerechten  Handelsgenehmigung  in  Bezug  auf  den  Gesell-
schaftszweck sein muss, was die Komparenten ausdrücklich anerkannt haben.

<i>Abhaltung einer Generalversammlung

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft fassten die oben genannten Personen, welche das gesamte gezeichnete

Kapital vertreten und die Befugnisse einer Generalversammlung ausüben, die folgenden Beschlüsse:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 15, route du Vin, L-5429 Hettermillen.
2. Folgende Person wird auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Herr Marco Zandbergen, geboren am 5. Juni 1968 in Ridderkerk, NL, ansässig im Bruchhausenstrasse 12a, 54294

Trier.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, Vornamen, sowie

Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Zandbergen et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 08 mai 2015. 2LAC/2015/10118. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2015.

Référence de publication: 2015072637/239.
(150082630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Grohe Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 57.142.857,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 101.086.

In the year two thousand and fifteen, on the first of April,
Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

GraceB S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share

capital of one billion four hundred fifty-three million twelve thousand five hundred euro (EUR 1,453,012,500), having its
registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 179188, holder of 49,999,999 shares of the
Company,

hereby represented by Me Nicolas Gauzès, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on March 31, 2015;
GraceA Co., Ltd, a company governed by the laws of Japan, having its registered office at 2-1-1, Ojima, J-136-8535

Koto-ku, Tokyo, Japan and registered with the Tokyo Chamber of Commerce and Industry under number 0106-01-045017,
holder of 1 share of the Company

hereby represented by Me Nicolas Gauzès, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on March 31, 2015; and
Lixil Corporation, a company incorporated in Japan under number 0106-01-028126, whose registered office is at 2-1-1

Ojima, Koto-Ku, Tokyo 136-8535, Japan, holder of 7,142,857 shares of the Company;

hereby represented by Me Nicolas Gauzès, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on March 31, 2015;
(collectively hereinafter referred to as the “Shareholders”).
The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

81585

L

U X E M B O U R G

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the sole shareholders of

Grohe Group S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a
share capital of fifty-seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven euro (EUR 57,142,857),
having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (the “Company”),
incorporated following a notarial deed dated 18 May 2004, published in the Mémorial C, Recueuil des Sociétés et Asso-
ciations number 637 of 21 June 2004 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, under
number B 101086.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 2 April 2014 pursuant to a notarial

deed published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association number 1658 of 27 June 2014.

The Shareholders, represented as above mentioned, have requested the notary to record the following:
(i) that the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1 To amend articles 18 and 19 of the articles of incorporation.
2 Miscellaneous.
(ii) that the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders and the undersigned notary will also

remain annexed to the present deed;

(iii) that the entire share capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared

that they had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting and waived their right to be formally convened;

(iv) that the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda;
(v) that the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

<i>Sole resolution

The general meeting of shareholders resolved to amend article 18 and article 19 of the articles of incorporation, which

will from now on read as follows:

“ Art. 18. The following items shall require the approval of the general meeting of shareholders and none of the following

decisions shall be adopted by the Managers or the Board of Managers, as applicable, without the express approval of the
general meeting of the shareholders with the majority set out in article 17 first paragraph:

- the approval of the business plan (original and revisions) of the Company;
- any corporate re-organization of the Company including merger with its majority shareholder and corporate splits;
- the nomination and dismissal of the Company’s Managers;
- the approval of yearly financial statements for the Company and associated net profit &amp; loss distribution;
- any action of the Company which could materially affect its enterprise value;
- the approval of the quarterly financial statements of the Company;
- the approval of the capital expenditures exceeding five million Euro (EUR 5,000,000) by the Company and the group

companies (including Joyou);

- the granting of loans (or other debt financing) exceeding seven million Euro (EUR 7,000,000) by the Company and

the group companies (including Joyou);

- the approval of any formula of foreign exchange hedge exceeding seven million Euro (EUR 7,000,000) by the Company

and the group companies (including Joyou);

- the establishment of a legal entity with share capital equal to or exceeding seven million Euro (EUR 7,000,000) as a

direct or indirect subsidiary of the Company;

- the assumption of new debt of third parties (parties not affiliated with Grohe Group SARL) or provision of guarantee

for third parties exceeding 1 Million Euro in a single case or 5 Million Euro p.a. in aggregate;

- any material organizational change of the Company and the group companies (including Joyou) resulting in a change

of the responsibilities of the Company's Managers or those other senior executives of the group companies directly reporting
to the CEO;

- any material change in the by-laws of the Company, Grohe Holding GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH, Grohe AG,

Joyou Grohe Holding AG and Joyou AG (each, excluding the Company, a “Key Subsidiary”);

- the nomination or dismissal of the corporate bodies ("Organe") of the Company or a Key Subsidiary;
- any other matter as determined by the general meeting of the shareholders.
As regards Joyou Grohe Holding AG and its direct and indirect subsidiaries, including Joyou AG, (collectively "Joyou"),

the above-mentioned approval and consent requirement shall only apply subject to the limitations under German stock
corporation law, in particular regarding the rights and powers of the management board and supervisory board of Joyou
Grohe Holding AG and Joyou AG under applicable law.

Art. 19. The shareholders undertake to vote in favour of a conversion of the Company’s legal form from a société à

responsabilité limitée into a société anonyme and, if so requested by GraceB S.à r.l. in the context of preparing an IPO, to

81586

L

U X E M B O U R G

vote in favour of further corporate measures required for such IPO, including capital increases and appointment of members
of the administrative board and management.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1.300,-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing parties, the present

deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing parties and in case of discre-
pancies between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known by the notary by their surname,

first name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am ersten April,
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

Sind erschienen:

GraceB S.à r.l., eine dem luxemburgischen Recht unterliegende société à responsabilité limitée, mit einem Stammkapital

von einer Milliarde vierhundertdreiundfünfzig Millionen zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 1.453.012.500), mit Sitz in
46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Han-
dels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 179188, Inhaberin von 49.999.999 Anteilen der Gesellschaft,

hier vertreten durch Me Nicolas Gauzès, Anwalt, beruflich ansässig in Luxemburg,
durch eine privatschriftliche Vollmacht, erteilt am 31. März 2015;
GraceA Co. Ltd, eine dem japanischen Recht unterliegende Gesellschaft, mit Sitz in 2-1-1, Ojima, J-136-8535 Koto-

ku,  Tokio,  Japan  und  eingetragen  beider  Industrie-  und  Handelskammer  Tokio  unter  der  Nummer  0106-01-045017,
Inhaberin von einem Anteil der Gesellschaft,

hier vertreten durch Me Nicolas Gauzès, Anwalt, beruflich ansässig in Luxemburg,
durch eine privatschriftliche Vollmacht, erteilt am 31. März 2015; und
Lixil Corporation, eine dem japanischen Recht unterliegende Gesellschaft, mit Sitz in 2-1-1 Ojima, Koto-Ku, Tokyo

136-8535, Japan, eingetragen unter der Nummer 0106-01-028126, Inhaberin von 7,142,857 Anteilen der Gesellschaft;

hier vertreten durch Maître Nicolas Gauzès, Anwalt, beruflich ansässig in Luxemburg,
durch eine privatschriftliche Vollmacht, erteilt am 31. März 2015;
(nachfolgend die “Gesellschafter”).
Die Vollmachten werden der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt.
Die Gesellschafter haben den unterzeichneten Notar gebeten, festzuhalten, dass sie die einzigen Gesellschafter von

Grohe Group S.à r.l. sind, eine dem Luxemburgischen Recht unterliegende société à responsabilité limitée, mit einem
Stammkapital von siebenundfünfzig Millionen einhundertzweiundvierzigtausendachthundertsiebenundfünfzig Euro (EUR
57.142.857), mit Sitz in 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg (die “Gesellschaft”), gegründet
am 18. Mai 2004 durch eine notarielle Urkunde, veröffentlicht im Mémorial C, Recueuil des Sociétés et Associations
Nummer 637 vom 21. Juni 2004 und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer
B 101086. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal am 2. April 2014 geändert durch eine notarielle Urkunde,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association Nummer 1658 vom 27. Juni 2014.

Die obigen genannten Gesellschafter, wie bereits aufgeführt, haben den Notar gebeten, folgendes festzuhalten:
(vi) Die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1 Abänderung der Artikel 18 und 19 der Satzung.
2 Sonstiges.
(vii) Dass die von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und von dem Notar unterzeichneten Vollmachten

der vorliegenden notariellen Urkunde beigefügt werden;

(viii) Dass das gesamte Stammkapital auf der Hauptversammlung vertreten war und dass alle vertretene oder anwesende

Gesellschafter  erklärt  haben,  dass  sie  rechtzeitig  benachrichtigt  wurden  und  Kenntnis  von  der  Tagesordnung  vor  der
Hauptversammlung hatten und auf ihr Recht, in förmlicher Weise einberufen worden zu sein, verzichten;

(ix) Dass die Hauptversammlung somit ordnungsgemäß zusammengekommen war und über alle Tagesordnungspunkte

beraten konnte;

(x) Dass die Hauptversammlung jedes Mal einstimmig folgende Beschlüsse gefasst hat:

81587

L

U X E M B O U R G

<i>Einziger Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, Artikel 18 und Artikel 19 der Satzung wie folgt abzuändern:

„ Art. 18. Die Folgenden Punkte sollen der Zustimmung der Hauptversammlung unterliegen und keine der folgenden

Entscheidungen soll dem Geschäftsführungsrat unterliegen, wenn anwendbar, ohne die Zustimmung der Hauptversamm-
lung gemäß Artikel 17 erster (1.) Absatz der Mehrheitsregel:

- Verabschiedung des Wirtschaftsplans (Originalversion und Teilüberarbeitungen) der Gesellschaft;
- Unternehmensrestrukturierungen, einschließlich Verschmelzung mit den Mehrheitsgesellschaftern und Betriebsauf-

spaltungen;

- Ernennung und Abberufung von Geschäftsführern der Gesellschaft;
- Verabschiedung des Jahresabschlusses der Gesellschaft sowie zusammenhängende Ausschüttung von Gewinn- und

Verlustvorträgen;

- Jede Handlung der Gesellschaft welche den Gesellschaftswert der Gesellschaft wesentlich beeinflusst;
- Die Verabschiedung des vierteljährlichen Finanzberichts;
- Gewährung von Kapitalausgaben der Gesellschaft und Konzerngesellschaften (Joyou mitinbegriffen) welche fünf

Millionen Euro (EUR 5.000.000) überschreiten;

- Gewährung von Darlehen (oder anderer Fremdfinanzierung) der Gesellschaft und Konzerngesellschaften (Joyou mi-

tinbegriffen) welche sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000) überschreiten;

- Freigabe von Hedging-Formeln für Wechselkursrisiken der Gesellschaft und Konzerngesellschaften (Joyou mitinbe-

griffen) welche sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000) überschreiten;

- Gründung einer Gesellschaft mit einem Kapital von sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000) oder mehr, als direkte

oder indirekte Tochtergesellschaft der Gesellschaft;

- Die Annahme von neuen Schulden Dritter (welche nicht der Grohe Group S.à r.l. angehören) oder Garantieleistungen

für Dritte, die eine Million Euro (EUR 1.000.000) einzeln oder fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000) insgesamt pro Jahr
überschreiten;

- Wesentliche organisatorische Veränderung der Gesellschaft und Konzerngesellschaften (Joyou mitinbegriffen) welche

eine Änderung von Verantwortung der Geschäftsführer der Gesellschaft oder andere Führungskräfte der Konzerngesell-
schaften, die direkt an den CEO berichten herbeiführen;

- Wesentliche Änderungen der Statuten der Gesellschaft, Grohe Holding GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH, Grohe AG,

Joyou Grohe Holding AG und Joyou AG (jede, ohne die Gesellschaft, ein „Wesentliches Tochterunternehmen“). Ernennung
und Abberufung von Organen der Gesellschaft oder einer wesentlichen Tochtergesellschaft;

- Alle anderen Themen, die von der Hauptversammlung entschieden werden.
Für Joyou Grohe Holding AG und ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Joyou AG mitinbegriffen (zu-

sammen „Joyou“), sind die oben aufgezählten Freigabe- und Zustimmungsvoraussetzungen nur anwendbar, sofern kein
Deutsches Aktiengesetz diese Regelungen einschränkt, insbesondere bezüglich der Befugnisse des Geschäftsführungsrates
von Joyou Grohe Holding AG und Joyou AG.

Art. 19. Die Gesellschafter verpflichten sich, einer Umwandlung der Gesellschaft von einer société à responsabilité

limitée in eine société anonyme zuzustimmen und, im Falle eines erstmaligen Angebotes der Anteile der Gesellschaft auf
einem organisierten Kapitalmarkt (IPO), anderen Maßnahmen, die im Rahmen des IPO notwendig sein werden, zuzustim-
men, einschließlich Kapitalerhöhungen und der Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftslei-
tung, sollte GraceB S.à r.l. diese anfragen.”

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund

dieser Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen

genannten Parteien das vorliegende Dokument auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf
Anfrage derselben Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die
englische Fassung Vorrang haben.

Aufgenommen wurde die Urkunde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Personenstand und Wohnort be-

kanntem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat derselbe die vorliegende Urkunde mit dem
unterzeichnenden Notar unterzeichnet.

Signé: N. Gauzès, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 8 avril 2015. GAC/2015/2982. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

81588

L

U X E M B O U R G

Mondorf-les-Bains, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015073193/193.
(150083306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

OAKS Estate Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 437.336.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 183.764.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015072660/9.
(150082881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Parquet Bembé S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 179, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 14.814.

L'an deux mille quinze, le cinq mai,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Parquet Bembé S.à r.l.", ayant

son siège social à L- 1471 Luxembourg, 179, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 14.814, constituée suivant acte notarié en date du 4 février 1977, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 68 du 26 mars 1977.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 25 octobre 2004 publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 97 du 3 février 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame BARTHELKLAUNER, employée privée, demeurant à L-3327

Crauthem, 12, rue Nei Wiss,

qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl GESCHWIND, employée privée, résidant professionnellement à L-1212

Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, résidant professionnellement

à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-1471 Luxembourg, 179, Route d'Esch à L-3225 Bettembourg, 212, Zone Industrielle

Scheleck 2;

2.- Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1471 Luxembourg, 179, Route d'Esch vers L-3225 Bet-

tembourg, 212, Zone Industrielle Scheleck 2 et par conséquent de modifier l’article 4 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 4. Le siège social est établi à Bettembourg.

81589

L

U X E M B O U R G

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés statuant comme en matière de modification des statuts.».

<i>Évaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: C. BARTHEL-KLAUNER, C. GESCHWIND, J.DIDERRICH et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 7 mai 2015. 1LAC/2015/14159. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015072669/58.
(150082728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Parquet Bembé S.à r.l. &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-3225 Bettembourg, 212, Zone Industrielle Scheleck 2.

R.C.S. Luxembourg B 14.815.

L'an deux mille quinze, le cinq mai,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite simple "Parquet Bembé S.à r.l. &amp; Cie",

ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 179, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 14.815, constituée suivant acte notarié en date du 4 février 1977, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 68 du 26 mars 1977.

Les statuts n’ont jamais été modifiés.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame BARTHELKLAUNER, employée privée, demeurant à L-3327

Crauthem, 12, rue Nei Wiss,

qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl GESCHWIND, employée privée, résidant professionnellement à L-1212

Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, résidant professionnellement

à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-1471 Luxembourg, 179, Route d'Esch à L-3225 Bettembourg, 212, Zone Industrielle

Scheleck 2;

2.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

81590

L

U X E M B O U R G

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1471 Luxembourg, 179, Route d'Esch vers L-3225 Bet-

tembourg, 212, Zone Industrielle Scheleck 2 et par conséquent de modifier l’article 5 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 5. Le siège social est établi à Bettembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés statuant comme en matière de modification des statuts.».

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: C. BARTHEL-KLAUNER, C. GESCHWIND, J. DIDERRICH et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 7 mai 2015. 1LAC/2015/14160. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015072670/57.
(150082727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Pentavest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.528.308,56.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 154.065.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 13 mai 2015.

Référence de publication: 2015072674/10.
(150082224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Gigaplex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 88.373.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 15 avril 2015

Le mandat du président du conseil d'administration, administrateur et administrateur-délégué, Monsieur Jean FELL, né

à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1956, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5,
avenue Gaston Diderich a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'année 2020.

Le mandat de l'administrateur, Monsieur Cornelius BECHTEL, né à Emmerich/Rhein (Allemagne), le 11 mars 1968,

demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'as-
semblée générale statutaire qui se tiendra en l'année 2020.

Le mandat de l'administrateur, Monsieur Claude CRAUSER, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 22

avril 1981, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich a été renouvelé jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'année 2020.

Le mandat du commissaire aux comptes INTERAUDIT, R.C.S. Luxembourg B29501, avec siège social à L-2529 Ho-

wald, 37, rue des Scillas a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'année 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

81591

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 18 mai 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GIGAPLEX S.A.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2015073209/24.
(150083812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Permotio International Learning S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.944,88.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 180.104.

Les comptes annuels au 31 août 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015072675/12.
(150083077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Gate Gourmet Luxembourg III A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.959.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 90.192.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 24 mars 2015

En date du 24 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Monsieur Andrew GIBSON de son mandat de gérant de catégorie A de la

Société avec effet au 31 mars 2015;

- de nommer Monsieur Christoph SCHMITZ, né le 21 septembre 1965 à Cologne, Allemagne, résidant à l'adresse

professionnelle suivante: 7, Balz Zimmermannstrasse, 8302 Kloten, Suisse, en tant que nouveau gérant de catégorie A de
la Société avec effet au 31 mars 2015 et ce pour une durée déterminée indéterminée.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 13 mai 2015

En date du 13 mai 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de catégorie B de la

Société avec effet au 30 avril 2015;

- de confirmer et d'accepter la démission de Monsieur Guy HARLES de son mandat de gérant de catégorie B de la

Société avec effet au 15 mai 2015;

- de nommer Madame Marie DRUINAUD, née le 4 août 1975 à Paris, France, résidant à l'adresse professionnelle

suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet au
30 avril 2015 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui statuera
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014;

- de nommer Monsieur Jean-Marc UEBERECKEN, né le 31 mai 1972 à Luxembourg, résidant à l'adresse professionnelle

suivante: 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet au 15
mai 2015 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui statuera sur
les comptes arrêtés au 31 décembre 2014;

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Jérôme TRIGANO, gérant de catégorie A
- Monsieur Dominik ANDERHALDEN, gérant de catégorie A
- Monsieur Christoph SCHMITZ, gérant de catégorie A
- Madame Kristin BROWN, gérant de catégorie A
- Monsieur Shaun RIXON (l'orthographe exacte du prénom doit se lire «Shaun» au lieu de Schaun), gérant de catégorie

A

- Madame Marie DRUINAUD, gérant de catégorie B
- Monsieur Jean-Marc UEBERECKEN, gérant de catégorie B

81592

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Gate Gourmet Luxembourg III A S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015073180/42.
(150083239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Plock S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.576.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2015.

Carsten SÖNS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015072677/12.
(150082123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.863.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 24 mars 2015

En date du 24 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Monsieur Andrew GIBSON de son mandat de gérant de catégorie A de la

Société avec effet au 31 mars 2015;

- de nommer Monsieur Christoph SCHMITZ, né le 21 septembre 1965 à Cologne, Allemagne, résidant à l'adresse

professionnelle suivante: 7, Balz Zimmermannstrasse, 8302 Kloten, Suisse, en tant que nouveau gérant de catégorie A de
la Société avec effet au 31 mars 2015 et ce pour une durée déterminée indéterminée.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 13 mai 2015

En date du 13 mai 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de catégorie B de la

Société avec effet au 30 avril 2015;

- de confirmer et d'accepter la démission de Monsieur Guy HARLES de son mandat de gérant de catégorie B de la

Société avec effet au 15 mai 2015;

- de nommer Madame Marie DRUINAUD, née le 4 août 1975 à Paris, France, résidant à l'adresse professionnelle

suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet au
30 avril 2015 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui statuera
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014;

- de nommer Monsieur Jean-Marc UEBERECKEN, né le 31 mai 1972 à Luxembourg, résidant à l'adresse professionnelle

suivante: 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet au 15
mai 2015 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui statuera sur
les comptes arrêtés au 31 décembre 2014;

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Jérôme TRIGANO, gérant de catégorie A
- Monsieur Dominik ANDERHALDEN, gérant de catégorie A
- Monsieur Christoph SCHMITZ, gérant de catégorie A
- Madame Kristin BROWN, gérant de catégorie A
- Monsieur Shaun RIXON (l'orthographe exacte du prénom doit se lire «Shaun» au lieu de Schaun), gérant de catégorie

A

- Madame Marie DRUINAUD, gérant de catégorie B

81593

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Jean-Marc UEBERECKEN, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015073181/42.
(150083241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

D4S Designer 4 Sport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9740 Boevange, maison 46B.

R.C.S. Luxembourg B 163.669.

L'an deux mille quinze, le trente avril.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

Ont comparu:

- Monsieur François Marie JASON, gérant, né le 7 novembre 1969 à Liège (Belgique), demeurant à L-9740 Boevange,

Maison 47,

- Monsieur Johan Dominique FROMENT, gérant, né le 4 juillet 1965 à Leuven (Belgique), demeurant à L-9647 Doncols,

Duerfstrooss 94,

Ici représenté par Monsieur François JASON, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à Perlé

le 27 avril 2015, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui

- Madame Françoise BLAVIER, née le 17/02/1970 à B-Liège domiciliée 15 Rue de la Digue à B-4032 Chenée;
Ici représenté par Monsieur François JASON, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à Perlé

le 27 avril 2015, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'ils sont les seuls associés de la société D4S Designer

4 Sport S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-8826 Perlé, 1, rue de Holtz, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.669, constituée suivant acte reçu par le Maître
Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Rambrouch, Grand- Duché de Luxembourg, en date du 19 septembre 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2765 du 12 novembre 2011, et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,
en date du 11 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1336 du 30 mai 2012 (ci-
après la "Société").

Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes entièrement libérées

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en as-

semblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont, à l'unanimité des voix, pris
la résolution suivante, qu'ils ont demandé au notaire d'acter comme suit:

ont requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:

<i>Unique résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-8826 Perlé, 1, rue de Holtz à L-9740 Boevange, maison 46B et

de modifier l'article 5 alinéa 1 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). Le siège social de la société est établi dans la commune de Boevange-sur-Attert"
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée.

<i>Frais.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 750,- EUR.

<i>Déclaration des comparants

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-5
du Code Pénal (financement du terrorisme).

81594

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeure, elles ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: François JASON, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 4 mai 2015. Relation: DAC/2015/7228. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015073103/58.
(150083136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Prodilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 5, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 16.854.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015072683/9.
(150082915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Parc Merveilleux, Société Anonyme.

Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 6.833.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015072687/10.
(150082085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Pars Transaction S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 3, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 46.431.

Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg que l'adresse du gérant

technique, Monsieur Abdolhossein Yaghma-Heinen est la suivante: 347, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Pars Transaction S.àr.l.

Référence de publication: 2015072688/11.
(150082485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Principia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, rue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 153.369.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 8 mai 2015 à Luxembourg

L'Assemblée Générale Annuelle de la Société a aussi décidé de nommer Grant Thornton Lux Audit S.A., domiciliée au

89A, Pafebruch, L-8308 Capellen, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 183.652,
en tant que commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2016.

ET
L'Assemblée Générale Annuelle de la Société a aussi décidé de nommer:
- M Hasan Gurhan Berker, avec adresse professionnelle à 100-102 Maya Akar Center, TR-34394 Istanbul, Turquie, en

tant qu'administrateur A de la Société;

- M Osman Necdet Türkay, avec adresse professionnelle à 100-102 Maya Akar Center, TR-34394 Istanbul, Turquie, en

tant qu'administrateur A de la Société;

81595

L

U X E M B O U R G

- M Charles Meyer, avec adresse professionnelle à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en tant qu'administrateur B de la Société; et

- M Jean Wantz, avec adresse professionnelle à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, en tant qu'administrateur B de la Société; jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2021.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Principia S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2015073400/24.
(150083233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Pasta Point Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.292.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015072691/9.
(150082219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

PAX S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 157.065.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PAX S.A. SPF
Société Anonyme

Référence de publication: 2015072692/11.
(150082229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Peinture Dany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5969 Itzig, 47, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 69.181.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire du 7 mai 2015 que:
L'associé unique décide de nommer comme gérant administratif pour une durée indéterminée Madame Lux Caroline,

née le 4 février 1969 à Luxembourg, demeurant à L-5942 Itzig, 7, rue Désiré Zahlen.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015072693/12.
(150082490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

BA Financial Trading (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 26.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 149.140.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 9 mars 2015

En date du 9 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission Monsieur Faruk Durusu, né 20 juin 1978 Yildizeli, Turquie, avec adresse professionnelle au

102 rue des Maraichers, L-2124, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet
au 9 mars 2015,

- nommer Monsieur Guy Knepper né 4 avril 1968 Luxembourg à Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse profes-

sionnelle au 33 rue du Puits Romain, L-8070, Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant B de la Société
avec effet au 9 mars 2015;

81596

L

U X E M B O U R G

- Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
Ms. Joanne Goodsell, Gérant A
Mr. Guy Knepper, Gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2015.

BA Financial Trading Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2015073000/22.
(150083270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Perennity Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 178.176.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015072694/9.
(150082951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Pixel.Lu, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 85, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 80.746.

L'an deux mille quinze, le seize avril.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Thierry Smets, administrateur de sociétés, né à Wilrijk (Belgique), le 1 

er

 décembre 1956, demeurant au

31 rue de la paix, L-7244 Bereldange,

2) Madame Carine Scheck, épouse Smets, commerçante, née à Liège (Belgique), le 5 juillet 1957, demeurant au 31 rue

de la paix, L-7244 Bereldange (les «Comparants»),

laquelle dernière nommée est ici représentée par Monsieur Thierry Smets, prénommé, en vertu d'un pouvoir donné sous

seing privé à Bereldange, le 15 avril 2015 (le «Mandataire»).

Lequel pouvoir après avoir été signé "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

Les Comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée «PIXEL.LU» avec siège social au 262 Route

d'Arlon, L-8010 Strassen (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 16 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°812 du 26 septembre
2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 80746.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden, notaire

de résidence à Luxembourg, en date du 15 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°1116
du 28 mai 2010.

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions sui-

vantes, prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social du 262 Route d'Arlon, L-8010 Strassen, au 85 rue de Luxembourg,

L-8077 Bertrange, et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 3. Le siège social est fixé dans la commune de Bertrange. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-

Duché de Luxembourg, par décision des associés.»

<i>Deuxième résolution

Les associés acceptent la démission du gérant technique, Madame Pascaline Smets, avec effet au 5 mai 2014.
Les associés décident dans le contexte donné qu'il n'y a pas lieu de pourvoir au remplacement du gérant technique

démissionnaire ni à désigner plusieurs gérants pour administrer la Société.

Les associés constatent ainsi que la Société est valablement administrée par le gérant unique, Monsieur Thierry Smets,

prénommé, pour une durée indéterminée.

81597

L

U X E M B O U R G

<i>Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont évalués à environ sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au Mandataire connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec

Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: SMETS, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/11925. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 13 mai 2015.

Référence de publication: 2015072696/50.
(150082271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Pixel.Lu, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 85, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 80.746.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015072697/11.
(150082885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Pneu Consult Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4876 Lamadelaine, 76, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 39.001.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2015072698/10.
(150082785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Prime Corvette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3383 Noertzange, 44, Cité Beaulieu.

R.C.S. Luxembourg B 181.121.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015072699/9.
(150082558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Alscot Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.255.214,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 137.865.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 11 mal 2015 que:
- M. Stef Oostvogels, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 7 mai 2015;
- M. Frédéric Feyten, né le 2 juillet 1966 à Bonheiden, Belgique, résidant professionnellement au 291, route d'Arlon,

L-1150 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société, avec effet au 11 mai 2015, et ce jusqu'à l'assemblée générale
annuelle devant se tenir en 2016.

81598

L

U X E M B O U R G

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais des gérants suivants:
1. M. Dominic Spiri, gérant;
2. M. Gérard Maîtrejean, gérant; et
3. M. Frédéric Feyten, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015072942/19.
(150083308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Prisma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 47.006.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRISMA S.A.

Référence de publication: 2015072700/10.
(150082367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Queensgate Carry Partner GP Coop S.A., Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 167.584.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015072702/9.
(150082346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Queensgate Investments I HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 300.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 167.652.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015072703/9.
(150082419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

R.P. Constructions Rainer Parmentier Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 105, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 100.599.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>La Gérance

Référence de publication: 2015072706/10.
(150082657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Delta Partners Luxembourg SV Coop S.A., Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 188.861.

EXTRAIT

En date du 19 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Vishal Sookloll comme administrateur de classe A de la société avec effet

au 17 mars 2015;

81599

L

U X E M B O U R G

- Nomination de Madame Diana Dumitru, née le 20 mai 1981 à Targoviste, Roumanie, et avec adresse professionnelle

au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au poste d'administrateur de classe A avec effet au 17 mars 2015 et pour
une durée indéterminée;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 18 mai 2015.

Référence de publication: 2015073078/16.
(150083426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Rendac - C.E.S., Société Anonyme.

Siège social: L-7396 Lorentzweiler, Schwanenthal.

R.C.S. Luxembourg B 20.576.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015072720/10.
(150082058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Resolution IV Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Firkin S.à r.l.).

Capital social: GBP 10.494.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 168.784.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015072721/10.
(150082896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Rib Elec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 170.665.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald, le 30/04/2015.

Référence de publication: 2015072722/10.
(150082191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Alken Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 111.842.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 24 avril 2015 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée a décidé de reconduire le mandat d'Administrateur de Mme Michèle Berger, M. Nicolaus P. Bocklandt

(6B Route de Trèves, L-2633 Luxembourg), M. Jean de Courrèges (2 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg) et M. Bruno
Vanderschelden (23 Rue des Bruyères, L-1274 Hesperange) pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire des Actionnaires de l'année 2016.

2. L'Assemblée décide de reconduire le mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé Deloitte Audit S.à r.l. pour un terme

venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l'année 2016.

Référence de publication: 2015072971/15.
(150083249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

81600


Document Outline

Alken Fund

Alscot Sàrl

BA Financial Trading (Luxembourg) S.à r.l.

Cube Infrastructure Fund

D4S Designer 4 Sport S.à r.l.

Delta Partners Luxembourg SV Coop S.A.

Firkin S.à r.l.

Gate Gourmet Luxembourg III A S.à r.l.

Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l.

Gigaplex S.A.

Grohe Group S.à r.l.

Letterone Holdings S.A.

Luxinvest Investment Advisors S.A.

Lux. Ouvrage d'Art S.à r.l.

Malabar Fund

Marim S.A.

Mishte Group S.A.

Nalys Investment S.A.

Next Code Health Corporation S.à r.l.

Nitteler Hof Event &amp; Traiteur

OAKS Estate Luxembourg S.à r.l.

Orange 3 S.à.r.l.

«Ouestia Intermediate S.à r.l

Parc Merveilleux

Parquet Bembé S.à r.l.

Parquet Bembé S.à r.l. &amp; Cie

Pars Transaction S.à.r.l.

Pasta Point Holding S.A.

PAX S.A. S.P.F.

Peinture Dany S.à r.l.

Pentavest S.à r.l.

Perennity Investments S.A.

Permotio International Learning S.à r.l.

Pixel.Lu

Pixel.Lu

Plock S.à r.l.

Pneu Consult Sàrl

Prime Corvette S.à r.l.

Principia S.A.

Prisma S.A.

Prodilux S.à r.l.

Queensgate Carry Partner GP Coop S.A.

Queensgate Investments I HoldCo S.à r.l.

Rendac - C.E.S.

Resolution IV Holdings S.à r.l.

Rib Elec S.à r.l.

R.P. Constructions Rainer Parmentier Sàrl

Shiplux III S.A.

Timelux S.à r.l.

WW¤studio