This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1667
6 juillet 2015
SOMMAIRE
Consulting HDR + Partner S.A. . . . . . . . . . . . .
80014
Emerging Markets Online Food Delivery Hold-
ing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79970
Frontiers Capital Mongolia . . . . . . . . . . . . . . .
79986
Galerie Commerciale de Kirchberg . . . . . . . . .
79996
Gambit Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
80001
Garage Pepin sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80001
Garantidata International S.A. . . . . . . . . . . . .
80001
Gastina Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80002
GDS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80002
Gefip Euroland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80002
Gelustok SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80005
GFM (CE) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80005
Global Management & Services S.A. . . . . . . . .
80005
Global Offshore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80006
Global Trust Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
80006
Global Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80006
Globoaves Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79986
Go Ahead SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80007
Gordon March S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80008
Grace Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80008
Grosvenor Retail European Properties II S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80009
GT Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80009
Gurkha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79995
Ham Investment Corporation S.à r.l. . . . . . . .
80012
Hamira SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80014
Hanau Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
80012
HDR Trading & Consulting S.A. . . . . . . . . . . .
80014
Henderson European Retail Property Fund
Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80012
HEPP III Luxembourg FRHB S.à r.l. . . . . . . .
80014
Herald Bramsche S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80013
Herald Lux Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
80013
Hifi-Participations-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80015
H.N.L. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80012
Hollux Horizon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80013
Horizont Immobilien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
80015
Hôtel des Vignes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80014
Hugo Insurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79995
Hydrogenious Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80013
IMC Asset Management Luxembourg S.A. . .
80015
Immoreal DE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79986
Intelligent Engineering S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
80015
KBL European Private Bankers S.A. . . . . . . .
80001
Luxembourg Contact Centers S.à r.l. . . . . . . .
80006
Munich LBS 160 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79996
NDG Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80002
Odyssey Opportunities 17 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
80009
Poba Lux Holdco (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .
80008
Rudel Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
80016
Rudel Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
80016
Ryan Express SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80016
Sabatelli 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80016
Saddle Luxco Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
80016
Spring Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80005
Wert RSR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80013
79969
L
U X E M B O U R G
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 121.527,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 175.738.
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of March,
before us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondof-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG), a Societas Europaea existing under the laws of Germany, registered
with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 165662 B, having its registered
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of twenty-one thousand sixty (21,060) common shares, one hundred eighty (180) series A1a shares,
eighty-three (83) series A2a shares, five thousand eight hundred thirty-one (5,831) series B5 shares, one thousand eight
hundred ten (1,810) series C1 shares, fifteen thousand nine hundred twenty-five (15,925) Series C4 shares and becoming
the holder of eleven thousand sixty-five (11,065) Series D shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Berlin, Germany, on 3 March 2015,
2. Kinnevik Online AB (formerly Kinnevik Online Ventures AB), a limited liability company (aktiebolag) existing
under the laws of Sweden registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under no. 556815-4958, having
its registered address at Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden, being the holder of one thousand eight hundred seven
(1,807) series A1b, one hundred nine (109) series A1c shares and eight hundred twenty-eight (828) series A2b shares of
the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Stockholm, Sweden, on 26 February 2015,
3. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-
chränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court
of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Germany,
being the holder of one hundred five (105) common shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Berlin, Germany, on 27 February 2015,
4. AI European Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under no. B 168.122, having its registered address at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
being the holder of eight hundred twenty-eight (828) series A2b shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in London, United Kingdom, on 23 February 2015 and in Bertrange, Grand
Duchy of Luxembourg, on 20 February 2015,
5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under number B 176544, having its registered address at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and with a share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000),
being the holder of three thousand seven hundred fifty (3,750) series B1 shares and seven hundred thirty-four (734)
series B5 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in London, United Kingdom, on 2 March 2015,
6. Phenomen Ventures LP, an exempted Limited Partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman
Islands, registration number OG - 66003, having its registered office at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands, represented by its General Partner, Phenomen Ventures Management, an exempted company
incorporated and existing under the Law of the Cayman Islands, registered with Registry of Companies, Cayman Islands,
under number OG-271195, having its registered address at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007,
Cayman Islands,
being the holder of four thousand six hundred eighty-seven (4,687) series B2 shares and one thousand three hundred
thirty-eight (1,338) series B4 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
79970
L
U X E M B O U R G
by virtue of a proxy under private seal given in Moscow, Russia, on 24 February 2015,
7. Mercura Capital GmbH (formerly Schuler-Beteiligungen GmbH), a limited liability company (Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung) existing under the laws of Germany with its statutory seat in Starnberg, Germany, registered with the
commercial register (Handelsregister) of the local court (Amtsgericht) of Munich under no. HRB 200948, having its bu-
siness address at Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Germany,
being the holder of one thousand eight hundred seventy-five (1,875) series B3 shares and one thousand two hundred
fifty (1,250) series B4 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Starnberg, Germany, on 25 February 2015,
8. Luxor Capital Partners, LP, organized and existing under the laws of Delaware, having its registered office at 1114
Avenue of the Americas, 29
th
Floor, New York, NY 10036, USA, represented by its General Partner LCG Holdings, LLC,
a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, registered with the Secretary of State of
the State of Delaware, having its registered office and principal place of business at 1114 Avenue of the Americas, 29
th
Floor, New York, NY 10036,
being the holder of two thousand five hundred ninety-eight (2,598) series B4 shares, one thousand five hundred eighty-
six (1,586) series B5 shares and two thousand four hundred seventy-one (2,471) series C1 shares and three hundred fourteen
(314) Series C4 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in New York, United States of America, on 20 February 2015,
9. Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP, organized and existing under the laws of Cayman Islands, having
its registered office at 390 GT Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, re-
presented by its General Partner LCG Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws
of Delaware, registered with the Secretary of State of the State of Delaware, having its registered office and principal place
of business at 1114 Avenue of the Americas, 29
th
Floor, New York, NY 10036,
being the holder of four thousand seventy-eight (4,078) series B4 shares, five hundred ninety-eight (598) series B5
shares, two thousand seven hundred eighty-four (2,784) series C1 shares and forty-eight (48) Series C4 shares of the
Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in New York, United States of America, on 20 February 2015,
10. Luxor Wavefront, LP, organized and existing under the laws of Delaware, having its registered office at 1114 Avenue
of the Americas, 29
th
Floor, New York, NY 10036, USA, represented by its General Partner LCG Holdings, LLC, a limited
liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, registered with the Secretary of State of the State
of Delaware, having its registered office and principal place of business at 1114 Avenue of the Americas, 29
th
Floor, New
York, NY 10036,
being the holder of eight hundred twenty-four (824) series B4 shares, one hundred forty-one (141) series B5 shares, five
hundred thirty-eight (538) series C1 shares and becoming the holder of five thousand one hundred seventeen (5,117) series
D shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in New York, United States of America, on 20 February 2015,
11. FEC Lux S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de
Commerce et des Sociétés) under no. B 173487, having its registered address at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
being the holder of two thousand six hundred seventy-nine (2,679) series C1 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in New York, United States of America, on 3 March 2015,
12. Pelham Capital Investments Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of England and having
its business address at the Economist Building, 9
th
Floor, 25 St James's Street, London, SW1A 1HA, United Kingdom,
being the holder of one thousand eight hundred ten (1,810) series C2 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in London, United Kingdom, on 27 February 2015,
13. Viride Investments Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of England, registered with
the Registrar of Companies for England and Wales under number 9184805 and having its business address at 29, Charles
II Place, London, SW3 4NG, United Kingdom,
being the holder of one hundred eighty-one (181) series C2 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
79971
L
U X E M B O U R G
by virtue of a proxy under private seal given in London, United Kingdom, on 27 February 2015,
14. The Hon. A.G. Hamilton’s 1987 Settlement, an incorporated trust with tax reference 2901674105, existing under
the laws of the United Kingdom and having its business address at 14, Tufton Court, Tufton Street, London, SW1P 3QH,
United Kingdom,
being the holder of forty-four (44) series C2 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in London, United Kingdom, on 23 February 2015,
15. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company under the laws of Germany with its statutory seat in
Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) of the local court (Amtsgericht) of Charlot-
tenburg, Germany, under no. HRB 139778 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of seven thousand four hundred one (7,401) Series C3 Shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Berlin, Germany, on 27 February 2015.
16. Tetral S.A., a société anonyme established under the laws of Switzerland with its statutory seat in Pully whose
registered office is at Avenue Général Guisan 70, 1009 Pully, Switzerland and which has been registered with the Registre
du Commerce of the Canton of Vaud under no. CH-550.1.000.845-3 (“Tetral”),
becoming the holder of twelve thousand forty (12,040) Series D shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Pully, Switzerland, on 2 March 2015, and
17. Longbow Finance S.A., incorporated in Switzerland since 1963 as a company limited by shares («société anonyme»),
with a share capital of CHF1,000,000, registered with the Commerce Register (“register du commerce”) of canton Vaud
under no. CHE-102.894.094, having its statutory seat at route de Lavaux 36, 1095 Lutry, Switzerland (“Longbow Finance”),
becoming the holder of three thousand ten (3,010) Series D shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Lutry, Switzerland, on 26 February 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties 1. through 15. (the “Shareholders”) are all the shareholders of Emerging Markets Online Food Delivery
Holding S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 175.738 and incorporated pursuant to a
deed of Maître Jean-Joseph Wagner on 28 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 956 dated 22 April 2013. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the notary
Maître Henri Hellinckx on 17 December 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Shareholders representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general meeting
is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the parties 16. and 17. participate and
vote for purposes of agenda point 4 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Decision to create one (1) additional class of shares, referred to as the series D shares (hereinafter “Series D Shares”)
and to hence have sixteen (16) classes of shares in total.
2. Acceptance of Tetral S.A., a société anonyme established under the laws of Switzerland with its statutory seat in Pully
whose registered office is at Avenue Général Guisan 70, 1009 Pully, Switzerland and which has been registered with the
Registre du Commerce of the Canton of Vaud under no. CH-550.1.000.845-3, and Longbow Finance S.A., incorporated
in Switzerland since 1963 as a company limited by shares («société anonyme»), with a share capital of CHF1,000,000,
registered with the Commerce Register (“register du commerce”) of canton Vaud under no. CHE-102.894.094, having its
statutory seat at route de Lavaux 36, 1095 Lutry, Switzerland, as new shareholders of the Company.
3. Increase of the Company’s share capital by an amount of thirty-one thousand two hundred thirty-two euro (EUR
31,232), so as to raise it from its current amount of ninety thousand two hundred ninety-five euro (EUR 90,295) up to one
hundred twenty-one thousand five hundred twenty-seven euro (EUR 121,527) by issuing thirty-one thousand two hundred
thirty-two (31,232) Series D Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as
follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at one hundred twenty-one thousand five hundred twenty-seven euro (EUR
121,527), represented by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter “Com-
mon Shares”), (ii) one hundred and eighty (180) series A1a shares (hereinafter “Series A1a Shares”), (iii) one thousand
79972
L
U X E M B O U R G
eight hundred and seven (1,807) series A1b shares (hereinafter “Series A1b shares”), (iv) one hundred and nine (109) series
A1c shares (hereinafter “Series A1c Shares”), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter “Series A2a Shares”),
(vi) one thousand six hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter “Series A2b Shares”), (vii) three thousand
seven hundred and fifty (3,750) series B1 shares (hereinafter “Series B1 Shares”), (viii) four thousand six hundred and
eighty-seven (4,687) series B2 shares (hereinafter “Series B2 Shares”, (ix) one thousand eight hundred and seventy-five
(1,875) series B3 shares (hereinafter “Series B3 Shares”), (x) ten thousand eighty-eight (10,088) series B4 shares (herei-
nafter “Series B4 Shares”, (xi) eight thousand eight hundred ninety (8,890) series B5 shares (hereinafter "Series B5 Shares"
together with the Series B1 Shares, the Series B2 Shares, the Series B3 Shares and the Series B4 Shares the “Series B
Shares”), (xii) ten thousand two hundred eighty-two (10,282) series C1 shares (hereinafter "Series C1 Shares"), (xiii) two
thousand thirty five (2,035) series C2 shares (hereinafter "Series C2 Shares"), (xiv) seven thousand four hundred and one
(7,401) series C3 shares (hereinafter "Series C3 Shares"), (xv) sixteen thousand two hundred eighty-seven euro (16,287)
series C4 shares (hereinafter "Series C4 Shares") and (xvi) thirty-one thousand two hundred thirty-two (31,232) series D
shares (hereinafter "Series D Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG), (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings
S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH, (vii) Luxor Capital
Partners, LP, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP and Luxor Wavefront, LP (jointly “LuxorCap”) (Luxor
Capital Partners, LP, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP and Luxor Wavefront, LP shall exercise their rights
under these articles of association jointly as if they were one shareholder; Luxor Capital Partners, LP shall be entitled to
make and receive all declarations on behalf of itself, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP and Luxor Wave-
front, LP regarding rights and obligations resulting from shares held by any of them), (viii) FEC Lux S.à r.l., (ix) Pelham
Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. and The Hon. A.G. Hamilton’s 1987 Settlement, (jointly “Pelham”);
(Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. and The Hon. A.G. Hamilton’s 1987 Settlement shall exercise
their rights under these articles of association jointly as if they were one shareholder; Pelham Capital Investments Ltd. shall
be entitled to make and receive all declarations on behalf of itself, Viride Investments Ltd. and The Hon. A.G. Hamilton’s
1987 Settlement regarding rights and obligations resulting from shares held by any of them), (x) MKC Brillant Services
GmbH, (xi) Tetral S.A. and (xii) Longbow Finance S.A. shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to
be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder
nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)
(a “Third Party Investor”)) and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective
whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage
ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party
Investment is based on. Each of (i) Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG), (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al
European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH,
(vii) LuxorCap, (viii) FEC Lux S.à r.l., (ix) Pelham, (x) MKC Brillant Services GmbH, (xi) Tetral S.A. and (xii) Longbow
Finance S.A. shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after they have been notified by the
Company regarding the Third Party Investment if Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG) and/or Kinnevik
Online AB and/or Al European Holdings S.à r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.à r.l. and/or Phenomen Ventures LP and/
or Mercura Capital GmbH and/or LuxorCap and/or FEC Lux S.à r.l. and/or Pelham and/or MKC Brillant Services GmbH
and/or Tetral S.A. and/or Longbow Finance S.A. intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this
Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further shares in the
Company.”
5. Subsequent amendment of article 7 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as
follows:
“ Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of any
shareholders agreement between the shareholders if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or
tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent that
such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
79973
L
U X E M B O U R G
a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet SE (formerly
Rocket Internet AG), (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v)
Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH (vii) Luxor Capital, Luxor Offshore and Luxor Wavefront (Luxor
Capital acting for itself as well as for Luxor Offshore and for Luxor Wavefront and exercising their rights under these
articles of association resulting from shares held by any of them jointly as if they were one shareholder), (viii) FEC Lux
S.à r.l.; (ix) Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. and The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement
(Pelham Capital Investments Ltd. acting for itself as well as for Viride Investments Ltd. and for The Hon. A.G. Hamilton’s
1987 Settlement and exercising their rights under these articles of association resulting from shares held by any of them
jointly as if they were one shareholder) (x) MKC Brillant Services GmbH (xi) Tetral S.A. and (xii) Longbow Finance S.A.
(Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG), Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l., Aismare Lux
Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP, Mercura Capital GmbH, Luxor Capital, Luxor Offshore, Luxor Wavefront, FEC
Lux S.à r.l., Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd., The Hon. A.G. Hamilton’s 1987 Settlement, MKC
Brillant Services GmbH, Tetral S.A. and Longbow Finance S.A. hereinafter jointly referred to as “Investors”; each indi-
vidually an “Investor”) to a company affiliated within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act
(AktG) to the respective Investor;
b) in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares of one Investor to a company or entity (x) which
is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect Controlling shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control”
or “Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by way of (a)
managing the company as managing shareholder, (b) holding the majority of shares, (c) holding the majority of voting
rights by means of a contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the
management and policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the
respective Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
c) in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares to a third party acquiring shares under the
simplified employee participation, or by a shareholder to the Company and/or any Investors pursuant to a call option under
a vesting scheme.
7.5 To the extent a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares requires no additional consent of the
shareholders’ meeting pursuant to article 7.4 a)-c) above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of first refusal,
rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any sale, transfer, assignment or other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification thereof to, or upon the acceptance thereof by the Company in accordance with article 1690
of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased
shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.”
6. Subsequent amendment of article 8 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as
follows:
“ Art. 8. Liquidation and sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty percent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the
Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty percent (50%) of the share capital or more than fifty
percent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more
related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the
proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to articles 8.2, 8.3, 8.4 and 8.5 below - will be distributed in accordance with article
8.6 to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level (“First Level””) the holders of Series D Shares shall receive an amount of EUR 3,322.44 per Series
D Share which, in each case, equals the amount of their respective total investment made in the Company (consisting of
the nominal amount of the Series D Shares, as acquired by the respective holder, and any share premium and/or other capital
contribution (account 115) paid by that holder to the Company).
8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series C1 Shares, the holders of Series C2 Shares and the holders
of Series C4 Shares shall receive an amount of EUR 2,762.94 per Series C1 Share and/or Series C2 Share and/or Series
C4 Share (as applicable), and the holders of Series C3 Shares shall receive an amount of EUR 2,465.67 per Series C3 Share,
which, in each case, equals the amount of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal
amount of the Series C1 Shares, the Series C2 Shares, the Series C3 Shares and the Series C4 Shares, as acquired by the
respective holder, and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder to the Com-
pany).
8.4 On a third level (“Third Level”) the holders of Series B Shares shall receive an amount of EUR 1,600 per Series B
Share which equals the amount of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount
79974
L
U X E M B O U R G
of the Series B Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid
by that holder to the Company)
8.5 On a fourth level (“Fourth Level”) the holders of Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series
A2a Shares, Series A2b Shares shall receive per share of the respective share class (and among the shareholders of each
share class pro rata to their shareholding in the respective share class) the amount stipulated as follows:
Share Class
Amount
per Share
in Euro
Series A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,380.84
Series A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,383.14
Series A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Series A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,556.82
Series A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,554.76
8.6 After the payments on the First Level, the Second Level, the Third Level and the Fourth Level have been made, the
remaining Exit Proceeds shall be allocated on a fifth level (“Fifth Level””)) to all shareholders pro rata corresponding to
their participation in the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on the First Level and/or the Second
Level and/or the Third Level and/or the Fourth Level shall reduce the amount to be allocated to such shareholder on the
Fifth Level and shall be allocated subsequently pursuant to this Fifth Level provided that no shareholder shall be obliged
to repay any amount received on the First Level and/or the Second Level and/or the Third Level and/or the Fourth Level.
The allocation at the Fifth Level shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to the shareholders. Irrespective
of whether or not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more
transactions no shareholder shall receive for the sale of all of its shares an amount exceeding the higher of (i) its share in
the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares sold or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First
Level and/or the Second Level and/or the Third Level and/or the Fourth Level. In case an exceeding amount is received,
the receiving shareholder shall repay such excess amount accordingly to the other shareholders. All rights related to the
liquidity preference stipulated herein are satisfied once the amount set forth in sentence 1 of this Section 8.6 has been
received regarding the respective shares.
8.7 The preferred allocation on the First Level and the Second Level and the Third Level and the Fourth Level applies
to each of the respective Series D Shares, Series C Shares, Series B Shares, Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series
A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares as long as on the respective Series D Shares, Series C Shares, Series B
Shares, Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares the amount
stipulated in article 8.2, article 8.3, article 8.4 and/or in the table pursuant to article 8.5 has not yet been distributed once.”
7. Subsequent amendment of article 25 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as
follows:
“ Art. 25. Advisory board.
25.1 The Company shall have an advisory board (the “Advisory Board”). It shall consist of up to eleven (11) voting
members. The shareholders’ meeting may by way of unanimous shareholders’ resolution increase or decrease the number
of members of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member (observer) of the Advisory
Board.
25.2 The shareholders’ meeting shall only adopt or amend the rules of procedure for the Advisory Board by way of a
unanimous shareholders’ resolution.
25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification towards
the Company as follows:
a) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet SE (formerly
Rocket Internet AG) in its sole discretion (such member the “Rocket-Member”);
b) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole
discretion;
c) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.à r.l.
in its sole discretion;
d) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.à r.l.
in its sole discretion;
e) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen Ventures LP in its
sole discretion;
f) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Mercura Capital GmbH in its
sole discretion;
g) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders LuxorCap in their sole discretion;
h) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder FEC Lux S.à r.l. in its sole
discretion;
79975
L
U X E M B O U R G
i) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder MKC Brillant Services GmbH
in its sole discretion;
j) the shareholder Tetral S.A., in its sole discretion, reserves the right to nominate one (1) voting member of the Advisory
Board, at any given time; and;
k) the shareholder Pelham Capital Investments Ltd. in its sole discretion, reserves the right to nominate one (1) voting
member of the Advisory Board, at any given time.
25.4 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. The Rocket-Member shall be the chairman of
the Advisory Board and shall not have a casting vote. Each voting member shall have one (1) vote, except the voting
member nominated by Rocket, which shall have five (5) votes and except the voting member nominated by LuxorCap,
which shall have three (3) votes and except for the voting member nominated by Kinnevik, which shall have two (2) votes.
The voting member to be appointed by shareholder Pelham Capital Investments Ltd. shall have one (1) vote. The voting
member to be appointed by shareholder Tetral S.A. shall have one (1) vote. For the avoidance of doubt, Viride Investments
Ltd. and The Hon. A.G. Hamilton’s 1987 Settlement, as well as Longbow Finance S.A. are not entitled to nominate a
member to the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board shall provide for further provisions in
particular on the self-organisation of the Advisory Board.
25.5 The Advisory Board shall be competent for the granting of consents to any transactions and measures of the
managers which the shareholders’ meeting has made subject to the consent of the Advisory Board either (i) in these articles
of association, (ii) in the rules of procedure of the managers, (iv) by way of shareholders’ resolution or (v) in any share-
holders’ agreement.
25.6 The remuneration of the members of the Advisory Board, if any, shall be determined by shareholders of the
Company by way of a unanimous shareholders’ resolution.
25.7 In addition to the consent requirements provided for in article 22.8 and article 22.9, the Advisory Board has a
consultative function and will not interfere in the management of the Company.”
8. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, as well as Mr Ruediger Trox, regardless of his
category, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register
of the Company.
9. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders decide to create one (1) additional class of shares, referred to as the series D shares (hereinafter “Series
D Shares”), and to hence have sixteen (16) classes of shares in total.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders accept Tetral S.A., a société anonyme established under the laws of Switzerland with its statutory seat
in Pully whose registered office is at Avenue Général Guisan 70, 1009 Pully, Switzerland and which has been registered
with the Registre du Commerce of the Canton of Vaud under no. CH-550.1.000.845-3, and Longbow Finance S.A., in-
corporated in Switzerland since 1963 as a company limited by shares («société anonyme»), with a share capital of
CHF1,000,000, registered with the Commerce Register (“register du commerce”) of canton Vaud under no.
CHE-102.894.094, having its statutory seat at route de Lavaux 36, 1095 Lutry, Switzerland, as new shareholders of the
Company.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the Company’s share capital by an amount of thirty-one thousand two hundred
thirty-two euro (EUR 31,232), so as to raise it from its current amount of ninety thousand two hundred ninety-five euro
(EUR 90,295) up to one hundred twenty-one thousand five hundred twenty-seven euro (EUR 121,527) by issuing thirty-
one thousand two hundred thirty-two (31,232) Series D Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
<i>Subscriptioni>
The Shareholders have waived any preferential subscription right they may have according to article 5.3 of the articles
of association of the Company.
Eleven thousand sixty-five (11,065) Series D Shares have been duly subscribed by Rocket Internet SE (formerly Rocket
Internet AG), aforementioned, for the price of eleven thousand sixty-five euro (EUR 11,065).
Five thousand one hundred seventeen (5,117) series D Shares have been duly subscribed by Luxor Wavefront, LP,
aforementioned, for the price of five thousand one hundred seventeen euro (EUR 5,117).
Twelve thousand forty (12,040) Series D Shares have been duly subscribed by Tetral, aforementioned, for the price of
twelve thousand forty euro (EUR 12,040).
Three thousand ten (3,010) Series D Shares have been duly subscribed by Longbow Finance, aforementioned, for the
price of three thousand ten euro (EUR 3,010).
79976
L
U X E M B O U R G
<i>Paymenti>
The eleven thousand sixty-five (11,065) Series D Shares subscribed by Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet
AG), aforementioned, the five thousand one hundred seventeen (5,117) Series D Shares subscribed by Luxor Wavefront,
LP, aforementioned, the twelve thousand forty (12,040) Series D Shares subscribed by Tetral, aforementioned and the three
thousand ten (3,010) Series D Shares subscribed by Longbow Finance, aforementioned, have been entirely paid up through
a contribution in cash in an amount of thirty-one thousand two hundred thirty-two euro (EUR 31,232).
The proof of the existence and of the value of the above contribution in cash has been produced to the undersigned
notary.
The amount of thirty-one thousand two hundred thirty-two euro (EUR 31,232) is as now available to the Company as
has been proved to the undersigned notary.
The contribution in the amount of thirty-one thousand two hundred thirty-two euro (EUR 31,232) is entirely allocated
to the share capital of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders acknowledge that Tetral, aforementioned, has now become the holder of twelve thousand forty
(12,040) Series D Shares and that Longbow Finance, aforementioned, has also now become the holder of three thousand
ten (3,010) Series D Shares.
As a consequence Tetral, aforementioned, and Longbow Finance, aforementioned, entitled to vote and here represented
by Philippe Sylvestre, avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of the aforementioned proxies, join the
meeting, which is henceforth referred to as “the general meeting of shareholders”, for the purpose of the following reso-
lutions.
The general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company so that it
shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article 7 of the articles of association of the Company so that it
shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article 8 of the articles of association of the Company so that it
shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article 25 of the articles of association of the Company so that
it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well
as Mr Rüdiger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders register
of the Company.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500)
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zwanzigsten März,
vor uns, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Mondof-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), eine Europäische Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 165662 B,
mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
79977
L
U X E M B O U R G
Inhaberin von einundzwanzigtausendsechzig (21.060) Stammanteilen, einhundertachtzig (180) Anteilen der Serie A1a,
dreiundachtzig (83) Anteilen der Serie A2a, fünftausendachthunderteinunddreißig (5.831) Anteilen der Serie B5, eintau-
sendachthundertzehn (1.810) Anteilen der Serie C1, fünfzehntausendneunhundertfünfundzwanzig (15.925) Anteilen der
Serie C4 und zukünftige Inhaberin von elftausendfünfundsechzig (11.065) Anteilen der Serie D der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 3. März 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland,
2. Kinnevik Online AB (vormals Kinnevik Online Ventures AB), eine Gesellschaft (aktiebolag) bestehend unter dem
Recht Schwedens, eingetragen im Gesellschaftsregister Schwedens (Bolagsverket) unter der Nummer 556815-4958, mit
Sitz in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Schweden,
Inhaberin von eintausendachthundertsieben (1.807) Anteilen der Serie A1b, einhundertneun (109) Anteilen der Serie
A1c und achthundertachtundzwanzig (828) Anteilen der Serie A2b der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 26. Februar 2015, ausgestellt in Stockholm, Schweden,
3. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und be-
stehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der
Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaberin von einhundertfünf (105) Stammanteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 27. Februar 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland,
4. Al European Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft (société à responsabilité limitée) bestehend unter dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et
des Sociétés) unter der Nummer B 168.122, mit Sitz in 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg,
Inhaberin von achthundertachtundzwanzig (828) Anteilen der Serie A2b der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich, am 23. Februar 2015, und in
Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, am 20. Februar 2015,
5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft (société à responsabilité limitée) bestehend unter dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et
des Sociétés) unter der Nummer B 176544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, und mit einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000),
Inhaberin von dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteilen der Serie B1 und siebenhundertvierunddreißig (734)
Anteilen der Serie B5 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 2. März 2015, ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich,
6. Phenomen Ventures LP, eine Gesellschaft (exempted Limited Partnership) gegründet und bestehend unter dem Recht
der Kaimaninseln (Cayman Islands), mit der Eintragungsnummer OG - 66003, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana Bay,
Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands, vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (General Partner),
Phenomen Ventures Management, einer Gesellschaft (exempted company) gegründet und bestehend unter dem Recht der
Kaimaninseln, eingetragen im Registry of Companies, Cayman Islands, unter der Nummer OG-271195, mit Sitz in 89
Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands,
Inhaberin von viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteilen der Serie B2 und eintausenddreihundertach-
tunddreißig (1.338) Anteilen der Serie B4 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 24. Februar 2015, ausgestellt in Moskau, Russland,
7. Mercura Capital GmbH (vormals Schuler-Beteiligungen GmbH), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung beste-
hend unter deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Starnberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 200948, mit Geschäftssitz in Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg,
Deutschland,
Inhaberin von eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie B3 und eintausendzweihundertfünfzig
(1.250) Anteilen der Serie B4 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 25 Februar 2015, ausgestellt in Starnberg, Deutschland,
8. Luxor Capital Partners, LP, gegründet und bestehend unter dem Recht des Bundesstaates Delaware, mit Sitz in 1114
Avenue of the Americas, 29
th
Floor, New York, NY 10036, USA, vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesell-
schafter (General Partner), LCG Holdings, LLC, einer Gesellschaft (limited liability company) gegründet und bestehend
79978
L
U X E M B O U R G
unter dem Recht des Bundesstaates Delaware, eingetragen beim Secretary of State of the State of Delaware, mit Sitz und
Hauptniederlassung in 1114 Avenue of the Americas, 29
th
Floor, New York, NY 10036,
Inhaberin von zweitausendfünfhundertachtundneunzig (2.598) Anteilen der Serie B4, eintausendfünfhundertsechsun-
dachtzig (1.586) Anteilen der Serie B5 und zweitausendvierhunderteinundsiebzig (2.471) Anteilen der Serie C1 und
dreihundertvierzehn (314) Anteilen der Serie C4 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 20. Februar 2015, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von
Amerika,
9. Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP, gegründet und bestehend unter dem Recht der Kaimaninseln
(Cayman Islands), mit Sitz in 390 GT Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (General Partner), LCG Holdings, LLC, einer Gesellschaft
(limited liability company) gegründet und bestehend unter dem Recht des Bundesstaates Delaware, eingetragen beim
Secretary of State of the State of Delaware, mit Sitz und Hauptniederlassung in 1114 Avenue of the Americas, 29
th
Floor,
New York, NY 10036,
Inhaberin von viertausendachtundsiebzig (4.078) Anteilen der Serie B4, fünfhundertachtundneunzig (598) Anteilen der
Serie B5, zweitausendsiebenhundertvierundachtzig (2.784) Anteilen der Serie C1 und achtundvierzig (48) Anteilen der
Serie C4 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 20. Februar 2015, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von
Amerika,
10. Luxor Wavefront, LP, gegründet und bestehend unter dem Recht des Bundesstaates Delaware, mit Sitz in 1114
Avenue of the Americas, 29
th
Floor, New York, NY 10036, USA, vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesell-
schafter (General Partner), LCG Holdings, LLC, einer Gesellschaft (limited liability company) gegründet und bestehend
unter dem Recht des Bundesstaates Delaware, eingetragen beim Secretary of State of the State of Delaware, mit Sitz und
Hauptniederlassung in 1114 Avenue of the Americas, 29
th
Floor, New York, NY 10036,
Inhaberin von achthundertvierundzwanzig (824) Anteilen der Serie B4, einhunderteinundvierzig (141) Anteilen der
Serie B5, fünfhundertachtunddreißig (538) Anteilen der Serie C1 und zukünftige Inhaberin von fünftausendeinhundert-
siebzehn (5.117) Anteilen der Serie D der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 20. Februar 2015, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von
Amerika,
11. FEC Lux S.à r.l., eine Gesellschaft (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des
Großherzogtums Luxemburgs, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce
et des Sociétés) unter der Nummer B 173487, mit Sitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg,
Inhaberin von zweitausendsechshundertneunundsiebzig (2.679) Anteilen der Serie C1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 3. März 2015, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika,
12. Pelham Capital Investments Ltd., eine Gesellschaft (limited company) gegründet und bestehend unter dem Recht
Englands, mit Geschäftssitz in Economist Building, 9
th
Floor, 25 St James’s Street, London, SW1A 1HA, Vereinigtes
Königreich,
Inhaberin von eintausendachthundertzehn (1.810) Anteilen der Serie C2 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 27. Februar 2015, ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich,
13. Viride Investments Ltd., eine Gesellschaft (limited company) gegründet und bestehend unter dem Recht Englands,
eingetragen im Registrar of Companies for England and Wales unter der Nummer 9184805, mit Geschäftssitz in 29, Charles
II Place, London, SW3 4NG, Vereinigtes Königreich,
Inhaberin von einhunderteinundachtzig (181) Anteilen der Serie C2 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 27. Februar 2015, ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich,
14. The Hon. A.G. Hamilton’s 1987 Settlement, eine Treuhandgesellschaft (trust) mit der Steuernummer 2901674105,
bestehend unter dem Recht des Vereinigten Königreichs, mit Geschäftssitz in 14, Tufton Court, Tufton Street, London,
SW1P 3QH, Vereinigtes Königreich,
Inhaberin von vierundvierzig (44) Anteilen der Serie C2 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 23. Februar 2015, ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich,
79979
L
U X E M B O U R G
15. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht mit
satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutsch-
land, unter der Nummer HRB 139778 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaberin von siebentausendvierhunderteins (7.401) Anteilen der Serie C3 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 27. Februar 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland,
16. Tetral S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht der Schweiz mit satzungsmäßigem Sitz in
Pully, mit Sitz in Avenue Général Guisan 70, 1009 Pully, Schweiz und eingetragen im Handelsregister des Kantons Waadt
unter der Nummer CH-550.1.000.845-3 („Tetral“),
zukünftige Inhaberin von zwölftausendvierzig (12.040) Anteilen der Serie D der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 2. März 2015, ausgestellt in Pully, Schweiz, und
17. Longbow Finance S.A., eine 1963 in der Schweiz gegründete Aktiengesellschaft (société anonyme) mit einem
Gesellschaftskapital von CHF 1.000.000, eingetragen im Handelsregister des Kantons Waadt unter der Nummer
CHE-102.894.094, mit satzungsmäßigem Sitz in route de Lavaux 36, 1095 Lutry, Schweiz („Longbow Finance“),
zukünftige Inhaberin von dreitausendzehn (3.010) Anteilen der Serie D der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 26. Februar 2015, ausgestellt in Lutry, Schweiz.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar
ne varietur paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien 1. bis 15. (die „Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Emerging Markets Online Food Delivery
Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), ge-
gründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B
175.738, gegründet am 28. Februar 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Jean-Joseph Wagner, welche am 22.
April 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 956 veröffentlicht wurde. Die Satzung der
Gesellschaft wurde zuletzt am 17. Dezember 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx geändert,
welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.
Da die Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet haben,
ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende Tagesord-
nung verhandeln, wobei die Parteien 16. und 17. ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und
stimmberechtigt sind:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse, welche als Anteile der Serie D bezeichnet werden
(die „Anteile der Serie D“), wodurch nunmehr insgesamt sechzehn (16) Anteilsklassen bestehen.
2. Aufnahme von Tetral S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht der Schweiz mit satzungs-
mäßigem Sitz in Pully, mit Sitz in Avenue Général Guisan 70, 1009 Pully, Schweiz und eingetragen im Handelsregister
des Kantons Waadt unter der Nummer CH-550.1.000.845-3, und von Longbow Finance S.A., einer 1963 in der Schweiz
gegründeten Aktiengesellschaft (société anonyme) mit einem Gesellschaftskapital von CHF 1.000.000, eingetragen im
Handelsregister des Kantons Waadt unter der Nummer CHE-102.894.094, mit satzungsmäßigem Sitz in route de Lavaux
36, 1095 Lutry, Schweiz, als neue Gesellschafterinnen der Gesellschaft.
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von neunzigtausendzweihun-
dertfünfundneunzig Euro (EUR 90.295) um einen Betrag von einunddreißigtausendzweihundertzweiunddreißig Euro (EUR
31.232) auf einen Betrag von einhunderteinundzwanzigtausendfünfhundertsiebenundzwanzig Euro (EUR 121.527) durch
die Ausgabe von einunddreißigtausendzweihundertzweiunddreißig (31.232) Anteilen der Serie D mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1,00).
4. Dementsprechende Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einhunderteinundzwanzigtausendfünfhundertsiebenundzwanzig
Euro (EUR 121.527), aufgeteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die
„Stammanteile”), (ii) einhundertachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie A1a“), (iii) eintausendach-
thundertsieben (1.807) Anteile der Serie A1b (die „Anteile der Serie A1b“), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie
A1c (die „Anteile der Serie A1c“), (v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a“), (vi)
eintausendsechshundertsechsundfünfzig (1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b“), (vii) dreitausend-
siebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der Serie B1 (die „Anteile der Serie B1“), (viii) viertausendsechshundertsiebenun-
dachtzig (4.687) Anteile der Serie B2 (die „Anteile der Serie B2“), (ix) eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875)
Anteile der Serie B3 (die „Anteile der Serie B3“), (x) zehntausendachtundachtzig (10.088) Anteile der Serie B4 (die „Anteile
79980
L
U X E M B O U R G
der Serie B4“), (xi) achttausendachthundertneunzig (8.890) Anteile der Serie B5 (die „Anteile der Serie B5“, gemeinsam
mit den Anteilen der Serie B1, den Anteilen der Serie B2, den Anteilen der Serie B3 und den Anteilen der Serie B4 die
„Anteile der Serie B“), (xii) zehntausendzweihundertzweiundachtzig (10.282) Anteile der Serie C1 (die „Anteile der Serie
C1“), (xiii) zweitausendfünfunddreißig (2.035) Anteile der Serie C2 (die „Anteile der Serie C2“), (xiv) siebentausend-
vierhunderteins (7.401) Anteile der Serie C3 (die „Anteile der Serie C3“), (xv) sechzehntausendzweihundertsiebenun-
dachtzig (16.287) Anteile der Serie C4 (die „Anteile der Serie C4“) und (xvi) einunddreißigtausendzweihundertzweiundd-
reißig (31.232) Anteile der Serie D (die „Anteile der Serie D“), mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch
das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al
European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH,
(vii) Luxor Capital Partners, LP, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP und Luxor Wavefront, LP (gemein-
schaftlich „LuxorCap“) (Luxor Capital Partners, LP, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP und Luxor
Wavefront, LP üben ihre Rechte unter dieser Satzung gemeinschaftlich aus, als ob es sich um einen einzigen Gesellschafter
handeln würde; Luxor Capital Partners, LP ist dazu berechtigt, sämtliche Erklärungen in ihrem eigenen Namen, im Namen
von Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP und von Luxor Wavefront, LP abzugeben und entgegenzunehmen,
welche sich auf Rechte und Pflichten beziehen, die sich aus von ihnen gehaltenen Anteilen ergeben), (viii) FEC Lux S.à
r.l. und (ix) Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. und The Hon. A.G. Hamilton’s 1987 Settlement
(gemeinschaftlich „Pelham“) (Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. und The Hon. A.G. Hamilton’s
1987 Settlement üben ihre Rechte unter dieser Satzung gemeinschaftlich aus, als ob es sich um einen einzigen Gesellschafter
handeln würde; Pelham Capital Investments Ltd. ist dazu berechtigt, sämtliche Erklärungen in ihrem eigenen Namen, im
Namen von Viride Investments Ltd. und von The Hon. A.G. Hamilton‘s 1987 Settlement abzugeben und entgegenzuneh-
men, welche sich auf Rechte und Pflichten beziehen, die sich aus von ihnen gehaltenen Anteilen ergeben), (x) MKC Brillant
Services GmbH, (xi) Tetral S.A. und (xii) Longbow Finance S.A. ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapi-
talerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), und der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „In-
vestition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren gleichziehenden
Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung
erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i)
Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare
Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH, (vii) LuxorCap, (viii) FEC Lux S.à r.l., (ix)
Pelham, (x) MKC Brillant Services GmbH, (xi) Tetral S.A. und (xii) Longbow Finance S.A. hat die Gesellschaft durch
eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen, nachdem sie von der Gesellschaft über die Investition eines
Dritten informiert wurde, darüber zu unterrichten, ob Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG) und/oder Kinnevik
Online AB und/oder Al European Holdings S.à r.l. und/oder Aismare Lux Holdings S.à r.l. und/oder Phenomen Ventures
LP und/oder Mercura Capital GmbH und/oder LuxorCap und/oder FEC Lux S.à r.l. und/oder Pelham und/oder MKC
Brillant Services GmbH und/oder Tetral S.A. und/oder Longbow Finance S.A. ihr Recht gemäß dem vorstehenden Satz
dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile der Gesellschaft zeichnet, ist
dieser Artikel 5.3 entsprechend anzuwenden.“
5. Anschließende Änderung des Artikels 7 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine zusätzliche Zustimmung zur
Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:
a) bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch (i) Rocket
Internet SE (vormals Rocket Internet AG), (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux
79981
L
U X E M B O U R G
Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH, (vii) Luxor Capital, Luxor Offshore und Luxor
Wavefront (wobei Luxor Capital insofern in eigenem Namen, sowie für Luxor Offshore und für Luxor Wavefront handelt
und Rechte, die sich aus Anteilen ergeben, die von einem von ihnen gehalten werden, unter dieser Satzung gemeinschaftlich
ausübt, als ob es sich um einen einzigen Gesellschafter handeln würde), (viii) FEC Lux S.à r.l.; (ix) Pelham Capital In-
vestments Ltd., Viride Investments Ltd. und The Hon. A.G. Hamilton’s 1987 Settlement (wobei Pelham Capital Investments
Ltd. insofern in eigenem Namen handelt, sowie für Viride Investments Ltd. und The Hon. A.G. Hamilton’s 1987 Settlement
und Rechte, die sich aus Anteilen ergeben, die von einem von ihnen gehalten werden, unter dieser Satzung gemeinschaftlich
ausübt, als ob es sich um einen einzigen Gesellschafter handeln würde), (x) MKC Brillant Services GmbH, (xi) Tetral S.A.
und (xii) Longbow Finance S.A. (Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), Kinnevik Online AB, Al European
Holdings S.à r.l., Aismare Lux Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP, Mercura Capital GmbH, Luxor Capital, Luxor
Offshore, Luxor Wavefront, FEC Lux S.à r.l., Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd., The Hon. A.G.
Hamilton’s 1987 Settlement, MKC Brillant Services GmbH, Tetral S.A. und Longbow Finance S.A. im Folgenden ge-
meinschaftlich die „Investoren“; jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit dem betreffenden Investor verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
b) bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines Investors
an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, welche/s (i) diesen Investor oder (ii) durch einen oder mehrere direkte oder
indirekte Kontrollierende Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) (x) direkt
oder indirekt kontrolliert, von diesem kontrolliert wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die
Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft
oder des Unternehmens bezeichnet, durch (a) die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter, (b) das
Halten der Mehrheit der Anteile, (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung,
oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person,
entweder durch das Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der
betreffende Investor oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteili-
gung haben;
c) bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen an einen Dritten,
welcher Anteile unter der vereinheitlichten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder von einem Gesellschafter an die Gesell-
schaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung.
7.5 Sofern ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen gemäß Artikel
7.4 a) bis c) keiner weiteren Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf, gelten weder Verpflichtungen zu Ver-
kaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesell-
schafter.
7.6 Ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft darüber in Kenntnis gesetzt
wurde oder diesem/dieser zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn die Zustimmung zu einer solchen Übertragung mit einer Qualifizierten Mehrheit erteilt wurde (wobei die Anteile des
verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht
erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen ge-
setzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.“
6. Anschließende Änderung des Artikels 8 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Transak-
tionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der
Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde,
dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimm-
rechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer
verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätser-
eignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) - vorbehaltlich der Artikel 8.2, 8.3, 8.4 und 8.5 - im Einklang
mit Artikel 8.6 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie D einen Betrag von EUR 3.322,44
pro Anteil der Serie D, welcher, in jedem Fall, dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht
(bestehend aus dem Nominalbetrag der Anteile der Serie D, wie von dem jeweiligen Inhaber erworben, und dem Agio und/
oder anderen Kapitaleinlagen (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber
an die Gesellschafter gezahlt wurden).
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene“) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie C1, die Inhaber von Anteilen
der Serie C2 und die Inhaber von Anteilen der Serie C4 einen Betrag von EUR 2.762,94 pro Anteil der Serie C1 und/oder
Anteil der Serie C2 und/oder Anteil der Serie C4 (gegebenenfalls), und die Inhaber von Anteilen der Serie C3 erhalten
einen Betrag von EUR 2.465,67 pro Anteil der Serie C3, welcher, in jedem Fall, dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtin-
79982
L
U X E M B O U R G
vestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem Nominalbetrag der Anteile der Serie C1, der Anteile der Serie
C2, der Anteile der Serie C3 und der Anteile der Serie C4, wie von dem jeweiligen Inhaber erworben, und dem Agio und/
oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an
die Gesellschaft gezahlt wurden).
8.4 Auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag von EUR 1.600
pro Anteil der Serie B, welcher dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend
aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderen Kapi-
taleinlagen (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesellschafter
gezahlt wurden).
8.5 Auf einer vierten Ebene („Vierte Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie A1b,
Anteilen der Serie A1c, Anteilen der Serie A2a, Anteilen der Serie A2b pro Anteil der entsprechenden Anteilsklasse (und
zwischen den Gesellschaftern jeder Anteilsklasse auf einer pro rata-Basis zu deren Anteilsbesitz in der entsprechenden
Anteilsklasse) den wie folgt festgelegten Betrag:
Anteilsklasse
Betrag
pro Anteil
in Euro
Anteil der Serie A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.380,84
Anteil der Serie A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.383,14
Anteil der Serie A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,00
Anteil der Serie A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.556,82
Anteil der Serie A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.554,76
8.6 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene, der Zweiten Ebene, der Dritten Ebene und der Vierten Ebene geleistet
wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer fünften Ebene („Fünfte Ebene“) an alle Gesellschafter auf einer pro rata-
Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten
Ebene und/oder der Zweiten Ebene und/oder der Dritten Ebene und/oder der Vierten Ebene erhaltenen Beträge mindern
den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Fünften Ebene und werden anschließend entsprechend dieser
Fünften Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der Ersten Ebene und/oder
der Zweiten Ebene und/oder der Dritten Ebene und/oder der Vierten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung
auf der Fünften Ebene erfolgt solange, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der
Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder
nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten, der höher ist, (i) als sein Anteil
an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den verkauften Anteilen, oder (ii) als der Betrag,
der diesem Gesellschafter auf der Ersten Ebene und/oder der Zweiten Ebene und/oder der Dritten Ebene und/oder der
Vierten Ebene zugeteilt wurde. Erhält ein Gesellschafter dennoch einen höheren Betrag, muss er den Überschuss dement-
sprechend an die anderen Gesellschafter zurückzahlen. Sämtliche mit der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbun-
denen Ansprüche sind erst dann erfüllt, wenn der in Satz 1 dieses Artikels 8.6 festgesetzte Betrag hinsichtlich der jeweiligen
Anteile erhalten wurde.
8.7 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten Ebene und der Zweiten Ebene und der Dritten Eben und der Vierten Ebene
ist auf alle entsprechenden Anteile der Serie D, Anteile der Serie C, Anteile der Serie B, Anteile der Serie A1a, Anteile der
Serie A1b, Anteile der Serie A1c, Anteile der Serie A2a, Anteile der Serie A2b anwendbar, solange bei den jeweiligen
Anteilen der Serie D, Anteilen der Serie C, Anteilen der Serie B, Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie A1b, Anteilen
der Serie A1c, Anteilen der Serie A2a, Anteilen der Serie A2b der in Artikel 8.2, Artikel 8.3, Artikel 8.4 und/oder der in
der Tabelle in Artikel 8.5 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde.“
7. Anschließende Änderung des Artikels 25 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat (der „Beirat“). Dieser besteht aus bis zu elf (11) stimmberechtigten Mitgliedern.
Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der Mitglieder des
Beirats erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nichtstimmberechtigtes Mitglied (Beobachter) des Beirats
ernennen.
25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesell-
schafterbeschluss genehmigen oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von den Gesellschaftern durch schriftliche Mitteilung an die
Gesellschaft wie folgt ernannt:
a) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Rocket Internet SE (vormals Rocket
Internet AG) nach eigenem Ermessen ernannt (das „Rocket-Mitglied“);
b) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB nach eigenem
Ermessen ernannt;
c) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter AI European Holdings S.à r.l. nach
eigenem Ermessen ernannt;
79983
L
U X E M B O U R G
d) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings S.à r.l. nach
eigenem Ermessen ernannt;
e) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Phenomen Ventures LP nach eigenem
Ermessen ernannt;
f) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Mercura Capital GmbH nach eigenem
Ermessen ernannt;
g) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von den Gesellschaftern LuxorCap nach eigenem Ermessen
ernannt;
h) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter FEC Lux S.à r.l. nach eigenem Ermessen
ernannt;
i) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter MKC Brillant Services GmbH nach
eigenem Ermessen ernannt;
j) der Gesellschafter Tetral S.A. hat, nach eigenem Ermessen, das Recht, jederzeit ein (1) stimmberechtigtes Mitglied
des Beirats zu ernennen; und
k) der Gesellschafter Pelham Capital Investments Ltd. hat, nach eigenem Ermessen, das Recht, jederzeit ein (1) stimm-
berechtigtes Mitglied des Beirats zu ernennen.
25.4 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Das Rocket-Mitglied ist der Vorsit-
zende des Beirats und hat nicht die entscheidende Stimme. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine (1) Stimme, außer
das von Rocket ernannte stimmberechtigte Mitglied, welches fünf (5) Stimmen hat, und das von LuxorCap ernannte
stimmberechtigte Mitglied, welches drei (3) Stimmen hat, und das von Kinnevik ernannte stimmberechtigte Mitglied,
welches zwei (2) Stimmen hat. Das von dem Gesellschafter Pelham Capital Investments Ltd. zu ernennende stimmbe-
rechtigte Mitglied hat eine (1) Stimme. Das von dem Gesellschafter Tetral S.A. zu ernennende stimmberechtigte Mitglied
hat eine (1) Stimme. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Viride Investments Ltd., The Hon. A.G. Hamilton’s
1987 Settlement, sowie Longbow Finance S.A. nicht zur Ernennung eines Beiratsmitglieds berechtigt sind. Die Geschäfts-
ordnung des Beirats hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten.
25.5 Der Beirat ist zuständig für die Erteilung von Zustimmungen zu Transaktionen und Maßnahmen der Geschäfts-
führer, die die Gesellschafterversammlung vorbehaltlich der Zustimmung des Beirats entweder (i) in dieser Satzung, (ii)
in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer, (iii) durch einen Gesellschafterbeschluss oder (iv) in jedweder Gesellschaf-
tervereinbarung erteilt hat.
25.6 Die Vergütung der Mitglieder des Beirats wird, sofern vorgesehen, von den Gesellschaftern der Gesellschaft durch
einstimmigen Gesellschafterbeschluss festgelegt.
25.7 Neben den in den Artikeln 22.8 und 22.9 vorgesehenen Zustimmungserfordernissen hat der Beirat eine beratende
Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.“
8. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie
Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit unein-
geschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung, zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
9. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, eine (1) weitere Anteilsklasse zu schaffen, welche als Anteile der Serie D bezeichnet
werden (die „Anteile der Serie D“), wodurch nunmehr insgesamt sechzehn (16) Anteilsklassen bestehen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter akzeptieren Tetral S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht der Schweiz mit
satzungsmäßigem Sitz in Pully, mit Sitz in Avenue Général Guisan 70, 1009 Pully, Schweiz und eingetragen im Handels-
register des Kantons Waadt unter der Nummer CH-550.1.000.845-3, und Longbow Finance S.A., eine 1963 in der Schweiz
gegründeten Aktiengesellschaft (société anonyme) mit einem Gesellschaftskapital von CHF 1.000.000, eingetragen im
Handelsregister des Kantons Waadt unter der Nummer CHE-102.894.094, mit satzungsmäßigem Sitz in route de Lavaux
36, 1095 Lutry, Schweiz, als neue Gesellschafterinnen der Gesellschaft.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von neunzig-
tausendzweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 90.295) um einen Betrag von einunddreißigtausendzweihundertzwei-
unddreißig Euro (EUR 31.232) auf einen Betrag von einhunderteinundzwanzigtausendfünfhundertsiebenundzwanzig Euro
(EUR 121.527) durch die Ausgabe von einunddreißigtausendzweihundertzweiunddreißig (31.232) Anteilen der Serie D
mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.
79984
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnungi>
Die Gesellschafter haben auf jegliche Vorzugsrechte, die ihnen gemäß Artikel 5.3 der Satzung der Gesellschaft zustehen
könnten, verzichtet.
Elftausendfünfundsechzig (11.065) Anteile der Serie D wurden ordnungsgemäß von Rocket Internet SE (vormals Rocket
Internet AG), vorbenannt, zum Preis von elftausendfünfundsechzig Euro (EUR 11.065) gezeichnet.
Fünftausendeinhundertsiebzehn (5.117) Anteile der Serie D wurden ordnungsgemäß von Luxor Wavefront, LP, vor-
benannt, zum Preis von fünftausendeinhundertsiebzehn Euro (EUR 5.117) gezeichnet.
Zwölftausendvierzig (12.040) Anteile der Serie D wurden ordnungsgemäß von Tetral, vorbenannt, zum Preis von
zwölftausendvierzig Euro (EUR 12.040) gezeichnet.
Dreitausendzehn (3.010) Anteile der Serie D wurden ordnungsgemäß von Longbow Finance, vorbenannt, zum Preis
von dreitausendzehn Euro (EUR 3.010) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), vorbenannt, gezeichneten elftausendfünfundsechzig (11.065)
Anteile der Serie D, die von Luxor Wavefront, LP, vorbenannt, gezeichneten fünftausendeinhundertsiebzehn (5.117) An-
teile der Serie D, die von Tetral, vorbenannt, gezeichneten zwölftausendvierzig (12.040) Anteile der Serie D und die von
Longbow Finance, vorbenannt, gezeichneten dreitausendzehn (3.010) Anteile der Serie D wurden vollständig eingezahlt
durch eine Bareinlage in Höhe von einunddreißigtausendzweihundertzweiunddreißig Euro (EUR 31.232).
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Bareinlage wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Der Betrag von einunddreißigtausendzweihundertzweiunddreißig Euro (EUR 31.232) steht der Gesellschaft ab sofort
zur Verfügung, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Die Einlage in Höhe von einunddreißigtausendzweihundertzweiunddreißig Euro (EUR 31.232) wird vollständig dem
Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugeführt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafter nehmen zur Kenntnis, dass Tetral, vorbenannt, nun Inhaberin von zwölftausendvierzig (12.040)
Anteilen der Serie D, und Longbow Finance, vorbenannt, ebenfalls Inhaberin von dreitausendzehn (3.010) Anteilen der
Serie D geworden sind.
Demzufolge schließen sich Tetral, vorbenannt, und Longbow Finance, vorbenannt, stimmberechtigt und hier vertreten
durch Philippe Sylvestre, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß der vorbenannten Vollmachten der Versamm-
lung, welche im Folgenden als „die Gesellschafterversammlung“ bezeichnet wird, für die folgenden Beschlüsse an.
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie
in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 7 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in
der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 8 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in
der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 25 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie
in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Achter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Herrn Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr zweitausendfünfhundert (EUR 2.500,-) geschätzt.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
79985
L
U X E M B O U R G
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notar mit Namen, Vornamen
und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Signé: P. Sylvestre, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 25 mars 2015. GAC/2015/2503. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 8 mai 2015.
Référence de publication: 2015069971/920.
(150079406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Globoaves Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 187.687.
Par résolutions prises en date du 10 avril 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
au mandat de commissaire aux comptes, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en
2015;
2. Acceptation de la démission de KPMG AUDIT, avec siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg de son
mandat de commissaire aux comptes, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2015.
Référence de publication: 2015070047/16.
(150079254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Immoreal DE 2, Société Anonyme,
(anc. Frontiers Capital Mongolia).
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 175.670.
In the year two thousand and fifteen, on the seventh of May.
Before Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme") “Frontiers
Capital Mongolia”, (the "Company"), with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscribed in the
Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 175.670, incorporated pursuant to a deed of
Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, on the 18
th
day of February 2013, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1089 on the 8
th
of May 2013.
The meeting is presided by Mr Bob PLEIN, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mrs. Cristiana SCHMIT, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route
de Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Lu-
xembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the
following:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Change the name of the Company into Immoreal DE 2, and the purpose of the Company and subsequently complete
rewording of the articles of association in accordance with the current provisions of Luxembourg law dated 10
th
August
1915 as modified.
2. Statutory appointments
3. Miscellaneous.
79986
L
U X E M B O U R G
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides:
- to change the name of the Company into “Immoreal DE 2”
- to modify the purpose of the Company as detailed in article 3 of the new By-Laws, and
- to reword completely the articles of association in order to put them in accordance with the current provisions of
Luxembourg law dated 10
th
August 1915 as modified.
I. Name, Duration, Object, Registered office
Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued,
a company in the form of a public limited company ("société anonyme"), under the name of “Immoreal DE 2” (hereinafter
the "Company").
Art. 2. The duration of the Company is unlimited.
Art. 3. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or
indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated
company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the “Connected Companies”). It may also
give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected
Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its
assets
The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual
property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their
efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
The object of the Company is also the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money. The Company can also perform in Luxembourg as well
as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which
are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and
companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and develop-
ment, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial
participations company according to the applicable provisions.
The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments
in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing,
draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging
or otherwise encumbering movable or immovable property.
The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
79987
L
U X E M B O U R G
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision
of the shareholders' meeting.
II. Social capital, Shares
Art. 5. The share capital is set at thirty one thousand Euro (31,000.-EUR), represented by three thousand one hundred
(3,100) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) each.
The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the "Law"), redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form,
at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares
will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two
directors or, if the Company as only one director, by this director.
The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided
for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.
The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may
be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual.
A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
must be filed in accordance with §§1 and 2 of the Law.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the Company.
III. General meetings of shareholders
Decision of the sole shareholder
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting
of shareholders.
The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders repre-
senting at least one tenth of the Company's share capital.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other
place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Monday of June of each year at 9:00. a.m..
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.
Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in
any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.
Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board
(bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.
All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar
means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical cha-
racteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
79988
L
U X E M B O U R G
IV. Board of directors
Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not
be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is ack-
nowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the
board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there
is more than one shareholders in the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,
remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled
out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders
or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance
of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency
shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar
means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical cha-
racteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held
by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a
meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,
the chairman of the board of directors shall have a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director
only, the sole director shall sign these documents.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests.
All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company
in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report
each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company
may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
79989
L
U X E M B O U R G
Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to
whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one
(1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
V. Supervision of the company
Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.
VI. Accounting year, balance
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1
st
of January of each year and shall terminate on 31
st
of
December of the same year.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by
Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in
article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder
of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.
VII. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
VIII. Amendment of the articles of incorporation
Art. 18. These articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.
IX. Final clause - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides:
- to accept the resignation of all the actual directors of the Company
- to confirm as statutory auditor: Compliance & Control, a public limited liability company, having its registered office
at L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, registered of the Trade and Register of Companies under the section B number
172.482
- appoint as sole director: Mr Kindy FRITSCH, Director, born at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on April
20
th
, 1983, and having his professional address at 20, rue des Peupliers L-2328 Luxembourg
The mandates of the sole director and the statutory auditor will end at the issue of the annual general meeting which
will be held in 2020.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are
estimated at one thousand three hundred and fifty Euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English and the French texts, the French version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le sept mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
79990
L
U X E M B O U R G
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Frontiers Capital Mongolia”, (ci-après
dénommée la "Société"), avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 175.670, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER,
notaire résidant à Luxembourg, en date du 18 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1089 du 8 mai 2013
L'assemblée est présidée par Monsieur Bob PLEIN, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route
de Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Cristiana SCHMIT, employée, ayant son domicile professionnel à
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster,
3, route de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la Société en Immoreal DE 2, et modification de l'objet social de la Société, ainsi
que refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi luxembourgeoise du
10 août 1915 telle que modifiée.
2. Nomination statutaires
3. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés
sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide:
- de changer la dénomination de la Société en “Immoreal DE 2”;
- de modifier l'objet social comme reproduit dans l'article 3 des nouveaux statuts,
- de reformuler complètement les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 telle que modifiée, afin de leurs donner la teneur suivante:
I. Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de “Immoreal DE 2” (ci-après la "Société").
Art. 2. La durée la de Société est illimitée.
Art. 3. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que
ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange
ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et
autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée.
La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties
ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci ne soit
substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société appartenant
au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra accorder toute
garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou
charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tout
contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées
La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
79991
L
U X E M B O U R G
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change,
taux d'intérêt et autres risques.
L'objet de la Société est également l'acquisition, la gestion, le développement, la vente et la location de biens immeubles,
meublés ou non meublés, et en général, toutes les opérations immobilières, à l'exception de ceux réservés à un courtier en/
agent immobilier, et celles concernant le placement et la gestion de l'argent. La Société peut également effectuer au Lu-
xembourg comme à l'étranger, sous forme que ce soit, toutes les transactions de propriété immobilières industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui sont directement en relation avec la création, la gestion et le
financement, sous forme que ce soit, de toutes entreprises et les entreprises dont l'objet est la performance de toutes les
activités sous forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, de façon permanente ou temporaire, du portefeuille
créé à cet effet. La Société sera considérée comme une société de participations financières conformément aux dispositions
applicables.
La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des inves-
tissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la
location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée
des actionnaires.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions
d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription
sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou,
si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-
ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la
Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait
été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires
représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 1
er
Lundi du mois de Juin à 09.00 heures. Si ce
jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
79992
L
U X E M B O U R G
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant
par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à
toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par
les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans
un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télé-
communication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant
la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une
réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'exi-
stence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la
durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut
être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en
son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par
de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de
partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
79993
L
U X E M B O U R G
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé
d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par
une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obli-
gation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quel-
conques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque
le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas
besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de
la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions
de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de
la Loi.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide:
- d'accepter les démissions de tous les administrateurs de la Société;
- de confirmer à la fonction de Commissaire aux Comptes: Compliance & Control, société anonyme ayant son siège
social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 172.482
79994
L
U X E M B O U R G
- de nommer à la fonction d'administrateur unique: Monsieur Kindy FRITSCH, administrateur, né à Luxembourg
(Grand-Duché du Luxembourg), le 20 avril 1983, et résidant professionnellement au 20, rue des Peupliers, L-2328 Lu-
xembourg
Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2020.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille trois cent cinquante euros.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes,
le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version française fera foi.
DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bob PLEIN, Cristiana SCHMIT, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 mai 2015. Relation GAC/2015/4005. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015070021/483.
(150080053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Gurkha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 182.744.
EXTRAIT
En date du 8 mai 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1) La nomination de M. Markus Leininger, avec adresse personnelle au 226A, route d'Arlon L-8010 Strassen, en tant
que gérant est acceptée avec effet au 1
er
mai 2015 et pour une durée indéterminée.
2) La nomination de Mme Richel van Weij, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxem-
bourg, en tant que gérant est acceptée avec effet au 1
er
mai 2015 et pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015070051/15.
(150079287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Hugo Insurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 117.417.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le jeudi 30 avril 2015i>
L'Assemblée renouvelle les mandats des administrateurs suivants:
- M. Pierre-Claude Perrenoud, Residenza al Parco, A 601, Via San Gottardo 8, CH-6600 Muralto-Locarno, Suisse
- M. Patrice Tourlière, Administrateur Président du Conseil d'Administration
- M. Laurent Barbagli
- M. Claude Weber
Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2016 et qui aura à statuer sur les
comptes de l'exercice de 2015.
L'Assemblée nomme ERNST & YOUNG S.A (RCS Luxembourg B 47771), 7, rue Gabriel Lippmann, L5365 Münsbach,
comme Réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en
2016 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice de 2015.
79995
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015070102/21.
(150079410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Galerie Commerciale de Kirchberg, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 50.172.
Par résolutions circulaires signées en date du 4 mai 2015, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Marc Maheut, avec adresse professionnelle à rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix,
France au mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en 2020;
2. Acceptation de la démission de Christelle Lanoy, avec adresse professionnelle à rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
59170 Croix, France de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2015.
Référence de publication: 2015070052/15.
(150079682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Munich LBS 160 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 140.882.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first of April.
Before Maître Jean SECKLER, notary public residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of “MUNICH LBS 160 SARL”, a “société à responsabilité
limitée”, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B
number 140.882. The company has been incorporated on August 1
st
, 2008 pursuant to a deed before Me Martine Schaeffer,
notary residing in Luxembourg, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2107 dated
August 30
th
, 2008.
The meeting is presided by Monsieur Max MAYER, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer, Monsieur Henri DA CRUZ, employee, residing
professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list which
will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the twelve thousand five hundred shares (12,500) shares having a par value of
one euro (EUR 1,-) each, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda. The articles of association have not been amended since.
The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Amendment of article 7 of the articles of association of the Company.- to appoint 2 categories of Managers, one
category A and one-category B and to amend article 7.1 of the bylaws in order to reflect the resolution to be taken;
2. Amendment of article 8.1 of the articles of association of the Company;
3. Amendment of article 8.2. paragraph (v) of the articles of association of the Company;
4. Amendment of article 8.3. of the articles of association of the Company to cancel the third paragraph of the article
8.3.;
5. Decision to accept the resignation of Mr. Olivier Liegeois and Mr. Patrick Moinet as managers of the Company;
6. Appointment of Dr. Michael Theim as category A manager of the Company;
79996
L
U X E M B O U R G
7. Appointment of Mr.Martin Hubert and Mrs. Sandrine Bisaro as category B managers of the Company;
8. Acknowledgement of a clerical error in article 5 of the French version of the deed of incorporation of the Company
and related amendment of such article;
9. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the notary to enact, the following resolutions:
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The general meeting of shareholders decides to insert provisions regarding the appointment of category A and category
B managers into the articles of association of the Company and therefore resolves to amend article 7 of the articles of
association of the Company which shall henceforth read as follows:
“ Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the
term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of class
A managers and class B managers. The managers need not be shareholders.
7.2. The shareholders may, by way of a resolution of the shareholders, decide to appoint managers of different categories,
namely category A managers and category B managers.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.”
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolution the general meeting of shareholders resolves to amend article 8.1. of the
articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
“ 8.1. Powers of the board of managers.
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Notwithstanding the above, the disposal of any asset directly held by the Company and having a value exceeding
ten thousand euro (EUR 10,000) requires the prior approval of the shareholders of the Company given by a resolution of
the shareholders of the Company adopted by a majority representing at least ninety percent (90%) of the share capital of
the Company.
(iii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.”
<i>Third resolution:i>
Further to the first resolution, the meeting decides to amend Articles 8.2. (i) and (v) and 8.3 (i) of the Articles of
Incorporation to read as follows:
" Art. 8.2.
"(i) The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
(v) The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and
among whom one class A manager and one class B manager imperatively. ) In case the shareholders have resolved to
classify the appointed managers as category A and category B managers, the Board may deliberate or act validly only if at
least one (1) category A manager and one (1) category B manager is present or represented at the meeting Resolutions of
the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast by the managers present or represented. The
resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by by the chairman of the meeting or, if no chairman
has been appointed, all the managers present or represented at the meeting.
<i>Fourth resolution:i>
The general meeting of shareholders resolves to amend article 8.3. of the articles of association of the Company which
shall henceforth read as follows:
“ 8.3. Representation.
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers. In case
the shareholders have resolved to classify the appointed managers as category A and category B managers, the Company
is bound towards third parties in all matters by the joint signature of at least one category A and one category B manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been
delegated.”
<i>Fifth resolution:i>
The meeting decides to cancel the third paragraph (iii) of the article 8.3.
79997
L
U X E M B O U R G
<i>Sixth resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to approve the resignation of Mr. Olivier LIEGEOIS, Mr. Patrick Moinet and Mr. Arnulf
Neumann-Damerau as managers of the Company, with immediate effect and to give them full discharge for the performance
of their duties as managers of the Company.
The Sole Shareholder resolves to appoint Mrs Sandrine BISARO, born in Metz (France) on June 28
th
1969, residing
professionally at 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, as manager category B of the Company, with immediate effect
and for an unlimited period of time.
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Martin Hubert, born in Messancy (Belgium) on April 28
th
1982, residing
at 65, rue de Grass, B-6700 Sterpenich (Belgium), as manager category B of the Company, with immediate effect and for
an unlimited period of time.
The Sole Shareholder resolves to appoint Dr. Michael Theim, born in Wetzlar (Germany) on May 1
th
, 1955, residing
professionally at Menzelstrasse 8, D-14193 Berlin, as manager category A of the Company, with immediate effect and for
an unlimited period of time.
<i>Seventh resolution:i>
The general meeting of shareholders notes that the French translation of the incorporation deed of the Company, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2107 on 30 August 2008, contains a clerical
error as it states that the Company has a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by
five hundred (500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1).
The general meeting of shareholders confirms that the French translation is incorrect as it should state that the share
capital of the Company is of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred
(12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1).
Therefore, the general meeting of shareholders decides to amend article 5 of the French translation of the articles of
association which shall henceforth read as follows:
« Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12,500)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.»
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are
estimated at one thousand eight hundred Euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-et-un avril.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Se réunit
l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «MUNICH LBS 160 S.à
r.l.», ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro
140.882, constituée suivant acte reçu le 1
er
août 2008 par Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2107 du 30 août 2008.
L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement au 3, route de Luxem-
bourg, L-6130 Junglinster.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri DA CRUZ, employé,
demeurant professionnellement au 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster.
Le président prie le notaire d'acter que:
79998
L
U X E M B O U R G
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient est renseigné sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un
euro, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 7 des statuts de la Société afin de nommer 2 catégories de Gérants, une catégorie A et une
catégorie B et modifier l'article 7.1 des statuts pour refléter la décision prise
2. Modification de l'article 8.1. des statuts de la Société
3. Modification de l'article 8.2. paragraphe (v) des statuts de la Société;
4. Modification de l'article 8.3. des statuts de la Société afin de supprimer le 3
ème
paragraphe de l'article 8.3;
5. Décision d'accepter la démission de Monsieur Olivier Liegeois et de Monsieur Patrick Moinet en tant que gérants de
la Société;
6. Nomination de Dr Michael Theim en tant que gérant de catégorie A de la Société;
7. Nomination de Monsieur Martin Hubert et Madame Sandrine Bisaro en tant que gérants de catégorie B de la Société;
8. Prise en compte de l'erreur d'impression dans l'article 5 de la traduction française de l'acte de constitution de la Société;
9. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale adopte à l'unanimité, et requiert
le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale des associés décide d'insérer des dispositions relatives à la nomination de 2 catégories gérants de
catégorie A et de catégorie B dans les statuts de la Société et pour cela de modifier l'article 7 des statuts de la Société qui
aura désormais la teneur suivante:
« Art. 7. Nomination et révocation des gérants. Suite à la décision qui précède l'article 7.1 des statuts aura dorénavant
la teneur suivante:
« Art. 7.1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixeront la durée
de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance constitué d'au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas nécessairement associé(s).
7.2. Les associés pourront, par le biais d'une résolution des associés, décider de nommer des gérants de différentes
catégories notamment des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B.
7.3 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.»
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 8.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur
suivante:
« 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance.
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Nonobstant ce qui précède, la vente de tout actif directement tenu par la Société et ayant une valeur excédant dix
mille euros (EUR 10.000) requière l'accord préalable des associés de la Société donné dans le cadre d'une résolution des
associés de la Société adoptée à une majorité représentant au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) du capital social de
la Société.
(iii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.»
<i>Troisième résolution:i>
Suite à la décision qui précède l'article 8.2 (i) et (v) et 8.3 (i) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 8.2.
(i) Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant au
lieu indiqué dans l'avis de convocation.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Au
cas où les associés ont décidé de nommer des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B, le Conseil peut délibérer
79999
L
U X E M B O U R G
ou agir valablement seulement si un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B est présent ou représenté. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Au cas où les
associés ont décidé de nommer des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B, les décisions sont valablement
adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés incluant au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1)
gérant de catégorie B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la
réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 8.3. des statuts de la Société qui aura désormais la teneur
suivante:
« 8.3. Représentation.
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
Au cas où les associés ont décidé de nommer des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B, la Société est engagée
vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de
catégorie B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.»
<i>Cinquième résolution:i>
L'Assemblée décide d'annuler le 3
ème
paragraphe (iii) de l'article 8.3.
<i>Sixième résolution:i>
L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Olivier Liegeois, Monsieur Patrick Moinet et de Monsieur
Arnulf Neumann-Damerau de leur mandat de Gérants et de leur donner décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à
ce jour.
L'Assemblée décide de nommer Madame Sandrine Bisaro, née à Metz (France) le 28 juin 1969, demeurant profession-
nellement au 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en tant que Gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée.
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Martin Hubert, né à Messancy (Belgique) le 28 avril 1982, demeurant au 65
rue de Grass, B-6700 Sterpenich (Belgique), en tant que Gérant catégorie B, avec effet immédiat et ce pour une période
indéterminée.
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Michel Theim, né à Wetzlar (Allemagne) le 17 mai 1955, demeurant à
Menzelstrasse 8, D-14193 Berlin, en tant que Gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale des associés note que la traduction française de l'acte de constitution de la Société, publiée au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2107 au 30 août 2008, contient une erreur matérielle car
il mentionne que la Société a un capital social de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500)
parts sociales avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1).
L'assemblée générale des associés confirme que la traduction française est incorrecte car elle devrait mentionner que le
capital social de la Société est de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1).
Pour cette raison, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 5 de la traduction française des statuts
de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille huit cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
80000
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connues du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 24 avril 2015. Relation GAC/2015/3483. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015070230/255.
(150080132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Gambit Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 167.418.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015070053/9.
(150079742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Garage Pepin sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9160 Ingeldorf, 12, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 134.623.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GARAGE PEPIN sàrl
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015070054/12.
(150079751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Garantidata International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 67.034.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que le commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE SEVE S.A., inscrite sous le numéro RCS B 82421 et ayant
son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, a changé de dénomination en date du 14 juin 2013 et
porte désormais la dénomination FIDUSEVE S.A.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour Garantidata International S.A.i>
Référence de publication: 2015070055/15.
(150079543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
KBL European Private Bankers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 6.395.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 19 mars 2015i>
Le Conseil d'Administration du 19 mars 2015 renomme la société Ernst & Young comme réviseur externe de la société
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.
L'adresse de Ernst & Young est:
7, rue Gabriel Lippmann
Parc d'Activité Syrdall 2
80001
L
U X E M B O U R G
L-5365 Munsbach
Luxembourg, le 19 mars 2015.
KBL European Private Bankers S.A
Yves Stein
<i>Groupe CEOi>
Référence de publication: 2015070152/18.
(150079594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Gastina Equity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 137.500.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GASTINA EQUITY S.A.
Référence de publication: 2015070056/10.
(150080066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
GDS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 6, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 126.195.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015070057/9.
(150079581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Gefip Euroland, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 52.100.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2015.
Référence de publication: 2015070059/10.
(150079592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
NDG Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 175.314.
L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de mars,
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est déroulée
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de NDG GROUP S.A., une société anonyme existante selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B
numéro 175.314 (la “Société”), constituée selon acte reçu le 12 février 2013 par le notaire soussigné et publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations le 15 avril 2013 sous le numéro 886.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par le notaire soussigné le 12 décembre
2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 20 février 2015 sous le numéro 473.
L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte à 9:00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre LENTZ,
licencié en sciences économiques, résidant professionnellement à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire Madame Suet Sum WONG, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée générale a choisi comme scrutatrice Madame Emmanuelle SCHILTZ, maître en sciences comptables et
financières, résidant professionnellement à Luxembourg.
80002
L
U X E M B O U R G
Le bureau de l’assemblée générale extraordinaire ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d’acter
que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, le bureau de l’assemblée, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II. Il ressort de ladite liste de présence que les quatorze millions quatre cent vingt mille (14.420.000) actions ordinaires
et les six cent trente mille (630.000) actions de préférence qui composent l’entièreté du capital sont représentés.
III. La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social de la Société, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
IV. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification du point 10.2. de l’article 10 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 10.2. En particulier, les décisions suivantes relatives à la Société et aux Filiales devront être préalablement approuvées
à la majorité simple des membres du Conseil d'Administration à moins que ladite décision n'ait été individuellement et
spécifiquement approuvée dans le cadre de l’approbation du budget annuel du Groupe communiqué au Conseil d'Admi-
nistration par ses Filiales, étant précisé, pour ce qui concerne les Filiales Françaises, que pour autant que les opérations
concernées concernent exclusivement lesdites Filiales Françaises et qu’elles aient été valablement approuvées par le Conseil
de Surveillance de Natural Santé France, lesdites décisions n’auront pas à être approuvées de nouveau par le Conseil
d’Administration de NDG Group:
(i) l’approbation ou la modification du budget annuel;
(ii) l’acquisition ou la cession de tout actif dont la valeur est supérieure à 100.000 EUR (cent mille euros) HT;
(iii) l’acquisition, le transfert, la création ou la cessation de toute participation, filiale, fonds de commerce ou activité;
(iv) la rémunération des membres du conseil d'administration (board) des Filiales de la Société et toute conclusion ou
modification de toute convention entre une des sociétés du Groupe et un Dirigeant;
(v) toute décision de désignation, révocation ou licenciement ou fin de fonctions d'un salarié dont la rémunération brute
annuelle (variable compris) est supérieure à 80.000 EUR (quatre-vingt mille euros), d'un Dirigeant ou d'un mandataire
social et notamment la nomination et la révocation des membres du Conseil de Surveillance de Natural Santé France;
(vi) l’arrêté des comptes annuels, l’affectation des résultats et tout changement de méthodes comptables ne résultant pas
directement d'une modification législative ou réglementaire;
(vii) toute émission ou tout Transfert de titres (autre que les Titres) et plus généralement toute opération sur le capital,
les fonds propres et quasi-fonds propres (en ce compris toute opération de fusion, scission ou apport partiel d'actifs à laquelle
serait partie l’une des sociétés du Groupe);
(viii) tout mécanisme général d'intéressement et de participation des salariés;
(ix) la souscription par toute société du Groupe de tout endettement ainsi que tout octroi de garantie d'un montant unitaire
ou cumulé au cours d'un même exercice social supérieur à 100.000 EUR (cent mille euros);
(x) l’engagement de toute action en justice, la prise de toute décision importante ayant trait à une telle action ou la
conclusion de toute transaction dont l’enjeu dans chaque cas est supérieur à 80.000 EUR (quatre-vingt mille euros); et
(xi) toute décision qui nécessite l’accord préalable des prêteurs aux termes de documents de financement auxquels la
Société ou des Filiales serait partie.
Pour éviter tout doute, le Conseil d'Administration n'aura aucun rôle opérationnel dans les Filiales mais un rôle d'ac-
compagnement sur les sujets stratégiques.»
2. Modification de l’article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 12. Indemnisation. Les fonctions d'Administrateur et d’Observateur ne sont pas rémunérées par la Société.»
3. Ajout d’une nouvelle définition à l’article 29 des statuts à la suite de la définition de «Filiale», qui aura la teneur
suivante:
«Filiale Française désigne Natural Santé France et toute entité dont Natural Santé France a ou aura, directement ou
indirectement, le Contrôle»
4. Remplacement des guillemets anglais “” par des guillemets français «» dans le texte du point 16.2.1. de l’article 16
et de l’article 29 des statuts sans en changer la substance.
5. Divers.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société adopte les résolutions suivantes:
80003
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société décide de modifier le point 10.2 de l’article 10 des
statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 10.2. En particulier, les décisions suivantes relatives à la Société et aux Filiales devront être préalablement approuvées
à la majorité simple des membres du Conseil d'Administration à moins que ladite décision n'ait été individuellement et
spécifiquement approuvée dans le cadre de l’approbation du budget annuel du Groupe communiqué au Conseil d'Admi-
nistration par ses Filiales, étant précisé, pour ce qui concerne les Filiales Françaises, que pour autant que les opérations
concernées concernent exclusivement lesdites Filiales Françaises et qu’elles aient été valablement approuvées par le Conseil
de Surveillance de Natural Santé France, lesdites décisions n’auront pas à être approuvées de nouveau par le Conseil
d’Administration de NDG Group:
(i) l’approbation ou la modification du budget annuel;
(ii) l’acquisition ou la cession de tout actif dont la valeur est supérieure à 100.000 EUR (cent mille euros) HT;
(iii) l’acquisition, le transfert, la création ou la cessation de toute participation, filiale, fonds de commerce ou activité;
(iv) la rémunération des membres du conseil d'administration (board) des Filiales de la Société et toute conclusion ou
modification de toute convention entre une des sociétés du Groupe et un Dirigeant;
(v) toute décision de désignation, révocation ou licenciement ou fin de fonctions d'un salarié dont la rémunération brute
annuelle (variable compris) est supérieure à 80.000 EUR (quatre-vingt mille euros), d'un Dirigeant ou d'un mandataire
social et notamment la nomination et la révocation des membres du Conseil de Surveillance de Natural Santé France;
(vi) l’arrêté des comptes annuels, l’affectation des résultats et tout changement de méthodes comptables ne résultant pas
directement d'une modification législative ou réglementaire;
(vii) toute émission ou tout Transfert de titres (autre que les Titres) et plus généralement toute opération sur le capital,
les fonds propres et quasi-fonds propres (en ce compris toute opération de fusion, scission ou apport partiel d'actifs à laquelle
serait partie l’une des sociétés du Groupe);
(viii) tout mécanisme général d'intéressement et de participation des salariés;
(ix) la souscription par toute société du Groupe de tout endettement ainsi que tout octroi de garantie d'un montant unitaire
ou cumulé au cours d'un même exercice social supérieur à 100.000 EUR (cent mille euros);
(x) l’engagement de toute action en justice, la prise de toute décision importante ayant trait à une telle action ou la
conclusion de toute transaction dont l’enjeu dans chaque cas est supérieur à 80.000 EUR (quatre-vingt mille euros); et
(xi) toute décision qui nécessite l’accord préalable des prêteurs aux termes de documents de financement auxquels la
Société ou des Filiales serait partie.
Pour éviter tout doute, le Conseil d'Administration n'aura aucun rôle opérationnel dans les Filiales mais un rôle d'ac-
compagnement sur les sujets stratégiques.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société décide de modifier l’article 12 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 12. Indemnisation. Les fonctions d'Administrateur et d’Observateur ne sont pas rémunérées par la Société.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société décide d’ajouter une nouvelle définition à l’article
29 des statuts à la suite de la définition de «Filiale», qui aura la teneur suivante:
«Filiale Française désigne Natural Santé France et toute entité dont Natural Santé France a ou aura, directement ou
indirectement, le Contrôle»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société décide de remplacer purement et simplement les
guillemets anglais “” par des guillemets français «» dans le texte du point 16.2.1 de l’article 16 et de l’article 29 des statuts
sans en changer la substance.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 9.15 heures.
<i>Frais et dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimés à mille cinq cents euros
(EUR 1.500).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: P. Lentz, S. S. Wong, E. Schiltz, M. Loesch.
80004
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 27 mars 2015. GAC/2015/2605. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 8 mai 2015.
Référence de publication: 2015070273/133.
(150079534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Gelustok SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
R.C.S. Luxembourg B 108.551.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 09 mai 2015.
Référence de publication: 2015070060/10.
(150079802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
GFM (CE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 101.245.
<i>Extrait rectificatif sur dépôt numéro L110115207 du 19 juillet 2011i>
Le dépôt L110115207 du 19 juillet 2011 mentionne, entre autre, que M. Herman Moors, ayant pour adresse profes-
sionnelle 240, rue de Luxembourg, L-2324 Luxembourg, est nommé en tant qu'administrateur de la Société.
Or, il convient de modifier son adresse comme suit: 240, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2015.
Référence de publication: 2015070062/13.
(150079247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Global Management & Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 68.566.
L'administrateur unique constate que le siège social du commissaire aux comptes INTERAUDIT est fixé au 37, rue des
Scillas L-2529 Howald depuis le 10 octobre 2013.
Référence de publication: 2015070063/9.
(150079541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Spring Capital, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 151.258.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique à Luxembourg le 30 avril 2015i>
Acceptation de la démission des administrateurs de leur mandat:
- M. Vincent TUCCI, né le 26 juillet 1968, à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement au 10A, rue
Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, administrateur,
- Madame Filippa RAULET, née le 12 septembre 1961, à Thionville (France), demeurant professionnellement au 10A,
rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, administrateur,
- Monsieur Eriks MARTINOWSKIS, né le 26 juillet 1980, à Latvia (Lettonie), demeurant professionnellement au 10A,
rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, administrateur,
Nomination d'un administrateur unique:
La Société NUTRILUXE Sàrl, domiciliée au 10A, rue Henri M.Schnadt L-2530 Luxembourg, immatriculée B 193406
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
L'administrateur unique est nommé pour un mandat d'une durée de trois ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
80005
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 avril 2015.
<i>Les administrateursi>
Référence de publication: 2015070427/22.
(150079400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Global Offshore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 34.671.
Le Bilan au 31.12.2014 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015070064/9.
(150079197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Global Trust Advisors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 68.731.
RECTIFICATIF
Cette mention vient modifier le bilan au 31 DECEMBRE 2012, enregistré et déposé au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg en date du 03/03/2014 sous la référence L140037496.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mai 2015.
Référence de publication: 2015070065/13.
(150079176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Global Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 69.727.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que le commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE SEVE S.A., inscrite sous le numéro RCS B 82421 et ayant
son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, a changé de dénomination en date du 14 juin 2013 et
porte désormais la dénomination FIDUSEVE S.A.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour Global Ventures S.A.i>
Référence de publication: 2015070066/15.
(150079542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Luxembourg Contact Centers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 26.357.
<i>Dépôt rectificatif: Modification L150076015i>
Les sièges sociaux des sociétés suivantes, associées de la Société, ont été transférés comme suit:
- le siège social de la société Téléperformance S.A. immatriculée au Registre de commerce de Paris sous le numéro 301
292 702, a été transféré au 21-25 rue Balzac, F-75008, Paris, France; et
- le siège social de la société Téléperformance France S.A.S. immatriculée au Registre de commerce de Paris sous le
numéro 353 380 793, a été transféré au 12-14-16 rue Sarah Bernhardt, F-92600 ASNIERES, France.
M. Olivier RIGAUDY, gérant de la Société a changé d'adresse. Il demeure professionnellement au 2125 rue Balzac,
F75008 Paris, France
80006
L
U X E M B O U R G
A Luxembourg, le 5 mai 2015.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015070175/17.
(150080115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Go Ahead SA, Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 149.908.
L'an deux mille quinze, le vingt avril.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Monsieur Jean-Michel GURRET,né le 28 novembre 1963 à Annecy (France) demeurant 99 route du vin L-5405 Bech-
Kleinmacher,
ici dûment représentée par Madame Joëlle Wurth demeurant à Beckerich en vertu d'une procuration «ad hoc» donnée
sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le représentant de la partie comparante et le notaire instrumentant, de-
meurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, ainsi représenté a requis le notaire soussigné d'acter qu'il se déclare être le seul et unique actionnaire
de la société anonyme «GO AHEAD S.A.», ayant son siège social à L-8826 Perlé, 1, rue de Holtz, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.908, constituée suivant acte reçu par Maître Roger
Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 13 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 49 du 8 janvier et dont les statuts ont été modifiés depuis.
Le comparant Monsieur Jean-Michel GURRET, représenté comme indiqué, a reconnu être pleinement informé des
résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social;
2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec
la résolution qui précède;
3. Mise en liquidation de la société;
4. Nomination d'un liquidateur;
5. Attribution des pouvoirs du liquidateur;
6. Divers.
Le comparant, représenté comme dit ci-avant, a ensuite requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à l'adresse suivante: L-1466
Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'actionnaire unique décide de modifier le
premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. (Premier alinéa). «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.».
<i>Troisième résolutioni>
L'actionnaire unique décide d'approuver les comptes de la Société datés du 31 décembre 2014.
<i>Quatrième résolutioni>
En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'actionnaire
unique décide de dissoudre la Société et de lancer la procédure de liquidation.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'actionnaire unique décide de nommer comme liquidateur (le «Liquidateur»):
Monsieur Jean-Michel GURRET, né le 28 novembre 1963 à Annecy (France) demeurant 99, route du Vin L-5405 Bech-
Kleinmacher
L'actionnaire unique accorde au Liquidateur les pouvoirs suivants:
80007
L
U X E M B O U R G
Le Liquidateur a comme mission de réaliser l'actif et le règlement du passif de la Société. Les actifs nets de la Société,
après paiement du passif, seront distribués en nature ou en espèces par le Liquidateur aux actionnaires de la Société.
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi. Il peut accomplir tous les
actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le Liquidateur peut payer une avance au surplus de la liquidation après avoir payé les dettes ou pris les dispositions
nécessaires pour le paiement des dettes de la Société.
Le Liquidateur peut lier la Société par sa seule signature. La Société pourra aussi être liée en toute circonstance par la
signature de quelque personne, dont le pouvoir de signature aura été délégué par le Liquidateur.
DONT ACTE, fait et passé à Rambrouch, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom,
prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Wurth, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 avril 2015. Relation: EAC/2015/9265. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2015.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2015070067/70.
(150079952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Gordon March S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 105.036.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015070068/9.
(150079619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Grace Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 184.877.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015070069/9.
(150080131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Poba Lux Holdco (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 64.390.818,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 189.111.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 6 mai 2015i>
En date du 6 mai 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Shi Young LEE de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet
au 8 mai 2015;
- de nommer Monsieur Jong Min KIM, né le 1
er
décembre 1966 à Séoul, République de Corée, ayant comme adresse
professionnelle: 10 F 23-10, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Séoul, République de Corée, en tant que nouveau gérant
de catégorie A de la Société avec effet au 8 mai 2015 et ce pour une durée indéterminée.
80008
L
U X E M B O U R G
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Jie-Uk LIMB, gérant de catégorie A
- Monsieur Jong Min KIM, gérant de catégorie A
- Monsieur Olivier HAMOU, gérant de catégorie B
- Madame Sonia BALDAN, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2015.
POBA LUX HOLDCO (LUXEMBOURG) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015070332/23.
(150080041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Grosvenor Retail European Properties II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 101.510.
<i>Extrait rectificatif sur dépôt numéro L110144688 du 7 septembre 2011i>
Le dépôt L110144688 du 7 septembre 2011 mentionne, entre autre, que M. Herman Moors, ayant pour adresse profes-
sionnelle 240, rue de Luxembourg, L-2324 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de la Société.
Or, il convient de modifier son adresse comme suit: 240, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2015.
Référence de publication: 2015070070/14.
(150079248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
GT Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.044.
Par résolutions signées en date du 28 avril 2015, l'associé unique a décidé de nommer Catiuscia Morciano, avec adresse
professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2015.
Référence de publication: 2015070071/13.
(150079680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Odyssey Opportunities 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 104.186,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 138.436.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of April.
Before the undersigned Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri
Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
THERE APPEARED
Software Luxembourg (Holdco 2) S.à r.l. (in liquidation), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing
under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under registration number
B 129183, having a share capital of GBP 900,495, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Maître Adrian Aldinger, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on 21 April 2015, and
80009
L
U X E M B O U R G
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Odyssey Opportunities 17 S.à r.l., a société à
responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under registration number B 138436, having a share capital of GBP 104,186 and its registered office at 7, rue
Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the “Company”), incorporated pursuant to a deed
of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 May 2008, and published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1363 on 3 June 2008. The articles of association were amended
for the last time on 21 January 2009 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°478 on 5 March 2009.
<i>Agendai>
1. Approval of the interim balance sheet dated 23 April 2015 as opening balance sheet of the liquidation;
2. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
3. Appointment of the liquidator;
4. Determination of the remuneration of the liquidator; and
5. Miscellaneous.
The appearing party representing the entire share capital and having waived its right to receive convening notices,
declares to have perfect knowledge of the agenda which was communicated in advance, and requires the notary to enact
the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the interim balance sheet dated 23 April 2015 as opening balance sheet of the
liquidation.
<i>Second Resolutioni>
In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”),
the Sole Shareholder of the Company resolves to dissolve and liquidate the Company.
<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder of the Company decides to appoint Exequtive
Partners S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under registration number B 174367, having its registered office at
48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as liquidator, of the Com-
pany (the “Liquidator”).
The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.
The Liquidator is hereby expressly empowered to execute all deeds and carry out all such acts as provided for by article
145 of the Law without requesting further authorisations of the general meeting or the Sole Shareholder.
The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.
The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realize all the Company’s assets on the best possible terms
and to pay all of its debts.
The Liquidator may distribute the Company’s assets to the Sole Shareholder in cash or in kind in its sole discretion.
Such distribution may take the form of advanced payments on future liquidation proceeds.
<i>Fourth Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the Liquidator’s remuneration as agreed among the parties concerned.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name, and
residence, the said proxyholder of the appearing person signed together with the notary this deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.
A COMPARU
80010
L
U X E M B O U R G
Software Luxembourg (Holdco 2) S.à r.l. (en cours de liquidation), une société à responsabilité limitée, constituée et
existant selon les lois du Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 129183, ayant un capital social de GBP 900.495, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ici représentée par Maître Adrian Aldinger, Rechtsanwalt, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privé donnée le 21 avril 2015,
Laquelle partie comparante est l’associé unique (l’«Associé Unique») d’Odyssey Opportunities 17 S.à r.l., une société
à responsabilité limitée, existant selon les lois du Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 138436, ayant un capital social de GBP 104,186 et ayant son siège social au 7A, rue
Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée selon acte reçu par Maître
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg en date du 6 mai 2008, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1363 en date 3 juin 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°478, en date du 5 mars 2009.
<i>Agendai>
1. Approbation du bilan intérimaire en date du 23 avril 2015 comme bilan d’ouverture de la liquidation;
2. Dissolution et Liquidation de la Société;
3. Nomination d’un liquidateur;
4. Détermination de la rémunération du liquidateur; et
5. Divers.
La partie comparante, représentant l’intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé à tout droit de convocation,
a déclaré avoir parfaite connaissance de l’ordre du jour qui a été communiquée à l’avance et a requis le notaire instrumentant
d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’approuver le bilan intérimaire en date du 23 avril 2015 comme bilan d’ouverture de la
liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
“Loi“), l’Associé Unique de la Société décide de dissoudre et de liquider la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’Associé Unique de la Société décide de nommer Exequtive Partners S.A.,
une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174367, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus tels que prévu aux articles 144 à 148bis de la Loi.
Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à exécuter et à accomplir tous les actes visés à l’article 145 de
la Loi sans devoir demander des autorisations supplémentaires à l’Associe Unique.
Le Liquidateur n’a pas à faire l’inventaire de la Société et peut se référer aux comptes de la Société.
La Société sera engagée à l’égard des tiers par la seule signature du Liquidateur.
L'Associé Unique décide de charger le Liquidateur de liquider tous les actifs de la société dans les meilleures conditions
possibles et de payer toutes ses dettes.
Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l’Associé Unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.
Cette distribution pourra prendre la forme d’une avance sur le boni de liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé unique a décidé que le Liquidateur percevra une compensation telle que déterminée par les parties concernées.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de cette même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. ALDINGER et C. WERSANDT.
80011
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/13526. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 7 mai 2015.
Référence de publication: 2015070289/125.
(150080270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
H.N.L. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 644.250,00.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 38.888.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique, en date du 21 avril 2015:i>
- acceptation de la démission de Monsieur Ingor Meuleman de son poste de gérant, avec effet au 21 avril 2015;
- transfert du siège social de la société au 76, route de Thionville, L-2610 Luxembourg, à compter du 27 avril 2015;
- nomination de Madame Catherine Zoller, administrateur de société, née à Arlon (Belgique) le 08 avril 1967, résidant
professionnellement au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg, comme nouveau gérant de la société pour une durée
indéterminée;
- constatation du changement d'adresse professionnelle des autres gérants, Messieurs Marc Schintgen, Monsieur Michal
Wittmann et Madame Stéphanie Marion, qui résident désormais au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015070074/16.
(150080048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Ham Investment Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 147.320.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015070075/9.
(150079293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Hanau Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 117.593.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015070076/9.
(150079332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Henderson European Retail Property Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 112.143.
<i>Extrait d'une décision prise par les Associés de la Société en date du 6 mai 2015i>
Les Associés de la Société décident de nommer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ayant son siège social
au 2 rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B65 477, comme Réviseur d'entreprises agréé jusqu'à
l'Assemblée générale ordinaire des Associés qui aura à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2015.
Référence de publication: 2015070079/14.
(150079340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
80012
L
U X E M B O U R G
Herald Bramsche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 123.894.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015070082/9.
(150079330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Herald Lux Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Gasperich, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 114.434.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015070083/9.
(150079331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Wert RSR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 175.410.
Il résulte d'une convention de cession entre l'actuel associé unique de la Société (l'Associé Unique) Värde Investment
Partners L.P., «a Delaware limited partnership», ayant son siège social au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover 19904,
County of Kent, Delaware, United States of America, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro 3462095, et Wert Investment Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.726, que l'Associé Unique a cédé l'intégralité de ses parts sociales (soit
12.500 parts sociales) dans le capital de la Société, à Wert Investment Holdings S.à r.l., avec effet au 29 avril 2015.
En conséquence de ce qui précède, Wert Investment Holdings S.à r.l. est l'associé unique de la Société depuis le 29 avril
2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
Wert RSR S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015070502/22.
(150079174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Hollux Horizon S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 171.922.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015070085/9.
(150080145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Hydrogenious Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 180.295.
Les statuts coordonnés au 17 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
80013
L
U X E M B O U R G
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015070086/11.
(150080054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Hamira SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 11a, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 156.625.
Les comptes annuels au 30.06.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HAMIRA S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015070087/11.
(150080052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
HDR Trading & Consulting S.A., Société Anonyme,
(anc. Consulting HDR + Partner S.A.).
Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.
R.C.S. Luxembourg B 82.439.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 09 mai 2015.
Référence de publication: 2015070090/10.
(150079821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Hôtel des Vignes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5552 Remich, 29, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 20.268.
Conformément à la signification d'une cession de parts du 29 août 2003, Madame Cécile OSWALD, gérante de la société
susmentionnée déclare que:
Feu Monsieur Pierre SCHREDER, ayant demeuré à B-6750 SIGNELUX, 109, rue de Lorraine, a cédé de son vivant 5
parts sociales qu'il détenait dans la société susmentionnée à Monsieur Jacques SCHREDER, demeurant à B-6700 ARLON,
58, rue Sonnetty.
Remich, le 7 mai 2015.
Référence de publication: 2015070100/13.
(150080117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
HEPP III Luxembourg FRHB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 139.900.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015070092/10.
(150079878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
80014
L
U X E M B O U R G
Hifi-Participations-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 131, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 42.749.
EXTRAIT
Par décision en date du 8 mai 2015, le Conseil d'Administration de la société HIFI-PARTICIPATIONS-SPF a décidé
de transférer le siège social de la société de L-1511 Luxembourg, 121 Avenue de la Faïencerie à L-1741 Luxembourg, 131,
rue de Hollerich.
L'adresse du commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée INTERAUDIT est dorénavant à L-2529
Howald, 37 rue des Scillas.
Howald.
Signature.
Référence de publication: 2015070093/14.
(150080029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Horizont Immobilien S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 112.142.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 23 mars 2015i>
Le Conseil d'administration a nommé Orangefield (Luxembourg) S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à
L-2163 Luxembourg, agent dépositaire des actions au porteur de la société.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015070096/14.
(150079964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Intelligent Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 104.890.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 7 mai 2015i>
1. M. Mark GORHOLT a démissionné de son mandat de gérant, avec effet au 14 janvier 2015.
2. La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES SARL, avec un capital de EUR
12.500,-, enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B64474 et ayant son siège social au L-2453 Luxembourg, 6,
Rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérante, pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour INTELLIGENT ENGINEERING S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015070124/16.
(150079867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
IMC Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 147.502.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015070119/10.
(150079153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
80015
L
U X E M B O U R G
Rudel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 81.967.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015070371/10.
(150079157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Rudel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 81.967.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015070372/10.
(150079158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Ryan Express SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 24, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 103.834.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015070374/10.
(150080152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Sabatelli 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 177.319.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015070380/10.
(150079944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Saddle Luxco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 185.017.
Les statuts coordonnés au 19 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015070381/11.
(150080133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
80016
Consulting HDR + Partner S.A.
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l.
Frontiers Capital Mongolia
Galerie Commerciale de Kirchberg
Gambit Luxembourg S.à r.l.
Garage Pepin sàrl
Garantidata International S.A.
Gastina Equity S.A.
GDS S.à r.l.
Gefip Euroland
Gelustok SA
GFM (CE) S.A.
Global Management & Services S.A.
Global Offshore S.A.
Global Trust Advisors S.A.
Global Ventures S.A.
Globoaves Finance S.A.
Go Ahead SA
Gordon March S.A.
Grace Properties S.à r.l.
Grosvenor Retail European Properties II S.à r.l.
GT Investments S.à r.l.
Gurkha S.à r.l.
Ham Investment Corporation S.à r.l.
Hamira SA
Hanau Luxembourg S.à r.l.
HDR Trading & Consulting S.A.
Henderson European Retail Property Fund Management S.à r.l.
HEPP III Luxembourg FRHB S.à r.l.
Herald Bramsche S.à r.l.
Herald Lux Finance S.à r.l.
Hifi-Participations-SPF
H.N.L. S.à r.l.
Hollux Horizon S.A.
Horizont Immobilien S.A.
Hôtel des Vignes S.à r.l.
Hugo Insurance S.A.
Hydrogenious Holdings
IMC Asset Management Luxembourg S.A.
Immoreal DE 2
Intelligent Engineering S.à r.l.
KBL European Private Bankers S.A.
Luxembourg Contact Centers S.à r.l.
Munich LBS 160 S.àr.l.
NDG Group S.A.
Odyssey Opportunities 17 S.à r.l.
Poba Lux Holdco (Luxembourg) S.à r.l.
Rudel Investments S.à r.l.
Rudel Investments S.à r.l.
Ryan Express SA
Sabatelli 3 S.à r.l.
Saddle Luxco Holding S.à r.l.
Spring Capital
Wert RSR S.à r.l.