This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1653
3 juillet 2015
SOMMAIRE
Helena 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79298
Helena 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79298
HHS Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79298
HV Portobello Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79298
Ican Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79309
IH Baseholding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79311
ILP II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79309
Immobilière Pierre Weydert S.A. . . . . . . . . . .
79298
Inazuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79311
Independent Star Venture . . . . . . . . . . . . . . . .
79299
Independent Star Venture . . . . . . . . . . . . . . . .
79299
Infracapital F1 Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
79299
Infris S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79308
Inspirit Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
79312
Interactive Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
79312
International Credit Mutuel Life . . . . . . . . . . .
79312
International Credit Mutuel Life . . . . . . . . . . .
79314
International Purchase & Rental Services
(IPRS) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79315
Iphias Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79315
Iwerall Direkt Emmer Exact . . . . . . . . . . . . . .
79309
Jacmar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79316
Jata SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79317
Java International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
79319
John Deere Holding Brazil S.à r.l. . . . . . . . . . .
79315
John Deere Holding Canada S.à r.l. . . . . . . . .
79316
John Deere Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
79316
John Deere Luxembourg Investment S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79316
K Agamemnon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79320
K-Buchs S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79320
Keystone Developers S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
79344
Kyarra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79315
Lamudi Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79320
Luxfrost S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79344
M.A. Topaz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79312
Merwood Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
79344
Merwood Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
79344
Minotaur S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79344
Praom-Tarantino S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79319
Saddle Luxco Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
79300
79297
L
U X E M B O U R G
Helena 1, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 111.053.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2015069388/11.
(150079103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Helena 2, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 111.054.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2015069389/11.
(150079092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
HHS Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 149.232.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015069391/9.
(150078526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
HV Portobello Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 21.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 196.527.
Le nom de Jeffrey R. Keay, gérant de classe A de la Société, a été Incorrectement orthographié lors de son inscription
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Il convient en conséquence de remplacer l'inscription
Jeff Jeay par Jeffrey R. Keay.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HV Portobello SARL
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015069395/14.
(150078423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Immobilière Pierre Weydert S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer.
R.C.S. Luxembourg B 127.107.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015069397/9.
(150078818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
79298
L
U X E M B O U R G
Independent Star Venture, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 294.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 186.763.
La Société a été constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à
Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 1800 du 10 juillet 2014.
Les comptes annuels de la Société pour la période du 30 avril 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2014 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Indenpendent Star Venture
Signature
Référence de publication: 2015069398/15.
(150078480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Independent Star Venture, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 294.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 186.763.
La Société a été constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à
Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 1800 du 10 juillet 2014.
Les comptes consolidés de la Société pour la période du 30 avril 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2014 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Independent Star Venture
Signature
Référence de publication: 2015069399/15.
(150078481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Infracapital F1 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 152.866.
<i>Cession de parts daté du 22 avril 2015i>
Nouvel actionnaire: Infracapital Partners LP, une société en commandite simple, ayant son siège social à Laurence
Pountney Hill, EC4R OHH Londres (Royaume-Uni), enregistrée auprès des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles
sous le numéro LP010696.
Ancien Actionnaire: Infracapital Nominees Limited, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Lau-
rence Pountney Hill, EC4R OHH Londres (Royaume-Uni), enregistré auprès du registre des Sociétés d'Angleterre et du
Pays de Galles sous le numéro 05456531.
Luxembourg, le 7 mai 2015.
Pour avis sincère et conforme
Infracapital F1 Holdings S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015069402/18.
(150078510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
79299
L
U X E M B O U R G
Saddle Luxco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 185.017.
<i>Rectificatif du dépôt L140196135 fait le 5 novembre 2014i>
In the year two thousand and fifteen,
on the nineteenth day of March, before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of
Luxembourg,
there appeared
Maître Catherine Kremer, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
as proxyholder of
(i) TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with its registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143926 (“Triton Masterluxco 3
S.à r.l.”); and
(ii) TFF III Limited, a limited liability company governed by the laws of Jersey, having its registered office at Charter
Place, 23-27 Seaton Place, St Helier, Jersey, Channel Islands, registered with the Companies Registry at the Jersey Financial
Services Commission under number 101339, acting as general partner of Triton Fund III F&F L.P., a limited partnership
governed by the laws of Jersey, having its registered office at Charter Place, 23-27 Seaton Place, St Helier, Jersey, Channel
Islands, registered with the Companies Registry at the Jersey Financial Services Commission under number 1079 (“Triton
Fund III F&F L.P.” and, together with Triton Masterluxco 3 S.à r.l., the “Shareholders”),
being the Shareholders of Saddle Luxco Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of
Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred two euro (EUR 12,502.-), with registered office at
2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed
dated 21 February 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1165 of 8 May 2014
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 185017 (the "Company").
The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Marc Loesch,
notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, of 10 October 2014, recorded with the Bureau de
l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, Actes Civils of Remich on 15 October 2014 under the reference
REM/2014/2257 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3591 of 27 November
2014 (the “Notarial Deed”),
by virtue of proxies under private seal given by Triton Masterluxco 3 S.à r.l. on 8 October 2014 and by Triton Fund III
F&F L.P. on 9 October 2014, which remained attached to the Notarial Deed.
The appearing person, acting in its above stated capacity, has requested the undersigned notary to record its declarations
and statements as follows:
- that a clerical error appears in the Notarial Deed;
- that the Company should have issued ten (10) new class A1 shares, ten (10) new class A2 shares, ten (10) new class
A3 shares, ten (10) new class A4 shares, ten (10) new class A5 shares, ten (10) new class A6 shares, ten (10) new class A7
shares, ten (10) new class A8 shares, ten (10) new class A9 shares, ten (10) new class A10 shares, ten (10) new class B1
shares, ten (10) new class B2 shares, ten (10) new class B3 shares, ten (10) new class B4 shares, ten (10) new class B5
shares, ten (10) new class B6 shares, ten (10) new class B7 shares, ten (10) new class B8 shares, ten (10) new class B9
shares and ten (10) new class B10 shares instead of one (1) new class A1 share, one (1) new class A2 share, one (1) new
class A3 share, one (1) new class A4 share, one (1) new class A5 share, one (1) new class A6 share, one (1) new class A7
share, one (1) new class A8 share, one (1) new class A9 share, one (1) new class A10 share, one (1) new class B1 share,
one (1) new class B2 share, one (1) new class B3 share, one (1) new class B4 share, one (1) new class B5 share, one (1)
new class B6 share, one (1) new class B7 share, one (1) new class B8 share, one (1) new class B9 share and one (1) new
class B10 share, each with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01);
- that accordingly the second resolution (English version) of the Notarial Deed shall henceforth read as follows:
“The general meeting of shareholders resolved to issue ten (10) new class A1 shares, ten (10) new class A2 shares, ten
(10) new class A3 shares, ten (10) new class A4 shares, ten (10) new class A5 shares, ten (10) new class A6 shares, ten
(10) new class A7 shares, ten (10) new class A8 shares, ten (10) new class A9 shares, ten (10) new class A10 shares, ten
(10) new class B1 shares, ten (10) new class B2 shares, ten (10) new class B3 shares, ten (10) new class B4 shares, ten (10)
new class B5 shares, ten (10) new class B6 shares, ten (10) new class B7 shares, ten (10) new class B8 shares, ten (10) new
class B9 shares and ten (10) new class B10 shares, each with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), having the
same rights and privileges as the existing shares.
79300
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared:
(i) TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with its registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143926 (hereafter referred as to
the “Subscriber 1”), hereby represented by Maître Catherine Kremer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
under private seal given on 8 October 2014;
The Subscriber 1 declared to subscribe to ten (10) new class A1 shares, ten (10) new class A2 shares, ten (10) new class
A3 shares, ten (10) new class A4 shares, ten (10) new class A5 shares, ten (10) new class A6 shares, ten (10) new class A7
shares, ten (10) new class A8 shares, ten (10) new class A9 shares and ten (10) new class A10 shares, each with a nominal
value of one euro cent (EUR 0.01), and to make full payment in cash for such new shares together with the payment of a
share premium in an amount of six million four hundred thirty thousand nine hundred ninety-nine euro and (EUR
6,430,999.-),
(ii) Triton Fund III F&F L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey, having its registered office at Charter
Place, 23-27 Seaton Place, St Helier, Jersey, Channel Islands, registered with the Companies Registry at the Jersey Financial
Services Commission under number 1079 (hereafter referred as to the “Subscriber 2”), hereby represented by Maître
Catherine Kremer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given on 9 October 2014;
The Subscriber 2 declared to subscribe to ten (10) new class B1 shares, ten (10) new class B2 shares, ten (10) new class
B3 shares, ten (10) new class B4 shares, ten (10) new class B5 shares, ten (10) new class B6 shares, ten (10) new class B7
shares, ten (10) new class B8 shares, ten (10) new class B9 shares and ten (10) new class B10 shares, each with a nominal
value of one euro cent (EUR 0.01), and to make full payment in cash for such new shares.
The amount of six million four hundred thirty-one thousand one euro (EUR 6,431,001.-) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.”;
- that accordingly the fourth resolution (English version) of the Notarial Deed shall henceforth read as follows:
“The general meeting of shareholders resolved to amend the 1
st
paragraph of article 5 of the articles of incorporation
of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
“The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred two euro (EUR 12,502.-) divided into:
- six hundred twenty thousand five hundred ten (620,510) A1 shares (the “A1 Shares”) with a nominal value of one euro
cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- six hundred twenty thousand five hundred ten (620,510) B1 shares (the “B1 Shares”) with a nominal value of one euro
cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A2 shares (the “A2 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B2 shares (the “B2 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A3 shares (the “A3 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B3 shares (the “B3 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A4 shares (the “A4 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B4 shares (the “B4 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A5 shares (the “A5 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B5 shares (the “B5 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A6 shares (the “A6 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B6 shares (the “B6 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A7 shares (the “A7 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B7 shares (the “B7 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A8 shares (the “A8 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
79301
L
U X E M B O U R G
- five hundred ten (510) B8 shares (the “B8 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A9 shares (the “A9 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B9 shares (the “B9 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A10 shares (the “A10 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B10 shares (the “B10 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
The A1 Shares, A2 Shares, A3 Shares, A4 Shares, A5 Shares, A6 Shares, A7 Shares, A8 Shares A9 Shares, and A10
Shares shall together be referred to as the “A Shares”.
The B1 Shares, B2 Shares, B3 Shares, B4 Shares, B5 Shares, B6 Shares, B7 Shares, B8 Shares B9 Shares, and B10
Shares shall together be referred to as the “B Shares” and together with the A Shares, the “Shares” and each a “Share”.
The A1 Shares and B1 Shares shall together be referred to as the “Class 1 Shares”.
The A2 Shares and B2 Shares shall together be referred to as the “Class 2 Shares”.
The A3 Shares and B3 Shares shall together be referred to as the “Class 3 Shares”.
The A4 Shares and B4 Shares shall together be referred to as the “Class 4 Shares”.
The A5 Shares and B5 Shares shall together be referred to as the “Class 5 Shares”.
The A6 Shares and B6 Shares shall together be referred to as the “Class 6 Shares”.
The A7 Shares and B7 Shares shall together be referred to as the “Class 7 Shares”.
The A8 Shares and B8 Shares shall together be referred to as the “Class 8 Shares”.
The A9 Shares and B9 Shares shall together be referred to as the “Class 9 Shares”.
The A10 Shares and B10 Shares shall together be referred to as the “Class 10 Shares”.
The Class 1 Shares, the Class 2 Shares, the Class 3 Shares, the Class 4 Shares, the Class 5 Shares, the Class 6 Shares,
the Class 7 Shares, the Class 8 Shares, the Class 9 Shares and the Class 10 Shares shall together be referred to as the “Classes
of Shares” and each a “Class of Shares”.”;
- that accordingly the second resolution (French version) of the Notarial Deed shall henceforth read as follows:
“L'assemblée générale des associés a décidé d'émettre dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A1, dix (10) nou-
velles parts sociales de catégorie A2, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A3, dix (10) nouvelles parts sociales
de catégorie A4, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A5, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A6, dix
(10) nouvelles parts sociales de catégorie A7, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A8, dix (10) nouvelles parts
sociales de catégorie A9, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A10, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie
B1, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B2, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B3, dix (10) nouvelles
parts sociales de catégorie B4, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B5, dix (10) nouvelles parts sociales B6, dix
(10) nouvelles parts sociales de catégorie B7, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B8, dix (10) nouvelles parts
sociales de catégorie B9 et dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B10, ayant une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant respectivement les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.»
<i>Souscription - Paiementi>
Ont ensuite comparu:
(i) TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143926 (ci-après définie comme étant le «Souscripteur 1»),
représentée aux fins des présentes par Me Catherine Kremer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procu-
ration sous seing privé donnée le 8 octobre 2014.
Le Souscripteur 1 a déclaré souscrire dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A1, dix (10) nouvelles parts sociales
de catégorie A2, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A3, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A4, dix
(10) nouvelles parts sociales de catégorie A5, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A6, dix (10) nouvelles parts
sociales de catégorie A7, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A8, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie
A9 et dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A10, d'une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01) chacune,
et libérer intégralement, en espèces, ces parts sociales avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de six millions
quatre cent trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 6.430.999,-),
(ii) Triton Fund III F&F L.P., une société en commandite ayant son siège social au Charter Place, 23-27 Seaton Place,
St. Hélier, Jersey, Îles Anglo- Normandes, inscrite au Registre des Sociétés de la Commission des Services Financiers de
Jersey sous le numéro 1079 (ci-après définie comme étant le «Souscripteur 2»), représentée aux fins des présentes par Me
Catherine Kremer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 9 octobre
2014.
79302
L
U X E M B O U R G
Le Souscripteur 2 a déclaré souscrire dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B1, dix (10) nouvelles parts sociales
de catégorie B2, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B3, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B4, dix
(10) nouvelles parts sociales de catégorie B5, dix (10) nouvelles parts sociales B6, dix (10) nouvelles parts sociales de
catégorie B7, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B8, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B9 et dix (10)
nouvelles parts sociales de catégorie B10, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et libérer inté-
gralement, en espèces, ces parts sociales.
Le montant de six millions quatre cent trente-et-un mille un euros (EUR 6.431.001,-) a dès lors été à la disposition de
la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.”; and
- that accordingly the fourth resolution (French version) of the Notarial Deed shall henceforth read as follows:
“L'assemblée générale des associés a décidé de modifier le 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter
les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cent deux euros (EUR 12.502,-) divisé en:
- six cent vingt mille cinq cent dix (620.510) parts sociales A1 (les «Parts Sociales A1») ayant une valeur nominale d'un
centime d'euro (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- six cent vingt mille cinq cent dix (620.510) parts sociales B1 (les «Parts Sociales B1») ayant une valeur nominale d'un
centime d'euro (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A2 (les «Parts Sociales A2») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B2 (les «Parts Sociales B2») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A3 (les «Parts Sociales A3») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B3 (les «Parts Sociales B3») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A4 (les «Parts Sociales A4») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B4 (les «Parts Sociales B4») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A5 (les «Parts Sociales A5») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B5 (les «Parts Sociales B5») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A6 (les «Parts Sociales A6») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B6 (les «Parts Sociales B6») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A7 (les «Parts Sociales A7») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B7 (les «Parts Sociales B7») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A8 (les «Parts Sociales A8») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B8 (les «Parts Sociales B8») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A9 (les «Parts Sociales A9») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B9 (les «Parts Sociales B9») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A10 (les «Parts Sociales A10») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B10 (les «Parts Sociales B10») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées.
Les Parts Sociales A1, les Parts Sociales A2, les Parts Sociales A3, les Parts Sociales A4, les Parts Sociales A5, les Parts
Sociales A6, les Parts Sociales A7, les Parts Sociales A8, les Parts Sociales A9, et les Parts Sociales A10 sont ensemble
désignées les «Parts Sociales A».
79303
L
U X E M B O U R G
Les Parts Sociales B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales A4, les Parts Sociales B5, les Parts
Sociales B6, les Parts Sociales B7, les Parts Sociales B8, les Parts Sociales B9, et les Parts Sociales B10 sont ensemble
désignées les «Parts Sociales B» et ensemble avec les Parts Sociales A, les «Parts Sociales» et chacune une «Part Sociale».
Les Parts Sociales A1 et les Parts Sociales B1 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 1».
Les Parts Sociales A2 et les Parts Sociales B2 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 2».
Les Parts Sociales A3 et les Parts Sociales B3 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 3».
Les Parts Sociales A4 et les Parts Sociales B4 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 4».
Les Parts Sociales A5 et les Parts Sociales B5 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 5».
Les Parts Sociales A6 et les Parts Sociales B6 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 6».
Les Parts Sociales A7 et les Parts Sociales B7 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 7».
Les Parts Sociales A8 et les Parts Sociales B8 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 8».
Les Parts Sociales A9 et les Parts Sociales B9 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 9».
Les Parts Sociales A10 et les Parts Sociales B10 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 10».
Les Parts Sociales des Catégorie 1, les Parts Sociales des Catégorie 2, les Parts Sociales des Catégorie 3, les Parts Sociales
des Catégorie 4, les Parts Sociales des Catégorie 5, les Parts Sociales des Catégorie 6, les Parts Sociales des Catégorie 7,
les Parts Sociales des Catégorie 8, les Parts Sociales des Catégorie 9, et les Parts Sociales des Catégorie 10 sont ensemble
désignées les «Catégories de Parts Sociales» et chacune une «Catégorie de Parts Sociales».”
The appearing person, acting in its above stated capacity, declared that all other articles and clauses of the Notarial Deed
remain unchanged and he has required the notary to mention the present rectification wherever necessary.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person who is known to the notary by its surname first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois de mars,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Maître Catherine Kremer, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de
(i) TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143926 («Triton Masterluxco 3 S.à r.l.»); et
(ii) TFF III Limited, une société à responsabilité limitée régie par les lois de Jersey, ayant son siège social au Charter
Place, 23-27 Seaton Place, St. Hélier, Jersey, Îles Anglo-Normandes, inscrite au Registre des Sociétés de la Commission
des Services Financiers de Jersey sous le numéro 101339, agissant en sa capacité d'associé commandité de Triton Fund III
F&F L.P., une société en commandite ayant son siège social au Charter Place, 23-27 Seaton Place, St. Hélier, Jersey, Îles
Anglo-Normandes, inscrite au Registre des Sociétés de la Commission des Services Financiers de Jersey sous le numéro
1079 («Triton Fund III F&F L.P.» et, ensemble avec Triton Masterluxco 3 S.à r.l., les «Associés»),
étant les Associés de Saddle Luxco Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois,
ayant un capital social de douze mille cinq cent deux euros (EUR 12.502), ayant son siège social 2C, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié du 21 février 2014, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1165, du 8 mai 2014 et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185017 (la “Société”). Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois
par un acte de Maître Marc Loesch, notaire résidant à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10
octobre 2014, enregistré au Bureau de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, Actes Civils de Remich en
date du 15 octobre 2014 sous la référence REM/2014/2257, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 3591 du 27 novembre 2014 (l'«Acte Notarié»),
aux termes de procurations données sous seing privé le 8 octobre 2014 par Triton Masterluxco 3 S.à r.l. et le 9 octobre
2014 par Triton Fund III F&F L.P., qui sont restées annexées à l'Acte Notarié.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu'il suit ses décla-
rations et constatations,
- qu'une erreur de plume s'est glissée dans l'Acte Notarié;
- que la Société aurait dû émettre dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A1, dix (10) nouvelles parts sociales de
catégorie A2, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A3, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A4, dix (10)
nouvelles parts sociales de catégorie A5, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A6, dix (10) nouvelles parts sociales
de catégorie A7, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A8, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A9, dix
(10) nouvelles parts sociales de catégorie A10, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B1, dix (10) nouvelles parts
79304
L
U X E M B O U R G
sociales de catégorie B2, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B3, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie
B4, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B5, dix (10) nouvelles parts sociales B6, dix (10) nouvelles parts sociales
de catégorie B7, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B8, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B9 et dix
(10) nouvelles parts sociales de catégorie B10, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;
- qu'en conséquence la deuxième résolution (version anglaise) dudit Acte Notarié doit désormais se lire comme suit:
«The general meeting of shareholders resolved to issue ten (10) new class A1 shares, ten (10) new class A2 shares, ten
(10) new class A3 shares, ten (10) new class A4 shares, ten (10) new class A5 shares, ten (10) new class A6 shares, ten
(10) new class A7 shares, ten (10) new class A8 shares, ten (10) new class A9 shares, ten (10) new class A10 shares, ten
(10) new class B1 shares, ten (10) new class B2 shares, ten (10) new class B3 shares, ten (10) new class B4 shares, ten (10)
new class B5 shares, ten (10) new class B6 shares, ten (10) new class B7 shares, ten (10) new class B8 shares, ten (10) new
class B9 shares and ten (10) new class B10 shares, each with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), having the
same rights and privileges as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared:
(i) TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with its registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143926 (hereafter referred as to
the “Subscriber 1”), hereby represented by Maître Catherine Kremer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
under private seal given on 8 October 2014;
The Subscriber 1 declared to subscribe to ten (10) new class A1 shares, ten (10) new class A2 shares, ten (10) new class
A3 shares, ten (10) new class A4 shares, ten (10) new class A5 shares, ten (10) new class A6 shares, ten (10) new class A7
shares, ten (10) new class A8 shares, ten (10) new class A9 shares and ten (10) new class A10 shares, each with a nominal
value of one euro cent (EUR 0.01), and to make full payment in cash for such new shares together with the payment of a
share premium in an amount of six million four hundred thirty thousand nine hundred ninety-nine euro (EUR 6,430,999.-),
(ii) Triton Fund III F&F L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey, having its registered office at Charter
Place, 23-27 Seaton Place, St Helier, Jersey, Channel Islands, registered with the Companies Registry at the Jersey Financial
Services Commission under number 1079 (hereafter referred as to the “Subscriber 2”), hereby represented by Maître
Catherine Kremer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given on 9 October 2014;
The Subscriber 2 declared to subscribe to ten (10) new class B1 shares, ten (10) new class B2 shares, ten (10) new class
B3 shares, ten (10) new class B4 shares, ten (10) new class B5 shares, ten (10) new class B6 shares, ten (10) new class B7
shares, ten (10) new class B8 shares, ten (10) new class B9 shares and ten (10) new class B10 shares, each with a nominal
value of one (1) euro cent (EUR 0.01), and to make full payment in cash for such new shares.
The amount of six million four hundred thirty-one thousand one euro (EUR 6,431,001.-) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.»;
- qu'en conséquence la quatrième résolution (version anglaise) dudit Acte Notarié doit désormais se lire comme suit:
«The general meeting of shareholders resolved to amend the 1
st
paragraph of article 5 of the articles of incorporation
of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
“The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred two euro (EUR 12,502.-) divided into:
- six hundred twenty thousand five hundred ten (620,510) A1 shares (the “A1 Shares”) with a nominal value of one euro
cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- six hundred twenty thousand five hundred ten (620,510) B1 shares (the “B1 Shares”) with a nominal value of one euro
cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A2 shares (the “A2 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B2 shares (the “B2 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A3 shares (the “A3 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B3 shares (the “B3 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A4 shares (the “A4 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B4 shares (the “B4 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A5 shares (the “A5 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
79305
L
U X E M B O U R G
- five hundred ten (510) B5 shares (the “B5 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A6 shares (the “A6 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B6 shares (the “B6 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A7 shares (the “A7 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B7 shares (the “B7 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A8 shares (the “A8 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B8 shares (the “B8 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A9 shares (the “A9 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B9 shares (the “B9 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) A10 shares (the “A10 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
- five hundred ten (510) B10 shares (the “B10 Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all
subscribed and fully paid up;
The A1 Shares, A2 Shares, A3 Shares, A4 Shares, A5 Shares, A6 Shares, A7 Shares, A8 Shares A9 Shares, and A10
Shares shall together be referred to as the “A Shares”.
The B1 Shares, B2 Shares, B3 Shares, B4 Shares, B5 Shares, B6 Shares, B7 Shares, B8 Shares B9 Shares, and B10
Shares shall together be referred to as the “B Shares” and together with the A Shares, the “Shares” and each a “Share”.
The A1 Shares and B1 Shares shall together be referred to as the “Class 1 Shares”.
The A2 Shares and B2 Shares shall together be referred to as the “Class 2 Shares”.
The A3 Shares and B3 Shares shall together be referred to as the “Class 3 Shares”.
The A4 Shares and B4 Shares shall together be referred to as the “Class 4 Shares”.
The A5 Shares and B5 Shares shall together be referred to as the “Class 5 Shares”.
The A6 Shares and B6 Shares shall together be referred to as the “Class 6 Shares”.
The A7 Shares and B7 Shares shall together be referred to as the “Class 7 Shares”.
The A8 Shares and B8 Shares shall together be referred to as the “Class 8 Shares”.
The A9 Shares and B9 Shares shall together be referred to as the “Class 9 Shares”.
The A10 Shares and B10 Shares shall together be referred to as the “Class 10 Shares”.
The Class 1 Shares, the Class 2 Shares, the Class 3 Shares, the Class 4 Shares, the Class 5 Shares, the Class 6 Shares,
the Class 7 Shares, the Class 8 Shares, the Class 9 Shares and the Class 10 Shares shall together be referred to as the “Classes
of Shares” and each a “Class of Shares”.»;
- qu'en conséquence la deuxième résolution (version française) dudit Acte Notarié doit désormais se lire comme suit:
«L'assemblée générale des associés a décidé d'émettre dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A1, dix (10) nou-
velles parts sociales de catégorie A2, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A3, dix (10) nouvelles parts sociales
de catégorie A4, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A5, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A6, dix
(10) nouvelles parts sociales de catégorie A7, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A8, dix (10) nouvelles parts
sociales de catégorie A9, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A10, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie
B1, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B2, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B3, dix (10) nouvelles
parts sociales de catégorie B4, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B5, dix (10) nouvelles parts sociales B6, dix
(10) nouvelles parts sociales de catégorie B7, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B8, dix (10) nouvelles parts
sociales de catégorie B9 et dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B10, ayant une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant respectivement les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.»
<i>Souscription - Paiementi>
Ont ensuite comparu:
(i) TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143926 (ci-après définie comme étant le «Souscripteur 1»),
79306
L
U X E M B O U R G
représentée aux fins des présentes par Me Catherine Kremer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procu-
ration sous seing privé donnée le 8 octobre 2014.
Le Souscripteur 1 a déclaré souscrire dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A1, dix (10) nouvelles parts sociales
de catégorie A2, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A3, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A4, dix
(10) nouvelles parts sociales de catégorie A5, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A6, dix (10) nouvelles parts
sociales de catégorie A7, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A8, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie
A9 et dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie A10, d'une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01) chacune,
et libérer intégralement, en espèces, ces parts sociales avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de six millions
quatre cent trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 6.430.999,-),
(ii) Triton Fund III F&F L.P., une société en commandite ayant son siège social au Charter Place, 23-27 Seaton Place,
St. Hélier, Jersey, Îles Anglo- Normandes, inscrite au Registre des Sociétés de la Commission des Services Financiers de
Jersey sous le numéro 1079 (ci-après définie comme étant le «Souscripteur 2»), représentée aux fins des présentes par Me
Catherine Kremer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 9 octobre
2014.
Le Souscripteur 2 a déclaré souscrire dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B1, dix (10) nouvelles parts sociales
de catégorie B2, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B3, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B4, dix
(10) nouvelles parts sociales de catégorie B5, dix (10) nouvelles parts sociales B6, dix (10) nouvelles parts sociales de
catégorie B7, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B8, dix (10) nouvelles parts sociales de catégorie B9 et dix (10)
nouvelles parts sociales de catégorie B10, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et libérer inté-
gralement, en espèces, ces parts sociales.
Le montant de six millions quatre cent trente-et-un mille un euros (EUR 6.431.001,-) a dès lors été à la disposition de
la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.»; et
- qu'en conséquence la quatrième résolution (version française) dudit Acte Notarié doit désormais se lire comme suit:
«L'assemblée générale des associés a décidé de modifier le 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter
les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cent deux euros (EUR 12.502,-) divisé en:
- six cent vingt mille cinq cent dix (620.510) parts sociales A1 (les «Parts Sociales A1») ayant une valeur nominale d'un
centime d'euro (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- six cent vingt mille cinq cent dix (620.510) parts sociales B1 (les «Parts Sociales B1») ayant une valeur nominale d'un
centime d'euro (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A2 (les «Parts Sociales A2») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B2 (les «Parts Sociales B2») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A3 (les «Parts Sociales A3») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B3 (les «Parts Sociales B3») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A4 (les «Parts Sociales A4») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B4 (les «Parts Sociales B4») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A5 (les «Parts Sociales A5») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B5 (les «Parts Sociales B5») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A6 (les «Parts Sociales A6») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B6 (les «Parts Sociales B6») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A7 (les «Parts Sociales A7») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B7 (les «Parts Sociales B7») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A8 (les «Parts Sociales A8») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B8 (les «Parts Sociales B8») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
79307
L
U X E M B O U R G
- cinq cent dix (510) parts sociales A9 (les «Parts Sociales A9») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B9 (les «Parts Sociales B9») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales A10 (les «Parts Sociales A10») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées;
- cinq cent dix (510) parts sociales B10 (les «Parts Sociales B10») ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, toutes entièrement libérées.
Les Parts Sociales A1, les Parts Sociales A2, les Parts Sociales A3, les Parts Sociales A4, les Parts Sociales A5, les Parts
Sociales A6, les Parts Sociales A7, les Parts Sociales A8, les Parts Sociales A9, et les Parts Sociales A10 sont ensemble
désignées les «Parts Sociales A».
Les Parts Sociales B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales A4, les Parts Sociales B5, les Parts
Sociales B6, les Parts Sociales B7, les Parts Sociales B8, les Parts Sociales B9, et les Parts Sociales B10 sont ensemble
désignées les «Parts Sociales B» et ensemble avec les Parts Sociales A, les «Parts Sociales» et chacune une «Part Sociale».
Les Parts Sociales A1 et les Parts Sociales B1 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 1».
Les Parts Sociales A2 et les Parts Sociales B2 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 2».
Les Parts Sociales A3 et les Parts Sociales B3 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 3».
Les Parts Sociales A4 et les Parts Sociales B4 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 4».
Les Parts Sociales A5 et les Parts Sociales B5 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 5».
Les Parts Sociales A6 et les Parts Sociales B6 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 6».
Les Parts Sociales A7 et les Parts Sociales B7 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 7».
Les Parts Sociales A8 et les Parts Sociales B8 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 8».
Les Parts Sociales A9 et les Parts Sociales B9 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 9».
Les Parts Sociales A10 et les Parts Sociales B10 sont ensemble désignées les «Parts Sociales de Catégorie 10».
Les Parts Sociales des Catégorie 1, les Parts Sociales des Catégorie 2, les Parts Sociales des Catégorie 3, les Parts Sociales
des Catégorie 4, les Parts Sociales des Catégorie 5, les Parts Sociales des Catégorie 6, les Parts Sociales des Catégorie 7,
les Parts Sociales des Catégorie 8, les Parts Sociales des Catégorie 9, et les Parts Sociales des Catégorie 10 sont ensemble
désignées les «Catégories de Parts Sociales» et chacune une «Catégorie de Parts Sociales».».
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, déclare que tous les autres articles et rubriques de ladite assemblée
générale extraordinaire restent inchangés et il a prié le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin
sera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: C. Kremer, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 25 mars 2015. GAC/2015/2496. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 6 mai 2015.
Référence de publication: 2015069620/492.
(150078921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Infris S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 133.024.
- Mons. Kailash Ramassur, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est
nommé gérant de la société, en remplacement le gérant démissionnaire, Mme Anja Wunsch, avec effet au 16 avril 2015.
- Le nouveau mandat de Mons. Kailash Ramassur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2016.
79308
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 16 avril 2015.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015069403/15.
(150078645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
I.D.E.E. Sàrl, Iwerall Direkt Emmer Exact, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3260 Bettembourg, 178, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 152.119.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 08/05/2015.
<i>Pour la société
i>C.F.N. GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P. 80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015069405/17.
(150079128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Ican Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 146.382.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique, en date du 30 avril 2015:i>
- transfert du siège social en date du 30 avril 2015 au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg;
- constatation du changement d'adresse professionnelle des administrateurs de la société, Monsieur Marc Schintgen,
Monsieur Michal Wittmann, Madame Stéphanie Marion et Madame Catherine Zoller, qui résident désormais au 76, route
de Thionville L-2610 Luxembourg;
- constatation du transfert de siège social du commissaire aux comptes de la société, la société Alpha Expert S.A., qui
est désormais au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015069406/15.
(150078969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
ILP II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 122.717.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth of April.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
ILP II Management LLP, a company having its registered office at Two Snowhill, Birmingham, B46WR, United King-
dom,
hereby represented by Mr. Adrien Coulombel, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxy established
on April 22, 2015.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that the appearing party is the existing sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of ILP II S.à r.l. (the “Company”), a
société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary on 18 December 2006 and published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 15 February 2007, number 186 having its registered office in
L-8030 Strassen, 163 rue du Kiem, registered with the Luxembourg Trade and Company Registry under number B 122.717
79309
L
U X E M B O U R G
(the “Company”). The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 6 December 2011, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 345 of 09 February
2012.
- that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of twenty thousand euros
(EUR 20,000.-) so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to thirty-
two thousand five hundred euros (EUR 32,500.-) by the issuance of two hundred (200) new shares, having a par value of
one hundred euros (EUR 100.-) each.
The new shares are to be subscribed by ILP II Management LLP, prenamed, paid up by a contribution in cash of a total
amount of ninety-five thousand euros (EUR 95,000.-).
The total contribution of ninety-five thousand euros (EUR 95,000.-) will be allocated as follows:
(i) twenty thousand euros (EUR 20,000.-) will be allocated to the share capital of the Company and
(ii) seventy-five thousand euros (EUR 75,000.-) will be allocated to the share premium account.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to amend Article 6.1. of the articles of association of the Company so that it will
henceforth read as follows:
“ 6.1. Share capital. The Company's corporate capital is fixed at thirty-two thousand five hundred euros (EUR 32,500.-)
represented by three hundred twenty-five (325) shares, of one hundred euro (EUR 100.-) each, all fully subscribed and
entirely paid up.”
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately at two thousand euro.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understand English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version. On request of the appearing person and in case of divergence between the English and the
French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing now to the notary by name, first name, civil
status and residence, this proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
ILP II Management LLP, une société ayant son siège social à Two Snowhill, Birmingham B46WR, Royaume Uni,
ici représentée par Monsieur Adrien Coulombel, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
délivrée le 22 avril 2015.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux
présentes pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante représentée comme il est dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de ILP II S.à r.l. (la «Société»), société à respon-
sabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 18 décembre 2006 et publiée au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 15 février 2007, numéro 186, ayant son siège social à L- 8030 Strassen, 163, rue
du Kiem, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.717 (la «Société»).
Les statuts ont été amendés en dernier lieu par un acte du notaire instrumentant en date du 6 décembre 2011, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 345 du 09 février 2012.
- Que l'Associé Unique a approuvé les résolutions suivantes:
a) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt mille euros (EUR 20.000) de manière à le porter
de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32.500)
par l'émission de deux cents (200) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune à
l'associé unique de la Société pour un montant total de souscription de quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 95.000) qui
sera alloué au compte de capital social de la Société pour un montant de vingt mille euros (EUR 20.000) et au compte de
prime d'émission pour un montant de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000);
b) Modification subséquente de l'article 6.1. des statuts de la Société;
79310
L
U X E M B O U R G
c) Divers.
- Que tous les associés sont dûment représentés à l'assemblée et ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de vingt mille euros
(EUR 20.000) de manière à le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à trente-deux
mille cinq cents euros (EUR 32.500) par l'émission de deux cents (200) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de
cent euros (EUR 100) chacune.
Les parts sociales nouvelles sont souscrites par ILP II Management LLP, prénommée, payées par un apport en numéraire
d'un montant total de quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 95.000,-).
L'apport de quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 95.000,-) sera alloué comme suit:
(i) vingt mille euros (EUR 20.000,-) au capital social et
(ii) soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) pour le compte de prime d'émission.
Les documents justificatifs de l'existence et de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 6.1. des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« 6.1. Capital social. Le capital social est fixé à trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32.500,-) représenté par trois
cent vingt-cinq (325) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société des présentes
sont évalués à environ deux mille euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Après lecture faire et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé le présent acte avec Nous le notaire
Signé: A. COULOMBEL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 avril 2015. Relation: EAC/2015/9652. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015069408/104.
(150078834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
IH Baseholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.284.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IH BASEHOLDING S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015069407/11.
(150078954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Inazuma, Société Anonyme.
Siège social: L-4731 Pétange, 8, rue des Ecoles.
R.C.S. Luxembourg B 137.156.
<i>Protokollauszug der Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters, vom 30. April 2015, in L-4731 Petange, 8 rue desi>
<i>écolesi>
Am 30. April 2015 hat der alleinige Gesellschafter folgendes entschieden:
Das Mandat des aktuellen Geschäftsführers, Peter LEHMANN, geboren am 10. Mai 1971 mit Wohnsitz in A-6156 Gries
am Brenner 411 Vinaders wird annuliert.
Zum neuen Geschäftsführer mit Wirkung ab dem 1. Mai 2015 wird ernannt:
79311
L
U X E M B O U R G
Frau Mona SCHMIDT, geboren am 16.März 1985 in Heilbronn (D), wohnhaft in D-74177 Bad Friedrichshall Panora-
mastrasse 22.
Pétange, am 30. April 2015.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschriften
Référence de publication: 2015069410/18.
(150078454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Inspirit Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 125.424.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que le commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE SEVE S.A., inscrite sous le numéro RCS B 82421 et ayant
son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, a changé de dénomination en date du 14 juin 2013 et
porte désormais la dénomination FIDUSEVE S.A.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour Inspirit Investments S.A.i>
Référence de publication: 2015069411/15.
(150078527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Interactive Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 36.015.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que le commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE SEVE S.A., inscrite sous le numéro RCS B 82421 et ayant
son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, a changé de dénomination en date du 14 juin 2013 et
porte désormais la dénomination FIDUSEVE S.A.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour Interactive Investments S.A.i>
Référence de publication: 2015069412/15.
(150079024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
International Credit Mutuel Life, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 53.451.
Il est porté à la connaissance des tiers que Monsieur LEROY Christophe, Directeur, est domicilié professionnellement
au 9, boulevard Prince-Henri, L-1724 LUXEMBOURG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2015.
Référence de publication: 2015069414/11.
(150078700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
M.A. Topaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-6944 Niederanven, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 189.892.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the twenty-three of April.
Before Me Karine REUTER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
79312
L
U X E M B O U R G
There appeared:
1) Mr. Assaf Shlomo TOPAZ, company's manager, born on August 8, 1970 in Ramat Gan (Israel), residing in L-6944
Niederanven, 30, rue Dicks;
2) Mrs. Manor TOPAZ, company's manager, born on July 15, 1972 in Tel Aviv Jaffa (Israel), residing in L-6944
Niederanven, 30, rue Dicks,
hereby represented by Mr. Assaf Shlomo TOPAZ, prenamed, by virtue of power of attorneys, with power of substitution,
given under private seal.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and appearing party and by the undersigned notary,
shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Hereafter “the Parties”
The parties declared and requested the notary to act:
- that M.A. Topaz S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, having its registered office in L-5367
Schuttrange, 64, rue Principale, was incorporated in Luxembourg on the 22
th
of April, 2014 by notarial deed drawn up by
Me Gérard LECUIT, notary public residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), published in the Recueil
Spécial du Mémorial C on the 18
th
of October, 2014, number 3011, page 144.511, registered in the Trade Register of
Luxembourg under the number R.C.S. B 189.892.
- That the corporate share capital is presently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) represented
by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) each.
- That the Parties are the owners of all the shares of the Company.
- That the Parties, as the shareholders resolve to dissolve the Company with immediate effect.
- That the Parties declare that they have the full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that
they are fully aware of the situation of the Company.
- That the Parties, as liquidators of the Company, declare that the activity of the Company has ceased, that all liabilities
of the said Company have been paid or fully provided for, that the shareholders are vested with the assets and hereby
expressly declare that they will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown
liabilities of the Company.
- That the shareholders hereby grants full discharge to the Managers for their mandates up to this date.
- That the books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at L-5367 Schuttrange, 64, rue
Principale.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. In the event of any discrepancy between the
English and the French text, the English version shall prevail.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their names, first names, civil status
and residences, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.
<i>Expensesi>
The expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at
approximately ONE THOUSAND THREE HUNDRED EURO (1,300.- €).
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le vingt-trois avril.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) Monsieur Assaf Shlomo TOPAZ, gérant, né le 8 août 1970, à Ramat Gan (Israël), demeurant à L-6944 Niederanven,
30, rue Dicks;
2) Madame Manor TOPAZ, gérante, née le 15 juillet 1972, à Tel Aviv-Jaffa (Israël), demeurant à L-6944 Niederanven,
30, rue Dicks,
ici représentée par Monsieur Assaf Shlomo TOPAZ, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
avec pouvoir de substitution.
Ladite procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
Ci-après dénommés "les Parties".
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs
déclarations et constatations:
79313
L
U X E M B O U R G
- Que la société à responsabilité limitée M.A. Topaz S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF,
ayant son siège social à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 2008, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations en date du 11 juin 2008, numéro 1.442, page 69.188, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 189.892.
- Que le capital social s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,00.-€) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant une valeur d'un euro (1,00.-€) chacune.
- Que les Parties préqualifiées sont devenues propriétaires de toutes les parts sociales de la susdite société.
- Qu'en tant qu'associés, les associés préqualifiés déclarent expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
- Qu'ils déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société.
- Que les parties en tant que liquidateurs de la société déclarent que l'activité de la société a cessé, que les dettes connues
ont été payées ou provisionnées et qu'ils prennent à leur charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus
ou inconnus, de la société dissoute.
- Que partant la liquidation de la Société est achevée.
- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à
ce jour.
- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-5367 Schuttrange, 64, rue
Principale.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa
charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300.-€). A l'égard du notaire
instrumentant, toutes les parties comparantes et / ou signataires des présentes reconnaissent être solidairement tenues du
paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
<i>Déclarations généralesi>
Les parties déclarent que le notaire instrumentant leur a expliqué tous les effets et toutes les conséquences du présent
acte. Elles ont persisté à procéder par le présent acte et ont déclaré décharger le notaire instrumentant de toute conséquence
et responsabilité éventuelle pouvant découler du présent acte.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les parties comparantes prémentionnées, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signés: A. S. TOPAZ, K. REUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 avril 2015. Relation: 2LAC/2015/9438. Reçu soixante-quinze euros 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME
Luxembourg, le 8 mai 2015.
Référence de publication: 2015069478/103.
(150079182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
International Credit Mutuel Life, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 53.451.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2014i>
L'Assemblée Générale renouvelle les mandats d'administrateur de monsieur Alain SCHMITTER pour une durée de 6
ans prenant fin le jour de la tenue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
L'Assemblée Générale renouvelle les mandats d'administrateur de monsieur Antoine CALVISI pour une durée de 6 ans
prenant fin le jour de la tenue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
79314
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2014.
Référence de publication: 2015069415/14.
(150078700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
International Purchase & Rental Services (IPRS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 94.864.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que le commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE SEVE S.A., inscrite sous le numéro RCS B 82421 et ayant
son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, a changé de dénomination en date du 14 juin 2013 et
porte désormais la dénomination FIDUSEVE S.A.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour International Purchase & Rental Services (IPRS) S.A.i>
Référence de publication: 2015069417/15.
(150079023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Iphias Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 83.321.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique, en date du 30 avril 2015:i>
- transfert du siège social en date du 30 avril 2015 au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg;
- constatation du changement d'adresse professionnelle des administrateurs de la société, Monsieur Marc Schintgen,
Monsieur Michal Wittmann, Madame Stéphanie Marion et Madame Catherine Zoller, qui résident désormais au 76, route
de Thionville L-2610 Luxembourg;
- constatation du transfert de siège social du commissaire aux comptes de la société, la société Alpha Expert S.A., qui
est désormais au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015069421/15.
(150078968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Kyarra S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 135.471.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015069444/10.
(150078900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
John Deere Holding Brazil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.743.
Les comptes annuels au 31 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
79315
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 06 mai 2015.
John Deere Holding Brazil S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A. / T. Pierrette
<i>Gérant B / Gérant Ai>
Référence de publication: 2015069423/13.
(150078411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
John Deere Holding Canada S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.760.
Les comptes annuels au 31 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 mai 2015.
John Deere Holding Canada S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A. / T. Pierrette
<i>Gérant B / Gérant Ai>
Référence de publication: 2015069424/13.
(150078424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
John Deere Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.515.
Les comptes annuels au 31 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 mai 2015.
John Deere Holding S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A. / T. Pierrette
<i>Gérant B / Gérant Ai>
Référence de publication: 2015069425/13.
(150078430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Jacmar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 82.894.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que le commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE SEVE S.A., inscrite sous le numéro RCS B 82421 et ayant
son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, a changé de dénomination en date du 14 juin 2013 et
porte désormais la dénomination FIDUSEVE S.A.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour Jacmar S.A.i>
Référence de publication: 2015069427/15.
(150079022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
John Deere Luxembourg Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.923.
Les comptes annuels au 31 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
79316
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 06 mai 2015.
John Deere Luxembourg Investment S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A. / T. Pierrette
<i>Gérant B / Gérant Ai>
Référence de publication: 2015069426/13.
(150078402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Jata SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5893 Hesperange, 4, rue Dr Theodore Urbain.
R.C.S. Luxembourg E 5.638.
STATUTS
L'an deux mille quinze, les vingt deuxième jours du mois d'avril;
Sous seing privé à HESPERANGE:
Ont comparu:
1) Monsieur Achille Fischer, employé CFL, né à Luxembourg-Ville, Se 25 avril 1961, demeurant à L-5893 Hesperange,
4 rue Dr. Theodore Urbain.
2) Madame Anita Fischer-Hesse, employée privée, née à Luxembourg-Ville, le 29 juin 1963, demeurent à L-5893
Hesperange, A rue Dr. Theodore Urbain.
3) Monsieur Tom Fischer, employé communal, éducateur diplômé, né à Luxembourg-Ville, le 15 novembre 1992,
demeurant à L-5893 Hesperange, 4 rue Dr. Theodore Urbain.
4) Monsieur Joe Fischer, agent de la BCEE, né à Luxembourg-Ville, le 14 novembre 1987, demeurant à L-5893 Hes-
perange, 4 rue Dr. Theodore Urbain.
Lesquels comparants requièrent d'acter les statuts d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer entre eux
et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société civile immobilière sous la dénomination sociale «JATA SCI», (la société), régie par
la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles
1832 et suivants du code civil
Art. 2. La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour son propre compte, la mise
en valeur et la gestion de tous immeubles, parts d'immeubles qu'elle pourra acquérir au Grand-Duché de Luxembourg et/
ou à l'étranger, dont notamment l'acquisition, la vente, le partage, l'acquisition ou la cession de droits immobiliers géné-
ralement quelconques le démembrement de tout droit immobilier, la location partielle ou totale et la location temporelle
des immeubles ainsi acquis, ainsi que toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
et pouvant en faciliter l'extension et le développement, le tout à l'exclusion de toute activité commerciale.
La Société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement
en faveur de tiers,
La Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou physiques.
Art. 3. Le siège social et établi à HESPERANGE (Grand-Duché de Luxembourg). Il pourra être transféré en toute localité
du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée générale.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des parts d'intérêts.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de dix mille Euros (EUR-, 10.000), divisé en cent (100) parts d'intérêts de
cent Euro (EUR-, 100) chacune.
En raison de leurs apports, il est attribué:
à. Monsieur Achille Fischer, employé CFL, né à Luxembourg-Ville, le 25 avril 1961, demeurant à L-5893
Hesperange, 4 rue Dr. Theodore Urbain, vingt-cinq parts d'intérêts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
à. Madame Anita Fischer-Hesse, employée privée, née à Luxembourg-Ville, le 29 juin 1963, demeurant à L-5893
Hesperange, 4 rue Dr. Theodore Urbain, vingt-cinq parts d'intérêts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
à. Monsieur Tom Fischer, employé communal, éducateur diplômé, né à Luxembourg-Ville, le 15 novembre 1991,
demeurant à L-5893 Hesperange, 4 rue Dr. Theodore Urbain, vingt-cinq parts d'intérêts, . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
à. Monsieur Joe Fischer, agent de la BCEE, né à Luxembourg-Ville, le 14 novembre 1987, demeurant à L-5893
Hesperange, 4 rue Dr. Theodore Urbain, vingt-cinq parts d'intérêts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent parts d'intérêts; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
79317
L
U X E M B O U R G
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L'intégralité de l'apport devra être libérée
sur demande du ou des gérants ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l'appel des fonds ou apports.
il est expressément prévu que la titularisé de chaque part représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un associé dénommé «nu-propriétaire».
Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu'il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droits de vote aux assemblés générales;
- droits aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d'augmentation de capital;
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le droit
commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la Société suivant les modalités prévues ci-après sub b).
En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée:
a) Par la valeur de la pleine propriété des parts établie en conformité avec les règles d'évaluation prescrites par la loi;
b) Par les valeurs respectives de l'usufruit de la nue-propriété conformément aux dixièmes forfaitaires fixés par les lois
applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière d'enregistrement et de droits de succession.
Art. 6. Les parts d'intérêts sont librement cessibles entre associés. Elles les sont incessibles entre vifs ou pour cause de
mort à des tiers non-associés sans l'accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs, respecti-
vement sans l'accord unanime de tous tes associés restants en cas de cession pour cause de mort
En cas de transfert par l'un associés de ses parts d'intérêts à un tiers les autres associés bénéficieront d'un droit de
préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés ou, en cas de désaccord, à fixer par dire d'experts.
Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de
renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part
dans le capital restant.
Par dérogation à ce qui précède, la cession est toujours libre aux descendants d'un associé en ligne directe.
Art. 7. La dissolution de la Société n'est pas entraînée de plein droit par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture
d'un gérant, qu'il soit associé ou non.
Si les associés survivants n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la Société continuera entre les associés et
les héritiers de l'associé décédé.
Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d'être exclus de ta gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation,
désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressants la Société.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l'unanimité de tous les associés.
Art. 9. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour
compte de la Société.
La société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux gérants tant pour les actes
d'administration que de disposition.
Art. 10. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts d'intérêts.
Art. 11. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du
code civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans
la Société.
Art. 12. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les Intérêts de la Société l'exigent sur convocation d'un
gérant ou sur convocation d'un des associés.
L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des
voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.
Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins que
l'assemblée n'en décide autrement.
<i>Disposition transitairei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.
79318
L
U X E M B O U R G
<i>Libération des parts d'intérêtsi>
Toutes les parts d'intérêts ont été libérées intégralement par les souscripteurs prédits, de sorte que la somme de dix mille
Euro [EUR 10.000,-] se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1, Le siège social est établi à L-5893 Hesperange, 4 rue Dr. Theodore Urbain,
2. Sont nommés aux fonctions de gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Achille Fischer, employé CFL, né à Luxembourg-Ville, le 25 avril 1961, demeurant à L-5893 Hesperange,
4 rue Dr. Theodore Urbain,
et
- Monsieur Joe Fischer agent de la BCEE, né à Luxembourg-Ville, le 14 novembre 1987, demeurant à L-5893 Hespe-
range, 4 rue Dr. Theodore Urbain.
3. Conformément à l'article 9 des statuts, la Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions
par la signature conjointe des deux gérants.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, évalués à la tarification en vigueur du RCSL
Dont acte, fait et passé à HESPERANGE, date qu'en tête des présentes et après lecture faite et interprétation de ce qui
précède par les associées, ils ont signé le présent acte.
ASSOCIES JATA SCI
Achille FISCHER / Anita FISCHER-HESSE / Tom FISCHER / Joe FISCHER
Référence de publication: 2015069429/123.
(150078529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Java International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 186.580.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015069430/9.
(150078410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Praom-Tarantino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 196.439.
EXTRAIT
Il résulte d'une cession de parts sociales en date du 7 mai 2015 que Monsieur Mikaël TARANTINO demeurant à F-40140
Soustons, 7, ailée des Plantes a cédé 30 parts sociales de la société PRAOM-TARANTINO S.à r.l. à Madame Bénédicte
PRAOM demeurant à L-7220 Walferdange, 14, route de Diekirch, détenant alors 100 parts sociales et devenant actionnaire
unique de la Société.
Luxembourg, le 7 mai 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015069567/17.
(150078985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
79319
L
U X E M B O U R G
K Agamemnon S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 160.311.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance de qui de droit que l'adresse des gérants suivants a été transférée au: 28, Boulevard Joseph
II, L-1840 Luxembourg:
<i>Gérants:i>
- Séverine Desnos
- Valérie Ingelbrecht
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Le 07 mai 2015.
Référence de publication: 2015069432/16.
(150078721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
K-Buchs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 143.879.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015069433/9.
(150079062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Lamudi Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.486.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of April.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 177.038, having
its registered office at 5, Heienhaff, L - 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “AIH”),
being the holder of six thousand two hundred fifty (6,250) common shares, six thousand two hundred fifty (6,250) series
A1 shares and four thousand two (4,002) series B shares,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on 9 April 2015,
2. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,
registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg),
Germany, under no. HRB 139778 B, having its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of three thousand one hundred twenty-five (3,125) common shares and three thousand one hundred
twenty-five (3,125) series A2 shares,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on 9 April 2015,
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 176.544, having
its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a share
capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000),
being the holder of one thousand five hundred sixty-two (1,562) common shares and one thousand five hundred sixty-
three (1,563) series A3 shares,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, on 9
April 2015,
4. TEC Global Invest VII GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,
registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Duisburg (Amtsgericht Duisburg), Germany,
79320
L
U X E M B O U R G
under no. HRB 26063, having its registered office at Wissollstrasse 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany (hereinafter
“TEC”),
being the holder of one thousand five hundred sixty-three (1,563) common shares, one thousand five hundred sixty-two
(1,562) series A4 shares and one thousand five hundred (1,500) series B shares,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Mülheim an der
Ruhr, Germany, on 9 April 2015, and
5. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 191.426 (hereinafter “Holtzbrinck”),
being the holder of one thousand two hundred fifty (1,250) series B shares, and becoming the holder of one thousand
two hundred fifty (1,250) new series B shares,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on 9 April 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all the shareholders, representing the entire share capital of Lamudi Global S.à r.l. (hereinafter
the “Company”), formerly Digital Services XXV S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 188486, incorporated pursuant to a deed of notary Carlo Wersandt on 18 June 2014, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2492 on 16 September 2014. The articles of association have
been amended pursuant to a deed of notary Cosita Delvaux dated 13 February 2015, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing parties representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general meeting
of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250) from
its current amount of thirty-one thousand seven hundred fifty-two euro (EUR 31,752) up to thirty-three thousand and two
euro (EUR 33,002) through the issuance of one thousand two hundred fifty (1,250) series B shares, with a nominal value
of one euro (EUR 1.00) each.
2. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth
read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-three thousand and two euro (EUR 33,002), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A1 Shares”),
5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A3 Shares”),
5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”), and
5.1.6 eight thousand and two (8,002) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter
“Series B Shares”).
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux
Holdings S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”) and (v) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS
(“Holtzbrinck”; AIH, LIH, Aismare, TEC and Holtzbrinck jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled
to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment
offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections
15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved by the Advisory
79321
L
U X E M B O U R G
Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching
shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the
same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv)
TEC and (v) Holtzbrinck shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it has been notified
by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and/or (v) Holtzbrinck
intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall
apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”
3. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Lamudi Global
S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may
be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-three thousand and two euro (EUR 33,002), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A1 Shares”),
5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A3 Shares”),
79322
L
U X E M B O U R G
5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”), and
5.1.6 eight thousand and two (8,002) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter
“Series B Shares”).
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux
Holdings S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”) and (v) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS
(“Holtzbrinck”; AIH, LIH, Aismare, TEC and Holtzbrinck jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled
to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment
offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections
15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved by the Advisory
Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching
shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the
same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv)
TEC and (v) Holtzbrinck shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it has been notified
by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and/or (v) Holtzbrinck
intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall
apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing Shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to
be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The Shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the Shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of any
shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or
tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent that
such approval has been granted, an additional consent to the transfer of Shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by an Investor to a company affiliated
to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (each an “Affiliate”);
7.4.2 in case of the transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares of one Investor to a company or entity (x)
which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or
more direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or
“Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by way of (a) managing
the company or entity as managing shareholder, (b) holding the majority of Shares or (c) holding the majority of voting
rights by means of a contractual voting pool, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders of such
Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by a Shareholder to the Company and/or any
of the Investors pursuant to a call-option under a vesting scheme;
7.5 To the extent a sale, transfer, assignment or any other disposal of Shares requires no additional consent of the
shareholders’ meeting pursuant to Article 7.4.1 through Article 7.4.3 above, neither duties to offer for sale, nor any rights
of first refusal, nor rights of pre-emption, nor tag-along rights, nor dragalong rights apply in favour of other shareholders.
79323
L
U X E M B O U R G
7.6 Any sale, transfer, assignment or other disposal of Shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification thereof to, or upon the acceptance thereof by the Company in accordance with Article 1690
of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the Shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an
economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii) of
the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of Shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50 % of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the events
described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to
Articles 8.2 and 8.3 below - will be distributed in accordance with Article 8.4 to the Shareholders pro rata to their partici-
pation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series B Shares shall receive per Share an amount of EUR 2,000 being
subject to the Liquidity Event.
8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series
A4 Shares shall receive per Share of the respective Share class an amount stipulated next to the relevant share class being
subject to the Liquidity Event in the following table:
Share Class
Amount
per Share
in Euro
Series A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Series A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,695.18
Series A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,599.49
Series A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,600.51
8.4 After the payments on the First Level and on the Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall
be allocated on a third level (“Third Level”) to all selling Shareholders pro rata to their participation in the Liquidity Event.
Any amounts received by any Investor on the First Level and/or Second Level shall reduce the amount to be allocated to
such Investor on this Third Level provided that no Investor shall be obliged to repay any amount received on the First Level
and/or Second Level. Irrespective of whether or not the sale of Shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity
Event in one transaction or more transactions, no shareholder shall receive for the sale of all of its Shares (and shall repay
any exceeding amount to the other shareholders) an amount exceeding the higher of (i) its Share in the total Exit Proceeds
or proceeds pro rata to the Shares sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on
the First Level and/or Second Level and/or Third Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference
stipulated herein can only be exercised once.
8.5 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies for the benefit of the respective Investor so long
as the respective Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to such Investor according to the First
Level.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own Shares. The voting rights of any of its Shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is
rejected for lack of assets;
9.2.2 the Share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such Share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the Shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles of association together with the
declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the Law and
the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the Shares in such case and undertakes to register the transfer
in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one person;
independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way through
one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.
79324
L
U X E M B O U R G
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed Shares. The effective date
is the date before the redemption resolution.
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the Shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert arbitrator
shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the Company. The
decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company and the
requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the redemption price and
the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption
price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the Shares to a person
named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or partial
assignment of the share to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of
association, for the Shares to be assigned is owed by the person acquiring the Shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by Law and by these articles
of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also
be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a
shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of
managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must
state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must
be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be
specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or regis-
tered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of
notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary share-
79325
L
U X E M B O U R G
holders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’ meeting
is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another shareholder
authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders’
resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’ meeting (for
purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds Shares.
14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s shareholders are
only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is no
quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with Article
13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this was
pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
Art. 17. Shareholders’ Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders’ resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the
consent of the advisory board (the “Advisory Board”):
17.1.1 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company;
17.1.2 amendment of these articles of association including the resolution with respect to the merger, separation and
transformation of the Company;
17.1.3 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such profits
to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;
17.1.4 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq. German
Stock Corporation Act (AktG));
17.1.5 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of existing shares
or issuance of new shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party
is granted a participation in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit;
this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light
of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of
business, e.g. agreements between the Company and advertising partners.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also requires the consent of
the Investors.
17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company’s own Shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and
transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.
17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of Shares the special rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders’ who hold all
the issued Shares of that class.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
79326
L
U X E M B O U R G
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-
ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
22.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board for the legal transactions and measures specified
below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance
been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:
22.8.1 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
79327
L
U X E M B O U R G
22.8.2 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of five hundred thousand Euros
(EUR 500,000.00) in aggregate;
22.8.3 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,
however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
22.8.4 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two hundred
thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework, excluding, however,
such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
22.8.5 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
22.8.6 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.7 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
22.8.8 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than five hundred thousand Euros (EUR 500,000.00) in the individual case;
22.8.9 passing on of industrial property rights or know-how by the Company to a third party outside the ordinary course
of business;
22.8.10 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals as set
forth in any shareholders’ agreement between the shareholders;
22.8.11 amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections
291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)); and
22.8.12 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options) other
than the establishment of any simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the Company in
a shareholders' agreement, if any.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also required
for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further transactions
and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also in advance for
certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in the
future.
Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) such minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1)
class B manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and
class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company has set up an Advisory Board. It consists of five (5) voting members. The shareholders may by way
of unanimous Shareholders’ Consent increase or decrease the number of voting members of the Advisory Board.
25.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous
shareholders’ consent.
25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s respective
appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
79328
L
U X E M B O U R G
25.3.1 One (1) voting member of the Advisory Board, having six (6) votes, shall be nominated by the shareholder AIH
in its sole discretion;
25.3.2 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder LIH
in its sole discretion;
25.3.3 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder Aismare
in its sole discretion; and
25.3.4 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder TEC
in its sole discretion.
25.3.5 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder
Holtzbrinck in its sole discretion.
25.4 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. The chairman shall be the member nominated
by the largest shareholder in terms of percentage participation that is entitled to nominate a member to the Advisory Board.
The rules of procedure of the Advisory Board may provide for further provisions in particular on the self-organization of
the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast. In case of a vote
tie, the chairman shall have a casting vote if at the point in time of the respective decision the Shareholder having nominated
the chairman holds more than 50 % of all shares in the Company. For the avoidance of doubt the deputy chairman shall
not have a casting vote.
25.5 The objective and responsibility of the Advisory Board shall be the granting of consents to specific transactions of
the management of the Company which pursuant to (i) any shareholders’ agreement relating to the Company, (ii) these
articles of association, (iii) the rules of procedure for the managers, (iv) the rules of procedure for the Advisory Board or
(v) respective shareholders’ resolutions require the consent of the Advisory Board. Further powers and responsibilities may
be conferred on the Advisory Board by shareholders’ resolution. In addition to those consent requirements, the Advisory
Board has a consultative function and will not interfere in the management of the Company.
25.6 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
E. Audit and supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they hold
in the Company.
Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
79329
L
U X E M B O U R G
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since the
end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried
forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities
of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with the
provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent per-
mitted by Luxembourg law.
31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
4. Subsequently, decision to grant power to any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr
Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders’
register of the Company.
5. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the undersigned notary to enact, the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand
two hundred fifty euro (EUR 1,250) from its current amount of thirty-one thousand seven hundred fifty-two euro (EUR
31,752) up to thirty-three thousand and two euro (EUR 33,002) through the issuance of one thousand two hundred fifty
(1,250) series B shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
<i>Subscriptioni>
The new one thousand two hundred fifty (1,250) Series B Shares have been duly subscribed by Holtzbrinck, aforemen-
tioned, for the subscription price of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250).
<i>Paymenti>
The new one thousand two hundred fifty (1,250) Series B Shares subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, have been
entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250).
The proof of the existence of the above contribution in cash has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250) is entirely allocated to the share
capital of the Company.
<i>Second Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article five (5) of
the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-three thousand and two euro (EUR 33,002), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A1 Shares”),
5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A3 Shares”),
79330
L
U X E M B O U R G
5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”), and
5.1.6 eight thousand and two (8,002) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter
“Series B Shares”).
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux
Holdings S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”) and (v) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS
(“Holtzbrinck”; AIH, LIH, Aismare, TEC and Holtzbrinck jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled
to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment
offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections
15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved by the Advisory
Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching
shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the
same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv)
TEC and (v) Holtzbrinck shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it has been notified
by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and/or (v) Holtzbrinck
intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall
apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”
<i>Third Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the
articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Fourth Resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby grants power to any manager of the Company, regardless of his category,
as well as Mr Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the
shareholders’ register of the Company.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at EUR 2,000.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizehnten April,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 177.038, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg
(„AIH“),
Inhaberin von sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Stammanteilen, sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) An-
teilen der Serie A1 und viertausendzwei (4.002) Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 9. April 2015,
ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
2. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 139778 B,
mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaberin von dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Stammanteilen und dreitausendeinhundertfünfundzwan-
zig (3.125) Anteilen der Serie A2,
79331
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 9. April 2015,
ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000),
Inhaberin von eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Stammanteilen und eintausendfünfhundertdreiundsechzig
(1.563) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 9. April 2015,
ausgestellt in London,
4. TEC Global Invest VII GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 26063, mit Sitz
in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland („TEC“),
Inhaberin von eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Stammanteilen, eintausendfünfhundertzweiundsechzig
(1.562) Anteilen der Serie A4 und eintausendfünfhundert (1.500) Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 9. April 2015,
ausgestellt in Mülheim an der Ruhr, Deutschland, und
5. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend
unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter
der Nummer B 191.426 („Holtzbrinck“),
Inhaberin von eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie B und zukünftige Inhaberin von eintausend-
zweihundertfünfzig (1.250) neuen Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 9. April 2015,
ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital der Lamudi Global
S.à r.l. (die „Gesellschaft”), vormals Digital Services XXV S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Lu-
xemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188486, gegründet am 18. Juni 2014 gemäß einer
Urkunde des Notars Carlo Wersandt, welche am 16. September 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 2492 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde am 13. Februar 2015 gemäß einer Urkunde der
Notarin Cosita Delvaux geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde.
Da die erschienenen Parteien das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet
haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
Tagesordnung verhandeln:
<i>Tagesordnungi>
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einunddreißigtausendsie-
benhundertzweiundfünfzig Euro (EUR 31.752) um einen Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) auf
einen Betrag von dreiunddreißigtausendzwei Euro (EUR 33.002) durch die Ausgabe von eintausendzweihundertfünfzig
(1.250) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
2. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiunddreißigtausendzwei Euro (EUR 33.002), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“),
5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und
79332
L
U X E M B O U R G
5.1.6 achttausendzwei (8.002) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die „Anteile
der Serie B“).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“) und (v) HV Holtzbrinck Ventures
Fund VI SCS („Holtzbrinck“; AIH, LIH, Aismare, TEC und Holtzbrinck gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils
ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wo-
durch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine
mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drit-
tinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom
Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteili-
gungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen,
wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) Holtzbrinck
hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition
eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und/oder (v)
Holtzbrinck ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser
Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“
3. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Lamudi Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
79333
L
U X E M B O U R G
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiunddreißigtausendzwei Euro (EUR 33.002), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“),
5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und
5.1.6 achttausendzwei (8.002) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die „Anteile
der Serie B“).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“) und (v) HV Holtzbrinck Ventures
Fund VI SCS („Holtzbrinck“; AIH, LIH, Aismare, TEC und Holtzbrinck gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils
ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wo-
durch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine
mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drit-
tinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom
Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteili-
gungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen,
wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) Holtzbrinck
hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition
eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und/oder (v)
Holtzbrinck ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser
Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-
venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
79334
L
U X E M B O U R G
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Über-
tragung von Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen
Investor an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes
(AktG) (jeweils eine „Verbundene Gesellschaft“);
7.4.2 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines In-
vestors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welche/s direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder
mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kon-
trolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte
„Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft oder
des Unternehmens bezeichnen, durch (a) die Leitung der Gesellschaft oder des Unternehmens als geschäftsführender Ge-
sellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine
vertragliche Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher/m der betreffende Investor oder ein oder mehrere Gesellschafter dieses
Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen
Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit
einer Vesting-Regelung.
7.5 Sofern ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen keiner weiteren
Zustimmung als der der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 7.4.1 bis 7.4.3 bedarf, gelten weder Verpflichtungen
zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesell-
schafter.
7.6 Ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft darüber in Kenntnis gesetzt
wurde oder diesem/dieser zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zugestimmt hat (wobei die Anteile des verstorbenen Gesell-
schafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des
verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer
Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Transaktionen oder in zeitlicher
Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der Übertragung von Anteilen an
der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder mehr als 50%
des Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären
(change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii)
beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) - vorbe-
haltlich der Artikel 8.2 und 8.3 - im Einklang mit Artikel 8.4 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B pro Anteil einen Betrag von
EUR 2.000, vorausgesetzt, dass das Liquiditätsereignis eingetroffen ist.
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2,
Anteilen der Serie A3 und Anteilen der Serie A4 pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse einen in der folgenden Tabelle
neben der entsprechenden vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteilsklasse vereinbarten Betrag:
Anteilsklasse
Betrag
pro
Anteil in
Euro
Serie A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,00
Serie A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.695,18
Serie A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.599,49
Serie A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600,51
79335
L
U X E M B O U R G
8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen
Exiterlöse auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene”) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entspre-
chend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Investor auf der Ersten Ebene und/oder
Zweiten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Investor zu erhaltenden Betrag auf dieser Dritten Ebene, mit
der Maßgabe, dass kein Investor zur Rückzahlung eines auf der Ersten Ebene und/oder Zweiten Ebene erhaltenen Betrags
verpflichtet ist. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer
oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu
erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der
Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleich-
wertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten Ebene und/oder Zweiten
Ebene und/oder Dritten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin festgelegten Liqui-
ditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.
8.5 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene gilt zugunsten des jeweiligen Investors solange, wie
dieser den Gesamtbetrag, welcher diesem Investor gemäß der Ersten Ebene zuzuteilen ist, noch nicht erhalten hat.
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
79336
L
U X E M B O U R G
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz von 1915 und diese
Satzung ausdrücklich vorbehalten sind.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschrif-
ten des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die
„Gesellschafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusam-
menhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleinge-
sellschafter ausgeübt.
Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche in
der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine schrift-
liche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer unter der
Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals
vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
79337
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.
Art. 17. Gesellschafterbeschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und
zudem die Zustimmung des Beirats (der „Beirat“):
17.1.1 Veräußerung des Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens, ein-
schließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
17.1.2 Änderung dieser Satzung, einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und
Umwandlung der Gesellschaft;
17.1.3 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag solcher
Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln;
17.1.4 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
17.1.5 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (zur Klarstellung, nicht durch die Veräußerung bestehender oder die
Ausgabe neuer Anteile) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere
Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der
Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich
Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wur-
den, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und
Werbepartnern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-
stimmung der Investoren:
17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.
17.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und ihre
Amtszeit festlegt.
19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterver-
sammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige
Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
79338
L
U X E M B O U R G
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikations-
mittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die untenstehenden Rechtsgeschäfte und Maßnah-
men. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im
Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:
22.8.1 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
22.8.2 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von fünfhun-
derttausend Euro (EUR 500.000,00) überschreiten;
22.8.3 Gewährung von Darlehen, die, im Einzelfall, einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00)
überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochter-
gesellschaften der Gesellschaft;
22.8.4 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,
einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, aller-
dings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der
Gesellschaft;
22.8.5 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transak-
tionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.6 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
22.8.7 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
79339
L
U X E M B O U R G
22.8.8 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streitwert
von über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,00) im Einzelfall;
22.8.9 Weitergabe von gewerblichen Schutzrechten oder Know-how von der Gesellschaft an Dritte außerhalb des ge-
wöhnlichen Geschäftsgangs;
22.8.10 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen,
wie in Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern dargelegt;
22.8.11 Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes
(AktG)); und
22.8.12 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung
jeglicher Anteilsoder Aktienoptionen) mit Ausnahme der Einführung einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwi-
schen den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,
so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und Maßnah-
men auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden),
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder
deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige
Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder von zwei
(2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von
Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden
solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder
deren Vertreter) unterzeichnet.
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat gebildet. Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesell-
schafter können die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats mit einstimmiger Zustimmung erhöhen oder
herabsetzen.
25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur mit einstimmiger Zustimmung festlegen und/
oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.3.1 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit sechs (6) Stimmen wird von dem Gesellschafter AIH nach
eigenem Ermessen ernannt;
25.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem Gesellschafter LIH nach
eigenem Ermessen ernannt;
79340
L
U X E M B O U R G
25.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem Gesellschafter Aismare nach
eigenem Ermessen ernannt; und
25.3.4 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem Gesellschafter TEC nach
eigenem Ermessen ernannt.
25.3.5 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem Gesellschafter Holtzbrinck
nach eigenem Ermessen ernannt.
25.4 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Beirats ist das
Mitglied, welches von dem Gesellschafter ernannt wurde, welcher von der prozentualen Beteiligung her der größte derje-
nigen ist, welche zur Ernennung eines Beiratsmitglieds ermächtigt sind. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende die entscheidende Stimme, sofern
zu dem Zeitpunkt der jeweiligen Entscheidung derjenige Gesellschafter, der den Vorsitzenden ernannt hat, mehr als 50%
aller Anteile an der Gesellschaft hält. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass der stellvertretende Vorsitzende nicht
die entscheidende Stimme hat.
25.5 Ziel und Zuständigkeit des Beirats ist die Erteilung von Zustimmungen zu spezifischen Transaktionen der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft, welche gemäß (i) einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft, (ii) dieser
Satzung, (iii) der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, (iv) der Geschäftsordnung für den Beirat oder (v) entsprech-
ender Gesellschafterbeschlüsse die Zustimmung des Beirats erfordern. Weitere Befugnisse und Zuständigkeiten können
dem Beirat durch einen Gesellschafterbeschluss übertragen werden. Neben diesen Zustimmungserfordernissen hat der
Beirat eine beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
25.6 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
79341
L
U X E M B O U R G
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Ver-
luste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die
Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der
Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den
Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen
den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
4. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie
Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit unein-
geschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
5. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von einunddreißigtausendsiebenhundertzweiundfünfzig Euro (EUR 31.752) um einen Betrag von eintausendzweihundert-
fünfzig Euro (EUR 1.250) auf einen Betrag von dreiunddreißigtausendzwei Euro (EUR 33.002) durch die Ausgabe von
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu
erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die neuen eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Serie B wurden ordnungsgemäß von Holtzbrinck, vorbe-
nannt, zum Bezugspreis von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Holtzbrinck, vorbenannt, gezeichneten eintausendzweihundertfünfzig (1.250) neuen Anteile der Serie B wurden
vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250).
Der Nachweis über die Existenz der oben bezeichneten Bareinlage wurde der unterzeichnenden Notarin erbracht.
Die Einlage in Höhe von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel fünf (5) der Satzung der Ge-
sellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiunddreißigtausendzwei Euro (EUR 33.002), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
79342
L
U X E M B O U R G
5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“),
5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und
5.1.6 achttausendzwei (8.002) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die „Anteile
der Serie B“).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“) und (v) HV Holtzbrinck Ventures
Fund VI SCS („Holtzbrinck“; AIH, LIH, Aismare, TEC und Holtzbrinck gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils
ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wo-
durch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine
mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drit-
tinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom
Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteili-
gungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen,
wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) Holtzbrinck
hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition
eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und/oder (v)
Holtzbrinck ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser
Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, einstimmig die gänzliche Neu-
fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt
lautet.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Herrn Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Ur-
kunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.
Gezeichnet: X. TANG, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/11606. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
79343
L
U X E M B O U R G
Luxemburg, den 07. Mai 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015069447/1323.
(150078799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Keystone Developers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 184.705.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015069439/9.
(150079056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Merwood Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.256.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015069485/10.
(150078539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Merwood Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.256.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015069486/10.
(150078547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Minotaur S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 150.864.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015069487/10.
(150078781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Luxfrost S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8241 Mamer, 29, rue Marie-Jeanne Birckel.
R.C.S. Luxembourg B 187.976.
Die Jahresabschlüsse am 31. Dezember 2014 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015069474/10.
(150078652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
79344
Helena 1
Helena 2
HHS Holding S.A.
HV Portobello Sàrl
Ican Investments S.A.
IH Baseholding S.à r.l.
ILP II S.à r.l.
Immobilière Pierre Weydert S.A.
Inazuma
Independent Star Venture
Independent Star Venture
Infracapital F1 Holdings S.à r.l.
Infris S.à r.l.
Inspirit Investments S.A.
Interactive Investments S.A.
International Credit Mutuel Life
International Credit Mutuel Life
International Purchase & Rental Services (IPRS) S.A.
Iphias Holding S.A.
Iwerall Direkt Emmer Exact
Jacmar S.A.
Jata SCI
Java International S.à r.l.
John Deere Holding Brazil S.à r.l.
John Deere Holding Canada S.à r.l.
John Deere Holding S.à r.l.
John Deere Luxembourg Investment S.à r.l.
K Agamemnon S.à r.l.
K-Buchs S.à r.l.
Keystone Developers S.A.
Kyarra S.à r.l.
Lamudi Global S.à r.l.
Luxfrost S.à r.l.
M.A. Topaz S.à r.l.
Merwood Properties S.à r.l.
Merwood Properties S.à r.l.
Minotaur S.à r.l.
Praom-Tarantino S.à r.l.
Saddle Luxco Holding S.à r.l.