This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1606
30 juin 2015
SOMMAIRE
Balote SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77084
Bielefeld Boulevard Holding S.à r.l. . . . . . . . .
77052
CBS Showtime - CBS-Lux Holding LLC S.C.S.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77075
KCS S.à r.l. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77042
Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l. . . . . .
77074
Lancefield Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77042
Leeverg Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
77050
LF Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77052
LIBF (I) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77060
Lion/Visor Lux 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77050
LMF Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77060
Loevarth Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77061
Logiver S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77061
Logwin Road + Rail Trier GmbH, Niederlas-
sung Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77051
London Bridge Investment Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77051
LO Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77060
Lorito L. Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77052
LSREF3 Eve Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
77061
Luxempart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77062
Lynckx Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
77063
Mac's Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77069
MaForm Holding Luxembourg S.àr.l. . . . . . . .
77065
MaForm S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77065
Mahkota S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77068
ManageMySelf S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77064
MAN Finance and Holding S.A. . . . . . . . . . . . .
77069
MAN Finance Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
77069
Marble Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
77064
Marine Participations SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
77072
Marsaco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77064
Mathy Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77065
Matma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77072
Matro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77073
Matro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77073
Matro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77073
Mayhill Investments Limited S.A. . . . . . . . . . .
77072
MC Diamond s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77074
MDC Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77074
Media Vision S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77066
Melville Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77067
Milano Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
77067
Milano Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
77067
Mirko S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77066
Misys Newco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77067
M-Square Finance S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . .
77064
Mt. Kailash S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77065
Munawwar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77066
Munich Holdings II Corporation . . . . . . . . . . .
77068
Mylan Luxembourg 8 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
77063
Mylan Luxembourg 9 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
77068
Novocure Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77063
OCM Luxembourg Portugal Investment Plat-
form S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77042
Ophelia Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
77086
Pearl JV Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77060
Peehold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77075
Profconsult S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77062
Traumgaard de Luxe GmbH . . . . . . . . . . . . . .
77050
Valorem Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .
77069
Yaletown Acquiror S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
77051
Yaletown Collector Co S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
77061
77041
L
U X E M B O U R G
KCS S.à r.l. - SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 185.434.
EXTRAIT
En date du 23 avril 2015, les gérants de la Société ont pris la résolution suivante:
- Le siège social de la Société est transféré du 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 15 rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Référence de publication: 2015064929/14.
(150074814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Lancefield Property, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.600,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 189.216.
Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Madame Catherine KOCH a démissionné de son mandat
de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Lancefield Property
Signature
Référence de publication: 2015064938/14.
(150074219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
OCM Luxembourg Portugal Investment Platform S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 196.494.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the seventeenth day of April,
before Maître Jean SECKLER, notary in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
OCM Luxembourg EPF III S.à r.l. a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)
having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and a share capital
of one million and one hundred twenty-seven thousand and three hundred euro (EUR 1,127,300.-), registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 159.343;
here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
“OCM Luxembourg Portugal Investment Platform S.à r.l.” (hereafter the Company), which will be governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended
(hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It
may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company.
77042
L
U X E M B O U R G
The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines that
extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or
events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may temporarily be transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company, which notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg incorporated
company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or
obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other
company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior approval
of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
77043
L
U X E M B O U R G
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members, appointed by a resolution of the sole
shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not be share-
holder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the board of managers, which has all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the board of managers of the Company or by two managers acting jointly.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon request of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the time set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail,
of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a sole document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two
managers of the Company, or by the joint or sole signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been
validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a sole document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or
facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
77044
L
U X E M B O U R G
13.3. However, resolutions to amend the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall end on the thirty-
first day of December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the board of managers must prepare the
balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value
of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the
managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers of the Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased
by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders of the
Company; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s)
or by law, the liquidators shall be vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company (if any)
shall be paid to the shareholder or, in case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
VII. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provision:i>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2015.
<i>Subscription - Payment:i>
Thereupon, OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declared to subscribe to
twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and to
fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).
<i>Resolutions of the sole shareholder:i>
Then, the sole shareholder, represented as stated above and representing the entirety of the share capital, has passed the
following resolutions:
77045
L
U X E M B O U R G
1. The following persons are appointed as managers (gérants) of the Company for an indefinite period of time:
- Mr. Jabir CHAKIB, born on November 5, 1967, in Casablanca (Morocco), residing professionally at 26A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Hugo NEUMAN, born on October 21, 1960, in Amsterdam (the Netherlands), residing at 16, rue J.B. Fresez,
L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Justin BICKLE, born on January 11, 1971, in Plymouth (United Kingdom), residing professionally at 27 Knights-
bridge, London SW1X 7LY, United Kingdom.
2. The registered office of the Company is set at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French version, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, such proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-sept avril,
par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
«OCM Luxembourg EPF III S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social d'un million cent
vingt-sept mille trois cents euros (EUR 1.127.300,-) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 159.343;
ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination «OCM Luxembourg
Portugal Investment Platform S.à r.l.» (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en
particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les
présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant
comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou
militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évènements seraient de nature à compromettre l'activité normale
de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société
luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra
en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou ins-
truments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'em-
77046
L
U X E M B O U R G
prunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts
et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra
aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre
société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transac-
tions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à
la réalisation de son objet social.
4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres qui seront nommés par résolution
de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s)
ne sont pas nécessairement associé(s).
7.2. Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants agissant conjointement.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
77047
L
U X E M B O U R G
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la
Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre
du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société
donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant, par la/les signature(s) individuelle(s) ou conjointe(s) de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque
associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,
soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des
associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou
téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le conseil de gérance doit préparer le bilan et les comptes
de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société,
avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel
est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le conseil de gérance de la Société;
77048
L
U X E M B O U R G
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à
la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés
de la Société; et
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société (s'il y en a)
sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts
sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoire:i>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2015.
<i>Souscription - Libération:i>
Ces faits exposés, «OCM Luxembourg EPF III S.à r.l.», prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare
souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d'un Euro (EUR
1.-) chacune, et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-).
La somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
<i>Résolutions de l'associé unique:i>
Et aussitôt, l'associé unique, représenté comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Jabir CHAKIB, né le 5 novembre 1967 à Casablanca (Maroc), résidant professionnellement au 26A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Hugo NEUMAN, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), résidant professionnellement au 16, rue J.B.
Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- M. Justin BICKLE, né le 11 janvier 1971 à Plymouth (Royaume-Uni), résidant professionnellement au 27 Knights-
bridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni.
2. Le siège social de la Société est établi au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 21 avril 2015. Relation GAC/2015/3335. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015066562/404.
(150076251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2015.
77049
L
U X E M B O U R G
Leeverg Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 155.483.
Il est porté à votre connaissance les changements suivants:
Patrick Wilwert, administrateur et administrateur délégué à la gestion journalière de la société n'a plus son adresse au:
36, rue Emile Mayrisch
L - 4240 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
Mais au:
24, rue Astrid
L - 1143 Luxembourg
Référence de publication: 2015064943/15.
(150074691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Lion/Visor Lux 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.259.107,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 128.536.
Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du changement de siège social de l'associé avec effet immédiat:
- Lion/Visor Lux 1, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2015.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015064946/14.
(150074787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Traumgaard de Luxe GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6187 Gonderange, Z.A. Gehaansraich.
R.C.S. Luxembourg B 185.030.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «TRAUMGAARD DE LUXE
GmbH», ayant son siège social à L-6187 Gonderange, Um Gehaansraich, Z.A. Gehaansraich,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 185.030,
tenue en date du 2 avril 2015, suivant acte reçu par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, enregistré
à Diekirch en date du 2 avril 2015, sous la référence DAC/2015/5683,
que Monsieur Manfred HEINZ, maître agriculteur, né le 3 août 1965 à Bitburg (Allemagne), demeurant à D-54636
Trimport, Hauptstrasse 32, associé unique de la prédite société a vendu avec effet immédiat toutes ses parts sociales (100
parts) à Monsieur Stefan SCHILZ, maître-jardinier, né le 16 avril 1982 à Saarburg (Allemagne), demeurant à D-54441
Kirf-Beuren, 17, Triererstrasse.
Révocation avec effet immédiat de Monsieur Manfred HEINZ, prénommé, de son poste de gérant.
Nomination avec effet immédiat en tant que gérant de Monsieur Stefan SCHILZ, prénommé, pour une durée indéter-
minée.
Monsieur Stefan SCHILZ pourra engager la société par sa seule signature.
Ettelbruck, le 29 avril 2015.
Pour extrait conforme
Pierre PROBST
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2015065313/25.
(150073926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
77050
L
U X E M B O U R G
Logwin Road + Rail Trier GmbH, Niederlassung Grevenmacher, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten.
R.C.S. Luxembourg B 123.150.
SCHLIESSUNG EINER NIEDERLASSUNG
<i>Auszugi>
Durch Beschluss der Geschäftsführung der Logwin Road + Rail Trier GmbH mit Sitz in Monaiser Straße 13, 54294
Trier, Deutschland (die „Gesellschaft“), vom 18. März 2015, wurde beschlossen die Geschäftsaktivitäten der Niederlassung
in Grevenmacher bis zum 30. April 2015 zu beenden und die Niederlassung zu schließen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 30. April 2015.
<i>Für die Gesellschafti>
Référence de publication: 2015064950/15.
(150074422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
London Bridge Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 169.038.
Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Madame Catherine KOCH a démissionné de son mandat
de gérant de la Société avec effet au 30 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
London Bridge Investment Holdings S. à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015064951/14.
(150074811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Yaletown Acquiror S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.013.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 23 avril 2015i>
En date du 23 avril 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de catégorie B de la
Société avec effet au 30 avril 2015;
- de nommer Monsieur Elvin MONTES, né le 12 avril 1982 à Jiabong, Samar, Les Philippines, résidant à l'adresse
professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société
avec effet au 30 avril 2015 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes
clos au 31 décembre 2014.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Brian Niranjan SHETH, gérant de catégorie A
- Monsieur James Patrick HICKEY, gérant de catégorie A
- Monsieur Olivier HAMOU, gérant de catégorie B
- Monsieur Elvin MONTES, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Yaletown Acquiror S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015065356/25.
(150074175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
77051
L
U X E M B O U R G
Lorito L. Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 171.387.
Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Madame Catherine KOCH a démissionné de son mandat
de gérant de la Société avec effet au 30 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Lorito L. Holdings S.à r.l.
Référence de publication: 2015064953/13.
(150075037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
LF Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 3.000.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.908.
Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Madame Catherine KOCH a démissionné de son mandat
de gérant de la Société avec effet au 30 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
LF Real Estate S.à r.l.
Référence de publication: 2015064968/13.
(150075033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Bielefeld Boulevard Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 196.523.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-ninth day of April
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1.- Shihan Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered
office at 146, Wickhams Cay 1, BVI, Road Town Tortola, British Virgin Islands and registered with the Register of
Companies of the British Virgin Islands under number 208.951,
2.- KH III Properties 612 Limited, a private liability company, having its registered office at Elizabeth House, 9 Castle
Street, St. Helier, JE4 2QP, Jersey, United-Kingdom and registered at the Jersey Register of companies under number
117959,
both here represented by Mr. Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg,
by virtue of two powers of attorney delivered to him.
The said powers, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing, represented as stated here-above, have requested the officiating notary, to state as follows the articles of
association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration
1. Form. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially
the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies such as amended.
2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
77052
L
U X E M B O U R G
The object of the Company is also the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money. The Company can also perform in Luxembourg as well
as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which
are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and
companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and develop-
ment, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose.
The Company shall be considered as a financial participations company according to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favor its development or the extension of its operations.
3. Name. The private limited liable Company is incorporated under the name of Bielefeld Boulevard Holding S.ar.l..
4. Registered office.
4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members adopted in the manner
required for the amendment of the Articles.
4.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
5. Duration.
5.1. The Company is constituted for an undetermined period.
5.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.
Title II. Capital - Shares
6. Capital.
6.1. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.
6.2. Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
6.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.
7. Shares.
7.1. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or
in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
7.2. If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are
transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval
of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
7.3. In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on
commercial companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case
the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year
or of those of the last two financial years.
Title III. Management
8. Board of managers and powers of the board of managers.
8.1. The Company is managed by a sole manager or a board of managers composed of at least one class A manager and
one class B manager.
8.2. The manager(s) are appointed, and may be removed at any time ad nutum (without any reason), by a resolution of
the member(s) whom shall set the term of their office. The manager(s) need not be member(s).
77053
L
U X E M B O U R G
8.3. All powers not expressly reserved, by the Law or the present Articles, to the members fall within the competence
of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have
all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.4. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether members or
not, by the sole manager or, as the case may be, any class A manager jointly with any class B manager.
9. Procedures.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings
that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the
Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy
by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. No resolutions of the board of managers will be valid or effective without votes in favour of the relevant resolution
from at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions of the board of managers will
be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the sole
manager, or (ii) the joint signatures of any one class A manager and any one class B manager, save for administrative
matters, where the Company is bound towards third parties by the single signature of any manager but only for transactions
up to an amount of twenty thousand euros (EUR 20,000) on a per transaction basis and an amount of one hundred thousand
euros (EUR 100,000) on an annual aggregate basis, or (iii) by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom
such signatory power has been validly delegated in accordance with Article 8.4.
11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any
commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
12. Powers and voting rights.
12.1. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid law
of August 10
th
, 1915.
12.2. As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
12.3. In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by
the meeting.
Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions
13. Financial year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the
thirty-first December of each year.
14. Balance sheet. Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and
liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
15. Distributions. Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the
Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and
77054
L
U X E M B O U R G
for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual con-
tribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the
sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant
laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI. Dissolution
16. Dissolution.
16.1. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
16.2. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in
office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The
liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
16.3. The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII. General provisions
17. General provisions. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer
to the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, the appearing parties, prenamed and represented as stated hereabove, declare to have subscribed to the whole
share capital of the Company as follows:
1.- Shihan Holdings Limited, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 shares
2.- KH III Properties 612 Limited, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 shares
Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 shares
The subscribed share capital of the Company has been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the officiating notary,
who expressly acknowledges it.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2015.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.-
<i>Resolutions of the membersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the members, representing the entirety of the subscribed share
capital have unanimously passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr Isaac SCHAPIRA, born on 16 December 1952 in Jerusalem, Israel and residing at 2 Danescroft Gardens, London
NW4 2ND, United Kingdom, as class A manager;
b) Mr Patrice GALLASIN, born on 9 December 1970 in Villers-Semeuse, France and with professional address at 70,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, as class A manager;
c) Mr Andrew PETTIT, born on 7 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom and with professional address at 105
Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager; and
d) Mr Nicholas WEST, born on 17 May 1972 in Aylesbury, United Kingdom and with professional address at 105
Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager.
2. The registered office of the Company is set at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
77055
L
U X E M B O U R G
Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am neunundzwanzigsten April.
Vor uns, dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Sitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1.- Shihan Holdings Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach dem Recht der Britischen
Jungferninseln mit Sitz 146, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britischen Jungferninseln und eingetragen im Ge-
sellschaftsregister der Britischen Jungferninseln unter der Registernummer 208951, und
2.- KH III Properties 612 Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach dem Recht von Jersey,
mit Sitz Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier JE4 2QP, Jersey, eingetragen im Gesellschaftsregister Jersey unter der
Registernummer 117959
beide hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Angestellter, geschäftsansässig in Junglinster, 3, route de Luxemburg,
aufgrund von zwei (2) ihm ausgestellten Vollmachten
Besagte Vollmachten wurden nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten
Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlagen zu Registrierungszwecken beigefügt.
Die Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung zu beurkunden, welche hiermit gegründet wird:
Titel I. Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
1. Rechtsform. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet,
die durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung
geregelt wird.
2. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art, in
Luxemburg oder im Ausland, sowie dem Besitz, der Verwaltung, Entwicklung und Leitung ihres Portfolios. Die Gesell-
schaft kann Pfandbriefe, Obligationen, Schuldverschreibungen, Wertpapiere und Anleihen durch Zeichnung, Ankauf oder
in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise veräußern. Die Gesellschaft kann
zudem Anteile an Gesellschaften halten und ihre Geschäfte über Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland tätigen.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung
von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen, die Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen, die einem Immobilienhändler vorbehalten sind und die Platzierung von Geld und die Vermö-
gensverwaltung betreffen. Die Gesellschaft kann zudem, in welcher Form auch immer, sowohl in Luxemburg als auch im
Ausland, sämtliche Industrie-, Handels-, Finanz-, Immobiliar- oder Mobiliargeschäfte tätigen, die, ganz gleich auf welche
Art, direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung von Unternehmen und Gesellschaften in Ver-
bindung stehen, deren Zweck Aktivitäten jedweder Art als auch die dauerhafte oder zeitweilige Verwaltung und Entwick-
lung des eigens zu diesem Zweck geschaffenen Portfolios sein können. Die Gesellschaft wird gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen als Société de Participations Financières (Finanzbeteiligungsgesellschaft) gegründet.
Die Gesellschaft kann sich durch beliebige Mittel an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften beteiligen,
die einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck haben oder ihren Gesellschaftszweck fördern oder ihm nützlich
sind.
3. Name. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen Bielefeld Boulevard Holding
S.a r.l..
4. Sitz.
4.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt des Großherzogtums Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch
Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer innerhalb der gleichen Gemeinde ver-
legt werden. Der Gesellschaftssitz kann des Weiteren durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder gegebenenfalls
der Gesellschafter entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen an jeden anderen Ort im
Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
4.2. Niederlassungen und Tochtergesellschaften sowie Büros der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen
Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnet werden.
Sofern nach Ansicht des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführer außerordentliche politische oder militärische
Entwicklungen oder Umstände eingetreten sind oder einzutreten drohen, welche die normalen Aktivitäten der Gesellschaft
an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können oder die Kommunikation zwischen diesem und Personen im Ausland,
kann der Gesellschaftssitz zeitweise ins Ausland verlegt werden, bis die beeinträchtigenden Umstände nicht mehr gegeben
sind. Solche zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche auch bei
zeitweiliger Sitzverlegung ins Ausland eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
5. Dauer.
5.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
77056
L
U X E M B O U R G
5.2. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, den Verlust der Geschäfts-
fähigkeit, die Insolvenz eines Gesellschafters oder mehrerer Gesellschafter oder ähnlicher Ereignisse aufgelöst
Titel II. Stammkapital - Gesellschaftsanteile
6. Stammkapital.
6.1. Das Kapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in ein-
hundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle vollständig gezeichnet
und eingezahlt.
6.2. Jeder Anteil berechtigt im direkten Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile zur Beteiligung am Vermögen
und an den Gewinnen der Gesellschaft.
6.3. Das Kapital der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch den Beschluss des alleiniges Gesellschafters oder gege-
benenfalls der Gesellschafterversammlung entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen
erhöht oder verringert werden.
7. Gesellschaftsanteile.
7.1. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den alleinigen Gesellschafter sowie die Übertragung von An-
teilen durch Erbschaft oder durch Auflösung einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
7.2. Bei mehreren Gesellschaftern sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen an
Nichtgesellschafter sind nur mit vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern möglich, die wenigstens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten. Auf die gleiche Weise können im Todesfall die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit
Zustimmung der Anteilsbesitzer übertragen werden, die mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile
vertreten.
7.3. Bei einer Anteilsübertragung gemäß den Bestimmungen des Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäftsjahre
berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten oder
der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
Titel III. Geschäftsführung
8. Geschäftsführung und Befugnisse.
8.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern muss sich
die Geschäftsführung aus wenigstens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B
zusammensetzen.
8.2. Der oder gegebenenfalls die Geschäftsführer können bestellt und zu jeder Zeit ad nutum per Gesellschafterbeschluss
abberufen werden. Der oder die Gesellschafter legen den Bestellungszeitraum der Geschäftsführer fest, die keine Gesell-
schafter sein müssen.
8.3. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich kraft Gesetzes oder vorliegender Artikel den Gesellschaftern vorbehalten
sind, fallen in den Kompetenzbereich des oder gegebenenfalls der Geschäftsführer, die mit allen Vollmachten ausgestattet
sind, um jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im
Einklang stehen.
8.4. Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - jeder Geschäftsführer der Kategorie A kann zusammen
mit jedem Geschäftsführer der Kategorie B besondere oder begrenzte Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten an einen
oder mehrere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Gesellschafter sein müssen.
9. Form, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.
9.1. Die Geschäftsführerversammlung tritt sooft zusammen, wie es erforderlich ist, oder bei Einberufung durch einzelne
Geschäftsführer, an einem Ort, der in der Einberufungsmitteilung angegeben ist.
9.2. Einberufungsmitteilungen für Geschäftsführerversammlungen müssen allen Geschäftsführern wenigstens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der jeweiligen Geschäftsführerversammlung schriftlich zugehen. In dringenden Fällen können
sie kurzfristiger einberufen werden, wobei die Umstände der Dringlichkeit in der Einberufungsmitteilung für die Ge-
schäftsführerversammlung dargelegt werden müssen.
9.3. Eine schriftliche Einberufungsmitteilung ist nicht erforderlich, wenn auf der Geschäftsführerversammlung alle
Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, und wenn sie erklären, ordnungsgemäß informiert worden
zu sein und eine vollständige Kenntnis der Tagesordnung zu haben. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann auf die
Einberufungsmitteilung verzichten und seine Zustimmung schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex,
Telefax oder E-Mail geben. Gesonderte schriftliche Einberufungsmitteilungen sind nicht erforderlich, wenn der jeweilige
Einberufungstermin und -ort in einem Zeitplan erfasst und zuvor per Geschäftsführerbeschluss angenommen wurde.
9.4. Jeder Geschäftsführer kann jeden anderen Geschäftsführer schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm,
Teletex, Telefax oder E-Mail als seinen Bevollmächtigten bestellen. Ein Geschäftsführer kann auch telefonisch durch einen
anderen Geschäftsführer zum Bevollmächtigten bestellt werden, wobei eine solche Bestellung anschließend schriftlich
bestätigt werden muss.
77057
L
U X E M B O U R G
9.5. Geschäftsführerbeschlüsse sind weder gültig noch wirksam, wenn nicht wenigstens ein (1) Geschäftsführer der
Kategorie A und wenigstens ein (1) Geschäftsführer der Kategorie B ihre Stimmen zugunsten des betreffenden Beschlusses
abgegeben haben. Die Geschäftsführerbeschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten und von allen auf der Geschäfts-
führerversammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer unterzeichnet.
9.6. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Geschäftsführerversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder ähn-
lichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, die es allen Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu identifizieren, zu hören
und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerversammlung mit ebensolchen Kommunikations-
mitteln wird wie die persönliche Teilnahme des jeweiligen Geschäftsführers an einer Geschäftsführerversammlung
bewertet.
9.7. Zirkularbeschlüsse, die durch alle Geschäftsführer unterzeichnet wurden, sind in gleichem Maße rechtsverbindlich
und gültig wie Geschäftsführerbeschlüsse, die auf einer ordnungsmäßig einberufenen und gehaltenen Geschäftsführerver-
sammlung gefasst wurden. Dabei können die Unterschriften auf einem einzigen Dokument oder auf mehrfachen Ausfer-
tigungen eines identischen Beschlusses erscheinen und schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex,
Telefax oder E-Mail nachgewiesen werden.
10. Vertretung. Die Gesellschaft wird in allen Gelegenheiten gegenüber Dritten durch die (i) Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers oder (ii) die gemeinschaftliche Unterschrift jeweils eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines
Geschäftsführers der Kategorie B rechtskräftig verpflichtet. In Bezug auf administrative Angelegenheiten hingegen wird
die Gesellschaft gegenüber Dritten entweder durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtkräftig
verpflichtet, und zwar für Transaktionen bis zu einem Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000) je Ge-
schäftsvorgang und einem Betrag in Höhe von einhunderttausend (EUR 100.000) pro Jahr, oder (iii) durch die alleinige
oder die gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, welchen eine Vertretungsvollmacht gemäß Artikel
8.4 rechtswirksam übertragen wurde.
11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer übernehmen im Rahmen ihres Mandats keine persönliche Haftung
in Bezug auf von ihnen im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangene Verpflichtungen, sofern solche Verpflichtung
im Einklang sowohl mit dieser Satzung als auch mit den anzuwendenen gesetzlichen Bestimmungen steht.
Titel IV. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesellschafter
12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1 Der alleinige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind und
die im Einklang mit dem vorbenannten Gesetz vom 10. August 1915 stehen.
12.2 Demzufolge werden alle Entscheidungen vom alleinigen Gesellschafter getroffen, die die Befugnisse des oder der
Geschäftsführer überschreiten.
12.3 Bei mehreren Gesellschaftern werden die Entscheidungen durch die Gesellschafterversammlung getroffen, wenn
diese die Befugnisse des oder der Geschäftsführer überschreiten.
Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
13. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
14. Bilanz. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird per einunddreißigsten Dezember durch die Geschäftsführung
eine Bilanz, welche das Inventar der Aktiva und Passiva zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf-
gestellt.
Der Saldo dieser Gewinn- und Verlustrechnung entspricht nach Abzug der Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen
und Rückstellungen dem Nettogewinn der Gesellschaft.
15. Gewinnverteilung. Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen
Rücklage der Gesellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem
gegebenen Zeitpunkt und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Rücklage unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals
fallen, so muss die jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden, bis die gesetzliche Rücklage wieder
ein Zehntel des Kapitals beträgt.
Der verbleibende Gewinn wird an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an die Gesellschafter ausgeschüttet.
Jedoch kann der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls die Gesellschafterversammlung durch Mehrheitsbeschluss
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auch entscheiden, dass der verbleibende Gewinn, nach Abzug jeglicher Rücklagen,
auf das folgende Jahr vorgetragen wird oder einer außerordentlichen Rücklage zugeführt wird.
Titel VI. Auflosung
16. Auflosung.
16.1. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Insolvenz, die gerichtliche Entmündigung oder den
Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
77058
L
U X E M B O U R G
16.2. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird diese Auflösung vom alleinigen Geschäftsführer oder gegebe-
nenfalls von den Geschäftsführern im Amt oder, sofern dies nicht möglich ist, von einem oder mehreren Insolvenzver-
waltern durchgeführt, die vom alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannt wurden. An den oder
die Insolvenzverwalter werden zur Abwicklung der Vermögenswerte und Schulden die ausgedehntesten Befugnisse über-
tragen.
16.3. Die Vermögenswerte werden nach Abzug aller Schulden an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgeschüttet.
Titel VII. Allgemeine Bestimmungen
17. Allgemeine Bestimmungen. Überall dort, wo vorliegende Satzung einzelne Fälle nicht ausdrücklich regelt, finden
die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils
gültigen Fassung Anwendung.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Erschienenen, vorgenannt und vertreten wie oben angegeben, erklären alle Anteile der Gesellschaft wie folgt ge-
zeichnet zu haben:
1.- Shihan Holdings Limited, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Anteile
2.- KH III Properties 612 Limited, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Anteile
Gesamt: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile
Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft wurde vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft
der Betrag in Höhe von zwolftausendfunfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche im
Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500.- EUR.
<i>Beschlüssei>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft fassen die Gesellschafter, welche das gesamte Stammkapital der Gesellschaft
vertreten, folgende Beschlüsse:
1. Es werden zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
a) Herr Isaac SCHAPIRA, geboren am 16. Dezember 1952 in Jerusalem, Israel und wohnhaft 2 Danescroft Gardens,
London NW4 2ND, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie A;
b) Herr Patrice GALLASIN, geboren am 9. Dezember 1970 in Villers-Semeuse, Frankreich und geschäftsansässig 70,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Geschäftsführer der Kategorie A;
c) Herr Andrew PETTIT, geboren am 7. März 1968 in Cleethorpes, Vereinigtes Königreich und geschäftsansässig 105
Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B; und
d) Herr Nicholas WEST, geboren am 17. Mai 1972 in Aylesbury, Vereinigtes Königreich und geschäftsansässig 105
Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B.
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1470 Luxemburg, 70, route d'Esch.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig und mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Wunsch der Erschienenen auf Englisch abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass
im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung der Urkunde durch den Notar haben der Bevollmächtigte der Erschienenen zusammen mit uns, dem
unterzeichneten Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 avril 2015. Relation GAC/2015/3706. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
Référence de publication: 2015066867/407.
(150077539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.
77059
L
U X E M B O U R G
LIBF (I) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 16.000,00.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 161.994.
Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Madame Catherine KOCH a démissionné de son mandat
de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
LIBF (I) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015064970/14.
(150074838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
LMF Lux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164A, rue de Belvaux.
R.C.S. Luxembourg B 106.118.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Laurent Martin
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015064971/12.
(150074316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
LO Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4960 Clémency, 2, rue de Bascharage.
R.C.S. Luxembourg B 180.553.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015064972/9.
(150074473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Pearl JV Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 195.698.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale de la société en date du 28 avril 2015i>
L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer Monsieur Arnold Louis Spruit, né le 13 octobre 1971 à Wim-
bledon, Royaume-Uni, résidant au 15a rue Langheck à, L-5410 Beyren, Luxembourg, en tant que gérant de la Société ayant
un pouvoir de signature A, avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
A compter du 28 avril 2015, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Pierre METZLER, en tant que gérant ayant un pouvoir de signature A;
- M. Arnold SPRUIT, en tant que gérant ayant un pouvoir de signature A;
- Mme Mary Ann SIGLER, en tant que gérant ayant un pouvoir de signature B.
- Mme Eva Monica KALAWSKI, en tant que gérant ayant un pouvoir de signature B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2015.
Référence de publication: 2015065105/19.
(150074817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
77060
L
U X E M B O U R G
Loevarth Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 133.107.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2015i>
Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société LOEVARTH
INVEST S.A., la fiduciaire FGA (Luxembourg) S.A., 53 Route d'Arlon, L-8211 Mamer, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.096, inscrite à l'Ordre des Expert-Comptables de Luxem-
bourg.
Référence de publication: 2015064973/12.
(150074495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Logiver S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 87.518.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 19 mars 2015i>
L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs sortant pour un terme annuel, leur mandat expirant lors
de l'assemblée générale de 2016:
- Monsieur Alain GEORGES, docteur en droit, demeurant à L-1457 Luxembourg, 72A, rue des Eglantiers;
- Monsieur André VERDICKT, ingénieur, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling;
- Monsieur Jean-Jacques VERDICKT, ingénieur, demeurant à B-1428 Braine-l'Alleud, 16, rue Comte Jacques de Meeus,
(Belgique);
- Monsieur Daniel VAN HOVE, ingénieur, demeurant à L-1314 Luxembourg, 6, rue G. Capus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015064974/17.
(150074063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
LSREF3 Eve Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 188.002.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 30 avril 2015.
Référence de publication: 2015064978/10.
(150074358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Yaletown Collector Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 742.440,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 167.993.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 23 avril 2015i>
En date du 23 avril 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de catégorie B de la
Société avec effet au 30 avril 2015;
- de nommer Monsieur Elvin MONTES, né le 12 avril 1982 à Jiabong, Samar, Les Philippines, résidant à l'adresse
professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société
avec effet au 30 avril 2015 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes
clos au 31 décembre 2014.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Brian Niranjan SHETH, gérant de catégorie A
- Monsieur James Patrick HICKEY, gérant de catégorie A
77061
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Olivier HAMOU, gérant de catégorie B
- Monsieur Elvin MONTES, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Yaletown Collector Co S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015065358/25.
(150074338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Profconsult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 143.809.
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am neunten April.
Vor Notar Henri HELLINCKX, im Amtssitze zu Luxemburg,
Ist erschienen
Die Aktiengesellschaft SILK ROAD GROUP S.A., mit Sitz in L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaue, (RCS Lu-
xembourg B 81231),
hier vertreten durch Herrn Michael ERNZERHOF, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
Welche Erschienene erklärt alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „PROFCONSULT S.à
r.l.“, mit Sitz in Luxemburg, zu sein. Die Gesellschaft wurde gegründet laut notarieller Urkunde vom 15. Dezember 2008,
veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 22. Januar 2009, Nummer 148. Die Satzung
wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 24. Juni 2010, veröffentlicht im Mémorial,
Recueil Spécial C, Nummer 2149 vom 12. Oktober 2010.
Die Erschienene ersuchte den Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft von L-5542 Roedt, 54 nach L-1650 Luxemburg, 6, avenue
Guillaume zu verlegen.
<i>Zweiter Beschluss:i>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 2, Absatz 1, der Satzung wie folgt abgeändert:
„ Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Gezeichnet: M. ERNZERHOF und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 15 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/11646. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 5. Mai 2015.
Référence de publication: 2015066579/35.
(150076124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2015.
Luxempart, Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 27.846.
La ‘liste des personnes autorisées à signer’ a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015064982/9.
(150074783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
77062
L
U X E M B O U R G
Mylan Luxembourg 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 28.452,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 154.100.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 23 avril 2015i>
En date du 23 avril 2015, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de classe B de la Société
avec effet au 30 avril 2015;
- de nommer Monsieur Elvin MONTES, né le 12 avril 1982 à Jiabong, Samar, Les Philippines, résidant à l'adresse
professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de la Société
avec effet au 30 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Alan Roy WEINER, gérant de classe A
- Madame Nadine GUIGUE, gérant de classe A
- Monsieur Olivier HAMOU, gérant de classe B
- Monsieur Elvin MONTES, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Mylan Luxembourg 8 S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015065015/24.
(150074081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Lynckx Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 129.724.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015064984/10.
(150074502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Novocure Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 14.508.001,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.966.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 30 avril 2015i>
En date du 30 avril 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de classe B de la Société
avec effet au 30 avril 2015;
- de nommer Monsieur Olivier HAMOU, né le 19 décembre 1973 à Levallois-Perret, France, résidant à l'adresse pro-
fessionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec
effet au 30 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Asaf DANZIGER, gérant de classe A
- Monsieur Wilco GROENHUYSEN, gérant de classe A
- Monsieur Olivier HAMOU, gérant de classe B
- Madame Véronique NAHOE, gérant de classe B
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg.
77063
L
U X E M B O U R G
L'adresse professionnelle de Monsieur Wilco GROENHUYSEN, gérant de classe A de la Société, est désormais la
suivante:
- 20, Valley Stream Parkway, Suite 300 Malvern, Pennsylvanie 19355, Etats Unis d'Amérique
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2015.
Novocure Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015067260/29.
(150077152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2015.
M-Square Finance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 82.901.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que le commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE SEVE S.A., inscrite sous le numéro RCS B 82421 et ayant
son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, a changé de dénomination en date du 14 juin 2013 et
porte désormais la dénomination FIDUSEVE S.A.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour M-Square Finance S.A. SPFi>
Référence de publication: 2015064985/15.
(150074665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
ManageMySelf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 163.464.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 29 avril 2015.
Référence de publication: 2015064987/10.
(150074052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Marble Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 186.616.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015064990/10.
(150075023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Marsaco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 169.809.
Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Madame Catherine KOCH a démissionné de son mandat
de gérant B de la Société avec effet au 30 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
77064
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Marsaco S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015064992/14.
(150074482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Mathy Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 105.379.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2015i>
Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société MATHY
INVEST S.A., la fiduciaire FGA (Luxembourg) S.A., 53 Route d'Arlon, L-8211 Mamer, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.096, inscrite à l'Ordre des Expert-Comptables de Luxem-
bourg.
Référence de publication: 2015064993/12.
(150074532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Mt. Kailash S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 187.065.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique daté du 10 avril 2015i>
En date du 10 avril 2015 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- Acceptation de la démission de Madame Min HE en tant que Gérante de classe A de la Société et ce avec effet immédiat.
- Nomination de Madame Yi DENG, née le 11 janvier 1975, à Sichuan (Chine), demeurant au 1, Jing Shan West Street,
100009 Xicheng District, Pékin (Chine), en tant que Gérante de classe A de la Société avec effet immédiat. Son mandat
aura une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2015.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015065006/18.
(150074781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
MaForm Holding Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 193.839.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015064994/9.
(150074914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
MaForm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 91.031.210,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 193.855.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015064995/9.
(150074913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
77065
L
U X E M B O U R G
Media Vision S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 183.047.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 23 avril 2015i>
En date du 23 avril 2015, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de catégorie B de la
Société avec effet au 30 avril 2015;
- de nommer Monsieur Olivier HAMOU, né le 19 décembre 1973 à Levallois-Perret, France, résidant à l'adresse pro-
fessionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société
avec effet au 30 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Fardad ZABETIAN, gérant de catégorie A
- Monsieur Olivier HAMOU, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Media Vision S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015064996/22.
(150074078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Mirko S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 190.224.
Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Madame Catherine KOCH a démissionné de son mandat
de gérant B de la Société avec effet au 30 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Mirko S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015065003/14.
(150074485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Munawwar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 141.384.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 11 février 2015i>
En date du 11 février 2015, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.,
ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le
numéro B 103.123 a été nommée pour une durée indéterminée à la fonction de dépositaire, en application des dispositions
de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions
nominatives et du registre des actions au porteur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015065007/17.
(150074278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
77066
L
U X E M B O U R G
Melville Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 190.883.
Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Madame Catherine KOCH a démissionné de son mandat
de gérant de la Société avec effet au 30 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Melville S.à r.l.
Référence de publication: 2015064999/13.
(150075034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Milano Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 117.787.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Soak Trust S.A.
Signature
Référence de publication: 2015065001/12.
(150074934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Milano Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 117.787.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Soak Trust S.A.
Signature
Référence de publication: 2015065002/12.
(150074935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Misys Newco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 8.421.353,81.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 167.479.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 23 avril 2015i>
En date du 23 avril 2015, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de catégorie B de la
Société avec effet au 30 avril 2015;
- de nommer Monsieur Elvin MONTES, né le 12 avril 1982 à Jiabong, Samar, Les Philippines, résidant à l'adresse
professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société
avec effet au 30 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Donald PARK, gérant de catégorie A
- Monsieur Olivier HAMOU, gérant de catégorie B
- Monsieur Elvin MONTES, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
77067
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Misys Newco S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015065004/23.
(150074612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Munich Holdings II Corporation, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 28.807.815,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 171.633.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 24 avril 2015 que:
- Monsieur Alexis de Montpellier d'Annevoie a démissionné de ses fonctions en tant que Gérant de type B de la Société
avec effet au 30 avril 2015.
- Monsieur Herman Schommarz, né le 20 novembre 1970 à Amersfoort, Afrique du Sud et résidant professionnellement
au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach a été nommé Gérant de type B avec effet au 30 avril 2015 et ce, pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 30 avril 2015.
Référence de publication: 2015065008/17.
(150074421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Mylan Luxembourg 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 155.120.
Il ressort d'une lettre de démission adressée à la Société que Madame Catherine KOCH a démissionné de son mandat
de gérant de classe B de la Société avec effet au 30 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Mylan Luxembourg 9 S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015065016/14.
(150074214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Mahkota S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 127.264.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 12 février 2015i>
En date du 12 février 2015, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.,
ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le
numéro B 103.123 a été nommée pour une durée indéterminée à la fonction de dépositaire, en application des dispositions
de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions
nominatives et du registre des actions au porteur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015065018/17.
(150074277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
77068
L
U X E M B O U R G
MAN Finance and Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 134.225.
Der Jahresabschluss vom 31/12/2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015065019/9.
(150074761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
MAN Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 183.299.
Der Jahresabschluss vom 31/12/2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015065020/9.
(150074760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Valorem Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 90.422.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 4 novembre 2014i>
L'assemblée décide à l'unanimité des voix la reconduction des mandats de M. Robert Boutonnet, M. Bernard Balestier,
M. Michael Boxford et M. Pierre Delandmeter en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire en 2015.
L'assemblée nomme Mme Julia Felicia Boutonnet, née le 8 janvier 1974 à Neuilly-sur-Seme avec adresse au Parc du
Château -Banquet 14, CH 1202 Genève, en qualité d'administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2015.
L'assemblée renouvelle le mandat de la Fiduciaire Vincent La Mendola, 4, place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg
en qualité de Commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015.
Luxembourg, le 22 Décembre 2014.
<i>Pour VALOREM INVESTISSEMENTS S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015065333/19.
(150074445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Mac's Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 152.901.
In the year two thousand and fifteen, on the fourteenth day of April,
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Mac’s Luxembourg, a société à responsabilité limitée, duly
incorporated and validly existing under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 2,700,000,
having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with
the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Register of Trade and Companies) under number B 152.901.
There appeared:
- 9121-2738 Québec Inc., a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the province of Québec,
Canada, with registered office at 4204, boulevard Industriel, CDN - H7L 0E3 Laval, Québec, Canada and registered with
the Registre des Entreprises du Québec under number 1161060372;
here represented by Mr Max Mayer, employee, residing professionally in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, by
virtue of a power of attorney;
and
77069
L
U X E M B O U R G
- Mac's Convenience Stores Inc., a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of Canada, with
registered office at 305, avenue Milner, bâtiment Bureau 400, CDN - M1B 3V4 Toronto, Ontario, Canada and registered
with the RCS Ontario under number 12649464;
here represented by Mr Max Mayer, employee, residing professionally in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, by
virtue of a power of attorney;
(the “Shareholders”).
The said powers of attorney, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The 2,650,000 (two million six hundred and fifty thousand) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and the 50,000
(fifty thousand) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”) representing the whole share capital of the Company
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholders have been
duly informed.
The Shareholders through their proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of USD 50,000 so as to reduce it from its current amount
of USD 2,700,000 to an amount of USD 2,650,000;
2. Redemption and cancellation of 50,000 mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of USD 1.-
each, in accordance with article 10 of the articles of association of the Company; and
3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been unanimously taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of USD 50,000 (fifty thousand US Dollars) so
as to reduce it from USD 2,700,000 (two million seven hundred thousand US Dollars) to USD 2,650,000 (two million six
hundred and fifty thousand US Dollars) by the redemption of all the 50,000 (fifty thousand) MRPS currently owned by
Mac's Convenience Stores Inc., prenamed, and all rights attached thereto, in accordance with article 10 of its articles of
association.
<i>Second resolutioni>
All the conditions of article 10 of the articles of association of the Company being met, it is resolved to redeem all the
50,000 (fifty thousand) MRPS with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, followed by the cancellation such
50,000 (fifty thousand) MRPS redeemed in accordance with article 10 of the articles of association of the Company and
to reimburse Mac's Convenience Stores Inc., prenamed.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is resolved to amend articles 6, 10, 19 and 23 of the articles of association
of the Company to read as follows:
“ Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at USD 2,650,000 (two million six hundred and fifty thousand US
Dollars) represented by 2,650,000 (two million six hundred and fifty thousand) ordinary shares (the “Ordinary Shares” or
the “Shares”) with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, fully paid-up.
Whereas the Company has mandatory redeemable preferred shares (or “MRPS”) in issue, any references to MRPS are
applicable to that type shares.
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of
plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital.”
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital decrease, have been estimated at about EUR 1,300.-.
The capital decrease of the corporate capital is valued at EUR 47,240.50-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
77070
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mil quinze, le quatorzième jour d’avril,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire des associés de Mac’s Luxembourg, une société à responsabilité limitée dûment
constituée et existant valablement conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, au capital social de 2.700.000
USD ayant son siège social au 5, rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 152.901
Ont comparu:
- 9121-2738 Québec Inc, une société (corporation) dûment constituée et existant valablement selon les lois de la Province
du Québec, Canada, ayant son adresse au 4204, boulevard Industriel, CDN - H7L 0E3 Laval, Québec, Canada et imma-
triculée auprès du Registre des Entreprises du Québec sous le numéro 1161060372;
ici représentée par Mr Max Mayer, demeurant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
et
- Mac’s Convenience Stores Inc, une société (corporation) dûment constituée et existant valablement selon les lois du
Canada, ayant son adresse au 305, avenue Milner, bâtiment Bureau 400, CDN - M1B 3V4 Toronto, Ontario, Canada et
immatriculée auprès du RCS Ontario sous le numéro 12649464;
ici représentée par Mr Max Mayer, demeurant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
(les «Associés»).
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur, resteront annexées au présent acte aux fins d’enregistrement.
Les 2.650.000 (deux millions six cent cinquante mille) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et les
50.000 (cinquante mille) parts sociales préférentielles à rachat obligatoire (les «MRPS») représentant l'intégralité du capital
social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour, dont les Associés ont été dûment informés.
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social de la Société à concurrence d’un montant de 50.000 USD, pour le réduire de 2.700.000
USD à 2.650.000 USD;
2. Rachat et annulation de 50.000 parts sociales préférentielles à rachat obligatoire ayant une valeur nominale de 1 USD
chacune conformément à l’article 10 des statuts de la Société; et
3. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société.
Après que l’agenda a été approuvé par les Associés, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de réduire le capital social de la Société à concurrence d’un montant de 50.000 USD (cinquante mille Dollars
américains), afin de le réduire de 2.700.000 USD (deux millions sept cent mille Dollars américains) à 2.650.000 USD (deux
millions six cent cinquante mille Dollars américains) par le rachat de 50.000 MRPS actuellement détenus par Mac’s Con-
venience Stores Inc, prénommée, et tous droits y attachés, conformément à l’article 10 des statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
Toutes les conditions de l’article 10 des statuts de la Société étant réunies, il est décidé de racheter l’ensemble des 50.000
(cinquante mille) MRPS avec une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, suivi par l’annulation desdites
50.000 (cinquante mille) MRPS rachetées conformément à l’article 10 des statuts de la Société et de rembourser Mac’s
Convenience Stores Inc. prénommée.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des décisions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de les lire
comme suit:
« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 2.650.000 USD (deux millions six cent cinquante mille Dollars américains)
représenté par 2.650.000 (deux millions six cent cinquante mille) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales») ayant une
valeur nominale de 1 USD chacune, entièrement libérées.
Lorsque la Société a émis des parts sociales préférentielles à rachat obligatoire (ou «MRPS»), toutes les références aux
MRPS sont applicables à ce type de parts sociales.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par
résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.»
77071
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou
qui sont mis à sa charge en raison de la réduction de son capital, s'élève à environ 1.300.- EUR.
Le montant de réduction du capital social est évalué à 47.250,50- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max Mayer, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 21 avril 2015. Relation GAC/2015/3008. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015066495/141.
(150075965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2015.
Marine Participations SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 97.632.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2015i>
Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société MARINE
PARTICIPATIONS S.A., la fiduciaire FGA (Luxembourg) S.A., 53 Route d'Arlon, L-8211 Mamer, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.096, inscrite à l'Ordre des Expert-Comptables
de Luxembourg.
Référence de publication: 2015065023/12.
(150074533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Matma S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 64.738.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que le commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE SEVE S.A., inscrite sous le numéro RCS B 82421 et ayant
son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, a changé de dénomination en date du 14 juin 2013 et
porte désormais la dénomination FIDUSEVE S.A.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour Matma S.A.i>
Référence de publication: 2015065024/15.
(150074667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Mayhill Investments Limited S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 179.574.
<i>Extrait des Résolutions de l'actionnaire uniquei>
<i>Première résolutioni>
Le siège social de la Société est transféré du 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg au 41, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg avec effet au 27 avril 2015.
<i>Deuxième résolutioni>
La démission de Madame Kalliopi FOURNARI et de Madame Régine BARBIER de leur mandat d'administrateur en
date du 27 avril 2015 est acceptée.
77072
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
- Madame Isabelle SCHUL, employée privée, née le 30 janvier 1968 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement
au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et
- Monsieur Alain RENARD, administrateur de sociétés, né le 18 juillet 1963 à Liège (Belgique), demeurant, 17, Rue
Eisenhower, L-8321 Olm
sont nommés administrateurs de la Société pour une période de 4 ans, à savoir, jusqu'à l'assemblée générale statutaire
qui se tiendra en 2019 en remplacement de Madame Kalliopi FOURNARI et de Madame Régine BARBIER.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est pris connaissance du changement d'adresse de Monsieur Christian FRANÇOIS, administrateur et président du
conseil d'administration de la société qui est désormais, 356, route de Diekirch, B-6700 Frassem.
Le 27 avril 2015.
Certifié sincère et conforme
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015066516/27.
(150076035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2015.
Matro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 128.541.
Par la présente, je tiens à vous faire part de ma décision de démissionner avec effet au 16.10.2014, de mon mandat
d'Administrateur de la Société MATRO S.A. RCS B 128541.
Luxembourg, le 30.04. 2014.
Alexander TKACHENKO.
Référence de publication: 2015065026/10.
(150074626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Matro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 128.541.
Par la présente je tiens à vous faire part de ma décision de démission en tant que commissaire aux comptes de la de la
Société MATRO S.A. RCS B 128541 avec effet au 16.10.2014.
Luxembourg, le 30.04.2015
EZD S.à r.l.
Maria Tkachenko
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015065027/13.
(150074626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
Matro S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 128.541.
Par la présente, nous dénonçons le siège social 4, Rue Jean Engling L-1466 Luxembourg de Matro S.A., Société Ano-
nyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 128541, avec effet au
16.10.2014.
Luxembourg, le 30.04.2015.
Ziffer S.àr.l.
Maria Tkachenko
Référence de publication: 2015065028/12.
(150074795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
77073
L
U X E M B O U R G
Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 162.534.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 28 avril 2015i>
L'associé unique de la Société:
- approuve le rapport du commissaire à la liquidation de la Société;
- donne décharge aux gérants, au commissaire à la liquidation et au liquidateur de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 28 avril 2015;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse
suivante: 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l. en liquidation volontaire
Signature
Référence de publication: 2015065727/19.
(150075497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2015.
MC Diamond s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 184.606.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/04/2015i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 30 avril 2015 que:
L'assemblée décide à l'unanimité de:
1) Transférer le siège social du L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers au L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveu-
gle, avec effet immédiat.
2) Divers
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.
Luxembourg, le 30 avril 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015065029/17.
(150074773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
MDC Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: ZAR 1.006.370,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, bouleard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 134.988.
<i>Extrait des résolutions des gérants prises par voie circulaire en date du 23 avril 2015i>
Les gérants de la Société ont décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la Société du 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, vers le 11-13 Boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 30 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MDC Holdco S.àr.l.
Société à Responsabilité Limitée
Référence de publication: 2015065030/15.
(150074136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
77074
L
U X E M B O U R G
Peehold S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 95.066.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 22 avril 2015i>
1. Mr Hans DE GRAAF a démissionné de son mandat d'administrateur et de président du conseil d'administration.
2. Mr Roeland DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Hilversum (Pays-Bas), le 23 décembre 1985, demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert 6 (Luxembourg), a été nommé comme administrateur et
président du Conseil jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020.
3. La société à responsabilité limitée Comcolux S.à r.l. a été renouvelée dans son mandat de commissaire aux comptes
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020.
1. Veuillez noter que l'adresse de Mme Monique JUNCKER, administrateur, se situe désormais au 6, rue Eugène Rup-
pert, L-2453, Luxembourg.
2. Veuillez noter que l'adresse de la société à responsabilité limitée Comcolux S.à r.l. se situe désormais au 19, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 avril 2015.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Peehold S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015065106/22.
(150074045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.
CBS Showtime - CBS-Lux Holding LLC S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 153.329.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of April,
before Maître Edouard Delosch notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
1. CBS-LUX HOLDING LLC, a limited liability corporation incorporated and existing under the laws of Delaware,
having its registered office at 2711, Centerville Road, USA - 19808 Wilmington, registered with the Delaware Division of
Corporation under number 4819356, acting as general partner,
here represented by Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 27
April 2015; and
2. CBS WORLDWIDE LTD., a limited company incorporated and existing under the laws of Bermuda, having its
registered office at Cumberland House, 1 Victoria Street, 9
th
Floor, Hamilton HM12 Bermuda, acting as general partner
and on behalf of PTC HOLDINGS C.V., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Netherlands,
having its address at 1017 AZ Amsterdam, the Netherlands, Singel 540, 5
th
floor, registered at the Rotterdam Chamber of
Commerce under number 24410683, acting as limited partner,
here represented by Julia Szafranska, lawyer professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 27
April 2015;
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing parties (together referred to as the “Partners”) represent the entire capital of CBS SHOWTIME - CBS-
LUX HOLDING LLC S.C.S., a société en commandite simple incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, and registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies’ Register under number B 153.329, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 10 May 2010, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on 20 July 2010 number 1488 (hereafter the “Partnership”). The articles of association
of the Partnership have not been amended since.
The Partners have waived any notice requirement.
The appearing parties requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Approval of the amendment and full restatement of the limited partnership agreement of the Partnership (it being
specified that the form and purpose of the Partnership are not amended).
77075
L
U X E M B O U R G
2. Miscellaneous.
The appearing parties, represented as stated above, representing the entire capital of the Partnership, unanimously take
the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Partners resolve to amend and full restate the limited partnership agreement of the Partnership (it being specified
that the form and purpose of the Partnership are not amended), which shall henceforth read as follows:
“Limited Partnership Agreement
Art. 1. Formation. There is hereby established a société en commandite simple (hereinafter the "Partnership"), which
shall be governed by the laws pertaining to such an entity and in particular Articles 16 through 22 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended thereafter (hereinafter the "Law"), as well as the present limited partnership
agreement (hereinafter the "Limited Partnership Agreement"), between:
1. CBS-LUX HOLDING LLC, aforementioned, as the sole general partner of the Partnership (hereinafter the "General
Partner"),
and
2. CBS WORLDWIDE LTD., aforementioned, acting as general partner of PTC HOLDINGS C.V., aforementioned,
and on behalf of PTC HOLDINGS C.V., as the sole limited partner of the Partnership (hereinafter the "Limited Partner").
(hereinafter together referred as to the "Partners")
Art. 2. Name. The Partnership's name shall be "CBS SHOWTIME - CBSLUX HOLDING LLC S.C.S."
Art. 3. Purpose. The Partners have organized the Partnership for the purpose of carrying on as a business in common,
with a view to profit, investment business and including the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in
companies or undertakings in any form whatsoever and the management of such participations.
The Partnership will in particular acquire intra-group license agreements and related receivable and payable and will
carry out and manage intragroup licensing activities.
The Partnership may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares,
and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally
any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,
development, management and control of any company or undertakings. It may further invest in the acquisition and ma-
nagement of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Partnership may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities. The Partnership may lend funds including the proceeds of any
borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries and affiliated companies. It may also give guarantees and
grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies
or any other company. The Partnership may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over
some of its assets and shall open bank accounts in its name.
The Partnership may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Partnership against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.
The Partnership may carry out any commercial or financial transactions with respect to movables or immovables, which
are directly or indirectly connected with the Partnership's purpose.
The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 4. Registered address. The registered address of the Partnership is established in Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg. The registered address may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision
of the Partners.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered address, or with easy communication between this address and abroad, the registered address may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Partnership. Such declaration of the transfer of
the registered address shall be made and brought to the attention of third parties by the General Partner(s).
Art. 5. Duration. The Partnership is established for an unlimited duration.
The existence of the Partnership does not terminate by the death, suspension of civil rights, resignation, dissolution,
bankruptcy or insolvency of the General Partner, in which case it shall be replaced, or, in case of a plurality of General
Partners, any of the General Partners, provided that the Partnership shall have at least one General Partner and one Limited
Partner.
77076
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Capital, Contributions. The Partnership's capital is initially set at one thousand US Dollars (USD 1,000), repre-
sented by one hundred thousand (100,000) partnership interests with a nominal value of one US Cent (USD 0.01) each (the
"Partnership Interests" and individually, a "Partnership Interest").
The General Partner owns one (1) Partnership Interest of the Partnership.
The Limited Partner owns ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (99,999) Partnership Interests of the
Partnership.
Each Partnership Interest of General Partner or Partnership Interest of Limited Partner gives one voting right in general
meetings of partners, either annual or extraordinary.
The Partnership’s capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Partners adopted in the
manner required for an amendment of this Limited Partnership Agreement.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Partnership
Interest in addition to its nominal value is booked.
Art. 7. Transfer of Partnership Interests. With the prior written consent of the General Partner(s), the Partnership Interests
are freely transferable among the Limited Partners.
No transfer of Partnership Interests to a non-partner may take place (i) without the agreement of the other Partners, either
General Partner or Limited Partner, and (ii) without having been first offered to the other Partners.
In accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code, a transfer of Partnership Interests shall be binding on
the Partnership only after the Partnership has been notified of such transfer or has accepted it. The Partnership Interests are
indivisible with regard to the Partnership, which allows only one owner for each Partnership Interest.
For the avoidance of doubt a Partner retains his right to receive any profits which have been appropriated to him in
accordance with Article 20.2a) but not yet distributed to him in accordance with Article 20.2b) at the time when he ceases
to be a Partner, except in case of redemption of Partnership Interests as foreseen under article 8 of the Limited Partnership
Agreement. Interim accounts have to be established and agreed by the transferor, the transferee and the General Partner(s)
as at the date of transfer of the Partnership Interests, to determine the right to profits of the leaving Partner.
Art. 8. Redemption of Partnerships Interests. With the prior written consent of the General Partner(s), the Partnership
may redeem its own Partnership Interests. All Partnership Interests redeemed by the Partnership may be cancelled or kept
in treasury by the Partnership. The voting and economic rights attached to the Partnership Interests redeemed by the
Partnership shall be suspended until these Partnership Interests are either cancelled or re-allocated.
For the avoidance of doubt the amount paid to a Partner in respect of the redemption of his Partnership Interest shall be
the amount credited to his Capital Account which shall include the amounts specified in Article 20.2c).
Art. 9. Form of Partnership Interests - Partners ' register. The Partnership Interests are and shall remain in registered
form.
A Partners' register of the Partnership will be kept at the registered office of the Partnership and may be examined by
each Partner who so requires.
Art. 10. Partners' liability. The General Partner is liable for all debt and losses which cannot be covered by the assets of
the Partnership. In case of several General Partners, they are jointly and severally liable for all the obligations of the
Partnership. The General Partner however is not bound to reimburse the Limited Partner for the paid-in amounts on the
Partnership Interests.
Subject to the applicable provisions of the Law, the Limited Partner is only liable up to the funds contributed to the
Partnership and has no liability other than for amounts not paid up on its Partnership Interests.
Art. 11. Management. The Partnership shall exclusively be managed by one or several General Partner(s). Subject to
the applicable provisions of the Law, the Limited Partner, or the Limited Partners if several, shall take no part in the
management or control of the business affairs of the Partnership and shall have no right or authority to act for the Partnership
or to take any part in or in anyway to interfere in the management of the Partnership or to vote on matters relating to the
Partnership.
The General Partner(s) are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the
Partnership's interest which are not expressly reserved by the Law or by this Limited Partnership Agreement to the general
meeting of Partners.
The General Partner(s) shall have full powers to carry out and approve for the Partnership all acts and operations
consistent with the Partnership's objects.
In case of plurality of General Partners, decisions of the General Partners shall be validly taken if adopted by a majority
of the General Partners.
In the event of insolvency, legal incapacity, liquidation or other situation preventing a General Partner from managing
the Partnership, the General Partner shall immediately and automatically be suspended as manager of the Partnership. Upon
the occurrence of such event in the case such General Partner was the sole General Partner, a successor General Partner
acting as manager shall be appointed in accordance with the provisions of following paragraph.
77077
L
U X E M B O U R G
In the event of vacancy of the sole General Partner’s office, a general meeting of the Partners must be held, without
undue delay, to appoint a provisional administrator, who does not need to be a Partner, in order to effect urgent acts and
simple administrative acts. Failing such appointment, any interested party may request the president of the Tribunal d’Ar-
rondissement de et à Luxembourg dealing with commercial matters to appoint an administrator for a maximum period of
one month. The provisional administrator shall convene within fifteen (15) days from its appointment a general meeting
of the Partners, at which the Partners shall appoint a successor General Partner at a simple majority. For the avoidance of
doubt, such appointment shall not be subject to the approval of the General Partner in whose office the vacancy occurred.
The decisions of the General Partner(s) shall be recorded in minutes which shall be signed by the General Partner. Copies
or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the General
Partner or by any person duly appointed to that effect by the General Partner.
Art. 12. Delegation of powers. The General Partner(s) may at any time appoint one or several ad hoc agent(s) to perform
specific tasks provided that in no circumstances shall such (an) agent(s) be (a) Limited Partner(s). The General Partner(s)
shall determine the powers and remuneration (if any) of such agents, the duration of the period of representation and any
other relevant condition of the agency. The agents so appointed are in any case revocable ad nutum by decision of the
General Partner(s).
The appointment of agents pursuant to the present Article shall have no effect on the unlimited liability of the General
Partner(s).
Art. 13. Auditor. The Partnership may appoint and shall do so in the cases provided by the Law one auditor. The auditor
shall be appointed by the general meeting of Partners for a term which may not exceed six years, renewable. The auditor
is revocable ad nutum by the general meeting of Partners.
Art. 14. Representation. The Partnership shall be bound by the sole signature of the General Partner, or in case of plurality
of General Partners, any General Partner, or by the sole signature of any person to whom the power to sign on behalf of
the Partnership has been validly delegated by the General Partner(s) in accordance with Article 12 of this Limited Part-
nership Agreement.
Art. 15. General meeting of partners. The Partners shall meet as often as necessary upon call of the General Partner or,
in case of plurality of General Partners, any General Partner with at least one-day prior written notice. The general meeting
of Partners shall be held at the place indicated in the convening notice, which shall set forth the agenda and be sent by
registered mail confirmed by the stamp evidencing the date of dispatch addressed to each Partner at least eight (8) days
prior to the meeting.
If all the Partners are present or represented at a general meeting of Partners, the convening notices may be waived in
writing.
Any partner can take part in any general meeting of Partners by appointing in writing by mail, by facsimile, by electronic
means or other suitable communication means, another person as proxyholder.
Partners taking part in a meeting by conference call, through videoconference or by any other means of communication
allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of
the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.
Subject to paragraphs 6 and 7 of Article 15 of this Limited Partnership Agreement, resolutions at general meetings of
Partners shall be passed validly by a simple majority of Partnership Interests present or represented at such meetings, with
the approval of the General Partner or, in case of plurality of General Partners, of all General Partners.
Notwithstanding the previous paragraph, the general meeting of Partners shall not validly deliberate unless the General
Partner or, in case of plurality of General Partners, each General Partner is present or represented and approves any decision
taken.
Any general meeting of Partners convened to amend any provision of this Limited Partnership Agreement shall not
validly deliberate unless at least three quarters of the Partnership Interests and the Partnership Interest of the General Partner
or, in case of plurality of General Partners, of all General Partners, are present or represented and the Agenda indicates the
proposed amendments to this Limited Partnership Agreement. If the quorum requirement is not satisfied, a second general
meeting of Partners may be convened by registered letter confirmed by the stamp evidencing the date of dispatch addressed
to each Partner. Such convening notice shall reproduce the Agenda and indicate the date and the results of the previous
general meeting of Partners. The second general meeting of Partners shall validly deliberate regardless of the proportion
of Partnership Interests represented. Resolutions at a general meeting convened to amend any provisions of this Limited
Partnership Agreement are validly adopted when approved by Partners representing three quarters of the Partnership In-
terests present or represented at such meeting and by the General Partner, or in case of plurality of General Partners, each
of the General Partners.
Decisions of the Partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to the Partners in writing,
whether in original or by facsimile, e-mail, electronics means or by other suitable communication means. The Partners
shall cast their vote by signing the circular resolution.
77078
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Annual General Meeting. An annual general meeting of Partners approving the Partnership’s financial statements
shall be held on the 3
rd
Monday of June at 11am and at the latest the date that is six months after the close of the accounting
year, at the registered address of the Partnership or at such other place as may be specified in the notice convening the
meeting.
Art. 17. Financial year. The Partnership's financial year shall begin on the first of January and shall terminate on the
thirty-first of December of the same year.
Art. 18. Balance sheet. Each year, as of the end of each financial year, the General Partner will draw up the Partnership's
balance sheet which will contain a record of the properties of the Partnership and the profit and loss account, with an
appendix according to the prescriptions of the law in force.
Art. 19. Communication of the documentation. Each Partner either in person or through a proxyholder may inspect at
the registered address of the Partnership the inventory, the balance sheet and the profit and loss account upon simple request
to the General Partner.
Art. 20. Capital account, appropriation of profits, interim dividends and premium.
20.1 Capital accounts
The Partners may make contributions recorded into a capital account ("Capital Account") established for each Partner.
20.2 Appropriation of profits
a) Each Partner in the Partnership has the right to participate in the profits of the Partnership in proportion to his
Partnership Interests in the Partnership for the period of time for which he is a Partner.
b) Upon recommendation of the General Partner, the general meeting of Partners shall determine how the Partnership’s
annual net profits shall be used in accordance with the Law and this Limited Partnership Agreement.
c) In accordance with Article 20.1, the Partnership shall establish a capital account for each Partner (both the General
Partner(s) and the Limited Partner(s)), which shall reflect (i) the Partnership capital contributed by such Partner and (ii) in
the event that the profits of the Partnership are not distributed to the Partners as per Article 20.2b), the amount of the
undistributed profit share of each Partner and (iii) the amount of losses incurred by the Partnership in proportion to his
Partnership Interests for the period of time for which he is a Partner. For the avoidance of doubt, such profits may be
distributed anytime after the annual general meeting of Partners upon recommendation of the General Partner(s) and
decision of the general meeting of Partners.
20.3 The General Partner(s) may decide to pay interim dividends on the basis of interim accounts prepared by it showing
that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the
end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or this Limited Partnership Agreement. For
the avoidance of doubt, no auditor’s report shall be required in this respect.
Art. 21. Dissolution - Liquidation. In the event of dissolution of the Partnership for any reason and at any time whatsoever,
liquidation will be carried out by one or several liquidator(s) appointed by the general meeting of Partners deciding such
liquidation.
Such general meeting of Partners shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).
Art. 22. Allocation of the liquidation surplus. After payment of all debts and liabilities of the Partnership or deposit of
any funds to that effect, the surplus will be paid:
(a) to the Partners in proportion to the balances of their respective Capital Accounts until they have received an amount
equal to the balances of their Capital Accounts immediately prior to such distribution, but after adjustment for gain or loss
with respect to the disposition of the Partnership's assets incident to the liquidation of the Partnership and the winding up
of its affairs, whether or not the disposition occurs prior to the liquidation of the Partnership; and thereafter
(b) to the Partners in proportion to the Partnership Interests held by each of them in the Partnership.
Art. 23. Miscellaneous. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in this Limited Partnership Agreement.”
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the proxyholder of
the appearing parties, this deed is worded in English, followed by a French version; and upon request of the same proxy-
holder and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing parties, said proxyholder appearing signed
together with the notary this deed.
77079
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois d’avril,
Par devant Maître Edouard Delosch notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg
ont comparu:
1. CBS-LUX HOLDING LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Delaware,
ayant son siège social au 2711, Centerville Road, USA - 19808 Wilmington, inscrite auprès du Registre des Sociétés du
Delaware sous le numéro 4819356, agissant en qualité d’associé commandité,
ici représentée par Julia Szafranska, juriste résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée le 27 avril 2015, et
2. CBS WORLDWIDE LTD., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois des Bermudes,
ayant son siège social à Cumberland House, 1 Victoria Street, 9
th
Floor, Hamilton HM12 Bermuda, agissant en tant que
et pour le compte de PTC HOLDINGS C.V., une société constituée et existante selon les lois des Pays-Bas, ayant son
adresse à 1017 AZ Amsterdam, the Netherlands, Singel 540, 5
th
floor, inscrite auprès de la Chambre de Commerce de
Rotterdam sous le numéro 24410683, agissant en qualité d’associé commanditaire,
ici représentée par Julia Szafranska, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée le 27 avril 2015;
lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les comparantes (dénommées les «Associés») représentent l’intégralité du capital de CBS SHOWTIME - CBS-LUX
HOLDING LLC S.C.S., une société en commandite simple constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Scheider, L-2522 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.329, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
Elvinger, notaire alors résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg en date du 10 mai 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations le 20 juillet 2010 sous le numéro 1488 (ci-après la «Société»). Les statuts de la
Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
Les Associés ont renoncé à toute formalité de convocation.
Les comparantes ont requis le notaire soussigné de prendre acte que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Approbation de la modification et refonte complète du contrat social de la Société (étant spécifié que la forme et
l’objet social de la Société ne sont pas modifiés).
2. Divers.
Les comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, représentant l’intégralité du capital de la Société, prennent à
l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les associés décident de modifier et procéder à la refonte complète du contrat social de la Société (étant spécifié que la
forme et l’objet social de la Société ne sont pas modifiés), qui aura désormais la teneur suivante:
«Contrat Social
Art. 1
er
. Constitution. Il existe une société en commandite simple (ci-après la "Société"), qui est régie par les lois y
relatives, en particulier les articles 16 à 22 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle que modifiée
par la suite (ci-après la "Loi") ainsi que par le présent contrat social (ci-après le "Contrat Social"), entre:
1. CBS-LUX HOLDING LLC, précité, comme associé commandité unique de la Société (ci-après le "Commandité"),
and
2. CBS WORLDWIDE LTD., précité, agissant comme associé commandité de PTC HOLDINGS C.V., précité, et au
nom et pour le compte de PTC HOLDINGS C.V. comme associé commanditaire unique de la Société (ci-après le "Com-
manditaire")
(Ci-après désigné ensemble par le terme les "Associés").
Art. 2. Raison sociale. La Société a pour raison sociale: "CBS SHOWTIME - CBS-LUX HOLDING LLC S.C.S."
Art. 3. Objet social. Les Associés ont organisé la Société dans l’objectif d'exercer une activité en commun, dans le but
de réaliser des profits, des investissements, et en particulier, d'acquérir des participations dans des sociétés ou entreprises,
au Luxembourg ou à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations.
La Société peut en particulier acquérir des contrats de licence intragroupe ainsi que les actifs et passif y relatifs et conduire
et gérer des activités de licence.
La Société peut en particulier acquérir par souscription, achat, échange, ou tout autre moyen, des actions, parts et autres
titres participatifs, obligations, certificat de dépôt et autres dettes et plus généralement, tout titre ou instrument financier
77080
L
U X E M B O U R G
émis par une entité publique ou privée. Elle peut participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de
toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou tout
autre droit de propriété intellectuelle de n'importe quelle nature et origine.
La Société peut emprunter sous toutes les formes, exceptées par voie d'offre publique. Elle peut émettre, par voie de
placement privé seulement, des titres, des obligations et tout autre instrument matérialisant une dette. La Société peut prêter
des fonds, y compris les fonds provenant d'un emprunt et/ou de l’émission d'instruments matérialisant une dette, à ses
filiales, sociétés affiliées. Elle peut également accorder des garanties ou sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obli-
gations ou celles de ses filiales, sociétés affiliées ou tout autre société. La Société peut de plus nantir, transférer, ou donner
en garantie d'une autre façon tout ou partie de ses actifs et ouvrir un ou des comptes bancaires à son nom.
La Société peut plus généralement avoir recours à toute technique et instrument se rapportant à ses investissements pour
permettre une gestion plus efficace, y compris les techniques et instruments permettant à la Société de se protéger contre
les risques de crédit, de change et de taux d'intérêts et tout autre risque.
La Société peut conclure toutes transactions commerciales ou financières relatives à des meubles ou immeubles, qui se
rapportent directement ou indirectement à l’objet de la Société.
La description ci-dessus doit être comprise dans son acception la plus large et l’énumération ci-dessus n'est pas limitative.
Art. 4. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré
à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des Associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société le(s) Commandité(s).
Art. 5. Durée. La Société est établie pour une durée indéterminée.
La Société ne finira d'exister par le décès, la suspension des droits civils, démission, dissolution, faillite ou l’insolvabilité
du Commandité, dans quel cas il doit être remplacé, ou, en cas de pluralité de Commandités, d'un des Commandités, à
condition que la Société ait au moins un Commandité et un Commanditaire.
Art. 6. Capital, Apports. Le capital social est fixé à mille U.S. Dollars (USD 1.000), représenté par cent mille (100.000)
parts d'intérêts d'une valeur nominale d'un U.S. Cent (USD 0,01) chacune (les "Parts d'Intérêt" et individuellement, une
"Part d'Intérêt") Le Commandité détient une (1) Part d'Intérêt de la Société.
Le Commanditaire détient quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) Parts d'Intérêt de la
Société.
Chaque Part d'Intérêt de Commandité ou Part d'Intérêt de Commanditaire donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales, annuelles ou extraordinaires.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale des Associés adoptée
selon les modalités requises pour la modification du présent Contrat Social.
En plus du capital émis, il pourra être établi un compte de prime auquel toute prime payée sur toute Part d'Intérêt en
plus de sa valeur nominale est comptabilisée.
Art. 7. Transfert des Parts d'Intérêt. Avec l’approbation préalable du Commandité(s), la cession de Parts d'Intérêt entre
Commanditaires est libre.
La cession des Parts d'Intérêt à un tiers non associé ne peut avoir lieu qu'avec (i) l’accord de tous les autres Associés,
Commandités et Commanditaires, et qu'après (ii) que ces Parts d'Intérêt aient été proposées aux Associés.
Conformément à l’article 1690 du Code civil luxembourgeois, un transfert de Parts d’Intérêt engage la Société unique-
ment après que la Société ait été notifiée de ce transfert ou l’ait accepté. Les Parts d'intérêt sont indivisibles pour la Société,
de telle sorte qu'elle ne reconnaît qu'un seul porteur de Part d'Intérêt pour chaque Part d'Intérêt.
Il doit être précisé qu'un Associé conserve son droit aux bénéfices acquis conformément à l’article 20.2 a), mais non
encore distribués conformément à l’article 20.2 b) lorsqu'il cesse d'être Associé, sauf pour le cas d'un remboursement de
Parts d'Intérêt comme indiqué à l’article 8 du Contrat Social. Des comptes intérimaires doivent être établis et approuvés
par le cédant, le cessionnaire et le Commandité à la date du transfert des Parts d'Intérêt, pour déterminer le droit aux profits
de l’Associé sortant.
Art. 8. Remboursement des Parts d'Intérêt. Avec l’approbation préalable du Commandité(s), la Société peut racheter
ses propres Parts d'Intérêt. Toutes les Parts d’Intérêt rachetées par la Société peuvent être annulées ou conservées par la
Société. Le droit de vote et les droits économiques attachés aux Parts d’Intérêt rachetées par la Société seront suspendus
jusqu'à ce que ces Parts d’intérêt soient annulées ou réallouées.
Il doit être précisé que le montant versé à l’Associé en remboursement de ses Parts d'Intérêt sera égal au montant crédité
à son Compte de Capital, qui inclura les montants spécifiés à l’article 20.2c.
Art. 9. Forme des Parts d'Intérêt - Registre des Associés. Les Parts d'Intérêt ont et devront conserver la forme nominative.
77081
L
U X E M B O U R G
Un registre des Associés ainsi que les livres de comptes de la Société seront conservés au siège social de la Société et
pourront être consultés par les Associés le souhaitant.
Art. 10. Responsabilité des Associés. Le Commandité est responsable de toutes les dettes et pertes qui ne pourront être
couvertes par les actifs de la Société. En cas de pluralité de Commandités, ils seront conjointement et solidairement res-
ponsables pour toutes les obligations de la Société. Le Commandité n'est cependant pas tenu de rembourser au Comman-
ditaire les montants libérés de ses Parts d'Intérêt.
Sous réserve des dispositions applicable de la Loi, le Commanditaire n'est responsable qu'à due proportion de ses apports,
et n'a d'autres dettes que le montant non libéré des Parts d'Intérêts qu'il détient.
Art. 11. Gestion. La Société est gérée exclusivement par un ou plusieurs Commandité(s). Sous réserve des dispositions
applicable de la Loi, le Commanditaire, ou les Commanditaires s'il y en a plusieurs, ne doivent pas prendre part à la gestion
ou à la direction des affaires de la Société et n'ont aucun droit ou autorité pour agir au nom de la Société ou pour prendre
part ou pour interférer de quelque façon que ce soit dans la gestion de la Société, ou pour voter sur des sujets relatif à la
Société.
Le(s) Commandité(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus larges pour effectuer tout acte d'administration et de
disposition dans l’intérêt de la Société qui ne sont pas expressément réservé à l’assemblée des Associés par la Loi ou par
ce Contrat Social.
Le(s) Commandité(s) aura/auront les pleins pouvoirs pour exécuter et approuver au nom de la Société tous les actes et
opérations en relation avec l’objet social de la Société.
En cas de pluralité de Commandités, les décisions des Commandités seront valablement adoptées à la majorité des
Commandités.
En cas d'insolvabilité, d'incapacité légale, de liquidation ou autre situation empêchant le Commandité de gérer la Société,
le Commandité est immédiatement et automatiquement révoqué comme gérant de la Société. À la survenance d'un tel
événement, si le Commandité était le seul gérant, un Commandité successeur agissant à titre de gérant sera nommé con-
formément aux dispositions de l’alinéa suivant.
En cas de vacance dans l’office de l’unique Commandité, une assemblée générale des Associés doit être tenue, sans
délai, afin de nommer un administrateur provisoire, qui n'a pas besoin d'être un associé, afin d'effectuer les opérations
urgentes et des tâches administratives simples. Faute d'une telle nomination, tout intéressé peut demander au président du
Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de nommer un administrateur pour une
période maximale d'un mois. L'administrateur provisoire doit convoquer dans les quinze (15) jours suivant sa nomination
une assemblée générale des Associés, à laquelle les Associés doivent désigner à la majorité un Commandité successeur.
Afin d’éviter toute ambiguïté, telle nomination ne doit pas être soumise à l’approbation du Commandité dans l’office duquel
la vacance est survenue.
Les décisions du Commandité(s) doivent être consignées dans un procès-verbal signé par le Commandité. Les copies
ou extraits de ces procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou ailleurs seront signés par le Commandité ou par
toute personne dûment mandatée à cet égard par le Commandité.
Art. 12. Délégation de pouvoir. Le(s) Commandité(s) peut/peuvent, à tout moment, designer un ou plusieurs mandataires
ad hoc pour exécuter des tâches spécifiques, sous réserve qu'en aucun cas, un Commanditaire ne peut être nommé man-
dataire. Le(s) Commandité(s) déterminera/détermineront les pouvoirs et la rémunération (s'il y a lieu) des mandataires, la
durée de leur mandat et toute autre caractéristique de ce mandat. Les mandataires ainsi désignés sont dans tous les cas
révocables ad nutum par décision du (des) Commandité(s).
La nomination de mandataires conformément à cet article n'aura pas d'incidence sur la responsabilité illimitée des
Commandités.
Art. 13. Auditeur. La Société peut nommer un auditeur et devra le faire dans les cas prévus par la Loi. L'auditeur sera
nommé pas l’assemblée générale des Associés pour une durée qui ne pourra pas excéder six ans, renouvelable. L'auditeur
peut être révoqué ad nutum par l’assemblée générale des Associés.
Art. 14. Représentation. La Société sera liée par la signature d'un Commandité seul, ou en cas de pluralité de Comman-
dités, par tout Commandité ou tout mandataire ayant pouvoir de signer au nom de la Société suite à une procuration donnée
en conformité avec l’article 12 de ce Contrat Social.
Art. 15. Assemblée générale des Associés. Les Associés se réuniront autant de fois que nécessaire sur convocation du
Commandité, ou, en cas de pluralité de Commandités, sur convocation de tout Commandité notifiée au moins un jour à
l’avance. L'assemblée générale des Associés sera tenue au lieu indiqué dans la convocation, qui doit énoncer l’ordre du
jour et être envoyée par courrier recommandé confirmé par le cachet attestant la date d'envoi adressé à chaque Associé au
moins huit (8) jours avant la réunion.
Si tous les Associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale des Associés, ils peuvent renoncer par écrit à
l’obligation de convocation préalable.
Tout Associé peut être représenté à une assemblée générale des Associés en nommant par écrit au moyen d'un courrier,
d'un fax, de moyens électroniques ou de tout autre moyen de communication adapté, une autre personne comme mandataire.
77082
L
U X E M B O U R G
Les Associés participant à une réunion par conférence téléphonique, par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de
communication, permettant leur identification et que toutes personnes prenant part à la réunion s’entendent mutuellement
sur une base continue et effective, sont déclarées comme étant présent pour le calcul du quorum et des votes, sous réserve
des moyens de communication étant mis à disposition sur le lieu de la réunion.
Sous réserve des alinéas 6 et 7 de l’article 15 du Contrat Social, les décisions à l’assemblée générale des Associés seront
valablement adoptées à la majorité simple des Associés présents ou représentés à l’assemblée.
Nonobstant l’alinéa précédent, l’assemblée générale des Associés ne pourra pas valablement délibérer à moins que le
Commandité ou, en cas de pluralité de Commandités, que tous les Commandités, soient présents ou représentés.
Toute assemblée générale des Associés convoquée pour modifier une clause du Contrat Social ne délibérera valablement
que si la moitié au moins des Parts d'Intérêt émises est présente ou représentée et si l’ordre du jour mentionne la proposition
de modification du Contrat Social. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale des Associés peut être
convoquée par lettre recommandée portant le tampon prouvant la date d'envoi à chaque Associé. Une telle convocation
doit reproduire l’ordre du jour et indiquer la date et le résultat de l’assemblée générale précédente. La seconde assemblée
générale des Associés délibère valablement quelle que soit la proportion de Parts d'Intérêts représentées. Les résolutions à
une assemblée générale convoquée pour modifier toutes dispositions de ce Contrat Social sont valablement adoptées par
l’approbation des Associés représentant les trois quarts des Parts d'Intérêt présentes ou représentées à l’assemblée et par
l’approbation du Commandité ou, en cas de pluralité de Commandités, par chacun des Commandités.
Les décisions des Associés peuvent être prises par résolutions circulaires, dont le texte doit être envoyé par écrit aux
Associés, en original ou par fax, e-mail, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication adapté. Les Associés
exprimeront leur vote en signant les résolutions circulaires.
Art. 16. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale annuelle des Associés approuvant les comptes doit être
tenue le 3e lundi du mois de juin à 11 heures et au plus tard la date intervenant six mois suivants la clôture de l’exercice
social, au siège social de la Société ou à toute autre place indiquée dans la convocation.
Art. 17. Exercice social. L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de la même année.
Art. 18. Bilan. Chaque année avec effet à la fin de l’exercice social, le Commandité établit le bilan qui comprendra
l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu'une
annexe conformément aux dispositions de la loi en vigueur.
Art. 19. Communication des documents. Tout Associé, soit en personne soit par un représentant, peut prendre commu-
nication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.
Art. 20. Compte de capital, allocation des profits et dividendes intérimaires et prime.
20.1 Compte de capital
Les Associés peuvent effectuer des apports inscrits dans un compte de capital ("Compte de Capital") établi pour chaque
Associé.
20.2 Allocation des bénéfices
(a) Les Associés auront un droit à participation aux bénéfices à proportion des Parts d'Intérêt qu'ils détiennent pour la
période durant laquelle ils ont été associés;
(b) Sur recommandation du Commandité, l’assemblée générale des Associés déterminera comment les profits annuels
nets de la Société doivent être utilisés conformément à la Loi et ce Contrat Social.
(c) Conformément à l’article 20.1, la Société établira un Compte de Capital pour chacun des Associés (Commanditaire
(s) et Commandité(s)) qui reflétera: (i) les apports fait à la Société par les Associés et (ii) dans l’hypothèse où les gains de
la Société ne sont pas distribués aux Associés, le montant de la part non distribuée de chaque Associé selon l’article 20.2b)
et (iii) le montant des pertes subies par la Société à proportion des Parts d'Intérêt qu'ils détiennent pour la période durant
laquelle ils ont été associés. Afin d’éviter toute ambiguïté, ces profits peuvent être distribués à tout moment postérieurement
à la réunion de l’assemblée générale des Associés sur recommandation du(des) Commandité(s) et décision de l’assemblée
générale des Associés.
20.3 Le(s) Commandité(s) peut(vent) décider de payer dividendes intérimaires sur la base de comptes intérimaires établis
par lui montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution. Le montant à distribuer ne peut excéder les
profits réalisés depuis la fin de la dernière année fiscale, augmenté par les profits reportés et réserves distribuables, réduit
par les pertes reportées et sommes à allouer à une réserve établie par la loi ou ce Contrat Social. Pour éviter toute ambiguïté,
un rapport d'auditeur ne sera pas nécessaire à cet égard.
Art. 21. Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution de la Société, quelle qu'en soit la raison et le moment, la
liquidation sera effectuée pas un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des Associés ayant décidé la
liquidation.
Cette assemblée générale des Associés déterminera également les pouvoirs du (des) liquidateur(s).
Art. 22. Répartition du boni de liquidation. Après paiement de toutes les dettes et obligations de la Société, ou le dépôt
de fonds à cette fin, le boni sera payé:
77083
L
U X E M B O U R G
(a) aux Associés, à due proportion du solde de leur Compte de Capital respectif jusqu'à ce qu'ils aient reçu un montant
égal à leur solde juste avant cette distribution, mais après ajustement pour gains et pertes relatif à la disposition des actifs
de la Société et la liquidation de ses affaires, que la disposition ait lieu ou non avant la liquidation de la Société, et par la
suite,
(b) aux Associés proportionnellement aux Parts d'Intérêts détenues par chacun d'entre eux.
Art. 23. Divers. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans ce Contrat Social, les parties s'en réfèrent à la Loi.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à mille cent euro (EUR 1.100,-).
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire
des comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande
du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec, le notaire soussigné,
le présent acte.
Signé: J. SZAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 avril 2015. Relation: DAC/2015/7082. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 05 mai 2015.
Référence de publication: 2015066217/499.
(150076478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2015.
Balote SPF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 177.760.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of April,
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg (herei-
nafter referred to as the “Notary”).
THERE APPEARED
VACON PROPERTIES S.A., a Panamanian limited liability company incorporated and existing under the laws of
Panama, having its registered office at Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, East 54
th
Street, PA - Panama City, under
Registro Público de Panamá number 924793/1/520207,
(hereinafter referred to as the "Appearing Party")
here represented by Mr Max MAYER, employee, professionally residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg
by virtue of a proxy given on 31 March 2015 (hereinafter referred to as the “Proxyholder”),
Such Appearing Party is the sole shareholder of BALOTE SPF S.A., a Luxembourg public limited liability company
(société anonyme), duly incorporated and existing under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and being registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies (hereinafter referred to as the “R.C.S.”) under number B 177.760 and
whose articles of incorporation (hereinafter referred to as the “Articles”) have been published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (hereinafter referred to as “Mémorial C”) under number 1748, page 83868 on 20
th
July 2013
and have been rectified on 02
nd
June 2014 (hereinafter referred to as the “Company”).
The Appearing Party representing the whole corporate capital require the Notary to act the following declarations and
statements:
1. That the share capital of the Company currently amounts to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented
by one thousand (1,000) shares with a nominal value of thirty-one Euro (EUR 31.-) each.
2. That pursuant to the shareholders register of the Company, the Appearing Party is the sole shareholder of the Company.
3. That the latest annual accounts of the Company have been approved by the Appearing Party and duly submitted to
R.C.S. for the purposes of publication.
4. That the Appearing Party, acting in its capacity of the sole shareholder, declares the anticipated dissolution of the
Company with immediate effect followed by its liquidation.
77084
L
U X E M B O U R G
5. That the Appearing Party declares that it has full knowledge of the Articles of the Company and that it is fully aware
of the financial situation of the Company.
6. That the Appearing Party, acting in its capacity of the sole shareholder, appoints itself liquidator of the Company and
declares that the activity of the Company has ceased.
7. That in that capacity, the Appearing Party requests the Notary to record that it has realised all of the Company’s assets
and has settled all liabilities and debts of the Company by way of payment or fully provided for of all of the known liabilities
of the Company.
8. That the Appearing Party is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume
liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to the sole
shareholder.
9. That consequently, the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed.
10. That the full and complete discharge is granted to the sole director of the Company for the execution of its mandate
up to this day.
11. That it is expedient to proceed with the cancellation of the shareholders register.
12. That the books and records of the Company shall be kept for at least five years at the former registered office of the
dissolved Company being 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed at EUR 2,000.-.
Whereof the present deed is drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned Notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the Appearing Party and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.
The document having been read to the Proxyholder of the Appearing Party known to the Notary by her name, first name,
civil status and residence, the Proxyholder of the Appearing Party signed together with the Notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-septième avril,
Par devant Maître Jean Seckler, notaire, de résidence au Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné (ci-après
le «Notaire»).
A COMPARU
VACON PROPETIES S.A., une société Panamienne à responsabilité limitée, dûment constituée et existante selon les
lois de la République de Panama, ayant son siège social à Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, East 54
th
Street, Panama,
République de Panama et enregistrée auprès du Registro Publico de Panama sous le numéro 924793/1/520207,
(ci-après la "Personne Comparante").
ici-représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, Grand Duché de
Luxembourg en vertu du mandat octroyé le 31 mars 2015 (ci-après le «Mandataire»),
Telle Personne Comparante est l’actionnaire unique de BALOTE SPF S.A., une société anonyme luxembourgeoise,
dûment constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume
Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg (ci-après le "R.C.S.") sous le numéro B 177.760, dont les statuts (ci-après les "Statuts") ont été
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après le "Mémorial C") le 20 juillet 2013, sous numéro
1748, page 83868 et ont été rectifiés en date du 02 juin 2014 (ci-après la "Société").
La Personne Comparante représentant la totalité du capital social demande le Notaire d'acter les déclarations et cons-
tatations suivantes:
1. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente-une mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille
(1,000) actions ayant la valeur nominale de trente-un euros (EUR 31,-) chacune.
2. Que selon le registre des actionnaires de la Société la Personne Comparante est l’actionnaire unique de la Société.
3. Que les derniers comptes annuels de la Société ont été approuvés par la Personne Comparante et dûment déposés
auprès du R.C.S. à des fins de la publication.
4. Que la Personne Comparante, en tant que l’actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec
effet immédiat et sa mise en liquidation.
5. Que la Personne Comparante déclare avoir pleine connaissance des Statuts de la Société et est pleinement consciente
de la situation financière de la Société.
6. Que la Personne Comparante, en tant qu’actionnaire unique, se désigne liquidatrice de la Société et déclare que
l’activité de la Société est cessée.
77085
L
U X E M B O U R G
7. Qu’en cette qualité, la Personne Comparante requiert le Notaire instrumentant d’acter qu’elle déclare avoir réalisé
tous les actifs de la Société et avoir réglé tout le passif de la Société par payement ou entière approvisionnement des dettes
connues de la Société.
8. Que la Personne Comparante, étant investie de tous les avoirs, déclare expressément prendre à sa charge et assumer
toute responsabilité pour tout passif connu mais impayé et pour toutes dettes encore inconnues de la Société avant tout
paiement à l’actionnaire unique.
9. Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme ayant été effectuée et terminée.
10. Que décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur unique de la Société pour l’exécution de son mandat
jusqu'à ce jour.
11. Qu'il y a lieu de procéder à l’annulation du registre des actionnaires.
12. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à son ancien siège
social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Coûts et fraisi>
Les coûts, frais, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en
conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement 2.000.- EUR.
Sur quoi le présent acte a été établi à Junglinster, à la date mentionnée au début du présent acte.
Le Notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que le présent acte est dressé en langue anglaise
suivi d'une traduction française; à la demande de la Personne Comparante et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Après que lecture de l’acte a été faite au Mandataire de la Personne Comparante, connu du Notaire par son nom, prénom,
statut marital et lieu de résidence, ledit Mandataire de la Personne Comparante a signé ensemble avec le Notaire le présent
acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 21 avril 2015. Relation GAC/2015/3334. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015066157/115.
(150076450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2015.
Ophelia Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.800.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 189.477.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of April.
Before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Pan European Value Added Venture S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions) orga-
nized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 186.543, represented by its general partner, Pan European Value Added Venture General Partner S.A., here
represented by Peggy Simon, private employee, with professional address at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a
power of attorney given under private seal on April 23, 2015.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record the following:
I. the appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Ophelia Investment S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 189.477, having a share capital of five million eight
hundred seventeen thousand euro (EUR 5,817,000.-) and incorporated on 1
st
August 2014 pursuant to a deed of Maître
Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations under number 2872 (the “Company”). The articles of association of the Company (the
“Articles”) have been amended for the last time on 20 October 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary
residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 3590.
77086
L
U X E M B O U R G
II. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million nine hundred
thousand euro (EUR 1,900,000.-) in order to bring it from its present amount of thirty-eight million nine hundred thousand
euro (EUR 38,900,000.-) represented by thirty-eight million nine hundred thousand (38,900,000) shares in registered form,
having a par value of one euro (EUR 1.-) each, to forty million eight hundred thousand euro (EUR 40,800,000.-) by way
of the issuance of one million nine hundred thousand (1,900,000) new shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each,
having the same rights, obligations and features as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to one million
nine hundred thousand (1,900,000) new shares with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and fully pays them up by way
of a contribution in cash of one million nine hundred thousand euro (EUR 1,900,000.-) to be allocated to the share capital
account of the Company.
The amount of one million nine hundred thousand euro (EUR 1,900,000.-) is at the Company's disposal and evidence
of such amount has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6, first paragraph of the
Articles, so that it shall henceforth read as follows:
“The share capital of the company is set at forty million eight hundred thousand euro (EUR 40,800,000.-), represented
by forty million eight hundred thousand (40,800,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each".
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company, acting individually, with full power of substitution, to
proceed on behalf of the Company to effect the registration of the newly issued ordinary shares in the shareholders' register
of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-septième jour du mois d'avril.
Par devant nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Pan European Value Added Venture S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, dont le
siège social est situé au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.543, représenté par son gérant commandité, Pan European
Value Added Venture General Partner S.A., ici représentée par Peggy Simon, employée privée, résidant professionnelle-
ment à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 avril 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexe au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. la partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de Ophelia Investment S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.477,
ayant un capital social s'élevant à cinq millions huit cent dix-sept mille euros (EUR 5.817.000,-) et constituée le 1
er
août
2014 suivant acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, publié au
77087
L
U X E M B O U R G
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg sous le numéro 2872 (la «Société»). Les statuts de la
Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le 20 octobre 2014 suivant acte de Maître Henri Beck, notaire
de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de
Luxembourg sous le numéro 3590.
II. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million neuf cent mille euro (EUR
1.900.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trente-huit millions neuf cent mille euro (EUR 38.900.000,-) re-
présenté par trente-huit millions neuf cent mille (38.900.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale
d'un euro (EUR 1,-) chacune, à un montant de quarante millions huit cent mille euro (EUR 40.800.000-) par l'émission d'un
million neuf cent mille (1.900.000) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et
disposant des mêmes droits, obligations et caractéristiques que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation
du capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits, l'Associé Unique, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux un million neuf
cent mille (1.900.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et les libérer
entièrement par un apport en numéraire d'un montant d'un million neuf cent mille euro (EUR 1.900.000,-) qui sera affecté
au compte de capital social de la Société.
Le montant d'un million neuf cent mille euro (EUR 1.900.000,-) est à la disposition de la Société, preuve en ayant été
apportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6, premier paragraphe des
Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quarante millions huit cent mille euro (EUR 40.800.000,-) représenté par quarante millions
huit cent mille (40.800.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications qui
précèdent et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substi-
tution, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales ordinaires nouvellement émises
dans le registre des associés de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la partie
comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 avril 2015. Relation: GAC/2015/3542. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 05 mai 2015.
Référence de publication: 2015066556/127.
(150076623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
77088
Balote SPF S.A.
Bielefeld Boulevard Holding S.à r.l.
CBS Showtime - CBS-Lux Holding LLC S.C.S.
KCS S.à r.l. - SPF
Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l.
Lancefield Property
Leeverg Luxembourg S.A.
LF Real Estate S.à r.l.
LIBF (I) S.à r.l.
Lion/Visor Lux 2
LMF Lux
Loevarth Invest S.A.
Logiver S.A.
Logwin Road + Rail Trier GmbH, Niederlassung Grevenmacher
London Bridge Investment Holdings S.à r.l.
LO Real Estate S.à r.l.
Lorito L. Holdings S.à r.l.
LSREF3 Eve Holdings S.à r.l.
Luxempart
Lynckx Management S.A.
Mac's Luxembourg
MaForm Holding Luxembourg S.àr.l.
MaForm S.à r.l.
Mahkota S.A.
ManageMySelf S.à r.l.
MAN Finance and Holding S.A.
MAN Finance Luxembourg S.A.
Marble Investments S.à r.l.
Marine Participations SA
Marsaco S.à r.l.
Mathy Invest S.A.
Matma S.A.
Matro S.A.
Matro S.A.
Matro S.A.
Mayhill Investments Limited S.A.
MC Diamond s.à r.l.
MDC Holdco S.à r.l.
Media Vision S.à r.l.
Melville Sàrl
Milano Investments S.à r.l.
Milano Investments S.à r.l.
Mirko S.à r.l.
Misys Newco S.à r.l.
M-Square Finance S.A. SPF
Mt. Kailash S.à r.l.
Munawwar S.A.
Munich Holdings II Corporation
Mylan Luxembourg 8 S.à r.l.
Mylan Luxembourg 9 S.à r.l.
Novocure Luxembourg
OCM Luxembourg Portugal Investment Platform S.à r.l.
Ophelia Investment S.à r.l.
Pearl JV Holding S.à r.l.
Peehold S.A.
Profconsult S.à r.l.
Traumgaard de Luxe GmbH
Valorem Investissements S.A.
Yaletown Acquiror S.à r.l.
Yaletown Collector Co S.à r.l.