logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1577

25 juin 2015

SOMMAIRE

7H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75654

ABTS & Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

75692

Access Storage Holdings (France), S.à r.l.  . . .

75696

Activité "Lensterbierg" S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

75696

Agat Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75696

A.R.T. - Absolute Return Target Fund  . . . . . .

75691

@vantage S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75691

ÄVWL Japan Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . .

75658

Faroe Investments Wolverhampton S.à.r.l.  . .

75692

Fondation Recherche sur le Sida  . . . . . . . . . . .

75690

KPMG Luxembourg Foundation . . . . . . . . . . .

75659

LBR Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75680

Mainbeach S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75653

MMA Alternative Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75691

Office Portfolio Minerva I Sàrl  . . . . . . . . . . . .

75677

RCM Immobilière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75695

Real Estate Development 2015 S.à r.l.  . . . . . . .

75664

TPG Utrecht S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75650

UKSA 60 CR S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75659

UKSA City University S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

75658

UKSA Hammersmith S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

75658

UK Students 60 CR S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

75655

UK Students Hammersmith S.à r.l.  . . . . . . . . .

75653

UK Students IHC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75654

UK Students Isledon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

75654

UK Students JV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75655

Umiak Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

75659

Valeo Foods Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

75684

Vam Funds (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75677

Vectorline Beteiligungsmanagement & Con-

sulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75664

Vertical Axions Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

75677

Villa Sphere Ovest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

75664

Violane Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75664

VisuConcept S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75664

Wealth International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

75695

WP Roaming IV S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75680

Yaletipart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75690

Zebra Luxco III S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75690

Zilat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75691

Zynga Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

75655

75649

L

U X E M B O U R G

TPG Utrecht S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 65.337,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 169.554.

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of the month of March.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared,

TOP Finance 3, LLC, a limited liability company with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,

Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801 (United States of America) and registered with the Secretary of State
of Delaware under number 5064508,

represented by Me Thierry Kauffman, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 13 March

2015 which shall be registered together with the present deed,

being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) and holding all the shares in “TPG Utrecht S.à r.l.” (the “Company”),

a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 15 June 2012 by deed
of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which has been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 17 July 2012 number 1796, with its registered
office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 169.554. The articles of association of the Company have been amended for the last time by
deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on 29 August 2012, published in the Mémorial on 2 October 2012, number
2448.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
(A) The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company, so that the decisions can validly be taken on all

items of the agenda.

(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:

<i>Agenda

1. Amendment of article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad
nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also at any time be held by conference call or similar means of communication only. The participation in,
or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a
meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the
number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty four (24) hours at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by e-mail pdf or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety  will  form  the  circular  documents  duly  executed  giving  evidence  of  the  resolution.  Managers'  resolutions  and

75650

L

U X E M B O U R G

meeting minutes, including circular resolutions, may be conclusively signed and/or certified or an extract thereof may be
issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of any manager, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed
different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will be validly bound by the
joint signature of one class A manager and one class B manager.

In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory

powers shall have been delegated by the sole manager or, in the case of a board of managers, by any one of the managers
provided that, in the event of classes of managers, signatory powers be delegated by one class A and one class B manager
acting together.”

2. Reclassification of all the managers of class A and class B in office in the Company as ordinary managers of the

Company so that the board of managers of the Company be composed as follows:

- Mr Pedro Fernandes das Neves, manager
- Mrs Alexandra Cabete Matias, manager
After the foregoing was approved, the following resolutions were passed.

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 7 of the articles of association of the Company so as to read as set out

in the agenda.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to reclassify all the managers of class A and class B in office in the Company as ordinary

managers of the Company so that the board of managers of the Company be composed as follows:

- Mr Pedro Fernandes das Neves, manager; and
- Mrs Alexandra Cabete Matias, manager.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le dix-huit mars.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu

TOP Finance 3, LLC, une limited liability company, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange

Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801 (Etats-Unis d'Amérique) et enregistrée auprès du Secretary
of State du Delaware sous le numéro 5064508,

représentée par Me Thierry Kauffman, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration en date

du 13 mars 2015, laquelle sera enregistrée avec le présent acte,

étant l’associé unique (l’«Associé Unique») et détenant l’intégralité des parts sociales de «TPG Utrecht S.à r.l.» (la

«Société»), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg le 15 juin
2012 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 17 juillet 2012, numéro 1796, ayant
son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.554. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 29
août 2012 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, publié au Mémorial en date du 2 octobre 2012, numéro
2448.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
(A) L’Associé Unique détient l’intégralité des parts sociales émises dans la Société, de sorte que des décisions peuvent

être prises valablement sur l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être adoptées sont les suivants:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l’article 7 des statuts de la Société afin de prendre la teneur suivante:
«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période

75651

L

U X E M B O U R G

indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue à tout moment uniquement sous forme
de conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires. La participation à ou la tenue d'une réunion
par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants
peuvent  être  représentés  aux  réunions  du  conseil  de  gérance  par  un  autre  gérant,  sans  limitation  quant  au  nombre  de
procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants

de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal
de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société (y

compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance ne
pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par e-mail pdf ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions
des gérants et les procès-verbaux des réunions, y compris celles prises par voie circulaire, seront signées et/ou certifiées
comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un gérant unique, et en cas d'un conseil de gérance,

par la signature unique de tout gérant, à condition toutefois que dans le cas où l’assemblée générale des associés a nommé
différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société sera valablement
engagée par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels

pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique ou, dans le cas d’un conseil de gérance, par un des gérants
à condition qu'en cas de différentes classes de gérants, les pouvoirs de signatures soient délégués par un gérant de classe
A et par un gérant de classe B agissant de concert.»

2. Reclassification de tous les gérants de classe A et de classe B de la Société comme gérants ordinaires de la Société

de façon à ce que le conseil de gérance de la Société soit composé comme suit:

- Monsieur Pedro Fernandes das Neves, gérant
- Madame Alexandra Cabete Matias, gérante
Après approbation de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

L’Associé Unique a décidé de modifier l’article 7 des statuts de la Société tel que rédigé dans l’ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique a décidé de reclasser tous les gérants de classe A et de classe B de la Société de façon à ce que le

conseil de gérance de la Société soit composé comme suit:

- Monsieur Pedro Fernandes das Neves, gérant; et
- Madame Alexandra Cabete Matias, gérante.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais a constaté qu'à la demande de la partie comparante, le présent

procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même personne comparante, en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. KAUFFMAN et H. HELLINCKX.

75652

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9298. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015063463/173.
(150072200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

UK Students Hammersmith S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 153.828.

Par résolutions prises en date du 22 avril 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination d'Ismaël Dian, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Vitalij Farafonov, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de Maxime Nino, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2015.

Référence de publication: 2015063481/17.
(150072233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Mainbeach S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 113.929.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue en date du 10 avril 2015,

en son siège social, que:

- L'assemblée prend acte de la venue à expiration, à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire, des mandats

de tous les administrateurs et du commissaire en place et décide de renouveler, pour une période de 6 ans prenant fin à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2021, les mandats de:

* la FIDUCIAIRE MEVEA LUXEMBOURG S.à.R.L., ayant son siège social au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxem-

bourg, en tant que commissaire;

* M. Cristian CORDELLA, né le 20.02.1981 à Lecce (Italie) et résidant professionnellement au 8, avenue de la Faïen-

cerie, L-1510 Luxembourg, en tant qu'administrateur;

* M. Hakim BERHOUNE, né le 17.12.1971 à Lyon (France) et résidant professionnellement au 22, rue Henri Mussard,

CH-1208, Genève (Suisse), en tant qu'administrateur et Président du Conseil d'Administration.

- L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur en la personne de Mme Alba RIVOLTA, née le 23.07.1973

à Carate Brianza (Italie), résidant professionnellement au 8, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, en remplacement
de M. Vincent WILLEMS, dont le mandat n'est pas renouvelé.

Le mandat du nouvel administrateur expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2021.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 29 avril 2015.

Référence de publication: 2015064156/26.
(150073613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

75653

L

U X E M B O U R G

UK Students Isledon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 154.726.

Par résolutions prises en date du 22 avril 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination d'Ismaël Dian, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Vitalij Farafonov, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de Maxime Nino, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2015.

Référence de publication: 2015063482/17.
(150072449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

UK Students IHC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 170.441.

Par résolutions prises en date du 22 avril 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination d'Ismaël Dian, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Vitalij Farafonov, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de Maxime Nino, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2015.

Référence de publication: 2015063483/17.
(150072442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

7H, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 115.479.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2015

En date du 14 avril 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Sigieri Diaz Della Vittoria Pallavicini, de Monsieur Gabriele Bartolucci et de

Monsieur Moataz El-Sherif en qualité d'Administrateurs avec effet au 19 mai 2014,

- de renouveler les mandats de Monsieur Alexis de Bernardi, de Monsieur Angelo de Bernardi et de Monsieur Georges

Gudenburg en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2016,

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, 2182 Luxembourg en qualité de Réviseur

d'Entreprises agréé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.

Luxembourg, le 28 avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour 7H
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2015064448/20.
(150073819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

75654

L

U X E M B O U R G

UK Students 60 CR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 173.529.

Par résolutions prises en date du 22 avril 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination d'Ismaël Dian, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Vitalij Farafonov, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de Maxime Nino, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2015.

Référence de publication: 2015063484/17.
(150072447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

UK Students JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 152.349.

Par résolutions prises en date du 22 avril 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination d'Ismaël Dian, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Vitalij Farafonov, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de Maxime Nino, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2015.

Référence de publication: 2015063485/17.
(150072338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Zynga Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 151.977.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of April.
Before us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Zynga Game Ireland Limited, a limited company established under the laws of Ireland and having its registered office

at 25-28, North Wall Quay, IRL-1 Dublin, Ireland and registered with the Companies Registry of Ireland under registration
number 481954 (the “Sole Shareholder”);

here represented by Peggy Simon, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a

proxy.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

established in Luxembourg under the name of “Zynga Luxembourg S.à r.l.”, incorporated pursuant to a deed of Me Henri
Hellinckx, notary in Luxembourg, on March 12, 2010 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 151.977, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

75655

L

U X E M B O U R G

et Associations on April 28, 2010, n° 880, which have been amended on September 6, 2010 pursuant to a deed of Me Joseph
Elvinger, notary then residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on
October 28, 2010, n° 2307 and on December 14, 2010 pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary in Luxembourg,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on April 13, 2011, n° 710 (the “Company”);

II. The Company’s share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) represented by twenty

thousand (20,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each;

III. The appearing party takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder expressly declares to proceed with the anticipated dissolution of the Company with immediate

effect and to put the Company into liquidation.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder wholly and fully discharges the managers, namely Mr. Brian Edward NORIEGA and Mr. Soufiane

SAADI, and the external auditor, namely Ernst &amp; Young Luxembourg, of the dissolved Company for the performance of
their duties during their mandates, without any reserve or restriction as of the date of this notarial deed.

<i>Third resolution

The accounting situation of the Company as of February 15, 2015 is presented to the Sole Shareholder. The accounting

situation of the Company is approved by the Sole Shareholder.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder declares that it takes over and assumes all assets, liabilities and commitments including all major

third-party liabilities of the dissolved Company, known or unknown at the day of this notarial deed.

The Sole Shareholder approves that it is thus vested with all the assets of the dissolved Company, if any, and undertakes

to settle all and any liabilities and commitments including all major third-party liabilities of the dissolved Company to be
wound up, known or unknown at the day of this notarial deed.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder declares that the activity of the Company has ceased and that the liquidation of the Company is

considered to be done and closed without prejudice as the Sole Shareholder assumes all its liabilities.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder declares to proceed with the cancellation of the share’s register as well as any other register as

the case may be as a result of the dissolution of the Company.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder declares that the accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during

a period of five years at the following place: Zynga Inc., 699 8 

th

 Street, San Francisco, CA 94103, United States of America.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the party appearing, who is known to the notary by her Surname,

Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour d'avril;
Par-devant Maître Henri BECK, notaire, résidant à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Zynga Game Ireland Limited, une limited company constituée selon les lois d’Irlande, ayant son siège social au 25-28,

North Wall Quay, IRL-1 Dublin, Irlande et enregistrée auprès du Companies Registry of Ireland sous le numéro 481954
(l’«Associé Unique»);

ici représenté par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu

d’une procuration.

75656

L

U X E M B O U R G

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de “Zynga Luxembourg S.à r.l.”, constituée suivant acte reçu par Me Henri Hellinckx, notaire à Luxembourg en date du
12 mars 2010 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.977,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 28 avril 2010, n°880, lequel a été modifié le 6 septembre
2010 suivant acte reçu par Me Joseph Elvinger, notaire alors résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations le 28 octobre 2010, n°2307 et le 4 décembre 2010 suivant acte reçu par Me Henri Hellinck, notaire
résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 13 avril 2011, n°710 (ci-après la
«Société»);

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (20.000,- USD) représenté par vingt mille

(20.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un dollar américain (1,- USD) chacune;

III. La comparante prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique déclare expressément procéder à la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et à la

mise en liquidation de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique donne décharge pleine et entière aux gérants, à savoir M. Brian Edward NORIEGA et M. Soufiane

SAADI, et au réviseur externe, à savoir Ernst &amp; Young Luxembourg, de la Société dissoute pour l’exécution de leurs
obligations pendant leurs mandats, sans réserve ni restriction à la date du présent acte notarié.

<i>Troisième résolution

La situation comptable de la Société en date du 15 février 2015 est présentée à l’Associé Unique. La situation comptable

de la Société est approuvée par l’Associé Unique.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique déclare qu'il prend en charge et assume l’ensemble de l’actif, du passif et des engagements y compris

le passif résultant de dettes envers les tiers créanciers de la Société dissoute, connus et inconnus à la date du présent acte
notarié.

L’Associé Unique accepte de recevoir tout l’actif de la Société dissoute, le cas échéant, et s’engage à régler toute dette

et engagement y compris le passif résultant de dettes envers les tiers créanciers de la Société devant être liquidée, connue
et inconnue à la date du présent acte notarié.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique déclare que l'activité de la Société a cessé et que la liquidation de la Société est considérée comme

réalisée et clôturée, sans préjudice, l'Associé Unique assumant toutes ses responsabilités.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique déclare procéder à l'annulation du registre des associés ainsi que, le cas échéant, de tout autre registre

du fait de la dissolution de la Société.

<i>Septième résolution

L’Associé Unique déclare que les documents et pièces comptables relatifs à la Société dissoute seront conservés pendant

une période de cinq ans auprès de: Zynga Inc., 699 8 

th

 Street, San Francisco, CA 94103, Etats-Unis d’Amérique.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent

acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché du Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 avril 2015. Relation: GAC/2015/3522. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

75657

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 29 avril 2015.

Référence de publication: 2015065366/128.
(150074034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.

UKSA City University S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 153.826.

Par résolutions prises en date du 22 avril 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination d'Ismaël Dian, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Vitalij Farafonov, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de Maxime Nino, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2015.

Référence de publication: 2015063486/17.
(150072452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

UKSA Hammersmith S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 153.810.

Par résolutions prises en date du 22 avril 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination d'Ismaël Dian, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Vitalij Farafonov, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de Maxime Nino, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2015.

Référence de publication: 2015063487/17.
(150072453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

ÄVWL Japan Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 1, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 171.382.

AUSZUG

Aus den Beschlüssen des alleinigen Gesellschafters vom 30. April 2015 geht hervor, dass:
1. Herr Holger WÄCHTER seit 01.05.2015 (0:00 Uhr) kein Geschäftsführer mehr ist.
2. Herr Georg GMEINEDER, geboren am 23.01.1973 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, geschäftsansässig in

Albrechtstraße 14, 80636 München, Deutschland, mit Wirkung zum 01.05.2015 (0:00 Uhr) zum Geschäftsführer auf un-
bestimmte Zeit ernannt wird.

3. Herrn Georg GMEINEDER gemäß Art. 12 der Satzung die Befugnis zur Unterzeichnung als alleiniger Geschäftsführer

(Einzelvertretungsberechtigung) für die Vorbereitung, Vornahme, Betreuung und Veräußerung von Immobilien-Invest-
ments in Japan erteilt wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

75658

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 4. Mai 2015.

<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2015065383/20.
(150075251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2015.

UKSA 60 CR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 173.575.

Par résolutions prises en date du 22 avril 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination d'Ismaël Dian, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Vitalij Farafonov, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

3. Acceptation de la démission de Maxime Nino, avec adresse professionnelle au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2015.

Référence de publication: 2015063488/17.
(150072337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Umiak Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 59.273.

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 22 avril 2015

Monsieur Stéphane Cosco, employé privé, né le 5 juin 1976 à Villerupt (F) demeurant professionnellement au 3, Place

Dargent, L-1413 Luxembourg est coopté administrateur en remplacement de Monsieur Pascal De Graeve, démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2018.

Certifié sincère et conforme
Umiak Development S.A.

Référence de publication: 2015063489/13.
(150072578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

KPMG Luxembourg Foundation, Fondation.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg G 204.

<i>Audited Annual Accounts for the year ended 30 September 2014

<i>Pour KPMG Luxembourg Foundation
Carlo JENTGEN
<i>Secretary to the Board of Directors

<i>Annual accounts for the year ended 30 September 2014

(with report of the Réviseur d'Entreprises Agréé thereon)

Report of the Board of Directors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
Report of the Réviseur d'Entreprises agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
Annual accounts
- Balance sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

- Statement of income and Expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

- Notes to the annual accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 9

75659

L

U X E M B O U R G

<i>Report of the Board of Directors for the year ended 30 September 2014

The KPMG Luxembourg Foundation (the “Foundation”) was incorporated on i 9 March 2009 in the form of a Foundation

in accordance with the law of 21 April 1928, for an indefinite period. The registered office of the Foundation is established
at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number G 204. The incorporation and the statutes of the Foundation were approved by Grand Ducal decree on 27 April
2009.

The Foundation's financial year starts on I October and ends on 30 September.
The object of the Foundation is to provide financial support either through donations or loans, to development projects

benefiting  groups  of  people  in  need,  across  the  world,  in  particular,  but  not  exclusively,  in  Africa  and  Asia.  Projects
supported by the Foundation may be from the social sector, education or health as well as agricultural, manual and income
generating projects. Projects may be supported via direct financial assistance or through other associations, whether based
in Luxembourg or elsewhere in the world. Projects focusing on children are a priority for the Foundation.

The Board of Directors of the Foundation during the financial year includes the following members.
Roger Molitor-President:
Georges Bock, John Li, Louis Thomas, Jane Wilkinson, Stephen Nye, Véronique Barbieux -members.
Carlo Jentgen acts as Secretary to the Board.
The Board has delegated the day to day management and operations of the Foundation to Jane Wilkinson.
KPMG Luxembourg, the founder of the Foundation, is committed to contribute 0.16% of its annual turnover (calculated

in accordance with KPMG International rules). The 2014 contribution, based upon the turnover of KPMG in Luxembourg
for the financial year ended 30 September 2013, increased by other minor project specific donations, totals EUR 206,000.
The Foundation also benefitted from donations from KPMG staff of EUR 18,491.76 corresponding to total for donations
received of EUR 224,491.76.

In 2014, KPMG Luxembourg Foundation made donations for a total of EUR 202,648.84.
The operating revenue and expenditure led to a loss of EUR (7.98).
A total amount of capital and reserves of EUR 406,137.71 is carried forward to the next financial year.
The following donations were made during the financial year ended 30 September 2014:

2014

2013

EUR

EUR

Local based projects:
ALUPSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37,535.00

65,155.00

Centre St Aubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,564.00

1,036.00

Ile aux clowns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

25,000.00

Fondation Kriibskrank Kanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

7,800.00

Nestwärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,000.00

10,000.00

Point d'eau/Grumelage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

10,000.00

Pédiatrie Enchantée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,000.00

10,000.00

Project 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

5,555.00

Fondation Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,200.00

-

Sundry Donations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,883.84

5,175.44

International projects:
Aide à l'enfance de l'Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,000.00

15,000.00

ASTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,000.00

15,000.00

Care in Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47,466.00

21,950.00

Chrétiens pour le Sahel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,000.00

-

CSI Letzebuerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,000.00

10,000.00

Friendship Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,000.00

40,000.00

LP4Y Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

15,000.00

Pour un Sourire d'Enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000.00

20,000.00

202,648.84 276,671.44

Luxembourg, 28 November 2014.

John Li / Jane Wilkinson
<i>Director of the Board / Director of the Board

<i>Report of the réviseur d'entreprises agréé

Report on the annual accounts

75660

L

U X E M B O U R G

We have audited the accompanying annual accounts of KPMG LUXEMBOURG FOUNDATION, which comprise the

balance sheet as at 30 September 2014 and the statement of income and expenditure for the year then ended, and a summary
of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of the Board of directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation of these annual accounts in accordance with the accounting

policies set out in the notes to the annual accounts, and for such internal control as the Board of Directors determines is
necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.

Responsibility of the Réviseur d'Entreprises Agréé
Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in

accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance about whether the annual accounts are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual

accounts. The procedures selected depend on the Réviseur d'Entreprises Agréé's judgement, including the assessment of
the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
the Réviseur d'Entreprises Agréé considers internal control relevant to the entity's preparation of the annual accounts in
order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion
on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors, as well as evaluating the
presentation of the annual accounts.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the annual accounts of KPMG LUXEMBOURG FOUNDATION for the year ended 30 September 2014

are prepared, in all material respects, in accordance with the accounting policies set out in the notes to the annual accounts.

Report on other legal and regulatory requirements
The Board of Directors' report, which is the responsibility of the Board of Directors, is consistent with the annual

accounts.

Luxembourg, 28 November 2014.

Fiduciaire Kohn Révision S.à r.l.
<i>Cabinet de révision agréé
Tania Kohn

<i>Balance sheet as at 30 September 2014

<i>(expressed in EUR)

30 September

2014

30 September

2013

Notes

EUR

EUR

ASSETS
Current assets
Debtors due within less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510.25

1.185.00

Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

406374.96

383.865.27

TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

406,885.21

385.050.27

LIABILITIES
Capital and reserves
Initial capital contribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

500,000.00

500,000.00

Profit or loss brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(115.697.23)

(44.339.75)

Net project related rcvcnue/(expenditure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,842.92

(72,372.46)

Net operating (loss)/profit for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7,98)

1,014.98

406,137.71

384,302.77

Creditors
Other creditors
Becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

747,50

747,50
747,50

TOTAL LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

406,885.21

385,050.27

75661

L

U X E M B O U R G

<i>Statement of Income and Expenditure

<i>For the year ended 30 September 2014

<i>(expressed in EUR)

Year ended

30 September

2014

Year ended

30 September

2013

Notes

EUR

EUR

PROJECT RELATED EXPENDITURE
Donations received
KPMG Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206,000.00

199,000.00

KPMG employee donations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,491.76

6,298.98

224,491.76

205,298.98

Donations made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

(202,648.84)

(276,671.44)

Event sponsorship and related costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

(1,000.00)

Net project related (expenditure)/revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,842.92

(72,372.46)

OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE
Interest receivable and similar income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

852.27

1,620.66

Other operating income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

576.24

Operating income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

852.27

2,196.90

Other operating charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

(747.50)

(1,061.67)

Interest payable and similar charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(112.75)

(120.25)

Operating expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(860.25)

(1.181.92)

Net operating profit for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7.98)

1,014.98

The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.

Notes to the annual accounts as at 30 September 2014

1. General. The KPMG Luxembourg Foundation (the "Foundation") was incorporated on 19 March 2009 in the form

of a Foundation in accordance with the law of 21 April 1928, for an indefinite period. The registered office of the Foundation
is established at 9, allée Scheffer. L-2520 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number G 204. The incorporation and the statutes of the Foundation were approved by Grand Ducal decree
on 27 April 2009.

The Foundation's financial year starts on 1 October and ends on 30 September.
The object of the Foundation is to provide financial support either through donations or loans, to development projects

benefiting  groups  of  people  in  need,  across  the  world,  in  particular,  but  not  exclusively,  in  Africa  and  Asia.  Projects
supported by the Foundation may be from the social sector, education or health as well as agricultural, manual and income
generating projects. Projects may be supported via direct financial assistance or through other associations, whether based
in Luxembourg or elsewhere in the world.

2. Presentation of the annual accounts and significant accounting policies. The annual accounts as at 30 September 2014

have been established principally in accordance with the law of 19 December 2002, as amended, relating to the preparation
of the annual accounts and the significant accounting policies outlined below. The presentation of the balance sheet and
the statement of income and expenditure have been adapted to reflect the specificities of the Foundation's activity.

The Foundation maintains its accounting records in Euro (EUR) and its annual accounts are expressed in this currency.

Monetary assets and liabilities denominated in other currencies are translated into EUR at the rates prevailing at the balance
sheet date. Expenditure and income in foreign currencies are converted into EUR at the exchange rate prevailing at date
of the transactions. Realised exchange gains and losses and unrealised losses are taken directly to the statement of income
and expenditure.

Donations received by the Foundation are accounted for on the date of receipt.
Donations made to associations for which a formal decision has been taken by the Board of Directors or where donations

have been collected by the Foundation, but which have not been paid as at the year end, are included in Donations Payable
in the balance sheet and Donations Made in the statement of income and expenditure.

Interest income and expenses are recorded in the statement of income and expenditure on an accruals basis.
Debtors and creditors are recorded at nominal value.

3.  Cash  at  bank.  The  Foundation  held  EUR  406,374.96  in  cash  balances  as  at  30  September  2014  (2013:  EUR

383,865.27). The Board of Directors of the Foundation has decided to hold all significant cash balances in a BCEE Etika
savings account. Etika, a Luxembourg based non-profit organisation ("asbl"), in collaboration with BCEE, offers an ethical
alternative savings account. The account is a capital savings account with a guaranteed interest return which is lower than

75662

L

U X E M B O U R G

a classic savings account but investors choose to accept a lower rate of return, in the knowledge that they are enabling
promoters of social and environmental projects to obtain credits and loans at a more advantageous rate, thus supporting
the financing of projects which combine an economic rate of return whilst respecting people and environmental projects.

4. Capital and reserves. The initial capital contribution received in March 2009 relates to the initial contribution made

by the Founder of the Foundation, amounting to EUR 500 000.00. The opening net reserves of the Foundation as at 1
October 2013 amounted to EUR 384,302.77 (1 October 2012: EUR 455.660.25).

5. Other operating charges. In 2012/33 other operating charges included an amount of EUR 314.17 which relates to the

expenses incurred visiting the projects operated by Friendship in Bangladesh.

The general indirect operating costs such as accounting, operations management etc are borne by KPMG Luxembourg

S.àr.l. on behalf of the Foundation.

6. Donations made. The following donations were made or committed during the year:

2014

2013

EUR

EUR

Local based projects:
ALUPSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37,535.00

65,155.00

Centre St Aubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,564.00

1,036.00

Ile aux clowns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

25,000.00

Fondation Kriibskrank Kanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

7,800.00

Nestwärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,000.00

10,000.00

Point d'eau/Grumelage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

10,000.00

Pédiatrie Enchantée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,000.00

10,000.00

Project 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

5,555.00

Fondation Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,200.00

-

Sundry Donations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,883.84

5,175.44

International projects:
Aide à l'enfance de l'Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,000.00

15,000.00

ASTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,000.00

15,000.00

Care in Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47,466.00

21,950.00

Chrétiens pour le Sahel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,000.00

-

CSI Letzebuerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,000.00

10,000.00

Friendship Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,000.00

40,000.00

LP4Y Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

15,000.00

Pour un Sourire d'Enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000.00

20,000.00

202,648.84 276,671.44

Subsequent to 30 September 2014, the Board of Directors resolved to make a donation from the 2013/2014 budget of

EUR 15,000 to Care in Luxembourg related to disaster relief support to the Philippines following Typhoon Haiyan. This
donation will be recorded in the Donations made in the following financial year 2014/2015.

During the previous financial year, the Board of Directors committed to make a total donation of EUR 50,000 to Ile aux

Clowns. A payment of EUR 25,000 has been made in the prior financial year. The remaining donation of EUR 25,000 will
become payable should the Board of Ile aux Clowns consider it necessary and make a formal request for payment. Such a
request has not yet been received by the Foundation.

<i>Budget for the year ending 30 September 2015

<i>(expressed in EUR)

1.10.2014-

30.9.2015

1.10.2013-

30.9.2014

EUR

EUR

PROJECT RELATED INCOME AND EXPENDITURE
Donations received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 000.00

200 000.00

Donations made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (200 000.00) (200 000.00)
Project related expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2 000.00)

(2 000.00)

Net project related income / (expenditure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2 000.00)

(2 000.00)

OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE
Interest receivable and similar income

-

-

Operating income

-

-

75663

L

U X E M B O U R G

Other operating charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 300.00)

(1 300.00)

Interest payable and similar charges

-

-

Operating expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 300.00)

(1 300.00)

Net operating profit / (loss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 300.00)

(1 300.00)

Référence de publication: 2015064934/240.
(150074252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.

Vectorline Beteiligungsmanagement &amp; Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 154.128.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015063495/9.
(150072480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Villa Sphere Ovest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 172.076.

Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VILLA SPHERE OVEST S.À.R.L.

Référence de publication: 2015063496/10.
(150072371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Violane Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 140.265.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015063497/10.
(150072078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

VisuConcept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 10, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 134.236.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015063498/9.
(150072031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Real Estate Development 2015 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 196.440.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of April.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg)

THERE APPEARED:

FMS Wertmanagement AöR, a German institution under public law (Anstalt des öffentlichen Rechts), having its regis-

tered office at Prinzregentenstrasse 56, 80538 Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court
in Munich under number HRA 96076 (the "Founding Shareholder"),

75664

L

U X E M B O U R G

here represented by Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, with business address in l-8510 Redange-sur-Attert, Grand

Duchy of Luxembourg (the "Representative"), by virtue of a power of attorney, which, after having been signed “ne varietur”
by the Representative and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Founding Shareholder, represented by the Representative, has requested the undersigned notary to draw up the

following articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declared
to establish.

Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form.
1.1 There is hereby established a company in the form of a private limited liability company ("société à responsabilité

limitée") (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10
August 1915 on commercial companies, as amended (the "Act"), Article 1832 of the Luxembourg Civil Code, as amended,
and the present articles of incorporation (the "Articles").

1.2 The Company may have one sole shareholder or several shareholders, provided that the number of shareholders

does not exceed forty (40).

2. Company name.
2.1 The Company exists under the name "Real Estate Development 2015 S.à r.l.".

3. Registered office.
3.1 The Company has its registered office in the city of Luxembourg.
3.2 The Management is authorised to change the address of the Company's registered office within the municipality of

the Company's registered office.

3.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of

the Management.

3.4 In the event that, in the opinion of the Management, extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the
registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a com-
pany governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

4. Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever,

in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such stake-
holdings.

This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public

offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-
liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in
any type of company, entity or other legal person.

The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or im-

movable asset in any form or of any kind.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of

indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans,

money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security)
to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to
undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is
in the Company's interest and does not trigger any license requirements.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other

activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and
development of its corporate purpose.

Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a

regulated activity or one that requires the Company to have a licence.

5. Duration. The Company is established for an indefinite period of time.

Share capital, Transfer of shares

6. Share capital.
6.1 The share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into twelve

thousand five hundred (12,500) shares, each with a par value of one euro (EUR 1.-).

75665

L

U X E M B O U R G

6.2 In addition to the share capital, the shareholder(s) of the Company (the "Shareholder(s)") may decide to set up a

share premium account. Any premium paid on shares in addition to the par value must be transferred into this share premium
account. The funds of the share premium account may be used by the Company to redeem the Company's own shares from
Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

6.3 In addition to the share capital and share premium account, the Company may maintain a capital contribution account

115 (compte 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres») on which the Company shall allocate any
capital contributions to the Company which will be made without issue by the Company of any new shares in consideration
for the relevant contribution.

6.4 The Company may only acquire its own shares for the purpose of and subject to their immediate cancellation.
6.5 The share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by the Shareholders in accor-

dance with these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to any amendment of these Articles.

7. Shares.
7.1 All shares will be and remain in registered form.
7.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles and the resolutions adopted by the Shareholders.
7.3 Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
7.4 Each share of the Company is indivisible vis-à-vis the Company. Co-owners of shares must be represented by a

common representative vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to the share until a common representative has been notified by the co-owners to the Company in writing or by fax.

8. Transfer of shares.
8.1 The shares may be transferred freely amongst the Shareholders.
8.2 Where the Company has a sole Shareholder, such Shareholder may freely transfer his/her/its shares.
8.3 Where the Company has several Shareholders, any transfer of shares to third parties requires the consent of the

Shareholders representing at least three quarters of the issued share capital.

8.4 Any transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. No transfer of shares is binding

vis-à-vis  the  Company  or  vis-à-vis  third  parties  unless  duly  notified  to  the  Company  or  accepted  by  the  Company  in
accordance with the applicable Luxembourg law on transfers of claims, in particular, without limitation, article 1690 of
the Luxembourg Civil Code.

Management; Auditor

9. Managers.
9.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be Shareholders (the "Manager

(s)").

9.2 The Managers are appointed by the Shareholders who determine (i) their number, (ii) their remuneration and (iii)

the limited or unlimited duration of their mandate.

9.3 The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected and may be removed at any

time, with or without cause, by the Shareholders.

9.4 The Shareholders may decide to qualify the appointed Managers as class A managers and class B managers res-

pectively.

9.5  Even  after  the  term  of  their  mandate,  the  Managers  are  not  entitled  to  disclose  confidential  information  of  the

Company or any Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure
is mandatory by law.

10. Board of Managers.
10.1 Where more than one Manager has been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board").
10.2 The Board may appoint a Manager as its chair (the "Chair of the Board").

11. Powers of Management.
11.1 The sole Manager or the Board (as applicable) (the "Management") is vested with full powers to act on behalf of

the Company and to authorize, on behalf of the Company, all acts whether of an administrative or of a disposal nature
which the Management in its full discretion deems necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers
not expressly reserved by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg to the Shareholders fall within the competence of
the Management.

11.2 The Management may also set up one or more committee(s) and determine its/their composition and powers and

delegate certain powers and/or special mandates to them.

11.3 The Management may confer certain powers and/or special mandates to act on behalf of and bind the Company,

vis-à-vis third parties, to one or several Manager(s), Shareholder(s) or third person(s), any of these acting either alone or
jointly as determined by the Management.

75666

L

U X E M B O U R G

12. Meetings of the Board and Written Decisions.
12.1 The Board will meet upon the request of any Manager.
12.2 Such Manager will inform the other Managers of the place, date, time and agenda of the meeting by written notice

or email. Such notice must be received by the Managers at least twenty-four hours prior to the meeting. No separate notice
is required for meetings held at places, dates and times specified in a time schedule previously adopted by a decision of
the Board and in case of urgency.

12.3 The above mentioned notice requirement may be waived in writing by the concerned Manager(s) or by the unani-

mous written consent of all Managers at the relevant meeting of the Board.

12.4 At each Board meeting, the Board shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of the majority of the

Managers present or represented at such meeting.

12.5 The Board may also appoint a secretary, whether a Manager or not, who will be responsible for keeping the minutes

of the meeting.

12.6 Managers may attend and act at any Board meeting by appointing another Manager in writing as her/his represen-

tative.

12.7 Managers may participate in a Board meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar

means of communication enabling several persons to communicate with each other. Such methods of participation are to
be considered as equivalent to a physical presence at the relevant meeting.

12.8 A quorum of the Board shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office,

provided, whenever applicable, that at least a Class A Manager and a Class B Manager are present. Decisions will be taken
by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting and this majority shall at least,
whenever applicable, include a Class A Manager and a Class B Manager.

12.9 Decisions of the Board are taken by a majority of the Managers present or represented at the relevant Board meeting.

In the case of a tied vote, the Chair of the Board does not have a casting vote.

12.10 The minutes of Board meetings must be drawn up and signed by all Managers present at the relevant meeting.

Any powers of attorney shall remain attached to the minutes.

12.11 A written decision signed by all Managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented in either a single document signed by all
Managers or in several separate documents all with the same content each of them signed by one or several Managers.

12.12 Where only one Manager has been appointed, such Manager has full power to act on behalf of and validly bind

the Company without the need of any decision in writing or minutes of the sole Manager´s decisions.

12.13 Copies or extracts of the minutes of the Board meeting shall be certified by the Management

13. Representation of the Company.
13.1 Where only one Manager has been appointed, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the sole signature

of that Manager.

13.2 Where the Company is managed by a Board, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the joint signatures

of any two Board members.

13.3 Notwithstanding the above, the Company will be bound vis-à-vis third parties only by sole signature of one class

A manager if the sole shareholder or the Shareholders (as applicable) have qualified the Managers as class A managers
and class B managers.

13.4 Notwithstanding the above, the Company will also be bound vis-à-vis third parties by any person to whom valid

powers of representation have been delegated by the sole Manager of the Board, as applicable.

14. Conflict of Interests.
14.1 Subject to the following, the conflict of interest rules as set out in article 57 of the Act shall apply.
14.2 No contract or other business between the Company and a third party be affected or invalidated by the sole fact

that one or several duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager may have a
direct or indirect personal interest in the relevant matter.

14.3 If the sole Manager or all Managers are conflicted with respect to a certain matter, the matter shall be resolved

upon by the General Meeting of Shareholders or the Sole Shareholder (as applicable).

15. Indemnification of Managers.
15.1 The Company will indemnify its Manager(s), and, if applicable, their successors, heirs, executors and administra-

tors, against damages and expenses reasonably incurred in connection with any action, suit or proceeding to which the
Manager(s) is/(are) party for being or having been Manager(s) of the Company or, at the request of the Company, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor if and to the extent they are not entitled to indemnification
by such other company.

15.2 Indemnification will only be provided if and to the extent the Manager(s) is/(are) not finally adjudged in an action,

suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct or mens rea.

75667

L

U X E M B O U R G

15.3 In the event of a settlement, indemnification will only be provided if and to the extent the Company is advised by

its legal counsel that the Manager(s) did not commit a breach of his/her duties.

15.4 The foregoing right of indemnification does not exclude other rights to which the Manager(s) and, if applicable

its/(their) successors, heirs, executors and administrators may be entitled.

16. Audit.
16.1 If no independent auditor is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has more

than twenty-five (25) Shareholders, the Company's annual accounts are to be audited by one or more statutory auditors,
which can either be one or several Shareholders or third persons.

16.2 If no independent auditor is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has twenty-

five (25) or less Shareholders, the Shareholders may decide, without being obliged to do so, to have the annual accounts
audited by one or more statutory auditors, being either Shareholders or third persons.

16.3 The auditor(s) shall be appointed by the Shareholders who shall determine the (i) number of auditors, (ii) remu-

neration of the auditor(s) and (iii) duration of the mandate of the auditor(s). The auditor(s) will hold office until their
successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without
cause, by the Shareholders.

Shareholders

17. Shareholders' Resolutions.
17.1 The Shareholders decide by passing resolutions either in Shareholders' meetings or, subject to the limitations set

forth in these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by written resolutions.

17.2 One vote is attached to each share, except as otherwise provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
17.3 Any amendment to the Articles must be approved by (i) the majority of Shareholders in number and (ii) three-

quarters of the issued share capital, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the
Articles.

17.4 All other Shareholders' resolutions will be taken by Shareholders representing more than half of the issued share

capital of the Company, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles.
In case the quorum is not reached at the first meeting, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by
registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of issued share
capital represented.

18. Written Resolutions.
18.1 If the Company has twenty five (25) or less Shareholders, the Shareholders' resolutions do not have to be passed

in Shareholders' meetings but may also be passed by written resolution.

18.2  The  text  of  resolutions  to  be  adopted  by  written  resolution  will  be  sent  to  the  Shareholders  in  writing  by  the

Management by registered letter, letter, e-mail or fax. Shareholders are under the obligation to cast their vote and send it
back to the Management of the company by registered letter, letter, e-mail or fax within fifteen (15) days as from the receipt
of the letter. Any votes not cast within this time frame will be considered as having abstained from voting.

18.3 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions may be waived by

unanimous written resolution of all Shareholders in the relevant written resolution or otherwise.

18.4 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions do not apply if the

Company has only one Shareholder. All resolutions adopted by a sole Shareholder must, however, be documented in writing
and signed by the sole Shareholder.

18.5 Any copies or extracts of the written Shareholders' resolutions shall be certified by the Management.

19. Shareholders' meetings.
19.1 An annual Shareholders' meeting needs only be held if the Company has more than twenty-five (25) Shareholders.

In that case, these Articles shall be amended in order to provide for the date and time at which such annual Shareholders'
meeting shall be held.

19.2 Extraordinary Shareholders' meetings are convened in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg

by notice of the Management, the auditor(s) of the Company or the Shareholder(s) representing at least half of the issued
share capital of the Company (if any).

19.3 A Shareholders' meeting may only be held abroad if, in the opinion of the Management, this should be necessary

due to circumstances of force majeure.

19.4 The notice convening the Shareholders' meeting shall indicate the place, date, time and agenda of the meeting and

shall be sent to the Shareholders at least eight (8) days prior to the meeting. The above mentioned notice requirement may
be waived in writing by the concerned Shareholder(s) or by the unanimous written consent of all Shareholders at the relevant
meeting of the Shareholders.

19.5 Any duly constituted Shareholders' meeting represents all the Shareholders of the Company.

75668

L

U X E M B O U R G

19.6 If the Company has only a sole Shareholder, this sole Shareholder exercises the powers granted to the general

meeting of shareholders by applicable law and these Articles. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915,
as amended from time to time, are not applicable to that situation.

20. Procedure at Shareholders' meetings.
20.1 A Shareholder may act at a Shareholders' meeting by appointing a representative, who does not have to be a

Shareholder, in writing or by fax.

20.2 Shareholder(s) may participate in a Shareholders' meeting by means of a conference call, by videoconference or

by any similar means of communication enabling several persons to communicate with each other. Such participation shall
be deemed equivalent to a physical presence at the relevant meeting.

20.3 The Management may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Shareholders'

meeting.

20.4 At each meeting of the Shareholders, the Shareholders shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of

the majority of the Shareholders present or represented at such meeting (the "Chair of the Shareholders' Meeting").

20.5 The Chair of the Shareholders' Meeting will appoint a secretary. The Shareholders will appoint one or several

scrutineer(s). The Chairman of the Shareholders' meeting together with the secretary and the scrutineer(s) form the bureau
of the general meeting (the "Bureau").

20.6 An attendance list indicating the (i) name of the Shareholders, (ii) number of shares held by them and, if applicable,

(iii) name of the representative, must be drawn up and signed by the members of the Bureau.

20.7 Minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting shall be drawn up and signed by the Bureau.
20.8 Copies or extracts of the minutes of the Shareholders' meeting shall be certified by the Management.

Financial year, Distributions of earnings

21. Financial year.
21.1 The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month

of December.

22. Approval of financial statements.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Management will draw up the annual accounts

of the Company in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

22.2 The Management will submit the annual accounts of the Company to the company's auditor(s), if any, for review

and to the Shareholders for approval.

22.3 Each Shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

23. Allocation of Profits.
23.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg. This allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. The reserve can be used in whole or in part
to (i) absorb existing losses, if any, (ii) put into a reserve or provision, (iii) carry it forward to the next following financial
year or (iv) be distributed to the Shareholders as a dividend.

23.2 The Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated.

24. Interim dividends. The Management is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts

have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a dis-
tribution.

Dissolution, Liquidation

25. Dissolution and liquidation.
25.1 The dissolution of the Company may be resolved by its Shareholders with the same quorum and majority required

to amend these Articles, unless otherwise provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

25.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

Shareholders determining powers and compensation of the liquidator(s).

25.3 After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses

pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the Shareholders
pro rata to the number of the shares held by them.

Applicable law

26. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined by the applicable law.

75669

L

U X E M B O U R G

<i>Transitory provisions:

The first financial year of the Company will begin on the present date and end on 31 December 2015.

<i>Subscription and payment:

Thereupon, the Founding Shareholder, represented by the Representative, declared to subscribe to and to fully pay in

cash all the twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value amount of one euro (EUR 1.-) each issued by
the Company.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183

of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended by article 1832 of the civil code, as amended, have
been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment..

<i>Resolutions of the founding shareholder:

The Founding Shareholder, represented by the Representative, in its capacity as sole shareholder of the Company,

thereupon passed the following shareholders' resolutions:

1. The company shall be represented by three (3) managers (the “Managers”).
2. The following are appointed as Managers of the Company for an unlimited period:
- Mr Mariano PEREZ-DURANTEZ, born in Valladolid, Spain, on 28 March 1979, residing professionally at Prinzre-

gentenstrasse 56, 80538 Munich, Germany, as class A Manager of the Company;

- Ms Katia CAMBON, born in Le Raincy, France on 24 May 1972, residing professionally at 16, Avenue Pasteur, L-2310

Luxembourg, as class B Manager of the Company;

- Ms Marina KERNEUR, born in Ploemeur, France on 19 June 1978, residing professionally at 16, Avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, as class B Manager of the Company.

3. The registered office of the Company shall be at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-

bourg).

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this deed are estimated at approximately EUR 1,600.-.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the date stated at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the French
text, the English text shall prevail.

This document was read to the Representative, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and

residence. This original deed was then signed by the Representative together with the notary.

Nachfolgend die Deutsche Fassung des Vorstehenden Textes:

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten April.
Ist vor mir, Maître Danielle KOLBACH, Notar mit Sitz in Redingen (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

FMS Wertmanagement AöR, eine nach Deutschem Recht gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts mit eingetragenem

Sitz in Prinzregentenstrasse 56, 80538 München, Deutschland, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mün-
chen, deutschland unter Nummer HRA 96076 (der „Gründungsgesellschafter“) erschienen,

vertreten durch Frau Virginie PIERRU, Notarschreiber, mit Adresse in L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue

(Großherzogtum Luxemburg) (der „Vertreter“), kraft einer Vollmacht.

Welche Vollmacht, nachdem sie durch den oben benannten Vertreter und den unterzeichnenden Notar „ne varietur“

gezeichnet wurde, mit dieser Urkunde verbunden bleiben soll, um zusammen registriert zu werden.

Die oben benannte Partei, vertretet wie oben erwähnt, erklärt ihre Absicht, mit dieser Urkunde eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung zu gründen und die folgende Satzung aufzuzeichnen:

Gesellschaftsform, Name, Geschäftssitz, Gegenstand, Dauer,

1. Gesellschaftsform.
1.1 Hiermit wird durch ein einziges Gründungsmitglied eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter

Haftung („société à responsabilité limitée“) (die „Gesellschaft“) gegründet, die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg
unterliegt, und zwar insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden
Fassung (das „Gesetz“), Artikel 1832 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung sowie
der vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung“).

75670

L

U X E M B O U R G

1.2 Die Gesellschaft besteht anfänglich aus einem alleinigen Gesellschafter. Die Gesellschaft darf jedoch jederzeit aus

einer beliebigen Anzahl von Gesellschaftern bestehen, soweit sie nicht über vierzig (40) beträgt.

2. Firmenname.
2.1 Die Gesellschaft besteht unter dem Namen „Real Estate Development 2015 S.à r.l.“.

3. Eingetragener Firmensitz.
3.1 Der eingetragene Firmensitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
3.2 Der Vorstand ist ermächtigt, die Anschrift des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde

des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft zu ändern.

3.3 Zweigstellen bzw. sonstige Niederlassungen können auf Beschluss des Vorstands entweder im Großherzogtum

Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

3.4 Sollten nach Ansicht der Geschäftsführung außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ent-

wicklungen vorliegen oder bevorstehen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Firmensitz
oder die problemlose Kommunikation mit dem besagten Sitz oder zwischen diesem Sitz und sich im Ausland aufhaltenden
Personen beeinträchtigen würden, so darf sie den eingetragenen Firmensitz vorübergehend und bis zum Ende dieser au-
ßerordentlichen  Umstände  ins  Ausland  verlegen.  Derartige  zeitweiligen  Maßnahmen  haben  keinen  Einfluss  auf  die
Nationalität der Gesellschaft; sie bleibt ungeachtet der zeitweiligen Verlegung des eingetragenen Firmensitzes eine dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft.

4. Gegenstand.
4.1 Der Gegenstand der Gesellschaft besteht in dem unmittelbaren und mittelbaren Erwerb und Halten von Beteiligun-

gen, in jedweder Form, an luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmungen, sowie der Verwaltung, Entwicklung
und dem Management von solchen Beteiligungen.

4.2 Dies umfasst, ohne jedoch darauf begrenzt zu sein, die Investition in, den Erwerb von und die Verfügung über, die

Gewährung von oder die Ausgabe (ohne öffentliche Auflegung) von Preferred Equity Certificates, Darlehen, Schuldver-
schreibungen, Anleihen, Pfandbriefe und andere Schuldtitel, Gesellschaftsanteile, Optionsscheine und andere Eigenkapi-
talinstrumente  und  -  rechte,  einschließlich  und  ohne  darauf  beschränkt  zu  sein,  Stammaktien,  Kapitaleinlagen  in
Kommanditgesellschaften, Kapitaleinlagen in Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Vorzugsaktien, Wandelschuld-
verschreibungen und Swaps, sowie jede Kombination davon, in jedem Fall unabhängig davon, ob leicht handelbar oder
nicht, und Obligationen (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, synthetische Schuldverschreibungen) in jeder Art
von Gesellschaft, juristischen Person oder anderem Rechtssubjekt.

4.3 Die Gesellschaft kann ihre Mittel auch dazu verwenden, in Immobilien, Immaterialgüterrechte oder andere beweg-

liche oder unbewegliche Vermögenswerte in jedweder Form oder jedweder Art zu investieren.

4.4 Die Gesellschaft kann luxemburgischen und ausländischen Rechtssubjekten Bürgschaften, Garantien, Pfandrechte,

Hypotheken und jede andere Form von Sicherheit sowie jede Form von Freistellung, im Hinblick auf ihre eigenen Ver-
pflichtungen und Schulden, gewähren.

4.5 Die Gesellschaft kann zudem den Tochtergesellschaften der Gesellschaft Unterstützung in jedweder Form (ein-

schließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, der Erweiterung von Vorauszahlungen, Darlehen, Geldeinlagen und Krediten
sowie der Gewährung von Bürgschaften, Garantien, Pfandrechten, Hypotheken und jeder anderen Form von Sicherheit)
zukommen lassen. Die Gesellschaft kann Unternehmungen, die Teil der gleichen Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört,
sind, oder Dritten gelegentlich die gleiche Art von Unterstützung zukommen lassen, vorausgesetzt, dass dies im Interesse
der Gesellschaft liegt und keine Genehmigungspflichten auslöst.

4.6 Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jedwede kommerzielle, industrielle und finanzielle Transaktionen durchfüh-

ren  und  solche  weiteren  Tätigkeiten  ausüben,  die  sie  zum  Erreichen  oder  zur  Entwicklung  des  Gesellschaftszwecks
notwendig, ratsam, geeignet, gelegen oder nicht unvereinbar erachtet.

4.7 Ungeachtet des Vorstehenden darf die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen, die dazu führen würden, dass sie eine

reglementierte Tätigkeit ausübt oder eine Tätigkeit, für die die Gesellschaft eine Lizenz benötigt.

5. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Stammkapital und Übertragung von Anteilen

6. Stammkapital.
6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), verteilt auf zwölftau-

sendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils ein Euro (EUR 1).

6.2 Der/die Gesellschafter der Gesellschaft (der/die „Gesellschafter“) ist/sind berechtigt, die Bildung einer Agiorücklage

zusätzlich zum Stammkapital zu beschließen. Jedes Aufgeld, das zusätzlich zum Nennwert für Anteile bezahlt wurde, muss
in  dieses  Agiorücklage  übertragen  werden.  Die  Mittel  der  Agiorücklage  dürfen  von  der  Gesellschaft  dafür  eingesetzt
werden, ihre Anteile von Gesellschaftern zurückzukaufen, Nettoverluste auszugleichen, Ausschüttungen an die Gesell-
schafter vorzunehmen oder Mittel in die gesetzliche Rücklage einzustellen.

75671

L

U X E M B O U R G

6.3  Neben  dem  Stammkapital  und  der  Agiorücklage  kann  die  Gesellschaft  ein  Kapitaleinlagenkonto  115  (compte

115»Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres«) einrichten, in das die Gesellschaft Einlagen in die Gesell-
schaft einstellen kann, die erfolgen, ohne dass die Gesellschaft neue Anteile als Gegenleistung für die entsprechende Einlage
ausgibt.

6.4 Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile nur zwecks und vorbehaltlich ihrer unverzüglichen Einziehung erwerben.
6.5 Die Gesellschafter können das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals in Übereinstimmung mit dieser

Satzung und dem auf die jeweiligen Fassung dieser Satzung anwendbaren Recht des Großherzogtums Luxemburg verrin-
gern oder erhöhen.

7. Anteile.
7.1 Alle Anteile sind Namensanteile und bleiben als Namensanteile bestehen.
7.2 Der Besitz eines Anteils ist mit der stillschweigenden Annahme der Satzung und der von den Gesellschaftern ge-

fassten Beschlüsse verbunden.

7.3 Jeder Anteil berechtigt in den von den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg auferlegten Grenzen zu einer

Stimme.

7.4 Gegenüber der Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Mitinhaber von Anteilen müssen gegenüber der Gesellschaft

durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte, die mit
einem Anteil verbunden sind, so lange auszusetzen, bis die Mitinhaber der Gesellschaft gegenüber schriftlich oder per
Telefax einen gemeinsamen Vertreter ernannt haben.

8. Übertragung von Anteilen.
8.1 Die Anteile können unter den Gesellschaftern frei übertragen werden.
8.2  Sofern  die  Gesellschaft  nur  einen  einzigen  Gesellschafter  hat,  darf  dieser  Gesellschafter  seine/ihre  Anteile  frei

übertragen.

8.3 Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, bedarf jede Übertragung von Anteilen an Dritte der Zustimmung

seitens der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des gesamten begebenen Stammkapitals repräsentieren.

8.4 Jede Übertragung der Anteile muss durch eine notarielle Urkunde oder einen privatschriftlichen Vertrag nachge-

wiesen werden. Für die Gesellschaft oder für Dritte sind keine Anteilsübertragungen bindend, die der Gesellschaft nicht
ordnungsgemäß bekannt gegeben oder nicht gemäß den Regeln für die Übertragung von Ansprüchen gemäß den Gesetzen
des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches von der
Gesellschaft angenommen wurden.

Geschäftsführung; Wirtschaftsprüfer

9. Geschäftsführer.
9.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, wobei es sich sowohl um Gesellschafter

als auch um Nicht-Gesellschafter handeln kann (der/die „Geschäftsführer“).

9.2 Der/die Geschäftsführer wird/werden von den Gesellschaftern ernannt, die (i) ihre Anzahl, (ii) ihre Vergütung und

(iii) die begrenzte oder unbegrenzte Dauer ihres Mandats bestimmen.

9.3 Der/die Geschäftsführer bekleidet/bekleiden sein Amt/ihre Ämter, bis sein/ihre Nachfolger gewählt werde(n). Sie

dürfen von den Gesellschaftern wiedergewählt und jederzeit mit oder ohne sachlichen Grund von ihnen entlassen werden.

9.4 Die Gesellschafter können beschließen, den/die ernannten Geschäftsführer als Klasse-A- und Klasse-B-Geschäfts-

führer zu qualifizieren.

9.5 Auch nach dem Ablauf ihres Mandats ist der/sind die Geschäftsführer nicht zur Offenlegung vertraulicher Infor-

mationen der Gesellschaft oder von Gesellschaftsinformationen berechtigt, die den Interessen der Gesellschaft schaden
könnten, es sei denn, eine solche Offenlegung ist gesetzlich vorgeschrieben.

10. Vorstand.
10.1 Sofern mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden die Geschäftsführer einen Vorstand (der „Vorstand“).
10.2 Der Vorstand ernennt einen Geschäftsführer zum Vorstandsvorsitzenden (der „Vorstandsvorsitzende“).

11. Befugnisse der Geschäftsführung.
11.1  Der  Geschäftsführer  oder  der  Vorstand  (je  nachdem,  was  zutreffend  ist)  (die  „Geschäftsführung“)  ist  mit  der

Befugnis ausgestattet, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Maßnahmen administrativer oder anordnender Natur
durchzuführen bzw. zu genehmigen, die im Sinne der Erreichung des Zwecks der Gesellschaft erforderlich bzw. nützlich
sind. Alle Befugnisse, die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg nicht ausdrücklich den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung.

11.2 Die Geschäftsführung kann auch einen oder mehrere beratende Ausschüsse bestellen und deren Zusammensetzung

und Zweck bestimmen.

11.3  Die  Geschäftsführung  kann  bestimmte  Befugnisse  und/oder  besondere  Mandate  einschließlich  der  Vertretung

gegenüber Drittparteien auf einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder Dritte übertragen, wobei diese jeweils
allein oder gemeinsam handeln können.

75672

L

U X E M B O U R G

12. Sitzungen des Vorstands und Schriftform der Beschlüsse.
12.1 Der Vorstand tritt auf Antrag eines beliebigen Vorstandsmitglieds zusammen.
12.2 Der Vorstandsvorsitzende informiert alle Vorstandsmitglieder mittels einer schriftlichen Mitteilung oder per E-

Mail über den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung. Diese Mitteilung muss den Vorstandsmit-
gliedern mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Sitzung zugehen. Im Fall von Sitzungen, die an Orten, an Tagen und
zu Uhrzeiten, die im Voraus durch einen Vorstandsbeschluss festgelegt wurden, und in dringenden Fällen ist eine gesonderte
Mitteilung nicht erforderlich.

12.3 Auf das Erfordernis einer Mitteilung kann durch einstimmige schriftliche Zustimmung aller Vorstandsmitglieder

bei der Sitzung des Vorstands oder auf andere Weise verzichtet werden.

12.4 Der/die Vorstandsvorsitzende hält den Vorsitz bei allen Vorstandssitzungen. Ist er/sie abwesend, kann der Vorstand

ein anderes Mitglied zum/zur Vorstandsvorsitzenden auf Zeit bestimmen, wenn eine Mehrheit der auf der entsprechenden
Sitzung anwesenden bzw. vertretenen Geschäftsführer dies mittels Abstimmung beschließt.

12.5 Der Vorstand kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht selbst Geschäftsführer sein muss und der für die

Führung der Protokolle der Vorstandssitzungen und Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

12.6 Vorstandsmitglieder können an jeder beliebigen Vorstandssitzung mitwirken, indem sie eine anderes Vorstands-

mitglied schriftlich zur ihrem Vertreter ernennen.

12.7 Vorstandsmitglieder können an einer Vorstandssitzung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher

Kommunikationsmittel teilnehmen, die es mehreren daran teilnehmenden Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander
zu kommunizieren. Eine derartige Teilnahme ist als der physischen Anwesenheit bei einer Sitzung gleichwertig zu be-
trachten.

12.8 Zur Beschlussfähigkeit des Vorstands bedarf es der Anwesenheit oder Vertretung der Mehrheit der amtierenden

Vorstandsmitglieder, vorausgesetzt, dass, sofern anwendbar, zumindest ein Vorstandsmitglied der Kategorie A und ein
Vorstandsmitglied der Kategorie B anwesend sind. Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit der bei der betreffenden
Sitzung anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder getroffen, und diese Mehrheit muss, sofern anwendbar, zumin-
dest ein Vorstandsmitglied der Kategorie A und ein Vorstandsmitglied der Kategorie B einschließen.

12.9 Beschlüsse des Vorstands werden durch eine Mehrheit der bei der betreffenden Sitzung anwesenden bzw. vertre-

tenen  Vorstandsmitglieder  gefasst.  Im  Fall  der  Stimmengleichheit  gibt  die  Stimme  des  Vorstandsvorsitzenden  den
Ausschlag.

12.10 Das Protokoll der Vorstandsbeschlüsse muss im Rahmen der entsprechenden Sitzung abgefasst und von allen

anwesenden Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden. Etwaige Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

12.11 Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, ist ebenso ordnungsgemäß und

gültig wie ein Beschluss, der bei einer Vorstandssitzung gefasst wurde, die ordnungsgemäß einberufen und abgehalten
wurde. Eine solche Entscheidung kann entweder durch ein einzelnes Dokument, das von allen Geschäftsführern unter-
zeichnet wurde, oder durch mehrere separate Dokumente belegt werden, die alle den gleichen Inhalt haben und jeweils von
einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet wurden.

12.12 Sofern nur ein Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin ernannt wurde, hat dieser/diese Protokolle seiner/ihrer

Entscheidungen schriftlich aufzusetzen und diese zu unterzeichnen.

12.13 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Vorstandssitzung sind vom Vorstand zu beglaubigen.

13. Vertretung der Gesellschaft.
13.1 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unter-

zeichnung durch diesen Geschäftsführer gebunden.

13.2  Sofern  die  Gesellschaft  von  einem  Vorstand  geleitet  wird,  wird  die  Gesellschaft  gegenüber  Dritten  durch  die

gemeinsame Unterzeichnung seitens zweier beliebige Vorstandsmitglieder gebunden.

13.3 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten nur durch die gemeinsamen Unterschriften

eines Klasse-A-Geschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers gebunden, wenn der alleinige Gesellschafter oder
die Gesellschafter (je nachdem, was zutreffend ist) (einen) Klasse-A- und Klasse-BGeschäftsführer ernannt haben.

13.4 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch jedwede Person vertreten, der vom

Einzelvorstand bzw. vom Vorstand gültige Vertretungsbefugnis erteilt worden ist.

14. Interessenkonflikt.
14.1 Vorbehaltlich des Nachstehenden gelten die in Artikel 57 des Gesetzes vorgesehenen Regeln zum Interessenkon-

flikt.

14.2 Kein Vertrag und kein sonstiges Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder eines

anderen Unternehmens wird allein durch die Tatsache beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere ordnungsgemäß
ermächtigte Vertreter der Gesellschaft, einschließlich ihrer Geschäftsführer, an der besagten anderen Gesellschaft oder
dem besagten anderen Unternehmen (i) persönlich beteiligt ist oder (ii) einen ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter
und/oder Gesellschafter derselben ist/sind.

75673

L

U X E M B O U R G

14.3 Falls der Einzelvorstand bzw. alle Vorstandmitglieder einen Interessenkonflikt bzgl. einer bestimmten Angele-

genheit haben, wird die Angelegenheit von der Gesellschafterversammlung bzw. dem Einzelgesellschafter entschieden.

15. Entschädigung der Vorstandsmitglieder.
15.1 Die Gesellschaft wird den Einzelvorstand bzw. die Vorstandsmitglieder und gegebenenfalls ihre Rechtsnachfolger,

Erben, Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter gegen Schäden und Aufwendungen, die vernünftigerweise in Verbin-
dung mit einem Rechtsstreit, einer Klage oder einem sonstigem Verfahren erlitten hat, an dem/der er (sie) Streitpartei wurde
(n) aufgrund seiner (ihrer) Stellung als amtierendes oder ehemaliges Vorstandsmitglied oder, auf Antrag der Gesellschaft,
jeder anderen Gesellschaft, in der die Gesellschaft Aktionärin oder gegenüber der sie Gläubigerin ist und soweit sie ge-
genüber dieser anderen Gesellschaft kein Recht auf Entschädigung haben.

15.2 Entschädigung wird nur geleistet wenn und soweit der Einzelvorstand bzw. die Vorstandsmitglieder in einem

Rechtsstreit, einer Klage oder einem sonstigem Verfahren nicht rechtskräftig für grobe Fahrlässigkeit oder Fehlverhalten
oder Vorsatz verurteilt wird.

15.3 Im Falle eines Vergleichs wird Entschädigung nur und nur soweit geleistet, als die Gesellschaft von ihrem Rechts-

beistand darauf hingewiesen wird, dass der Einzelvorstand bzw. die Vorstandsmitglieder seine/ihre Pflichten nicht verletzt
hat/haben.

15.4 Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte, die dem Einzelvorstand bzw. den Vorstands-

mitgliedern und gegebenenfalls ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern gege-
benenfalls zustehen, nicht aus.

16. Audit.
16.1 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger Wirtschaftsprüfer erforderlich ist

und die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaft von einem
oder mehreren gesetzlichen Wirtschaftsprüfern zu prüfen, bei denen es sich entweder um einen oder mehrere Gesellschafter
oder um Dritte handeln kann.

16.2 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger Wirtschaftsprüfer erforderlich ist

und die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) Gesellschafter oder weniger hat, können die Gesellschafter entscheiden, ohne
hierzu verpflichtet zu sein, die Jahresabschlüsse von einem oder mehreren gesetzlichen Wirtschaftsprüfern prüfen zu lassen,
bei denen es sich entweder um Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.

16.3 Der/Die Wirtschaftsprüfer ist/sind von den Gesellschaftern zu ernennen, die (i) die Anzahl der Wirtschaftsprüfer,

(ii) die Vergütung des/der Wirtschaftsprüfer(s) und (iii) die Dauer des Mandats des/der Wirtschaftsprüfer(s) bestimmen.
Der/Die Wirtschaftsprüfer bleibt/bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie können am Ende ihrer Beauf-
tragungszeit wiedergewählt werden und können jederzeit mit oder ohne Grund von den Gesellschaftern aus ihrem Amt
enthoben werden.

Gesellschafter

17. Gesellschafterbeschlüsse.
17.1 Die Gesellschafter können Beschlüsse entweder im Rahmen von Gesellschafterversammlungen oder, unter Vor-

behalt  der  in  dieser  Satzung  definierten  Beschränkungen  und  den  Gesetzen  des  Großherzogtums  Luxemburg,  durch
schriftliche Beschlüsse fassen.

17.2 Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, sofern nicht anderweitig durch die Gesetze des Großherzogtums Luxem-

burg vorgegeben.

17.3  Änderungen  der  Satzung  müssen  (i)  durch  Mehrheit  der  Gesellschafter  nach  Köpfen  und  (ii)  drei  Viertel  des

ausgegebenen Gesellschaftskapitals genehmigt werden, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg oder gemäß der Satzung erforderlich.

17.4 Alle anderen Gesellschafterbeschlüsse werden durch Gesellschafter getroffen, die mehr als die Hälfte des ausge-

gebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegeln, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Groß-
herzogtums Luxemburg erforderlich. Wenn bei der ersten Versammlung keine beschlussfähige Mehrheit erreicht wird,
werden die Gesellschafter per Einschreiben ein zweites Mal zusammengerufen oder zur Abstimmung gebeten und Be-
schlüsse werden in diesem Fall durch Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, unabhängig von dem Anteil des
vertretenen ausgegebenen Gesellschaftskapitals.

18. Schriftliche Beschlüsse.
18.1 Wenn die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter hat, müssen die Gesellschafterbeschlüsse

nicht in Gesellschafterversammlungen verabschiedet werden, sondern können auch durch schriftliche Beschlüsse verab-
schiedet werden.

18.2 Der Text von Beschlüssen, die durch schriftlichen Beschluss getroffen werden sollen, wird den Gesellschaftern

durch das Management per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zugesandt. Gesellschafter sind verpflichtet, ihre Stimme
abzugeben und sie innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt des Briefes dem Management der Gesellschaft per
Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zurückzusenden. Stimmen, die nicht innerhalb dieses Zeitraums abgegeben werden,
gelten als Enthaltungen.

75674

L

U X E M B O U R G

18.3 Die formellen in Paragraph 18.2 dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschaf-

terbeschlüssen können durch einstimmigen schriftlichen Beschluss aller Gesellschafter in dem jeweiligen schriftlichen
Beschluss oder anderweitig aufgehoben werden Die formellen in Paragraph 18.2 dargelegten Anforderungen zur Verab-
schiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen gelten nicht, wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat.
Alle durch einen alleinigen Gesellschafter getroffenen Beschlüsse müssen jedoch schriftlich dokumentiert und von dem
alleinigen Gesellschafter unterzeichnet werden.

18.4 Kopien oder Auszüge der schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse sind vom Management zu bestätigen.

19. Gesellschafterversammlungen.
19.1 Eine Jahreshauptversammlung muss nur abgehalten werden, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25)

Gesellschafter hat. In diesem Fall werden diese Satzung dahingehend geändert, dass sie das Datum und die Uhrzeit ent-
halten, zu dem solche Jahreshauptversammlung stattzufinden hat.

19.2 Außerordentliche Gesellschafterversammlungen werden im Einklang mit den Gesetzen des Großherzogtums Lu-

xemburg durch Mitteilung des Management, des/der Wirtschaftsprüfer(s) der Gesellschaft oder des/der Gesellschafter(s),
der/die mindestens die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegelt, einberufen.

19.3 Eine Gesellschafterversammlung darf nur im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach Meinung des Manage-

ment aufgrund von Umständen höherer Gewalt erforderlich ist.

19.4 Die Mitteilung zur Einberufung der Gesellschafterversammlung und zur Angabe des Ortes, des Datums, der Uhrzeit

und der Agenda solcher Versammlung ist den Gesellschaftern mindestens acht (8) Tage vor der Gesellschafterversammlung
zuzusenden. Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung zugegen oder Vertretern sind, können sie er-
klären, dass sie über die Agenda der Versammlung informiert wurden und können auf die obengenannte Anforderung der
vorherigen Mitteilung verzichten.

19.5 Ordnungsgemäß zusammengesetzte Gesellschafterversammlungen vertreten die Gesellschafter der Gesellschaft.
19.6 Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter hat, übt solcher Gesellschafter die Befugnisse aus, die der

Hauptversammlung  gemäß  geltenden  Gesetzen  und  dieser  Satzung  gewährt  werden.  Artikel  194  bis  196  und  199  des
Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung, gelten für diese Situation nicht.

20. Verfahren bei Gesellschafterversammlungen.
20.1 Ein Gesellschafter kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung durch Ernennung eines Vertreters, entweder

schriftlich oder per Fax, handeln. Bei solchem Vertreter muss es sich nicht um einen Gesellschafter handeln.

20.2  Gesellschafter  können  durch  Telefonkonferenz,  Videokonferenz  oder  ähnliche  Kommunikationswege,  die  die

gleichzeitige Kommunikation mehrerer Personen miteinander ermöglichen, an einer Gesellschafterversammlung teilneh-
men. Solche Teilnahme gilt als gleichwertig zu einer physischen Präsenz bei der Versammlung.

20.3 Das Management kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die erfüllt werden müssen, um an einer Gesell-

schafterversammlung teilzunehmen.

20.4 Der/Die Vorstandsvorsitzende oder im Falle seiner/ihrer Abwesenheit eine beliebige andere von den Gesellschaf-

tern ernannte Person, führt den Vorsitz über jede Gesellschafterversammlung (der/die „Vorsitzende der Gesellschafter-
versammlung“).

20.5 Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt ein/e Sekretär/in. Die Gesellschafter ernennen einen

oder mehrere Stimmrechtsprüfer. Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bildet zusammen mit dem/der Sek-
retär/in und dem/den Stimmrechtsprüfer(n) das Vorsitzgremium der Hauptversammlung (das „Vorsitzgremium“).

20.6 Die Mitglieder des Vorsitzgremiums müssen eine Teilnehmerliste unter Angabe (i) des Namens der Gesellschafter,

(ii) der Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Anteile und, wenn zutreffend, (iii) des Namens ihres Vertreters anfertigen
und unterzeichnen.

20.7 Das Vorsitzgremium hat ferner Protokoll über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung zu führen und dieses

Protokoll zu unterzeichnen.

20.8 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Gesellschafterversammlung sind vom Vorstand zu bestätigen.

Finanzjahr, Gewinnausschüttung

21. Geschäftsjahr.
21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats

Dezember.

22. Genehmigung des Jahresabschlusses.
22.1 Am Ende jedes Finanzjahres werden die Bücher abgeschlossen und der Vorstand erstellt den Jahresabschluss der

Gesellschaft gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg.

22.2 Der Vorstand reicht den Jahresabschluss der Gesellschaft bei dem/den etwaigen Wirtschaftsprüfer(n) der Gesell-

schaft zur Prüfung ein und legt ihn den Gesellschaftern zur Genehmigung vor.

22.3 Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss beim Geschäftssitz der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen der

Gesetze des Großherzogtums Luxemburg einsehen.

75675

L

U X E M B O U R G

23. Gewinnverteilung. Vom Jahresnettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die Rücklagen eingestellt,

wie gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg erforderlich. Diese Zuteilung ist nicht mehr erforderlich, sobald
und solange die Rücklagen zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft betragen. Die
Gesellschafter bestimmen, wie der restlichen Jahresnettogewinn verteilt wird. Die Rücklagen können ganz oder teilweise
eingesetzt werden, um (i) etwaige existierende Verluste aufzufangen, (ii) als Rücklagen oder Rückstellungen genutzt zu
werden, (iii) sie zum nächsten folgenden Finanzjahr zu übertragen oder (iv) um den Gesellschaftern als Dividende ausge-
schüttet zu werden.

24. Abschlagsdividenden.
24.1 Der Vorstand ist befugt, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt, dass ein Zwischenabschluss erstellt

wurde und dass solcher Zwischenabschluss zeigt, dass die Gesellschaft über ausreichend verfügbare Mittel für solche
Ausschüttung verfügt.

Auflösung, Liquidierung

25. Auflösung und Liquidation.
25.1 Die Auflösung der Gesellschaft kann von seinen Gesellschaftern mit der gleichen beschlussfähigen Mehrheit be-

schlossen werden, die für die Änderung dieser Satzung erforderlich ist, sofern die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg
nicht anderweitige Bestimmungen enthalten.

25.2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern

ernannte/n Liquidator(en) durchgeführt. Die Gesellschafter bestimmen außerdem die Befugnisse und die Vergütung des
Liquidators/der Liquidatoren.

25.3  Nach  Zahlung  aller  ausstehenden  Schulden  und  Gebühren  gegen  die  Gesellschaft,  einschließlich  Steuern  und

Auslagen in Verbindung mit dem Liquidationsprozess wird das restliche Nettovermögen der Gesellschaft den Gesell-
schaftern anteilig zur Anzahl der Anteile, die sie jeweils halten, ausgeschüttet.

Geltendes recht

26. Geltendes Recht.
26.1 Alle Angelegenheiten, die nicht dieser Satzung unterliegen, werden gemäß geltendem Recht entschieden.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Datum und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung und Zahlung

Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, erklärte danach die Zeichnung und vollständige Zahlung in bar

der gesamten zwölftausend fünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennbetrag von jeweils einem Euro (1 EUR), von der
Gesellschaft ausgegeben.

Dem unterzeichnenden Notar wurde ein Beleg für solche Zahlung vorgelegt. Der unterzeichnende Notar erklärt, dass

die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften, wie gemäß Artikel 1832 des Zivilgesetz-
buches geändert, dargelegten Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung erfüllt wurden und bezeugt ausdrücklich ihre
Erfüllung.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, verabschiedete danach in seiner Kapazität als alleiniger Gesell-

schafter der Gesellschaft die folgenden Gesellschafterbeschlüsse:

1. Die Gesellschaft wird von drei (3) Geschäftsführern vertreten (die „Geschäftsführer“):
- Herr Mariano PEREZ-DURANTEZ, geboren in Valladolid, Spain am 28. März 1979, mit beruflicher Adresse in

Prinzregentenstrasse 56, 80538 München, Deutschland, als A Geschäftsführer;

- Frau Katia CAMBON, geboren in Le Raincy, Frankreich am 24. Mai 1972, mit beruflicher Adresse in 16, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxemburg, als B Geschäftsführer; und

- Frau Marina KERNEUR, geboren in Ploemeur, Frankreich am 19. Juni 1978, mit beruflicher Adresse in 16, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxemburg, als B Geschäftsführer

2. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft ist unter der Adresse 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg (Groß-

herzogtum Luxemburg).

<i>Kosten

Auslagen, Kosten und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu entrichten sind,

betragen etwa 1.600,- EUR.

WORÜBER URKUNDE aufgenommen zu Redingen, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung

der oben erschienen Parteien die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Version verfasst

75676

L

U X E M B O U R G

ist, und dass auf Hinweis derselben erschienen Parteien im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen
Versionen, die englische Version maßgebend sein soll.

Nachdem diese Urkunde dem anwesenden Bevollmächtigten, welche dem unterzeichnenden Notar nach Name, Nach-

name, Familienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat der Bevollmächtigten zusammen mit dem Notar
diese Urkunde unterzeichnet.

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 30 avril 2015. Relation: DAC/2015/7093. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 avril 2015.

Référence de publication: 2015065871/683.
(150074936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2015.

Vam Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 107.134.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB Finance S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015063500/11.
(150072588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Vertical Axions Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 98.342.

<i>Extrait du dépôt rectificatif concernant le dépôt du 20 février 2015 n° L150034737

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

et par décision du Conseil d'Administration en date du 13 février 2015, ROOSEVELT SERVICES S.A., société anonyme,
15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B-42.411, a été nommée dépositaire
des actions au porteur de la société VERTICAL AXIONS HOLDING S.A..

Luxembourg, le 28 avril 2015.

<i>Pour la société VERTICAL AXIONS HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2015063502/15.
(150072426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Office Portfolio Minerva I Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 135.148.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first of April.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

German Retail Portfolio 2 S.à.r.l., having its registered office at 6D, route de Tréves, L-2633 Senningerberg, registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 116.968,

here represented by Mrs Corinne PETIT, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on April 17 

th

 , 2015.

Said proxy after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as aforesaid, is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “Office Portfolio

Minerva I SARL”, having its registered office at 6D, route de Tréves, L-2633 Senningerberg, incorporated pursuant to a
deed of the notary, on December 14 

th

 , 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number

75677

L

U X E M B O U R G

314 on February 6 

th

 , 2008 and registered with the Trade and Register Companies of Luxembourg under B 135.148 (the

“Company”).

The Articles of Association have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Marc LOESCH,

notary residing in Mondorf-les-Bains, on December 31 

st

 , 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, number 917 on April 3 

rd

 , 2015.

The Sole Shareholder represented as aforesaid, request the undersigned notary to act resolutions contained into agenda

as following:

<i>Agenda:

1. Waiver of convening notice.
2. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation.
3. Appointment of one Liquidator and determination of his powers.
4. Miscellaneous.
Then the Sole Shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notice, the shareholder represented considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated in advance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decides to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (the “Li-

quidation”).

<i>Third resolution

The Sole Shareholder appoints Mr Mark HATHERLY, company director, born in Auckland, New Zealand on November

13 

th

 , 1965, professionally residing at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, to assume the role of liquidator of the

Company (the “Liquidator”).

The  Liquidator  shall  have  the  broadest  powers  as  set  out  in  articles  144  and  following  of  the  co-ordinated  law  on

commercial companies of 10 August 1915 (the "Law"). He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law
without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The Liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of

his powers which he will define and for the duration fixed by him.

The shareholder further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance

payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholder of the Company, in accordance with article
148 of the Law.

When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholders, in

accordance with article 151 of the Law.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

All the expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated

at approximately two thousand four hundred euro (EUR 2,400).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed

together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt et un avril.
Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire, de résidence à Luxembourg.

A comparu:

German Retail Portfolio 2 S.à.r.l., ayant son siège social au 6D, route de Tréves, L-2633 Senningerberg, immatriculée

auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 116.968,

75678

L

U X E M B O U R G

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement au 74, Avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 17 avril 2015.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

La partie comparante, représentée comme ci-avant, est l'associée unique («l'Associée Unique») de «Office Portfolio

Minerva I SARL», ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, constituée suivant un acte reçu
par le notaire instrumentaire, en date du 14 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 314 en date du 06 février 2008 et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 135.148 («la Société»).

Les statuts ont été modifiés a différentes reprises et en dernier lieu par l'acte de Maître March LOESCH, notaire de

résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 31 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 917 en date du 3 avril 2015.

L'Associée Unique, représentée comme ci-avant, requiert le notaire instrumentant d'acter les points contenus dans l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du Jour:

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société.
3. Nomination d'un liquidateur de la Société et définition de ses responsabilités.
4. Divers.
Ensuite l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convo-

cation, l'associé représenté se considérant dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui
lui a été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L'Associée Unique décide la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (la «Liqui-

dation»).

<i>Troisième résolution

L'Associée Unique décide de nommer Monsieur Mark HATHERLY, gérant, né à Auckland, Nouvelle Zélande, le 13

novembre 1965, ayant son siège professionnel au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, d'assumer le rôle du liquidateur
de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales

du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir
à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle

partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée  décide  en  outre  d'autoriser  le  Liquidateur,  à  sa  seule  discrétion  à  verser  des  acomptes  sur  le  boni  de

liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur prépare un rapport à l'assemblée générale conformément à l'article

151 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de deux mille quatre

cents euros (2.400.- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par son

nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

75679

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 24 avril 2015. 2LAC/2015/8909. Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2015.

Référence de publication: 2015064215/127.
(150073287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

WP Roaming IV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.868.200,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 109.441.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 29 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1207 du 15 novembre 2005.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WP Roaming IV S. à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015063517/14.
(150072414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

LBR Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.176.163,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 147.995.

In the year two thousand and fifteen, on the second day of April.
Before the undersigned, Maître Henri HELLINCKX, notary residing Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the Shareholders of LBR Investments S. à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office in L - 1653 Luxembourg, 2 - 8 Avenue Charles de Gaulle,
registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B147995, incorporated by a
deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, on August 7, 2009, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations under the number 1847, dated September 24, 2009. The Articles of Association have been
amended by a deed of the same Notary on March 24, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
under the number 1294, dated June 15, 2011 (the “Company”).

The meeting was opened by Arlette Siebenaler, with professional address at L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, being

in the chair,

who appointed as Secretary Annick Braquet, with professional address at L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
The meeting elected as Scrutineer Annick Braquet, with professional address at L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance list.

This list and the proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to the
present deed for registration purposes.

II.- This attendance list shows that the 450 (four hundred and fifty) shares, representing the entire share capital are

represented at the present extraordinary general meeting (the “Meeting”) so that the Meeting can validly decide on all the
issues of the agenda which are known to the Shareholders.

III.- The agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Modification of the nominal value of all the existing shares so that the nominal value of each shares is brought from

EUR 28 (twenty eight euro) to EUR 1 (one euro), and so that the share capital of the company amounting to EUR 12,600
is now represented by 12.600 shares of a nominal value of EUR 1 (one euro) each;

3. New composition of the shareholding of the Company;

75680

L

U X E M B O U R G

4. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 35,163,563.- (thirty five million one hundred and

sixty three thousand five hundred and sixty three euro) in order to bring the share capital of the Company from its present
amount of EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred euro) to EUR 35,176,163.- (thirty five million one hundred seventy
six thousand one hundred sixty three euro) by the creation of 35.163.563 (thirty five million one hundred and sixty three
thousand five hundred and sixty three) new shares (the “New Shares”).

5. Subscription and payment of the New Shares;
6. Subsequent amendment of paragraph 1 of the article 5, of the articles of associations which will read as follows:

5.1. ”The Company’s corporate capital is fixed at subscribed capital of the corporation is fixed at thirty five million one

hundred seventy six thousand one hundred sixty three euro (EUR 35,176,163.- ) represented by thirty five million one
hundred seventy six thousand one hundred sixty three (35.176.163) shares with a par value of one euro (1.- EUR) each, all
subscribed and fully paid up.”

7. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the Meeting:

<i>First resolution

The general meeting resolved to waive their rights to the prior notice of the current meeting, acknowledge being suffi-

ciently informed on the agenda, consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the
items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal
of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

<i>Second resolution

The general meeting resolved to modify the nominal value of all the existing shares so that the nominal value of each

shares is brought from EUR 28 (twenty eight euro) to EUR 1 (one euro), and so that the share capital of the company
amounting to EUR 12,600 (twelve thousand six hundred euro) is now represented by 12,600 (twelve thousand six hundred)
shares of a nominal value of EUR 1 (one euro) each

<i>Third resolution

Further to the above resolution, the general meeting resolved to reattribute the 12,600 (twelve thousand six hundred)

shares to the existing shareholders, in proportion to their respective shareholding, and as follows:

- RY Investments S. à r.l., a company organized and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at

2-8 avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg, 4,200 (four thousand two hundred) shares of the Company;

- LEON Holding A.S., a company organized and existing under the laws of Norway, with registered office at Brygge-

torget 1, 0250 Oslo, Norway, 4,200 (four thousand two hundred) shares of the Company;

- KARAN Holding B.V., a company organized and existing under the laws of the Netherlands, with registered office at

5 Wieringen, 1967 EA Heemskerk, The Netherlands, 4,200 (four thousand two hundred) shares of the Company.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 35,163,563.- (thirty

five million one hundred and sixty three thousand five hundred and sixty three euro) in order to bring the share capital of
the Company from its present amount of EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred euro) to EUR 35,176,163.- (thirty
five million one hundred seventy six thousand one hundred sixty three euro) by the creation and issuance of 35,163,563
(thirty five million one hundred and sixty three thousand five hundred and sixty three) new shares (the “New Shares”) with
a par value of one euro (EUR 1) each.

<i>Fifth resolution

The general meeting declared that the New Shares were subscribed as follows:
- RY Investments S.à r.l., prenamed, subscribed 11,709,690 (eleven million seven hundred and nine thousand six hundred

and ninety) New Shares

- Leon Holding A.S., prenamed, subscribed to 11,724,595 (eleven million seven hundred and twenty-four thousand five

hundred and ninety-five) New Shares

- Karan Holding B.V., prenamed, subscribed to 11,729,278 (eleven million seven hundred and twenty-nine thousand

two hundred and seventy-eight) New Shares.

Such New Shares have been fully paid up through the contribution in kind consisting of a freely distributable reserve

(the “Contribution”) in the aggregate amount of EUR 35,163,563 (thirty five million one hundred and sixty three thousand
five hundred and sixty three euro) as further described in the report of the Board of Managers of the Company dated April
1, 2015.

This report, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of the registration.

75681

L

U X E M B O U R G

<i>Sixth resolution

The general meeting resolved to amend the paragraph 1 of the article 5 of the articles of associations which will read as

follows:

“ 5.1. The Company’s corporate capital is fixed at thirty five million one hundred seventy six thousand one hundred

sixty three euro (EUR 35,176,163.- ) represented by thirty five million one hundred seventy six thousand one hundred sixty
three (35,176,163) shares with a par value of one euro (1. - EUR) each, all subscribed and fully paid up.”

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 7,000.-

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le deuxième jour d’avril.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de LBR Investments S. à r.l., une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8 , avenue Charles de Gaulle, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B147995, constituée par acte de Maître Carlo
Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, le 7 août 2009, publié au Mémorial C , Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1847 du 24 septembre 2009. Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire le 24 mars 2011, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1294 du 15 juin 2011 (la «Société»).

L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Arlette Siebenaler avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg,

101, rue Cents, qui désigne comme secrétaire Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101,
rue Cents.

L'assemblée choisit comme scrutateur Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue

Cents.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par les comparants et le notaire, resteront annexées au
présent acte aux fins d’enregistrement.

II.-. Cette liste de présence montre que les 450 (quatre cent cinquante) parts sociales, représentant la totalité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») afin que l'Assemblée puisse va-
lablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour connus des associés.

III.- L'ordre du jour de la réunion est le suivant:
1. Renonciation aux convocations.
2. Modification de la valeur nominale de toutes les parts sociales de sorte que la valeur nominale de chaque part sociale

est portée de EUR 28.- (vingt-huit euros) à EUR 1.- (un euro), et de sorte que le capital social de la Société d’un montant
de EUR 12.600 (douze mille six cents euros) est maintenant représenté par 12.600 (douze mille six cents) parts sociales
d’une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune;

3. Nouvelle répartition des parts sociales de la Société;
4. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 35.163.563.- (trente-cinq millions

cent soixante-trois mille cinq cent soixante-trois euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.600.- (douze mille
six cents euros) à EUR 35.176.163 (trente-cinq millions cent soixante-seize mille cent soixante-trois euros), par la création
de 35.163.563 (trente-cinq millions cent soixante-trois mille cinq cent soixante-trois) parts sociales nouvelles (les «Nou-
velles Parts»).

5. Souscription et paiement des Nouvelles Parts.
6. Modification subséquente du paragraphe 1 de l’article 5 des statuts de la société qui se lira comme suit:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à trente-cinq millions cent soixante-seize mille cent soixante-trois euros

(EUR 35.176.163.-) représenté par trente-cinq millions cent soixante-seize mille cent soixante-trois (35.176.163) ayant une
valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

75682

L

U X E M B O U R G

7. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité par l'Assemblée:

<i>Première résolution

L'assemblée  générale  décide  de  renoncer  à  ses  droits  à  l'avis  préalable  de  l'assemblée  actuelle,  reconnaît  avoir  été

suffisamment informé sur l'ordre du jour, se considère valablement convoquée et donc accepte de délibérer et de voter sur
tous les points de l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite à l’assemblée a été mise à la
disposition des associés dans un délai de temps suffisant afin de leur permettre d'examiner attentivement chaque document.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la valeur nominale des parts sociales de sorte que la valeur nominale de chaque

part sociale est portée de EUR 28.- (vingt-huit euros) à EUR 1.- (un euro), de sorte que le capital social de la Société d’un
montant de EUR 12.600.- (douze mille six cents euros) est maintenant représenté par 12.600 (douze mille six cents) part
sociales d’une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale a décidé d’attribuer les 12.600 (douze mille six cents) parts

sociales aux associés actuels, proportionnellement à leur participation respective, comme suit:

- RY Investments S. à r.l., une société créée et existant sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2-8 avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, 4.200 (quatre mille deux cents) parts sociales de la Société;

- LEON Holding A.S., une société créée et existant sous les lois de Norvège, ayant son siège social au Bryggetorget 1,

0250 Oslo, Norvège, 4.200 (quatre mille deux cents) parts sociales de la Société;

- KARAN Holding B.V., une société créée et existant sous les lois des Pays Bas, ayant son siège social au 5 Wieringen,

1967 EA Heemskerk, Pays- Bas, 4.200 (quatre mille deux cents) parts sociales de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 35.163.563.- (trente-

cinq millions cent soixante-trois mille cinq cent soixante-trois euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.600.-
(douze mille six cents euros) à EUR 35.176.163 (trente-cinq millions cent soixante-seize mille cent soixante-trois euros),
par la création de 35.163.563 (trente-cinq millions cent soixante-trois mille cinq cent soixante-trois) parts sociales nouvelles
(les «Nouvelles Parts») d’une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale déclare que les Nouvelles Parts ont été souscrites comme suit:
- RY Investments S.à r.l., précitée, a souscrit à 11.709.690 (onze millions sept cent neuf mille six cent quatre-vingt-dix)

nouvelles parts sociales;

- Leon Holding A.S., précitée, a souscrit à 11.724.595 (onze millions sept cent vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-

quinze) nouvelles parts sociales;

- Karan Holding B.V., précitée, a souscrit à 11.729.278 (onze millions sept cent vingt-neuf mille deux cent soixante-

dix-huit) nouvelles parts sociales.

Ces nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en une réserve librement

distribuable (l’«Apport») d’un montant de EUR 35.163.563 (trente-cinq millions cent soixante-trois mille cinq cent soixan-
te-trois) comme détaillé dans le rapport du conseil d’administration de la société daté du 1 

er

 avril 2015.

Ce rapport, après avoir été signé «ne varietur» par les parties présentes et le notaire soussigné, restera annexé au présent

acte aux fins d’enregistrement.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier en conséquence le paragraphe 1 de l'article 5 des Statuts qui sera lu comme

suit:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à trente-cinq millions cent soixante-seize mille cent soixante-trois euros

(EUR 35.176.163.-) représenté par trente-cinq millions cent soixante-seize mille cent soixante-trois (35.176.163) ayant une
valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société en

raison du présent acte sont estimés à environ EUR 7.000.-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

75683

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 3 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/10579. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 mai 2015.

Référence de publication: 2015065753/202.
(150075502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2015.

Valeo Foods Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 196.475.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of April,
before the undersigned Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared

Valeo Foods Group Limited, a private limited company incorporated under the laws of Jersey, having its registered

address at 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands, registered under number No. 106322,

here represented by Mr Luca Ellul, having his professional address at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel,

Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal, given in St. Helier, Jersey, Channel Islands on 17 April 2015.
The said proxy, initialed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, required the officiating notary to document the deed of incorporation

of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorporation of which shall be as
follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become

shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect

participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The Company will be incorporated under the name of "Valeo Foods Luxco S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Municipality of Niederanven.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its shareholders.

Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of

managers. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad through
resolution of the manager or the board of managers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred pounds (GBP 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one pound (GBP 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

75684

L

U X E M B O U R G

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to

new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the

approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two managers

or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may

choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in advance

of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emergency, in
which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in
case of assent of each manager in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication.
A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without

electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will
form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

75685

L

U X E M B O U R G

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general

meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 20. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The board of
managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which

do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the
liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of

the Company held by them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of

10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All of the twelve thousand five hundred (12,500) shares are subscribed by Valeo Foods Group Limited, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Pounds (GBP

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December

2015.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The sole shareholder resolves to elect as managers of the company for an unlimited period:
- Mr Ganash Lokanathen, private employee, born on 5 July 1978 in Pahang, Malaysia, with professional address at 7,

rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.

- Mrs Anke Jager, private employee, born on 22 April 1968 in Salzgitter, Germany, with professional address at 7, rue

Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.

- Mrs Elke Leenders, private employee, born on 2 August 1980 in Maaseik, Belgium, with professional address at 7,

rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.

75686

L

U X E M B O U R G

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Findel, on the day stated at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the proxyholder of

the above appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences
between the English and the French texts, the English version prevails.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt et un avril,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

Valeo Foods Group Limited, une société à responsabilité limitée régie par les lois de Jersey, dont le siège social se situe

au 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, iles anglo-normandes, inscrite sous le numéro No. 106322,

ici représentée par Monsieur Luca Ellul, demeurant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-

Findel, Grand-Duché de Luxembourg

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à St Helier, Jersey, en date du 17 avril 2015.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le

devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une

participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement
à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société est constituée sous le nom de "Valeo Foods Luxco S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l’assemblée générale des associés.
A l’intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance. La

Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous
autres pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents sterling (GBP 12,500.-) représenté par douze mille

cinq cents (12,500) parts sociales, d'une valeur d’un sterling chacune (GBP 1.-).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à

des non-associés qu'avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés

75687

L

U X E M B O U R G

que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement

révocables à tout moment et sans cause.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature unique d'un seul gérant.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants

ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil de gérance.

Art. 12. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir

parmi ses membres un vice-président.

Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-

verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les

associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la
présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation  spéciale  ne  sera  pas  requise  pour  une  réunion  du  conseil  de  gérance  se  tenant  à  une  heure  et  un  endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier

électronique ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou d'autres

moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les
autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,

par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution
de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Art. 18. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés

par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

75688

L

U X E M B O U R G

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 19. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre

de la même année.

Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un

inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication
au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le conseil
de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont dispo-
nibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

L'intégralité des douze mille cinq cents (12,500) parts sociales a été souscrite par Valeo Foods Group Limited, préqua-

lifiée.

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents sterling (GBP

12,500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de décembre

2015.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR 1.300).

<i>Résolutions

Et aussitôt, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

2. L'associé unique décide d'élire les personnes suivantes en tant que gérants de la société pour une durée illimitée:
- Monsieur Ganash Lokanathen, employé privé, né le 5 juillet 1978 à Pahang, Malaisie, avec adresse professionnelle à

7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg.

- Madame Anke Jager, employée privée, née le 22 avril 1968 à Salzgitter (Allemagne), avec adresse professionnelle à

7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg.

- Madame Elke Leenders, employée privée, née le 2 août 1980 à Maaseik (Belgique), avec adresse professionnelle à 7,

rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Findel, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise
et française, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: l. Ellul, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 24 avril 2015. GAC/2015/3494. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

75689

L

U X E M B O U R G

Mondorf-les-Bains, le 4 mai 2015.

Référence de publication: 2015065983/305.
(150075565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2015.

Yaletipart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.633.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 avril 2015

1. La liquidation de la société YALETTPART S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée au liquidateur et commissaire de liquidation pour l'exécution de leurs mandats.
3. Les livres et documents sociaux sont déposés au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et y seront conservés pendant

cinq ans au moins.

Extrait certifié sincère et conforme
MERLIS S.à. r.l.
Signatures
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2015063521/17.
(150072834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Zebra Luxco III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 195.756.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2015.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2015063523/11.
(150072197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Fondation Recherche sur le Sida, Fondation.

Siège social: L-1210 Luxembourg, 4, rue Nicolas Ernest Barblé.

R.C.S. Luxembourg G 52.

<i>Comptes de l'exercice 2014

Recettes

Dépenses

Subsides des administrations
communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 415,00 €

Frais de salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 759,08 €

Stonnelaaf geint AIDS . . . . . . . . . . . . . . 32 000,00 €

Frais de fonctionnement de la Fondation  . .

57,90 €

Dons à la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . 11 430,00 €

Frais de formation continue  . . . . . . . . . . . .

926,14 €

Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 534,70 €

Frais de projets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 549,00 €

Avoir en caisse au 1 

er

 janvier 2014 . . . . 500 625,79 €

Avoir en caisse au 31 décembre 2014  . . . . 511 713,37 €

548 005,49 €

548 005,49 €

<i>Budget de l'exercice 2015

Soutien à des projets de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000,00 €
Frais d'équipement du laboratoire de rétrovirologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000,00 €
Prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000,00 €
Frais de formation continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000,00 €
Frais de fonctionnement de la Fondation Recherche sur le S.I.D.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000,00 €

256 000,00 €

75690

L

U X E M B O U R G

<i>Pour le Conseil d'Administration
Robert Hemmer / Pierre Kirpach
<i>Président / Trésorier

Référence de publication: 2015064788/26.
(150074888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2015.

Zilat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 167.779.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015063525/9.
(150072595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

@vantage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 77.797.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015063547/9.
(150073652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

A.R.T. - Absolute Return Target Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 79.444.

Le Rapport Annuel Révisé abrégé au 31 Décembre 2014 et la distribution des dividendes relative à l’Assemblée Générale

Ordinaire du 24 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2015.

Référence de publication: 2015063549/11.
(150073379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

MMA Alternative Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 104.349.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 17 avril 2015:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide:
- de renouveler le mandat des Administrateurs suivants, pour une période d'un an se terminant avec la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui aura lieu en 2016:

* Monsieur Philippe NARZUL, Administrateur
* Monsieur Francis JAISSON, Administrateur
* Monsieur Pierre MAINGUY, Administrateur
- de nommer DELOITTE AUDIT., en tant que Réviseur d'Entreprises agréé, pour une période d'un an se terminant avec

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui aura lieu en 2016.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:
- Monsieur Philippe NARZUL, MMA, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, F- 72030 Le Mans Cedex 9
- Monsieur Francis JAISSON, MMA Finance, 11 Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, F- 75663 Paris Cedex 14
- Monsieur Pierre MAINGUY, MMA VIE, 14 Boulevard Marie Alexandre Oyon, F- 72030 Le Mans Cedex 9
Le Réviseur d'Entreprises agréé est:
DELOITTE AUDIT., ayant son siège social à L - 2220 Luxembourg, 560, Rue de Neudorf, BP 1173.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations.

75691

L

U X E M B O U R G

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme

Référence de publication: 2015065808/25.
(150075526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2015.

ABTS &amp; Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 106.174.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015063552/9.
(150073679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Faroe Investments Wolverhampton S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.538.007,00.

Siège social: L-80710 Luxembourg, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 195.821.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty fourth day of April,
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Faroe Investments Holdco S.à r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum,
33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 24,076,616.-
(twentyfour million seventy-six thousand six hundred sixteen pounds sterling) and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the RCS) under number B 195310
(the Shareholder),

hereby represented by Valérie FAGNANT, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg on 23 April 2015,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to

act that it represents the entire share capital of Faroe Investments Wolverhampton S.à r.l., a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue
du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 3,840,621.- (three million
eight hundred forty thousand six hundred twenty one pounds sterling), registered with the RCS under number B 195821
and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 27 March 2015, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”), which articles of incorporation have been amended for the last time
on 21 April 2015 by a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial (the “Company”).

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:
A. The entire issued share capital represented by 3,840,621 (three million eight hundred forty thousand six hundred

twenty-one) shares is held by the Shareholder.

B. The Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary

decision of the Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below agenda.

C. The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. (a) Decrease of (i) the share capital of the Company by an amount of GBP 302,614.- (three hundred two thousand six

hundred fourteen pounds sterling) so as to reduce it from its current amount of GBP 3,840,621.- (three million eight hundred
forty thousand six hundred twenty-one pounds sterling) to an amount of GBP 3,538,007.- (three million five hundred thirty
eight thousand seven pounds sterling) by way of the cancellation of 302,614 (three hundred two thousand six hundred
fourteen) ordinary shares (the Cancelled Shares), having a nominal value of GBP 1.- (one pound sterling) each, representing
an aggregate nominal value of GBP 302,614.- (three hundred two thousand six hundred fourteen pounds sterling) and (ii)
the share premium by an amount of GBP 0.53 (fifty three pence), and as a result thereof (b) reimbursement to the Shareholder
of an aggregate amount of GBP 302,614.53 (three hundred two thousand six hundred fourteen pounds sterling and fifty
three pence).

75692

L

U X E M B O U R G

2. As a consequence, amendment of the first paragraph of article 6 of the Company’s articles of association as follows

to reflect the share capital decrease proposed above:

“ Art. 6. Subscribed capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 3,538,007.- (three million five

hundred thirty eight thousand seven pounds sterling), represented by 3,538,007 (three million five hundred thirty eight
thousand seven) ordinary shares having a nominal value of GBP 1.- (one pound sterling) each.”

3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and

authority to any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l., to proceed, under
his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the Cancelled Shares in the share register of the
Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

This having been declared, the Shareholder, represented as stated above, then asked the undersigned notary to record

its resolutions as follows:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to:
(a) decrease (i) the share capital of the Company by an amount of GBP 302,614.- (three hundred two thousand six

hundred fourteen pounds sterling)

to reduce it from its current amount of GBP 3,840,621.- (three million eight hundred forty thousand six hundred twenty

one pounds sterling) represented by 3,840,621 (three million eight hundred forty thousand six hundred twenty one) ordinary
shares, having a nominal value of GBP 1.-(one pound sterling) each,

to an amount of GBP 3,538,007.- (three million five hundred thirty eight thousand seven pounds sterling), represented

by 3,538,007 (three million five hundred thirty eight thousand seven) ordinary shares, having a nominal value of GBP 1.-
(one pound sterling) each,

by way of the cancellation of 302,614 (three hundred two thousand six hundred fourteen) ordinary shares, having a

nominal value of GBP 1.- (one pound sterling) each, representing an aggregate nominal value of GBP 302,614.- (three
hundred two thousand six hundred fourteen pounds sterling)

and (ii) the share premium by an amount of GBP 0.53 (fifty-three pence), and as a result thereof,
(b) reimburse to the Shareholder an aggregate amount of GBP 302,614.53 (three hundred two thousand six hundred

fourteen pounds sterling and fifty three pence).

As a consequence of the above-resolved share capital decrease, the Shareholder now holds 3,538,007 (three million five

hundred thirty-eight thousand seven) ordinary shares of the Company.

<i>Second resolution

As  a  consequence  of  the  first  resolution,  the  Shareholder  resolves  to  amend  the  first  paragraph  of  article  6  of  the

Company’s articles of association, which English version shall be henceforth reworded as follows:

“ Art. 6. Subscribed capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 3,538,007.- (three million five

hundred thirty eight thousand seven pounds sterling), represented by 3,538,007 (three million five hundred thirty eight
thousand seven) ordinary shares having a nominal value of GBP 1.- (one pound sterling) each.”

<i>Third resolution

The Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the changes resolved above and

hereby empower and authorise any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à
r.l., to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the Cancelled Shares in the
share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing party and in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-quatre avril,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

A COMPARU:

Faroe Investments Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois,

ayant son siège social à l’Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de
Luxembourg, ayant un capital social de GBP 24.076.616,-(vingt-quatre million soixante-seize mille six cent seize livres

75693

L

U X E M B O U R G

sterling) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le numéro B
195310 (l'Associé),

ici représentée par Valérie FAGNANT, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, le 23 avril 2015,

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente

la  totalité  du  capital  social  de  Faroe  Investments  Woverhampton  S.à  r.l.,  une  société  à  responsabilité  limitée  de  droit
luxembourgeois, ayant son siège social à l’Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,
Grand-Duché de Luxembourg, au capital social de GBP 3.840.621,- (trois millions huit cent quarante mille six cent vingt
et  une  livres  sterling),  immatriculée  auprès  du  RCS  sous  le  numéro  B  195821,  et  constituée  selon  un  acte  du  notaire
instrumentaire, daté du 27 mars 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mé-
morial»), lesquels statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 21 avril 2015 par un acte du notaire instrumentaire,
non encore publié au Mémorial (la Société).

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
A. La totalité du capital social, représentée par 3.840.621 (trois millions huit cent quarante mille six cent vingt et une)

parts sociales, est détenu par l’Associé.

B. L’Associé est représenté en vertu d’une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société sont

représentées à cette décision extraordinaire de l’Associé et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les
points de l'ordre du jour ci-après.

C. L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. (a) Réduction (i) du capital social de la Société par un montant de GBP 302.614,- (trois cent deux mille six cent

quatorze livres sterling) afin de le réduire de son montant actuel de GBP 3.840.621,- (trois millions huit cent quarante mille
six cent vingt-et-une livres sterling) à un montant de GBP 3.538.007,- (trois millions cinq cent trente-huit mille sept livres
sterling), par voie d'annulation de 302.614 (trois cent deux mille six cent quatorze) parts sociales ordinaires (les Parts
Sociales Annulées), ayant une valeur nominale de GBP 1,-(une livre sterling) chacune, représentant une valeur nominale
globale de GBP 302.614,- (trois cent deux mille six cent quatorze livres sterling) et (ii) du compte de prime d'émission par
un  montant  de  GBP  0,53  (cinquante-trois  pence),  et  ainsi  (b)  remboursement  à  l’Associé  d'un  montant  total  de  GBP
302.614,53 (trois cent deux mille six cent quatorze livres sterling et cinquante-trois pence);

2. En conséquence, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit afin de refléter

l’augmentation de capital proposée ci-dessus:

« Art. 6. Capital Social Souscrit. Le capital social est fixé à GBP 3.538.007,- (trois millions cinq cent trente-huit mille

sept livres sterling) représenté par 3.538.007 (trois millions cinq cent trente-huit mille sept) parts sociales ordinaires d’une
valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune.»

3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l., afin
d’effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Parts Sociales Annulées dans le registre
de parts sociales de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Ceci ayant été déclaré, l’Associé représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé décide de:
(a) réduire (i) le capital social de la Société, par un montant de GBP 302.614,- (trois cent deux mille six cent quatorze

livres sterling)

afin de le réduire de son montant actuel de GBP 3.840.621,- (trois millions huit cent quarante mille six cent vingt-et-

une livres sterling), représenté par 3.840.621 (trois millions huit cent quarante mille six cent vingt-et-une) parts sociales
ordinaires, ayant une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune,

à un montant de GBP 3.538.007,- (trois millions cinq cent trente-huit mille sept livres sterling) représenté par 3.538.007

(trois millions cinq cent trente-huit mille sept) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de GBP 1,- (une livre
sterling) chacune,

par voie d'annulation de 302.614 (trois cent deux mille six cent quatorze) parts sociales ordinaires ayant une valeur

nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune, représentant une valeur nominale globale de GBP 302.614,- (trois cent
deux mille six cent quatorze livres sterling)

et (ii) du compte de prime d'émission par un montant de GBP 0,53 (cinquante-trois pence), et ainsi,
(b) rembourser à l'Associé un montant global de GBP 302.614,53 (trois cent deux mille six cent quatorze livres sterling

et cinquante-trois pence).

75694

L

U X E M B O U R G

Suite à la réduction de capital décidée ci-dessus, l'Associé détient maintenant 3.538.007 (trois millions cinq cent trente-

huit mille sept) parts sociales ordinaires de la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l’Associé décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société,

dont la version française aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Capital Social Souscrit. Le capital social est fixé à GBP 3.538.007,- (trois millions cinq cent trente-huit mille

sept livres sterling) représenté par 3.538.007 (trois millions cinq cent trente-huit mille sept) parts sociales ordinaires d’une
valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune.»

<i>Troisième résolution

L'Associé décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués ci-

dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de Lone Star Capital Investments
S.à r.l., afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Parts Sociales Annulées
dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point dans
le registre de parts sociales de la Société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: V. Fagnant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 27 avril 2015. 2LAC/2015/9040. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2015.

Référence de publication: 2015063878/183.
(150073578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Wealth International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 181.477.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015063508/9.
(150072035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

RCM Immobilière, Société Civile.

Siège social: L-7475 Schoos, 4, rue du Puits.

R.C.S. Luxembourg E 591.

Les soussignés:
1. Monsieur REYTER Nicolas, ingénieur diplômé THK,
demeurant à L-7636 Ernzen, 6, montée d'Ernzen
2. Monsieur MÜLHEIMS François,
demeurant à L-3216 Bettembourg, 2, rue Belair
3. Madame CASTAGNA Anne, technicien,
demeurant à L-7475 Schoos, 4, rue du Puits
seuls associés de la société susmentionnée, constituée le 6 novembre 1995, réunis en assemblée générale, ont pris à

l'unanimité des voix la résolution suivante:

- de procéder à un changement des statuts, à savoir:
l'article 5 à été modifié comme suit:

75695

L

U X E M B O U R G

Le siège social de la société est établi à Schoos:
4, rue du Puits L-7475 Schoos
- de procéder à un changement d'adresse privée ou professionnelle de la personne physique suivante
- REYTER Nicolas, demeurant à L-7636 Ernzen, 6, montée d'Ernzen

Ce changement entre en vigueur avec effet au 1 

er

 avril 2015

Fait à Luxembourg, le 30 avril 2015.

Référence de publication: 2015065882/24.
(150074959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2015.

Access Storage Holdings (France), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.020,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 65.722.

<i>Extrait des Résolutions prises par l'Associé Unique en date du 24 Avril 2015

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique que:
- Madame Séverine Lambert a démissionné de son mandat de gérant de classe B en date du 24 avril 2015.
- Mademoiselle Claire Sabbatucci, née le 24 juin 1984 à Thionville (France), résidant professionnellement au 412F route

d'Esch, L-1030 Luxembourg, est nommée gérant de classe B avec effet au 24 avril 2015, pour un mandat à durée illimitée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2015.

Référence de publication: 2015063553/14.
(150073623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Activité "Lensterbierg" S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6139 Junglinster, 6, rue Mère Teresa.

R.C.S. Luxembourg B 186.666.

<i>Auszug des Protokolls der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2015

<i>Beschlussfassung

1. Die Versammlung beschliesst, den Rücktritt des alleinigen Verwalters, Herrn Helmut Regnery, zum heutigen Tage

anzunehmen.

2. Die Versammlung beschliesst zum neuen alleinigen Verwalter zu ernennen:
Herr Marco REGNERY, mit Berufsadresse in L-6139 Junglinster, 6, rue Mere Teresa.
Sein Mandat endet mit der Jahreshauptversammlung des Jahres 2019.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die einzelne Unterschrift des alleinigen Verwalters.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2015.

Référence de publication: 2015063554/17.
(150073596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Agat Re, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 78.214.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société AGAT RE
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015063589/11.
(150072882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

75696


Document Outline

7H

ABTS &amp; Partners S.à r.l.

Access Storage Holdings (France), S.à r.l.

Activité "Lensterbierg" S.A.

Agat Re

A.R.T. - Absolute Return Target Fund

@vantage S.A.

ÄVWL Japan Real Estate S.à r.l.

Faroe Investments Wolverhampton S.à.r.l.

Fondation Recherche sur le Sida

KPMG Luxembourg Foundation

LBR Investments S.à r.l.

Mainbeach S.A.

MMA Alternative Fund

Office Portfolio Minerva I Sàrl

RCM Immobilière

Real Estate Development 2015 S.à r.l.

TPG Utrecht S.à r.l.

UKSA 60 CR S.à r.l.

UKSA City University S.à r.l.

UKSA Hammersmith S.à r.l.

UK Students 60 CR S.à r.l.

UK Students Hammersmith S.à r.l.

UK Students IHC S.à r.l.

UK Students Isledon S.à r.l.

UK Students JV S.à r.l.

Umiak Development S.A.

Valeo Foods Luxco S.à r.l.

Vam Funds (Lux)

Vectorline Beteiligungsmanagement &amp; Consulting S.A.

Vertical Axions Holding S.A.

Villa Sphere Ovest S.à r.l.

Violane Finance S.à r.l.

VisuConcept S.à r.l.

Wealth International S.A.

WP Roaming IV S. à r.l.

Yaletipart S.A.

Zebra Luxco III S.à.r.l.

Zilat S.A.

Zynga Luxembourg S.à r.l.