logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1569

24 juin 2015

SOMMAIRE

Abate Constructions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

75290

Acqua Marcia International S.A. . . . . . . . . . . .

75291

AD & S Alessi Design & Structures S.à r.l. . . .

75291

Afcard S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75312

Agat Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75312

Alta Design S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75268

Autonomy Iceland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75291

Autonomy Iceland Two S.à r.l  . . . . . . . . . . . . .

75291

Beausoleil Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75268

Chez Nono 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75266

Clearview One  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75268

Finagra S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75312

GoldenTree Holdco Lux 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

75266

ING Lease Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75266

Jargonnant Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

75266

Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75268

Luxe International S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . .

75267

LVS Hotels & Resorts (Europe) S.A. . . . . . . . .

75292

Mediacapital Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

75267

Meersel Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75311

Mercury Europe Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . .

75267

Millicom Africa International Finance S.à r.l.

& Partners S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75266

Molux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75267

MONO Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75267

MONO Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75267

Noble Invest International  . . . . . . . . . . . . . . . .

75311

Pfizer PFE Pilsa Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

75309

Platheg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75268

Prestinvest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75266

Sofina Multi Strategy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75269

Solartec S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75270

Starpetroleum Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75270

Starpetroleum Qatar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75270

Suisscourtage Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . .

75271

Swiss Life (Luxembourg)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

75268

Sybaris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75269

Syren Capitalisation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

75269

Temrex S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75269

Termidor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75271

TJ Capital S.à r.l. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75271

TMF Corporate Services S.A.  . . . . . . . . . . . . .

75271

TMF Secretarial Services S.A.  . . . . . . . . . . . . .

75272

Tomasa Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

75273

TPG Merl S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75273

TPG Varnish S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75281

TPL Aschersleben S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

75284

TPL Biberach S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75276

Triton Masterluxco 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

75281

Trufilux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75281

Universal Care S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75289

Valartis German Residential Health Care  . . .

75289

Value Secondary Investments SICAR (S.C.A.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75289

Vector Investments B S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

75289

75265

L

U X E M B O U R G

GoldenTree Holdco Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 177.261.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015062204/9.
(150070826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.

ING Lease Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 31.049.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015059083/9.
(150067934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

Millicom Africa International Finance S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 174.966.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015059182/9.
(150067798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

Prestinvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 112.646.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015059289/9.
(150067853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

Jargonnant Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 78.830.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015059111/9.
(150067769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

Chez Nono 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5495 Wintrange, 36, rue Brekelter.

R.C.S. Luxembourg B 175.802.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015060399/9.
(150069643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.

75266

L

U X E M B O U R G

Mercury Europe Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 165.501.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061331/9.
(150070192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2015.

Molux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippman.

R.C.S. Luxembourg B 191.747.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061360/9.
(150070355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2015.

MONO Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 95.538.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061361/9.
(150069993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2015.

MONO Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 95.538.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061362/9.
(150069994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2015.

Mediacapital Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 191.578.

Le bilan au 31.12.2014 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061327/9.
(150069962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2015.

Luxe International S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 141.878.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061319/9.
(150070205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2015.

75267

L

U X E M B O U R G

Swiss Life (Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 22.663.

Le Bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061538/9.
(150070386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2015.

Platheg, Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 262-266, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 31.693.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061435/9.
(150069987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2015.

Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 28.121.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061285/9.
(150070275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2015.

Beausoleil Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 189.511.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061737/9.
(150071152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.

Alta Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 161.622.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061696/9.
(150071459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.

Clearview One, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 168.104.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061806/9.
(150071081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.

75268

L

U X E M B O U R G

Sybaris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.345.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 13 avril 2015.

Le Conseil d'Administration accepte la démission de BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-51.675 en tant que déléguée à la gestion journalière des affaires de la société.

<i>Pour la société
SYBARIS S.A.

Référence de publication: 2015063413/12.
(150072081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Syren Capitalisation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5899 Syren, 7, rue de Hassel.

R.C.S. Luxembourg B 165.136.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2015

<i>3 

<i>ème

<i> Résolution

L'assemblée approuve de manière unanime la révocation de Monsieur Antonio DIMURO de son poste comme admi-

nistrateur de la société.

<i>4 

<i>ème

<i> Résolution

L'assemblée approuve unanimement la constatation que la société n'a qu'un seul administrateur unique, à savoir, Mon-

sieur Romain GLODEN, demeurant à L-5899 Syren, 7, rue de Hassel.

Pour extrait conforme
<i>Le président de l'assemblée générale extraordinaire

Référence de publication: 2015063416/16.
(150072145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Temrex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 181.738.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015063421/10.
(150071977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Sofina Multi Strategy, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 149.521.

Constituée par acte du 26 novembre 2009, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg , Recueil spécial, du

10 décembre 2009 , n° 2404.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale tenue en date du 21 avril 2015

L'Assemblée Générale réélit aux fonctions d'administrateurs Messieurs Pierre Ahlborn, Harold Boël, Xavier Coirbay,

Bernard Trempont, Laurent Jouret, Paul Mousel ainsi que Mesdames Stéphanie Delperdange et Alessandra Salà pour un
terme d'un an finissant en 2016.

L'Assemblée Générale renouvèle le mandat de Monsieur Xavier Coirbay en tant qu'administrateur délégué pour un terme

d'un an finissant en 2016.

75269

L

U X E M B O U R G

L'Assemblée réélit, en qualité de Réviseur d'entreprises, pour un terme d'un an, la société Mazars Luxembourg S.A.,

réviseur agréé, 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.

Référence de publication: 2015063397/17.
(150072816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Solartec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.900,00.

Siège social: L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 81.344.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution unique prise par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue en date du 22 avril 2015

que la Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du Gérant
technique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Blaschette, le 22 avril 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015063398/16.
(150072532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Starpetroleum Oman, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 140.192.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 23 avril 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:

- La société anonyme STARPETROLEUM OMAN SA (RCS B140192), dont le siège social à L-2146 Luxembourg -

74, rue de Merl, a été dénoncé en date du 13 janvier 2011,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et désigné liquidateur Maître Ana ALEXANDRE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 15 mai

2015.

Pour extrait conforme
Maître Ana ALEXANDRE
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015063405/18.
(150071586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Starpetroleum Qatar, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 140.190.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 23 avril 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:

- La société anonyme STARPETROLEUM QATAR SA (RCS B140190), dont le siège social à L-2146 Luxembourg -

74, rue de Merl, a été dénoncé en date du 13 janvier 2011,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et désigné liquidateur Maître Ana ALEXANDRE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 15 mai

2015.

75270

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Maître Ana ALEXANDRE
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015063406/18.
(150071585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Suisscourtage Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 136.536.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 16 avril 2015

1. la démission de Monsieur Christophe GOUDOU, Directeur financier, né le 8 mars 1971 à Pithiviers, France, résidant

professionnellement au 12, Quai Antoine 1 

er

 , MC-98000 Monaco de son mandat d'Administrateur délégué à la gestion

journalière est acceptée, avec effet immédiat.

2. Conformément à l'article 15 paragraphe 1 des statuts de la Société, les Administrateurs décident de nommer Monsieur

Jérôme RAGAS, Directeur Général, né le 9 août 1969 à Arcachon, France, résidant au 215 Ter Chemin de Terron, La
centenaire, F-06200 Nice comme Administrateur-délégué à la gestion journalière supplémentaire, avec effet immédiat.

Son mandat viendra à échéance en même temps que son mandat d'Administrateur, soit lors de l'Assemblée Générale

Statutaire devant se tenir en 2017.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015063411/17.
(150071691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Termidor S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 115.715.

Les comptes annuels au 30.09.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TERMIDOR S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015063451/11.
(150072585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

TJ Capital S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 19, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 178.757.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015063454/10.
(150072044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

TMF Corporate Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 84.993.

Les décisions suivantes ont été approuvées et ratifiées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la

Société qui s'est tenue en date du 21 avril 2015 et par le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le
22 avril 2015;

- Révocation du mandat de Monsieur Franciscus Willem Josephine Johannes Welman en tant que administrateur et

administrateur-délégué et Président du Conseil d'Administration de la société effectif à partir du 20 janvier 2015;

- Nomination de Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas, et de-

meurant  professionnellement  au  46A,  avenue  J.F.  Kennedy,  L-1855  Luxembourg,  en  tant  que  Président  du  Conseil
d'Administration à partir du 20 janvier 2015 pour une période indéterminée;

75271

L

U X E M B O U R G

- Confirmation que le conseil d'administration de la Société est désormais composé par les administrateurs suivants;
* Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, administrateur et Président du Conseil d'Administration;
* Monsieur Jorge Pérez Lozano, administrateur;
* Monsieur Jacob Mudde, administrateur;
* Monsieur Johannes Laurens de Zwart, administrateur;
* Monsieur Gérald Olivier David Welvaert, administrateur;
* Monsieur Jean-Jacques Josset, administrateur;
* Monsieur Martin Paul Galliver, administrateur;
* Monsieur Fabrice Michel Gilles Mas, administrateur;
* Monsieur Fabrice Stéphane Rota, administrateur;
* Madame Zora Bass, administrateur et
* Monsieur Fabian Sires, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2015063456/33.
(150072403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

TMF Secretarial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.029.

Les décisions suivantes ont été approuvées et ratifiées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la

Société qui s'est tenue en date du 21 avril 2015 et par le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le
22 avril 2015:

- Révocation du mandat de Monsieur Franciscus Willem Josephine Johannes Welman en tant que administrateur et

administrateur-délégué et Président du Conseil d'Administration de la société effectif à partir du 20 janvier 2015;

- Nomination de Monsieur Jacob Mudde, né le 14 octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, et demeurant professionnelle-

ment au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que Président de Conseil d'Administration à partir du 20
janvier 2015 pour une période indéterminée;

- Confirmation que le conseil d'administration de la Société est désormais composé par les administrateurs suivants:
* Monsieur Jacob Mudde, administrateur et Président du Conseil d'Administration;
* Monsieur Jorge Pérez Lozano, administrateur;
* Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, administrateur;
* Monsieur Johannes Laurens de Zwart, administrateur;
* Monsieur Gérald Olivier David Welvaert, administrateur;
* Monsieur Jean-Jacques Josset, administrateur;
* Monsieur Martin Paul Galliver, administrateur;
* Monsieur Fabrice Michel Gilles Mas, administrateur;
* Monsieur Fabrice Stéphane Rota, administrateur;
* Madame Zora Bass, administrateur et
* Monsieur Fabian Sires, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2015063457/33.
(150072415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

75272

L

U X E M B O U R G

Tomasa Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.428.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
TOMASA INVESTMENTS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015063458/12.
(150072687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

TPG Merl S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 716.476,25.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 160.273.

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of the month of March.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared,

TPG  VI  Saxo,  L.P.,  an  exempted  limited  partnership  established  under  the  laws  of  the  Cayman  Islands  having  its

registered office at PO BOX 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, George Town, Cayman Islands, and being
registered with the Assistant Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-50823, acting through its
general partner TPG VI Saxo Advisors, Inc., an exempted company incorporated under the laws of the Cayman Islands
having its registered office at PO BOX 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, and being re-
gistered with the Assistant Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-261195,

represented by Me Thierry Kauffman, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 13 March

2015 which shall be registered together with the present deed,

being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) and holding all the shares in “TPG Merl S.à r.l.” (the “Company”),

a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 22 March 2011 by
deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which has been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 19 July 2011 number 1616, with its registered
office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 160.273. The articles of association of the Company have been amended for the last time by
deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 16 December 2011, published in the Mémorial on 13 March 2012, number
658.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
(A) The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company, so that the decisions can validly be taken on all

items of the agenda.

(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:

<i>Agenda

1. Amendment of article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad
nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also at any time be held by conference call or similar means of communication only.The participation in,
or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a
meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the
number of proxies which a manager may accept and vote.

75273

L

U X E M B O U R G

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty four (24) hours at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by email pdf or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety  will  form  the  circular  documents  duly  executed  giving  evidence  of  the  resolution.  Managers'  resolutions  and
meeting minutes, including circular resolutions, may be conclusively signed and/or certified or an extract thereof may be
issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of any manager, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed
different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will be validly bound by the
joint signature of one class A manager and one class B manager.

In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory

powers shall have been delegated by the sole manager or, in the case of a board of managers, by any one of the managers
provided that, in the event of classes of managers, signatory powers be delegated by one class A and one class B manager
acting together.”

2. Reclassification of all the managers of class A and class B in office in the Company as ordinary managers of the

Company so that the board of managers of the Company be composed as follows:

- Mr Pedro Fernandes das Neves, manager
- Mrs Alexandra Cabete Matias, manager
After the foregoing was approved, the following resolutions were passed.

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 7 of the articles of association of the Company so as to read as set out

in the agenda.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to reclassify all the managers of class A and class B in office in the Company as ordinary

managers of the Company so that the board of managers of the Company be composed as follows:

- Mr Pedro Fernandes das Neves, manager; and
- Mrs Alexandra Cabete Matias, manager.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le dix-huit mars.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

TPG VI Saxo, L.P., un exempted limited partnership établi sous les lois des Iles Caïmans ayant son siège social au PO

BOX 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, George Town, Iles Caïmans, et inscrit auprès de l’Assistant Registrar
of Companies des Iles Caïmans sous le numéro MC-50823, agissant par son associé commandité (general partner) TPG
VI Saxo Advisors, Inc., une société constituée sous les lois des Iles Caïmans ayant son siège social au PO BOX 309, Ugland
House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans, et inscrite auprès de l’Assistant Registrar of Companies des Iles Caïmans

75274

L

U X E M B O U R G

sous le numéro MC-261195, représentée par Me Thierry Kauffman, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration en date du 13 mars 2015, laquelle sera enregistrée avec le présent acte,

étant l’associé unique (l’«Associé Unique») et détenant l’intégralité des parts sociales de «TPG Merl S.à r.l.» (la «So-

ciété»), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg le 22 mars 2011
suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 19 juillet 2011, numéro 1616, ayant son
siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 160.273. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 16 décembre
2011 suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, prénommé, publié au Mémorial en date du 13 mars 2012, numéro 658.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
(A) L’Associé Unique détient l’intégralité des parts sociales émises dans la Société, de sorte que des décisions peuvent

être prises valablement sur l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être adoptées sont les suivants:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l’article 7 des statuts de la Société afin de prendre la teneur suivante:
«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue à tout moment uniquement sous forme
de conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires. La participation à ou la tenue d'une réunion
par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants
peuvent  être  représentés  aux  réunions  du  conseil  de  gérance  par  un  autre  gérant,  sans  limitation  quant  au  nombre  de
procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants

de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal
de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y

compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance ne
pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par e-mail pdf ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions
des gérants et les procès-verbaux des réunions, y compris celles prises par voie circulaire, seront signées et/ou certifiées
comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un gérant unique, et en cas d'un conseil de gérance,

par la signature unique de tout gérant, à condition toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé
différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société sera valablement
engagée par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels

pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique ou, dans le cas d’un conseil de gérance, par un des gérants
à condition qu'en cas de différentes classes de gérants, les pouvoirs de signatures soient délégués par un gérant de classe
A et par un gérant de classe B agissant de concert.»

2. Reclassification de tous les gérants de classe A et de classe B de la Société comme gérants ordinaires de la Société

de façon à ce que le conseil de gérance de la Société soit composé comme suit:

- Monsieur Pedro Fernandes das Neves, gérant

75275

L

U X E M B O U R G

- Madame Alexandra Cabete Matias, gérante
Après approbation de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

L’Associé Unique a décidé de modifier l’article 7 des statuts de la Société tel que rédigé dans l’ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique a décidé de reclasser tous les gérants de classe A et de classe B de la Société de façon à ce que le

conseil de gérance de la Société soit composé comme suit:

- Monsieur Pedro Fernandes das Neves, gérant; et
- Madame Alexandra Cabete Matias, gérante.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais a constaté qu'à la demande de la partie comparante, le présent

procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même personne comparante, en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. KAUFFMAN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9295. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015063462/177.
(150072385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

TPL Biberach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.175,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.064.

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of March.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of TPL Biberach S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 123.064 and having a share capital of thirteen
thousand one hundred and twenty-five euro (EUR 13,125) (the Company).

The Company was incorporated on December 15, 2006 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing

in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
261 of February 27, 2007.

The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of

Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated August 5, 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2479 of October 14, 2011.

THERE APPEARED:

Brack Capital Kaufland S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 159.866 and having a share capital of fifteen thousand euro (EUR 15,000) (Shareholder 1),

here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal,

and
Heli Olami, residing at 5 

th

 , Tnu’at Hameri Street, 52325 Ramat Gan, Israel (Shareholder 2, and together with Share-

holder 1, the Shareholders),

here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal.

75276

L

U X E M B O U R G

The said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as set out above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening notices;
2. increase of the share capital of the Company by an amount of fifty euro (EUR 50) in order to bring it from its present

amount of thirteen thousand one hundred and twenty-five euro (EUR 13,125), represented by five hundred and twenty-
five (525) class A shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, to thirteen thousand one hundred and
seventy-five euro (EUR 13,175) by way of the creation and the issuance of two (2) new class B shares of the Company,
having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each;

3. subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 2 above by a contribution in kind;
4. subsequent amendment to the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to

reflect the changes adopted under item 2 above;

5. amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and

6. miscellaneous.
III. The Shareholders have unanimously taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entire share capital of the Company being present or represented at the Meeting, the Shareholders represented

consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated
to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of fifty euro (EUR 50) in order to

bring it from its present amount of thirteen thousand one hundred and twenty-five euro (EUR 13,125), represented by five
hundred and twenty-five (525) class A shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, to thirteen thousand
one hundred and seventy-five euro (EUR 13,175) by way of the creation and the issuance of two (2) new class B shares of
the Company, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Subscription and payment

Thereupon, Shareholder 1, pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to the two (2) newly issued

class B shares of the Company in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and to fully pay
them up by a contribution in kind consisting of a receivable in the aggregate amount of nine million four hundred and
twenty-six thousand euro (EUR 9,426,000) held by Shareholder 1 towards the Company (the Receivable).

The Receivable in the aggregate amount of nine million four hundred and twenty-six thousand euro (EUR 9,426,000)

shall be allocated as follows:

(i) an amount of fifty euro (EUR 50) shall be allocated to the share capital account of the Company; and
(ii) the remaining amount of nine million four hundred and twenty-five thousand nine hundred and fifty euro (EUR

9,425,950) shall be allocated to the share premium account attached to the class B shares of the Company.

The valuation of the Receivable is evidenced inter alia, by (i) the balance sheet of the Company as at December 31,

2014 signed for approval by the management of the Company (the Balance Sheet) and (ii) a management certificate issued
by the management of Shareholder 1 and acknowledged and approved by the management of the Company, stating that:

“1. Shareholder 1 is the legal and beneficial owner of the Receivable;
2. the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
3. Shareholder 1 is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;
4. the Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct

on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment;

5. there exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that the Receivable be transferred to it;

6. according to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,

the Receivable is freely transferable;

75277

L

U X E M B O U R G

7. all formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the

Receivable to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind;

8. all corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the

Company, as the case may be, have been obtained;

9. based on generally accepted accounting principles, the value of the Receivable is at least equal to nine million four

hundred and twenty-six thousand euro (EUR 9,426,000) as shown by the balance sheet of the Company as at December
31, 2014 and since such valuation no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made
to the Company; and

10. all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be

accomplished by Shareholder 1 and upon the contribution of the Receivable by Shareholder 1 to the Company, the Company
will become the full owner of Receivable, which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300
of the Luxembourg Civil Code.”

Such management certificate and a copy of the Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxy-holder of the

appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of article 8 of the

Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 8. The share capital of the Company is set at thirteen thousand one hundred and seventy-five euro (EUR 13,175.-),

represented by five hundred twenty-five (525) class A shares in registered form, having a par value of twenty-five euro
(EUR 25.-) each (the Class A Shares) and two (2) class B shares in registered form, having a par value of twenty-five euro
(EUR 25.-) each (the Class B Shares), all subscribed and fully paid-up.”

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and empower and authorize any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company
with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

There being no further business on the agenda, the Meeting was closed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed

are estimated at approximately four thousand seven hundred Euro (EUR 4,700.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing parties, that this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorized representative of the appearing parties.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour de mars.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de TPL Biberach S.à r.l., une société à responsabilité

limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 25C, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 123.064 et disposant d’un capital de treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125) (la
Société).

La Société a été constituée le 15 décembre 2006 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 261 du
27 février 2007.

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Martine Schaeffer,

notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 5 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2479 du 14 octobre 2011.

ONT COMPARU:

75278

L

U X E M B O U R G

Brack Capital Kaufland S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, dont le siège social se situe au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.866 et disposant d’un capital
social de quinze mille euros (EUR 15.000) (l’Associé 1),

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé.

et

Heli  Olami,  domiciliée  5 

th

  ,  Tnu’at  Hameri  Street,  52325  Ramat  Gan,  Israël  (l’Associé  2  et  avec  l’Associé  1,  les

Associés),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les Associés possèdent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. augmentation du capital social de la Société d’un montant de cinquante euros (EUR 50) afin de le porter de son

montant actuel de treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125), représenté par cinq cent vingt-cinq (525) parts sociales
de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à treize mille cent soixante-quinze euros
(EUR 13.175) par la création et l’émission de deux (2) nouvelles parts sociales de classe B de la Société, ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune;

3. souscription et libération de l’augmentation du capital social mentionnée au point 2 ci-dessus par un apport en nature;
4. modification subséquente du premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société afin d’y refléter les modifi-

cations adoptées au point 2 ci-dessus;

5. modification du registre des associés de la Société afin d’y refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à
l’enregistrement de la part sociale nouvellement émise dans le registre des associés de la Société; et

6. divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant présent ou représenté à l’Assemblée, les Associés décident de renoncer aux formalités

de convocation, comme ils se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et connaissant parfaitement l’ordre du
jour de l’Assemblée qui leur a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cinquante euros (EUR 50) afin de le

porter de son montant actuel de treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125), représenté par cinq cent vingt-cinq (525)
parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à treize mille cent soixante-
quinze euros (EUR 13.175) par la création et l’émission de deux (2) nouvelles parts sociales de classe B de la Société, ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l’augmentation du

capital social de la manière suivante:

<i>Souscription - Libération

Sur ces faits, l’Associé 1, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux deux (2) nouvelles parts

sociales de classe B de la Société sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune,
et les libérer intégralement par un apport en nature qui se compose d’une créance d’un montant total de neuf millions quatre
cent vingt-six mille euros (EUR 9.426.000) que l’Associé 1 détient envers la Société (la Créance).

La Créance d’un montant total de neuf millions quatre cent vingt-six mille euros (EUR 9.426.000) sera affectée de la

manière suivante:

(i) un montant de cinquante euros (EUR 50) sera affecté au compte de capital social de la Société; et
(ii) le montant restant de neuf millions quatre cent vingt-cinq mille neuf cent cinquante euros (EUR 9.425.950) sera

affecté au compte de prime d’émission rattaché aux parts sociales de classe B de la Société.

75279

L

U X E M B O U R G

La valeur de la Créance est certifiée inter alia par (i) le bilan de la Société au 31 décembre 2014 signé pour accord par

la gérance de la Société (le Bilan) et (ii) un certificat de gestion émis par la gérance de l’Associé 1, reconnu et approuvé
par la gérance de la Société (le Certificat) qui indique que:

1. Associé 1 est le propriétaire et le bénéficiaire de la Créance;
2. la Créance est certaine, liquide et exigible en date due et sans aucune déduction;
3. Associé 1 est le seul ayant droit à la Créance et a le droit de disposer de la Créance;
4. la Créance n’est grevée d’aucun nantissement ou usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un nantissement ou usufruit

sur la Créance et la Créance n’est soumise à aucun privilège;

5. il n’existe ni droits de préemption ni d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait demander que la Créance

lui soit cédée;

6. en vertu du droit applicable et des statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance

est librement cessible;

7. toutes les formalités requises à Luxembourg ou dans toute autre juridiction concernée consécutives à l’apport en

nature de la Créance à la Société seront effectuées dès réception d’une copie certifiée de l’acte notarié documentant ledit
apport en nature;

8. toutes les approbations d’entreprises, réglementaires ou autres pour l’exécution, la délivrance et la performance de

la Créance à la Société, le cas échéant, ont été obtenues;

9. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur de la Créance est au moins égale à neuf millions

quatre cent vingt-six mille euros (EUR 9.426.000) d’après le bilan de la Société au 31 décembre 2014 et aucun changement
matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la Société n’a eu lieu depuis cette évaluation; et

10. toutes les formalités requises dans le cadre du transfert de propriété de la Créance apportée à la Société ont été ou

seront accomplies par Associé 1 et dès l’apport de la Créance par Associé 1 à la Société, la Société deviendra le propriétaire
de plein droit de la Créance qui s’éteindra par voie de confusion conformément à l’article 1300 du Code Civil luxembour-
geois.»

Le certificat de gestion et une copie du Bilan, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des parties comparantes

et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l’article 8 des

Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

“ Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à treize mille cent soixante-quinze euros (EUR 13.175,-), représenté par

cinq cent vingt-cinq (525) parts sociales de classe A sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune (les Parts Sociales de Classe A) et deux (2) parts sociales de classe B sous forme nominative ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune (les Parts Sociales de Classe B), toutes souscrites et entière-
ment libérées.”

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d’y refléter les changements ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte
de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent

acte sont estimés à environ quatre mille sept cents Euros (EUR 4.700.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu'en cas de divergences entre les textes anglais et français, le
texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de cet acte, le notaire le signe avec le mandataire des parties comparantes.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9660. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

75280

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 20 avril 2015.

Référence de publication: 2015063466/246.
(150072793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Triton Masterluxco 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 177.725.

Les statuts coordonnés au 11 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015063468/11.
(150071763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Trufilux, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 94.345.

Constituée par acte le 08 juillet 2003, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial du 30 juillet

2003, n° 799.

Les statuts ont été modifiés par actes des 08 septembre 2003, 22 décembre 2005, 20 décembre 2006 et le 20 juillet
2010, 10 septembre 2013 publiés au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial du 10 octobre 2003
C-n° 1065, 09 mars 2006 C-n° 503, le 21 mars 2007 C-n°418 le 18 août 2010 C-1678 et le 08 novembre 2013 C-n°
2798.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale tenue en date du 21 avril 2015

L'Assemblée Générale réélit à la fonction d'administrateur Monsieur Harold Boël pour une durée de 6 ans se finissant

en 2021.

L'Assemblée Générale réélit à la fonction d'administrateur et d'administrateur délégué Monsieur Xavier Coirbay pour

une durée de 4 ans se finissant en 2019.

L'Assemblée élit, en qualité de Réviseur d'entreprises, pour un terme d'un an, la société Mazars Luxembourg S.A.,

réviseur agréé, 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.

Référence de publication: 2015063471/20.
(150072168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

TPG Varnish S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 120.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 186.012.

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of the month of March.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TPG Varnish Holdings, L.P., a limited partnership, incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered

office at Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands and registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership of the Cayman Islands under number
74259,

represented by Me Thierry Kauffman, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 13 March

2015 which shall be registered together with the present deed,

being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) and holding all the shares in “TPG Varnish S.à r.l.” (the “Company”),

a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 27 March 2014 by
deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which has been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 14 June 2014, number 1535, with its registered
office at 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, being registered with the Luxembourg Registre de Commerce et
des Sociétés under number B 186.012. The articles of association of the Company have been amended for the last time by
deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 23 April 2014, published in the Mémorial on 31 July 2014, number 2009.

75281

L

U X E M B O U R G

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
(A) The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company, so that the decisions can validly be taken on the

item of the agenda.

(B) The item on which resolutions are to be passed is as follows:

<i>Agenda

Amendment of article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad
nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also at any time be held by conference call or similar means of communication only.The participation in,
or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a
meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the
number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty four (24) hours at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by email pdf or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety  will  form  the  circular  documents  duly  executed  giving  evidence  of  the  resolution.  Managers'  resolutions  and
meeting minutes, including circular resolutions, may be conclusively signed and/or certified or an extract thereof may be
issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of any manager, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed
different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will be validly bound by the
joint signature of one class A manager and one class B manager.

In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory

powers shall have been delegated by the sole manager or, in the case of a board of managers, by any one of the managers
provided that, in the event of classes of managers, signatory powers be delegated by one class A and one class B manager
acting together.”

After the foregoing was approved, the following resolutions were passed.

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 7 of the articles of association of the Company so as to read as set out

in the agenda.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le dix-huit mars.

75282

L

U X E M B O U R G

Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

TPG Varnish Holdings, L.P., un limited partnership constitué en vertu des lois des Îles Caïmans, dont le siège social est

situé à Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Îles
Caïmans, et immatriculé auprès du Registrar of Exempted Limited Partnership des Iles Caïmans sous le numéro 74259,

représentée par Me Thierry Kauffman, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration en date

du 13 mars 2015, laquelle sera enregistrée avec le présent acte,

étant l’associé unique (l’«Associé Unique») et détenant l’intégralité des parts sociales de «TPG Varnish S.à r.l.» (la

«Société»), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg le 27 mars
2014 suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 14 juin 2014, numéro 1535, ayant son
siège social au 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 186.012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu prénommé, le
23 avril 2014, publié au Mémorial en date du 31 juillet 2014, numéro 2009.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
(A) L’Associé Unique détient l’intégralité des parts sociales émises dans la Société, de sorte que des décisions peuvent

être prises valablement sur le point porté à l’ordre du jour.

(B) Le point sur lequel des résolutions doivent être adoptées est le suivant:

<i>Ordre du jour

Modification de l’article 7 des statuts de la Société afin de prendre la teneur suivante:
«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue à tout moment uniquement sous forme
de conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires. La participation à ou la tenue d'une réunion
par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants
peuvent  être  représentés  aux  réunions  du  conseil  de  gérance  par  un  autre  gérant,  sans  limitation  quant  au  nombre  de
procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants

de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal
de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y

compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance ne
pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par e-mail pdf ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions
des gérants et les procès-verbaux des réunions, y compris celles prises par voie circulaire, seront signées et/ou certifiées
comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un gérant unique, et en cas d'un conseil de gérance,

par la signature unique de tout gérant, à condition toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé
différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société sera valablement
engagée par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels

pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique ou, dans le cas d’un conseil de gérance, par un des gérants

75283

L

U X E M B O U R G

à condition qu'en cas de différentes classes de gérants, les pouvoirs de signatures soient délégués par un gérant de classe
A et par un gérant de classe B agissant de concert.»

Après approbation de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Résolution unique

L’Associé Unique a décidé de modifier l’article 7 des statuts de la Société tel que rédigé dans l’ordre du jour.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais a constaté qu'à la demande de la partie comparante, le présent

procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même personne comparante, en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. KAUFFMAN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9294. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015063464/154.
(150072383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

TPL Aschersleben S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.175,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.095.

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of March.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of TPL Aschersleben S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 123.095 and having a share capital of thirteen
thousand one hundred and twenty-five euro (EUR 13,125) (the Company).

The Company was incorporated on December 15, 2006 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing

in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
270 of February 28, 2007.

The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of

Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated August 5, 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2410 of October 7, 2011.

THERE APPEARED:

Brack Capital Kaufland S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 159.866 and having a share capital of fifteen thousand euro (EUR 15,000) (Shareholder 1),

here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal,

and
Heli Olami, residing at 5 

th

 , Tnu’at Hameri Street, 52325 Ramat Gan, Israel (Shareholder 2, and together with Share-

holder 1, the Shareholders),

here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal,

The said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as set out above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.

75284

L

U X E M B O U R G

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening notices;
2. increase of the share capital of the Company by an amount of fifty euro (EUR 50) in order to bring it from its present

amount of thirteen thousand one hundred and twenty-five euro (EUR 13,125), represented by five hundred and twenty-
five (525) class A shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, to thirteen thousand one hundred and
seventy-five euro (EUR 13,175) by way of the creation and the issuance of two (2) new class B shares of the Company,
having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each;

3. subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 2 above by a contribution in kind;
4. subsequent amendment to the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to

reflect the changes adopted under item 2 above;

5. amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and

6. miscellaneous.
III. The Shareholders have unanimously taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entire share capital of the Company being present or represented at the Meeting, the Shareholders represented

consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated
to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of fifty euro (EUR 50) in order to

bring it from its present amount of thirteen thousand one hundred and twenty-five euro (EUR 13,125), represented by five
hundred and twenty-five (525) class A shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, to thirteen thousand
one hundred and seventy-five euro (EUR 13,175) by way of the creation and the issuance of two (2) new class B share of
the Company, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Subscription and payment

Thereupon, Shareholder 1, pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to the two (2) newly issued

class B shares of the Company in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and to fully pay
them up by a contribution in kind consisting of a receivable in the aggregate amount of eleven million six hundred and
nineteen thousand euro (EUR 11,619,000) held by Shareholder 1 towards the Company (the Receivable).

The Receivable in the aggregate amount of eleven million six hundred and nineteen thousand euro (EUR 11,619,000)

shall be allocated as follows:

(i) an amount of fifty euro (EUR 50) shall be allocated to the share capital account of the Company; and
(ii)  the  remaining  amount  of  eleven  million  six  hundred  and  eighteen  thousand  six  hundred  and  five  euro  (EUR

11,618,950) shall be allocated to the share premium account attached to the class B shares of the Company.

The valuation of the Receivable is evidenced inter alia, by (i) the balance sheet of the Company as at December 31,

2014 signed for approval by the management of the Company (the Balance Sheet) and (ii) a management certificate issued
by the management of Shareholder 1 and acknowledged and approved by the management of the Company, stating that:

“1. Shareholder 1 is the legal and beneficial owner of the Receivable;
2. the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
3. Shareholder 1 is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;
4. the Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct

on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment;

5. there exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that the Receivable be transferred to it;

6. according to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,

the Receivable is freely transferable;

7. all formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the

Receivable to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind;

8. all corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the

Company, as the case may be, have been obtained;

75285

L

U X E M B O U R G

9. based on generally accepted accounting principles, the value of the Receivable is at least equal to eleven million six

hundred and nineteen thousand euro (EUR 11,619,000) as shown by the balance sheet of the Company as at December 31,
2014 and since such valuation no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to
the Company; and

10. all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be

accomplished by Shareholder 1 and upon the contribution of the Receivable by Shareholder 1 to the Company, the Company
will become the full owner of Receivable, which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300
of the Luxembourg Civil Code.”

Such management certificate and a copy of the Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxy-holder of the

appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of article 8 of the

Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 8. The share capital of the Company is set at thirteen thousand one hundred and seventy-five euro (EUR 13,175.-),

represented by five hundred twenty-five (525) class A shares in registered form, having a par value of twenty-five euro
(EUR 25.-) each (the Class A Shares) and two (2) class B shares in registered form, having a par value of twenty-five euro
(EUR 25.-) each (the Class B Shares), all subscribed and fully paid-up.”

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and empower and authorize any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company
with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

There being no further business on the agenda, the Meeting was closed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed

are estimated at approximately five thousand two hundred Euros (EUR 5,200.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing parties, that this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorized representative of the appearing parties.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour de mars,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de TPL Aschersleben S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 25C,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.095 et disposant d’un capital de treize mille cent vingt-cinq euros (EUR
13.125) (la Société).

La Société a été constituée le 15 décembre 2006 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 270 du
28 février 2007.

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Martine Schaeffer,

notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 5 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2410 du 7 octobre 2011.

ONT COMPARU:

Brack Capital Kaufland S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, dont le siège social se situe au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.866 et disposant d’un capital
social de quinze mille euros (EUR 15.000) (l’Associé 1),

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé.

75286

L

U X E M B O U R G

et
Heli  Olami,  domiciliée  5 

th

  ,  Tnu’at  Hameri  Street,  52325  Ramat  Gan,  Israël  (l’Associé  2  et  avec  l’Associé  1,  les

Associés),

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les Associés possèdent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. augmentation du capital social de la Société d’un montant de cinquante euros (EUR 50) afin de le porter de son

montant actuel de treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125), représenté par cinq cent vingt-cinq (525) parts sociales
de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à treize mille cent soixante-quinze euros
(EUR 13.175) par la création et l’émission de deux (2) nouvelle parts sociales de classe B de la Société, ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune;

3. souscription à et libération de l’augmentation du capital social mentionnée au point 2 ci-dessus par un apport en

nature;

4. modification subséquente du premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société afin d’y refléter les modifi-

cations adoptées au point 2 ci-dessus;

5. modification du registre des associés de la Société afin d’y refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à
l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

6. divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant présent ou représenté à l’Assemblée, les Associés décident de renoncer aux formalités

de convocation, comme ils se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et connaissant parfaitement l’ordre du
jour de l’Assemblée qui leur a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cinquante euros (EUR 50) afin de le

porter de son montant actuel de treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125), représenté par cinq cent vingt-cinq (525)
parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à treize mille cent soixante-
quinze euros (EUR 13.175) par la création et l’émission de deux (2) nouvelle parts sociales de classe B de la Société, ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l’augmentation du

capital social de la manière suivante:

<i>Souscription - Libération

Sur ces faits, l’Associé 1, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux deux (2) nouvelles parts

sociales de classe B de la Société sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune,
et les libérer intégralement par un apport en nature qui se compose d’une créance d’un montant total de onze millions six
cent dix-neuf mille euros (EUR 11.619.000) que l’Associé 1 détient envers la Société (la Créance).

La Créance d’un montant total de onze millions six cent dix-neuf mille euros (EUR 11.619.000) sera affectée de la

manière suivante:

(i) un montant de cinquante euros (EUR 50) sera affecté au compte de capital social de la Société; et
(ii) le montant restant de onze millions six cent dix-huit mille neuf cent cinquante euros (EUR 11.618.950) sera affecté

au compte de prime d’émission rattaché aux parts sociales de classe B de la Société.

La valeur de la Créance est certifiée inter alia par (i) le bilan de la Société au 31 décembre 2014 signé pour accord par

la gérance de la Société (le Bilan) et (ii) un certificat de gestion émis par la gérance de l’Associé 1, reconnu et approuvé
par la gérance de la Société (le Certificat) qui indique que.

1. Associé 1 est le propriétaire et le bénéficiaire de la Créance;
2. la Créance est certaine, liquide et exigible en date due et sans aucune déduction;
3. Associé 1 est le seul ayant droit à la Créance et a le droit de disposer de la Créance;

75287

L

U X E M B O U R G

4. la Créance n’est grevée d’aucun nantissement ou usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un nantissement ou usufruit

sur la Créance et la Créance n’est soumise à aucun privilège;

5. il n’existe ni droits de préemption ni d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait demander que la Créance

lui soit cédée;

6. en vertu du droit applicable et des statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance

est librement cessible;

7. toutes les formalités requises à Luxembourg ou dans toute autre juridiction concernée consécutives à l’apport en

nature de la Créance à la Société seront effectuées dès réception d’une copie certifiée de l’acte notarié documentant ledit
apport en nature;

8. toutes les approbations d’entreprises, réglementaires ou autres pour l’exécution, la délivrance et la performance de

la Créance à la Société, le cas échéant, ont été obtenues;

9. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur de la Créance est au moins égale à onze millions

six cent dix-neuf mille euros (EUR 11.619.000) d’après le bilan de la Société au 31 décembre 2014 et aucun changement
matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la Société n’a eu lieu depuis cette évaluation; et

10. toutes les formalités requises dans le cadre du transfert de propriété de la Créance apportée à la Société ont été ou

seront accomplies par Associé 1 et dès l’apport de la Créance par Associé 1 à la Société, la Société deviendra le propriétaire
de plein droit de la Créance qui s’éteindra par voie de confusion conformément à l’article 1300 du Code Civil luxembour-
geois.»

Le certificat de gestion et une copie du Bilan, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des parties comparantes

et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l’article 8 des

Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

“ Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à treize mille cent soixante-quinze euros (EUR 13.175), représenté par

cinq cent vingt-cinq (525) parts sociales de classe A sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune (les Parts Sociales de Classe A) et deux (2) parts sociales de classe B sous forme nominative ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune (les Parts Sociales de Classe B), toutes souscrites et entière-
ment libérées.”

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d’y refléter les changements ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte
de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émise dans le registre des associés de la Société.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent

acte sont estimés à environ cinq mille deux cents Euros (EUR 5.200.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu'en cas de divergences entre les textes anglais et français, le
texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de cet acte, le notaire le signe avec le mandataire des parties comparantes.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9658. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 avril 2015.

Référence de publication: 2015063465/247.
(150072714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

75288

L

U X E M B O U R G

Universal Care S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 83.591.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2015.

Référence de publication: 2015063490/11.
(150072572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Valartis German Residential Health Care, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 132.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB Finance S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015063491/12.
(150072584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Value Secondary Investments SICAR (S.C.A.), Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 124.492.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2015.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015063492/13.
(150072176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

Vector Investments B S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 212.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 102.861.

EXTRAIT

Le 09 Avril 2015, l'associé unique a pris la résolution suivante:
- Acceptation de la démission de Mr Ryan Loggie, gérant, avec effet immédiat,
et nomme:
- Mme Viravyne Chhim, gérante, né le 07 juillet 1979 à Winderbarrow, Géorgie, USA, domiciliée au 133 Water Street,

Apartment 12C, Brooklyn, 11201 New-York, USA.

A dater de ce jour, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Mme Viravyne Chhim, gérante
- Halsey Sàrl, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015063494/18.
(150071808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

75289

L

U X E M B O U R G

Abate Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4420 Soleuvre, 5, rue des Cerisiers.

R.C.S. Luxembourg B 60.278.

L’an deux mil quinze, le quatorzième jour du mois d’avril.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Luciano ABATE, entrepreneur de construction, né le 30 mars 1955 à Mammola (Italie), demeurant à L-4420

Soleuvre, 5, rue des Cerisiers,

Ici représenté par Monsieur Stefano ABATE, demeurant à L – 4682 Differdange, en vertu d’une procuration donnée

sous seing privé le 14 avril 2015.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant déclare être le seul et unique associé de la société à res-

ponsabilité limitée Abate Constructions S.à r.l., avec siège social à L-4734 Pétange, 18, avenue de la Gare, inscrite au
Registre de Commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 60278, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse
BIEL, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 615 en date
du 5 novembre 1997 et modifié en dernier lieu par le notaire Aloyse BIEL, prénommé, en date du 9 juin 2011, publié au
Mémorial C du 10 août 2011, numéro 1823.

L'associé unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-4734 Pétange, 18, avenue de la Gare, à L-4420

Soleuvre, 5, Rue des Cerisiers.

<i>Deuxième résolution

En conséquence l'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner doré-

navant la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). "Le siège de la société est établi dans la commune de Sanem."

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec la partie

comparante représentée comme dit ci-avant, au paiement desdits frais.

<i>Pouvoirs

Le mandataire de la partie comparante es qualité qu'il agit donne pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire

soussigné, chacun pouvant agir séparément à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs (faute(s) de frappe)
éventuels des présentes.

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante es qualité qu'il agit, connu du notaire

par nom, prénoms usuels, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Stefano Abate, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 17 avril 2015. 1LAC / 2015 / 11899. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 avril 2015.

Référence de publication: 2015063577/47.

(150073660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

75290

L

U X E M B O U R G

Acqua Marcia International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 132.464.

<i>Extrait d'une des résolutions prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2015 au siège social.

<i>Résolution

<i>(Renouvellement du mandat de l'administrateur Camillo Bellavista Caltagirone)

L'Assemblée Générale donne acte du renouvellement du mandat de l'administrateur Mr Camillo BELLAVISTA CAL-

TAGIRONE, demeurant à Monaco MC - 98000, 11, Avenue Princesse Grace, avec effet immédiat.

Son mandat s'achèvera à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera tenue en 2017.

Luxembourg, le 28/04/2015.

ACQUA MARCIA INTERNATIONAL SA
Me Claude Geiben / Mr Camillo Bellavista Caltagirone

Référence de publication: 2015063581/16.
(150073154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

AD &amp; S S.à r.l., AD &amp; S Alessi Design &amp; Structures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 152.911.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour AD &amp; S S.à r.l., AD &amp; S ALESSI DESIGN &amp; STRUCTURES
Fideco S.A.

Référence de publication: 2015063582/12.
(150072827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Autonomy Iceland, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 152.526.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 23 avril 2015 renomme pour une période indéterminée:
- Mr Richard HAWEL, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, aux fonctions de gérant.

Luxembourg, le 29 avril 2015.

<i>Pour AUTONOMY ICELAND
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2015063625/14.
(150073237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Autonomy Iceland Two S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 170.747.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 23 avril 2015, renomme pour une période indéterminée:
- Mr Richard HAWEL, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, aux fonctions de gérant.

75291

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 29 avril 2015.

<i>Pour AUTONOMY ICELAND TWO S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2015063626/14.
(150073236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

LVS Hotels &amp; Resorts (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 196.406.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of April.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

AIM Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

office at L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 74.676,

here represented by Mrs Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Luxembourg, on 20 April 2015.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company

(société anonyme) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered Office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name LVS Hotels &amp;

Resorts (Europe) S.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities

or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations

of any Luxembourg or foreign entity.

2.5 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies,
the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate
properties.

2.6 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors.

It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

75292

L

U X E M B O U R G

4.4 In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.
5.1. The issued share capital of the Company is set at forty-six thousand euro (EUR 46,000) and divided into ordinary

shares and preference shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, with such rights and obligations as set out in
the present Articles and upon the following repartition:

i. thirty-one thousand (31,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);
ii. three thousand (3,000) class A shares, (the “Class A Shares”);
iii. three thousand (3,000) class B shares (the “Class B Shares”);
iv. three thousand (3,000) class C shares (the “Class C Shares”);
v. three thousand (3,000) class D shares (the “Class D Shares”); and
vi. three thousand (3,000) class E shares (the “Class E Shares”, together with the Class A Shares, the Class B Shares,

the Class C Shares and the Class D Shares the “Preferences Shares” and together with the Ordinary Shares, the “Shares”).

5.2. The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3. Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality

of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the
Company’s share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential sub-
scription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered
letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders
may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amend-
ment of these articles of association.

5.4. The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.
5.5. A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the

respective Class Periods (as this term is defined in article 5.10) as follows:

i. the period for the Class A Shares starts on the day of the signature of this notarial deed and ends no later than on 31

December 2015 (the “Class A Period”);

ii. the period for the Class B Shares starts after the last day of the Class A Period and ends no later than on 31 December

2016 (the “Class B Period”);

iii. the period for the Class C Shares starts after the last day of the Class B Period and ends no later than on 31 December

2017 (the “Class C Period”);

iv. the period for the Class D Shares starts after the last day of the Class C Period and ends no later than on 31 December

2018 (the “Class D Period”); and

v. the period for the Class E Shares starts after the last day of the Class D Period and ends no later than on 31 December

2019 (the “Class E Period”).

5.6. Where a class of Preference Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the

redemption and cancellation of such class(es) of Preference Shares can be made during a new period (the “New Period”)
which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately
preceding New Period of another class of Preference Shares) and end no later than one year after the start date of such New
Period. The first New Period shall start on the day after the Class E Period and the class of Preference Shares not repurchased
and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order from class A to class E (to the extent not previously
repurchased and cancelled).

5.7. For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Preference Shares shall take

place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period
(or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of Preference
Shares and shall continue to end on 31 December of the following year.

5.8. Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount (as this term is

defined in article 5.10) will become due and payable by the Company to the shareholder(s) prorata to their holding in such
class(es). For the avoidance of doubt the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-
off.

5.9. The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the sole director

or, in case of plurality of directors the Board of Directors (as both terms defined below) in its reasonable discretion and
within the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the Sole Director or, in case of plurality of

75293

L

U X E M B O U R G

directors the Board of Directors can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the
Cancellation Amount the freely distributable reserves either in part or in totality.

5.10. For the purposes of this article 5, the following capitalised terms shall have the following meanings:
i. “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)

increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and
legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included
carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of
Law, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) and
(iii) any Profit Entitlement so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+ PE)
Whereby:
AA = Available Amount.
NP = net profits (including carried forward profits).
P = any freely distributable reserves.
CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be

cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by

the Sole Director or, in case of plurality of directors the Board of Directors of the Company in good faith and with the view
to the Company’s ability to continue as a going concern.

ii. “Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a

remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and
any receivable which in the opinion of the Board of Directors will be paid to the Company in the short term less any
indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim
Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as Shares, stock
or securities of other kind held by the Company.

iii. “Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class

Period (or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available
Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).

iv. “Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period

and the Class E Period.

v. “Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
vi. “Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before

the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.

vii. “Law” shall mean the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time.
viii. “Profit Entitlement” shall mean the preferred dividends of the Preference Shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the
relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the Law.
7.4 Any transfer of registered shares shall become effective (opposable) towards the Company and third parties either

(i) through a declaration of transfer recorded in the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee
or their representatives, or (ii) upon notification of a transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.

75294

L

U X E M B O U R G

C. General meetings of shareholders

Art. 8. Powers of the general meeting of shareholders.
8.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted

general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of
association.

8.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall

be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers conferred
upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 9. Convening of general meetings of shareholders.
9.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or, as

the case may be, by the internal auditor(s).

9.2 It must be convened by the board of directors or the internal auditor(s) upon written request of one or several

shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of
shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.

9.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of

the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and
eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality
has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by
registered letter only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date
scheduled for the meeting.

9.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any

convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Conduct of general meetings of shareholders.
10.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on 15 May at 11 o'clock.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings
of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

10.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary

and a scrutineer who need neither be shareholders, nor members of the board of directors. If all the shareholders present
at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide
to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case
there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the “board of the meeting” shall in such case be
construed as a reference to the “chairman and secretary” or, as the case may be, to the “single person who assumes the role
of the board”, depending on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

10.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
10.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.

10.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of

communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.

10.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile

or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening notice.
The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of
the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three
boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

10.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the

proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account
voting forms received prior to the general meeting to which they relate.

Art. 11. Quorum and vote.
11.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.

75295

L

U X E M B O U R G

11.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of sha-

reholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association

may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of
more than half of the Company’s share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second
meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate regardless of
the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and
nil votes shall not be taken into account.

Art. 13. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 14. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the board of directors

may adjourn any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The board of directors shall do so
at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event
of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

Art. 15. Minutes of general meetings of shareholders.
15.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by

the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

15.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two
of its members.

D. Management

Art. 16. Composition and powers of the board of directors.
16.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members. However, where

the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders’ meeting that all the shares
issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the next
general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such case, to the extent applicable
and where the term “sole director” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of
directors” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “sole director”.

16.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.

16.3 Notwithstanding the above, the disposal of any asset directly held by the Company and having a value exceeding

ten thousand euro (EUR 10,000) requires the prior approval of the shareholders of the Company given by a resolution of
the shareholders of the Company adopted by a majority representing at least fifty percent (50%) of the share capital of the
Company.

Art. 17. Daily management.
17.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily

management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other agents,
acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of
directors.

17.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 18. Appointment, removal and term of office of directors.
18.1 The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor

is appointed. Directors may be re-appointed for successive terms.

18.3 Each director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.
18.4  The  general  meeting  of  shareholders  may  decide  to  appoint  directors  of  different  classes,  namely  category  A

directors and category B directors.

18.5 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders

at a simple majority of the votes validly cast.

18.6 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a physical person as

permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.

75296

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Vacancy in the office of a director.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole director, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 20. Convening meetings of the board of directors.
20.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors

shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient
proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.

20.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a

board meeting and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all
members of the board of directors.

Art. 21. Conduct of meetings of the board of directors.
21.1 The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not need

to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

21.2 The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may

appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at any such meeting.

21.3 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.

21.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means

of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5  The  board  of  directors  may  deliberate  or  act  validly  only  if  at  least  a  majority  of  the  directors  are  present  or

represented at a meeting of the board of directors. In case the shareholders have resolved to classify the appointed directors
as category A and category B directors, the board of directors may deliberate or act validly only if at least one (1) category
A director and one (1) category B director is present or represented at the meeting.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case the

shareholders have resolved to classify the appointed directors as category A and category B directors, decisions shall be
taken by a majority of the directors present or represented including at least one (1) category A director and one (1) category
B director. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

21.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction

submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company’s interest, must inform the board of
directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant
director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest
must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

21.8 Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having

an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.

21.9 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates

to current operations entered into under normal conditions.

21.10 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.
22.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman, or in his absence by the

chairman pro tempore, or by any two (2) directors. In case the shareholders have resolved to classify the appointed directors
as category A and category B directors, the minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by one (1)
category A director and one (1) category B director (including by way of representation). Copies or excerpts of such minutes,

75297

L

U X E M B O U R G

which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
directors.

22.2 Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or

excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.

Art. 23. Dealing with third parties.
23.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole director, or,

if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors, or (ii) by the joint signatures or the
sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of directors within
the limits of such delegation. In case the shareholders have resolved to classify the appointed directors as category A and
category B directors, the Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of at least one category
A and one category B director.

23.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of

any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 24. Auditor(s).
24.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general

meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office, which may not exceed
six (6) years.

24.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

24.3 The internal auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
24.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur(s)

d’entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies
register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is sup-
pressed.

24.5  An  independent  auditor  may  only  be  removed  by  the  general  meeting  of  shareholders  with  cause  or  with  his

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.
26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of the

Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

26.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

26.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

26.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

26.5 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

26.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
27.1. Upon recommendation of the Board of Directors, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

27.2. Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they hold in the Company

and allocated and paid in the following order:

i. the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.1% of the nominal value of the Ordinary

Shares;

ii. the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.2% of the nominal value of the Class A

Shares;

iii. the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.3% of the nominal value of the Class B

Shares;

75298

L

U X E M B O U R G

iv. the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.4% of the nominal value of the Class C

Shares;

v. the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.5% of the nominal value of the Class D

Shares;

vi. the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.6% of the nominal value of the Class E

Shares; and

vii. the balance shall be allocated to the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to a decision taken by the general

meeting of shareholders.

27.3. In accordance with the Law and these articles of association, the board of directors or the general meeting of

shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been
drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made
since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward
and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve
pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company’s auditor, if any, has stated
in his/her report to the board of directors that the first two conditions have been satisfied.

27.4. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or

of the director(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation.
28.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators  shall  have  the  most  extensive  powers  for  the  realisation  of  the  assets  and  payment  of  the  liabilities  of  the
Company.

28.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 29. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2016.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and Payment

The forty-six thousand (46,000) shares issued have been subscribed by AIM Services S.à r.l., aforementioned, for the

price of forty-six thousand euro (EUR 46,000).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of forty-six thousand euro

(EUR 46,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of forty-six thousand euro (EUR 46,000) is entirely allocated to the share capital.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred

to in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately two thousand euro.

<i>Resolutions of the shareholders

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
2. The following persons are appointed as directors of the Company until the general meeting of shareholders convened

to approve the Company’s annual accounts for the first financial year;

(i) Dr. Michael Theim, born in Wetzlar, Germany, on 17 Mai 1955, professionally residing at Menzelstr.8, 14193 Berlin,

Germany as category A director;

75299

L

U X E M B O U R G

(ii) Mr. Olivier Hamou, born in Levallois-Perret, France, on 19 December 1973, professionally residing at 19, rue de

Bitbourg, L-1273 Luxembourg, as category B director; and

(iii) Mrs. Sonia Baldan, born in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 27 January 1960, professionally residing

at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, as category B director.

3. The following person is appointed as internal auditor until the general meeting of shareholders convened to approve

the Company’s annual accounts for the first financial year:

A3T S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered

with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B158687, having its registered office at 44, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the German text, the German version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing partiy signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am einundzwanzigsten April.
Vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Lu-

xemburg),

IST ERSCHIENEN:

AIM Services S.à r.l., eine société à responsabilité limitée mit Sitz in L-1468, 14, rue Erasme eingetragen im Luxem-

burger Handels- und Gesellschaftsregister mit der Nummer B 74.676,

hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

20. April 2015, ausgestellt in Luxemburg.

Besagte Vollmacht, welche von der Vertreterin der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur

paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Aktiengesellschaft (société anonyme)

mit der folgenden Satzung zu beurkunden:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen LVS Hotels &amp; Resorts

(Europe) S.A. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1  Zweck  der  Gesellschaft  ist  das  Halten  von  Beteiligungen  jeglicher  Art  an  luxemburgischen  und  ausländischen

Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher

Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen
und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Aktionär/Gesellschafter für Rechnung jeglicher luxemburgischen und ausländischen

Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Ein weiterer Gesellschaftszweck ist der Erwerb und Verkauf von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften,
deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, Förderung, Verkauf oder Verwaltung von Immobilien ist.

2.6 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst

werden, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

75300

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt wer-

den. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforder-
lichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großher-

zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Verwaltungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklun-

gen  aufgetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen,  welche  die  gewöhnlichen  Aktivitäten  der  Gesellschaft  an  ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen  Umstände  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt  werden;  solche  vorübergehenden  Maßnahmen  haben  keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1. Das ausgegebene Gesellschaftskapital beträgt sechsundvierzig tausend Euro (EUR 46.000) und ist aufgeteilt in

Stammaktien und Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), mit Rechten und Pflichten gemäß
der vorliegenden Satzung und gemäß der folgenden Unterteilung:

i. einunddreißigtausend (31.000) Stammaktien (die „Stammaktien“);
ii. dreitausend (3.000) Aktien der Klasse A (die „Klasse A Aktien“);
iii. dreitausend (3.000) Aktien der Klasse B (die „Klasse B Aktien“);
iv. dreitausend (3.000) Aktien der Klasse C (die „Klasse C Aktien“);
v. dreitausend (3.000) Aktien der Klasse D (die „Klasse D Aktien“); und
vi. dreitausend (3.000) Aktien der Klasse E (die „Klasse E Aktien“ und zusammen mit den Klasse A Aktien, den Klasse

B Aktien, den Klasse C Aktien und den Klasse D Aktien die „Vorzugsaktien“ und zusammen mit den Stammaktien, die
„Aktien“).

5.2. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der

für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, oder im Einklang mit Artikel 6 dieser Satzung
erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3. Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen einzuzahlen sind, werden bevorzugt dem bestehenden Aktionär angeboten.

Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden diese Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen am
Gesellschaftskapital jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum in dem dieses Vor-
zugsrecht ausgeübt werden kann und welcher nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines an den
Aktionär gesendeten Einschreibens, welches die Eröffnung der Zeichnungsfrist ankündigt, beträgt. Die Hauptversammlung
der Aktionäre kann das Vorzugsrecht des bestehenden Aktionärs durch einen Beschluss, welcher in und mit der für eine
Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, begrenzen oder aufheben.

5.4. Im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
5.5. Eine Herabsetzung des Gesellschaftskapitals durch den Rückkauf einer Klasse von Vorzugsaktien kann nur inner-

halb der jeweiligen Klassenlaufzeit (gemäß der Begriffsdefinition in Artikel 5.10) erfolgen:

i. Die Laufzeit für die Klasse A Aktien beginnt mit dem Tag der Unterzeichnung dieser notariellen Urkunde und endet

spätestens mit dem 31. Dezember 2015 (die „A Klasse Laufzeit“);

ii. Die Laufzeit für die Klasse B Aktien beginnt nach dem letzten Tag der A Klasse Laufzeit und endet spätestens mit

dem 31. Dezember 2016 (die „B Klasse Laufzeit“);

iii. Die Laufzeit für die Klasse C Aktien beginnt nach dem letzten Tag der B Klasse Laufzeit und endet spätestens mit

dem 31. Dezember 2017 (die „C Klasse Laufzeit“);

iv. Die Laufzeit für die Klasse D Aktien beginnt nach dem letzten Tag der C Klasse Laufzeit und endet spätestens mit

dem 31. Dezember 2018 (die „D Klasse Laufzeit“); und

v. Die Laufzeit für die Klasse E Aktien beginnt nach dem letzten Tag der D Klasse Laufzeit und endet spätestens mit

dem 31. Dezember 2019 (die „E Klasse Laufzeit“);

5.6. Sollte eine Vorzugsaktienklasse innerhalb der jeweiligen Klassenlaufzeit nicht zurückgekauft und gelöscht worden

sein, kann der Rückkauf und die Löschung dieser Vorzugsaktienklasse während einer Neuen Laufzeit vorgenommen wer-
den  (die  “Neue  Laufzeit”),  welche  am  Tag  nach  der  letzten  Klassenlaufzeit  (oder  gegebenenfalls  der  unmittelbar
vorangehenden Neuen Laufzeit einer anderen Vorzugsaktienklasse) beginnt und spätestens ein Jahr nach dem Beginn der
Neuen Laufzeit endet. Die erste Neue Laufzeit soll am Tag nach der E Klasse Laufzeit beginnen und zwar für die Klassen
der in ihrer jeweiligen Klassenlaufzeit nicht zurückgekauften und nicht gelöschten Vorzugsaktien in alphabetischer Rei-
henfolge von Klasse A bis Klasse E.

75301

L

U X E M B O U R G

5.7.  Sollte  ein  Rückkauf  und  eine  Löschung  einer  Klasse  von  Vorzugsaktien  vor  dem  letzten  Tag  ihrer  jeweiligen

Klassenlaufzeit (oder gegebenenfalls der Neuen Laufzeit) eintreten, beginnt die darauffolgende Klassenlaufzeit (oder ge-
gebenenfalls die Neue Laufzeit) am Tage nach dem Rückkauf und der Löschung dieser Klasse von Vorzugsaktien und
endet am 31. Dezember des darauffolgenden Jahres.

5.8. Sollte eine gesamte Klasse bzw. alle Klassen zurückgekauft und gelöscht werden, wird der Löschwert (gemäß der

Begriffsdefinition in Artikel 5.10) fällig und zahlbar seitens der Gesellschaft gegenüber dem Aktionär bzw. den Aktionären
anteilsmäßig ihrer Beteiligung an dieser Klasse bzw. diesen Klassen. Die Gesellschaft kann ihrer Zahlungsverpflichtung
sowohl durch Barzahlung, durch Sachleistung, oder durch Forderungsaufrechnung nachkommen.

5.9. Der im obigen Paragraphen genannte Löschwert wird vom alleinigen Verwaltungsratsmitglied oder, im Falle einer

Vielzahl von Verwaltungsratsmitgliedern, durch den Verwaltungsrat (im Sinne der unten aufgeführten Begriffsbestim-
mungen) nach pflichtgemäßem Ermessen und im Interesse der Gesellschaft bestimmt. Das alleinige Verwaltungsratsmit-
glied,  oder  im  Falle  einer  Vielzahl  von  Verwaltungsratsmitgliedern,  der  Verwaltungsrat  kann,  nach  seinem  alleinigen
Ermessen, die frei ausschüttbaren Reserven, entweder ganz oder teilweise, in die Bestimmung des Löschwertes miteinbe-
ziehen oder davon ausschließen.

5.10. Im Rahmen des vorliegenden Artikels 5 sollen die folgenden großgeschriebenen Begriffe die ihnen zugeordnete

Bedeutung haben:

i. „Zur Verfügung Stehender Betrag” bedeutet der Gesamtbetrag des Nettogewinns (zuzüglich Gewinnvorträge) erhöht

durch (i) alle frei ausschüttbaren Reserven und (ii) gegebenenfalls die Summe der Kapitalherabsetzung und der Reduzierung
der gesetzlichen Reserve in Zusammenhang mit der zu löschenden Vorzugsaktienklasse, aber reduziert durch (i) alle Ver-
luste  (zuzüglich  Verlustvorträge)  nicht  mit  Minuszeichen  darzustellen,  (ii)  alle  Beträge  welche  einer  durch  Gesetz
vorgeschriebenen Reserve zugeschrieben werden müssen, bestimmt auf der Grundlage der Zwischenbilanz (ohne Dop-
pelzählung), und (iii) die Gewinnanteilsberechtigung, und der sich wie folgt berechnet:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+ PE)
Wobei:
AA = zur Verfügung stehender Betrag
NP = Nettogewinn (zuzüglich Gewinnvorträge)
P = alle frei ausschüttbaren Reserven
CR = die Summe der Kapitalherabsetzung und der Reduzierung der gesetzlichen Reserve in Zusammenhang mit der zu

löschenden Vorzugsaktienklasse

L = alle Verluste (zuzüglich Verlustvorträge) nicht mit einem Minuszeichen darzustellen
LR = alle Beträge welche einer durch Gesetz vorgeschriebenen Reserve zugeschrieben werden müssen
PE = Gewinnanteilsberechtigung
Der zur Verfügung stehende Betrag muss in der Zwischenbilanz in der jeweiligen Klassenlaufzeit ausgewiesen werden

und wird vom alleinigen Verwaltungsrastmitglied, oder im Falle einer Vielzahl von Verwaltungsratsmitgliedern, vom
Verwaltungsrat der Gesellschaft, nach Treu und Glauben und im besten Gesellschaftsinteresse, dass diese für die Zukunft
gut aufgestellt ist, festgesetzt.

ii. „Zur Verfügung stehende Finanzmittel“ bedeutet (i) jedwedes Bargeld, welches der Gesellschaft zur Verfügung steht

(außer Festgeld mit einer Restlaufzeit von über sechs (6) Monaten), (ii) jedes gängige Geldmarktinstrument, Anleihen und
Depotverbindlichkeiten und jede Forderung, die, gemäß der Einschätzung des Verwaltungsrats, der Gesellschaft, abzüglich
der Nettoverschuldung oder anderer Schulden der Gesellschaft, innerhalb von sechs (6) Monaten, gemäß der Zwischen-
bilanz in Beziehung zu der jeweiligen Klassenlaufzeit (oder gegebenenfalls Neuen Laufzeit), gutgeschrieben werden kann
und (iii) jede Art von Vermögenswerten im Sinne von Aktien oder Sacheinlagen, gehalten von der Gesellschaft.

iii. „Löschwert“ bedeutet einen Wert, welcher den Zur Verfügung Stehenden Betrag nicht überschreitet unter Zugrun-

delegung der jeweiligen Klassenlaufzeit (oder gegebenenfalls der Neuen Laufzeit) unter der Voraussetzung, dass dieser
Löschwert nicht höher ist als die zur Verfügung stehenden Finanzmittel, unter Zugrundelegung der jeweiligen Klassen-
laufzeit (oder Neuen Laufzeit).

iv. „Klassenlaufzeit“, bedeutet jede der Klasse A Laufzeit, Klasse B Laufzeit, Klasse C Laufzeit, Klasse D Laufzeit und

Klasse E Laufzeit.

v. „Zwischenbilanz“, bedeutet der Zwischenabschluss der Gesellschaft zum entsprechenden Zwischenabschlusszeit-

punkt.

vi. „Zwischenabschlusszeitpunkt“, bedeutet das Datum, nicht früher als dreißig (30) Kalendertage aber nicht später als

zehn (10) Kalendertage vor dem Termin des Rückkaufs und der Löschung der entsprechenden Vorzugsaktienklasse.

vii. „Gesetz“ bedeutet das Gesetz von 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Form.
viii. „Gewinnanteilberechtigung“ bedeutet die Vorzugsdividende der jeweiligen Vorzugsaktie.

Art. 6. Aktien.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

75302

L

U X E M B O U R G

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Aktienregister - Übertragung von Aktien.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann.

Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Eigentum
an Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten
des betreffenden Aktionärs werden Zertifikate über die Eintragung ausgegeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt,  die  Ausübung  aller  Rechte  im  Zusammenhang  mit  einer  derartigen  Aktie  auszusetzen,  bis  eine  Person  als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Aktien sind im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 frei übertragbar.
7.4 Jede Übertragung von Namensaktien wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten wirksam (i) durch Eintragung

einer vom Zedenten und vom Zessionar oder deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung im
Aktienregister, oder (ii) nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder dieser zugestimmt
hat.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.
8.1 Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig ein-

berufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptver-
sammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

8.2 Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, so ist jeder Bezug auf die „Hauptversammlung der Aktionäre“ in der

vorliegenden Satzung je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als Bezug auf den „alleinigen Aktionär“ zu verstehen
und alle Befugnisse der Hauptversammlung werden vom alleinigen Aktionär ausgeübt.

Art. 9. Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre.
9.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Verwaltungsrat oder, soweit vorhanden, durch den/

die Rechnungsprüfer einberufen werden.

9.2 Sie muss auf schriftliche Aufforderung von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals halten, vom Verwaltungsrat oder vom Rechnungsprüfer/den Rechnungsprüfern einberufen
werden. In einem derartigen Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines (1) Monats ab Zugang des
Ersuchens abgehalten werden.

9.3 Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss das Datum, die Uhrzeit, den Ort und die Tages-

ordnung der Versammlung enthalten und zweimal in Form einer Einberufung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations und in einer Luxemburger Tageszeitung mit einem Zeitabstand von mindestens acht (8) Tagen und acht (8)
Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum erfolgen. Einberufungen per Post sind acht (8) Tage vor
dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Inhaber von Namensaktien zu versenden, wobei kein Beweis der
Einhaltung dieser Formvorschrift erbracht werden muss. Handelt es sich bei allen Aktien um Namensaktien, so kann die
Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen, die mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung
anberaumten Datum an jeden Aktionär zu versenden sind.

9.4 Falls alle Aktionäre in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf Ladungsformalitäten verzichtet

haben, kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einladung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird in der Gemeinde, in der sich der Gesellschaftssitz befindet, oder

an einem anderen in der Einberufung bestimmten Ort am 15 Mai um 11 Uhr abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher
Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten. Weitere Hauptver-
sammlungen der Aktionäre können an dem in der Einberufung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit abgehalten
werden.

10.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird ein Rat der Versammlung bestimmt, der aus einem Vorsitzenden,

einem Schriftführer und einem Stimmzähler besteht, die weder Aktionäre, noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein müs-
sen. Wenn alle bei der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre entscheiden, dass eine ordnungsgemäße Abstimmung
derart  gewährleisten  werden  kann,  so  können  sie  einstimmig  beschließen,  lediglich  (i)  einen  Vorsitzenden  und  einen
Schriftführer oder (ii) eine Person zu ernennen, die die Rolle des Rates der Versammlung übernimmt und in einem solchen
Fall ist die Ernennung eines Stimmzählers nicht erforderlich. Soweit anwendbar und je nach Zusammenhang ist jeder Bezug
auf den „Rat der Versammlung“ in dieser Satzung als Verweis auf den „Vorsitzenden und Schriftführer“ oder gegebenen-
falls als Verweis auf die „Einzelperson, die die Rolle des Rates übernommen hat“, zu verstehen. Der Rat der Versammlung

75303

L

U X E M B O U R G

soll sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und vor allem im Einklang mit den Regeln
betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktionären abgehalten wird.

10.3 In jeder Hauptversammlung wird eine Anwesenheitsliste geführt.
10.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person durch ein

unterzeichnetes Dokument, das per Post, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt
wird, schriftlich bevollmächtigt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.

10.5 Aktionäre, die an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und
tatsächlich an der Versammlung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Bestimmung des Quorums und des Stimmrechts,
insofern diese Kommunikationsmittel am Ort der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt werden.

10.6 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch eine unterzeichnete Stimmkarte

abgeben, welche per Post, E-Mail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft oder
an die in der Einberufung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche Stimmkarten verwenden, die
von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung,
die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionären
ermöglichen, seine Stimme für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das
entsprechende Kästchen ankreuzt.

10.7 Stimmkarten, die für einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen

den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungültig. Die
Gesellschaft wird nur Stimmkarten berücksichtigen, die sie vor der entsprechenden Hauptversammlung der Aktionäre
erhalten hat.

Art. 11. Quorum und Stimmrecht.
11.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre.
11.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in

einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesell-
schaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Art. 12. Änderungen der Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der

Satzung einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der
abgegebenen gültigen Stimmen, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist. Falls
die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung
eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, die unabhängig von einem Anwesenheitsquorum be-
schlussfähig ist und in welcher Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen gültigen
Stimmen gefasst werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Art. 13. Änderung der Nationalität. Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 14. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915

kann der Verwaltungsrat jede sich im Gange befindliche Hauptversammlung der Aktionäre um vier (4) Wochen vertagen.
Der Verwaltungsrat muss eine Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder mehreren Aktionären,
die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals halten, gefordert wird. Durch derartige Vertagung wird
jeder bereits gefasste Beschluss in dieser Versammlung annulliert.

Art. 15. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.
15.1 Der Rat der Versammlung nimmt ein Protokoll jeder Versammlung auf, welches vom Rat der Versammlung sowie

von jedem Aktionär, der darum ersucht, unterzeichnet wird.

15.2 Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht wer-

den sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die
Originalurkunde verwahrt, beglaubigt werden, oder ansonsten vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei beliebigen
Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 16. Zusammensetzung und Befugnisse des Verwaltungsrates.
16.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusam-

mensetzt. Sollte die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionären gegründet worden sein oder wird in einer Hauptver-
sammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionären hat, so kann die Gesellschaft bis
zu der Hauptversammlung der Aktionäre durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geleitet werden, die auf die Feststel-
lung folgt, dass es wieder mehr als einen Aktionär gibt. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff
„einziges Verwaltungsratsmitglied“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Ver-
waltungsrat“ als Verweis auf das „einzige Verwaltungsratsmitglied“ auszulegen.

75304

L

U X E M B O U R G

16.2 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle

Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der
durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.

16.3 Ungeachtet dessen, bedarf der Verkauf jeglicher Aktiva, die direkt von der Gesellschaft gehalten werden und einen

Wert von mehr als zehntausend Euro (EUR 10.000) haben, der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung der Ak-
tionäre und dies durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, der mit einer Mehrheit von mindestens
fünfzig Prozent (50%) des Grundkapitals der Gesellschaft gefasst wird.

Art. 17. Tägliche Geschäftsführung.
17.1 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung

der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten oder anderen Personen, mit
gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden
durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.

17.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.

Art. 18. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
18.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

18.2 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten und jedes Verwaltungsrats-

mitglied übt sein Amt aus, bis sein Nachfolger ernannt ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann wiederernannt werden.

18.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen in einer Hauptversamm-

lung ernannt.

18.4 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann beschließen Verwaltungsratsmitglieder verschiedener Kategorien zu

ernennen und zwar Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A und Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B.

18.5 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund mit einfacher Mehrheit der in einer Hauptversamm-

lung der Aktionäre abgegebenen Stimmen abberufen werden.

18.6 Wird eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt, so muss diese eine natürliche Person als ihren

ständigen Vertreter benennen, die ihr Mandat in ihrem Namen und für ihre Rechnung ausübt. Die betreffende juristische
Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche
Person kann nur ständiger Vertreter eines (1) Verwaltungsratsmitglieds und nicht gleichzeitig persönlich Verwaltungs-
ratsmitglied sein.

Art. 19. Vakanz des Amtes eines Verwaltungsratsmitglieds.
19.1 Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen

Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Haupt-
versammlung der Aktionäre vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Verwaltungsrats-
mitglieds nicht übersteigenden Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre ausgefüllt werden, welche im
Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

19.2 Für den Fall, dass das einzige Verwaltungsratsmitglied aus seinem Amt scheidet, muss die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Hauptversammlung der Aktionäre neu besetzt werden.

Art. 20. Einladung zu Verwaltungsratssitzungen.
20.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder eines beliebigen Verwaltungsrats-

mitglieds. Die Verwaltungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft
statt.

20.2 Die Verwaltungsratsmitglieder werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anbe-

raumten Datum zu jeder Sitzung des Verwaltungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Verwaltungs-
ratsmitglieder schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung
abgegeben  haben,  wobei  eine  Kopie  einer  solchen  unterzeichneten  Zustimmung  ein  hinreichender  Nachweis  ist.  Eine
Einladung zu Sitzungen des Verwaltungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Verwaltungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Verwaltungsratsmitgliedern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und diese

alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des
Verwaltungsrats diesen zugestimmt und sie unterzeichnet haben.

Art. 21. Durchführung von Verwaltungsratssitzungen.
21.1 Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen

Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokollfüh-
rung der Verwaltungsratssitzungen verantwortlich ist.

75305

L

U X E M B O U R G

21.2 Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. In dessen Abwesenheit

kann der Verwaltungsrat ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder
vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

21.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Mit-

glied  des  Verwaltungsrats  schriftlich,  per  Fax,  E-Mail  oder  ein  anderes  vergleichbares  Kommunikationsmittel  bevoll-
mächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Verwaltungsrats
kann ein oder mehrere, aber nicht alle anderen Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

21.4 Eine Verwaltungsratssitzung kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kom-

munikationsmittel  abgehalten  werden,  welches  es  allen  Teilnehmern  ermöglicht,  einander  durchgängig  zu  hören  und
tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleich-
bedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
abgehalten erachtet.

21.5 Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mit-

glieder  in  der  Sitzung  anwesend  oder  vertreten  ist.  Falls  die  Aktionäre  die  Verwaltungsratsmitglieder  in  Kategorie  A
Verwaltungsratsmitglieder und Kategorie B Verwaltungsratsmitglieder unterteilt haben, kann der Verwaltungsrat nur dann
wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest ein Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A und ein Verwaltungs-
ratsmitglied der Kategorie B in der Sitzung anwesend oder vertreten sind.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Verwaltungsratssitzung teilnehmenden

oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Falls die Aktionäre die Verwaltungsratsmitglieder in Kategorie A
Verwaltungsratsmitglieder und Kategorie B Verwaltungsratsmitglieder unterteilt haben, werden Beschlüsse mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen der an der Verwaltungsratssitzung teilnehmenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst wobei mindestens ein Kategorie A Verwaltungsratsmitglied und ein Kategorie B Verwaltungsratsmitglied
teilnehmen oder vertreten sind. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entschei-
dende Stimme.

21.7 Soweit nicht gesetzlich anders bestimmt muss jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an einem Geschäft, das dem

Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein Interesse hat, welches den Interessen der Gesellschaft
entgegensteht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenskonflikt informieren; die Erklärung wird im Protokoll der be-
treffenden Sitzung aufgenommen. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied darf weder an der Beratung über das in Frage
stehende Geschäft teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Hauptversammlung der Aktionäre muss von derar-
tigen Interessenkonflikten informiert werden, bevor Beschlüsse zu anderen Tagesordnungspunkten gefasst werden.

21.8 Hat die Gesellschaft nur ein einziges Verwaltungsratsmitglied, so werden Geschäfte zwischen der Gesellschaft und

dem Verwaltungsratsmitglied, welches daran ein der Gesellschaft entgegenstehendes Interesse hat, nur im Beschluss des
einzigen Verwaltungsratsmitglieds erwähnt.

21.9 Regeln zum Interessenkonflikt finden keine Anwendung, sofern sich die Entscheidung des Verwaltungsrats oder

des einzigen Verwaltungsratsmitglieds auf gängige Geschäfte bezieht, die unter normalen Bedingungen eingegangen wur-
den.

21.10 Der Verwaltungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax,

E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Zustim-
mung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 22. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen - Protokoll der Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds.
22.1 Das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder, im Falle seiner

Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore oder von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Falls
die Aktionäre die Verwaltungsratsmitglieder in Kategorie A Verwaltungsratsmitglieder und Kategorie B Verwaltungs-
ratsmitglieder unterteilt haben, soll das Protokoll jener Verwaltungsratssitzung von einem Verwaltungsratsmitglied der
Kategorie A und einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B unterschrieben werden (einschließlich im Wege der
Vertretung). Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind,
werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom

einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Art. 23. Geschäfte mit Dritten.
23.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des einzigen Verwal-

tungsratsmitglieds oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Verwaltungsratsmitglieder hat, durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch (ii) die gemeinsame oder Einzelunterschrift
jedweder Person(en), der/denen eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, im Rahmen dieser
Befugnis verpflichtet. Falls die Aktionäre die Verwaltungsratsmitglieder in Kategorie A Verwaltungsratsmitglieder und
Kategorie B Verwaltungsratsmitglieder unterteilt haben, wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift eines

75306

L

U X E M B O U R G

Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B verpflichtet (einschließlich
im Wege der Vertretung).

23.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder

Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der/denen diese Vollmacht übertragen wurde.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 24. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
24.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)).

Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre nicht
überschreiten darf.

24.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.
24.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte der

Gesellschaft.

24.4 Wenn die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom

19. Dezember 2002 betreffend das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss
von Unternehmen in seiner geänderten Fassung einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises
agréé(s)) ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

24.5  Ein  unabhängiger  Wirtschaftsprüfer  darf  nur  aus  berechtigtem  Grund  oder  mit  seiner  Zustimmung  durch  die

Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 25. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 26. Jahresabschluss und Gewinne.
26.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit

den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

26.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

26.3 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der

gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

26.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

26.5 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit dem Gesetz

von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.

26.6 Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen

Aktien.

Art. 27. Ausschüttungen - Dividenden - Zwischendividenden - Emissionsagio.
27.1. Nach Empfehlung des Verwaltungsrates, bestimmt die Hauptversammlung über die Verwendung der Gewinn-

überschüsse der Gesellschaft wie im Gesetz und in der vorliegenden Satzung vorgeschrieben.

27.2. Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgen im Verhältnis zu der Anzahl der Aktien, die sie in der Gesellschaft

halten und werden in folgender Reihenfolge ausgezahlt:

i. Stammaktieninhaber haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,1% des Nominalwertes der Stammaktien;
ii. Inhaber von Klasse A Aktien haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,2% des Nominalwertes der Klasse

A Aktien;

iii. Inhaber von Klasse B Aktien haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,3% des Nominalwertes der Klasse

B Aktien;

iv. Inhaber von Klasse C Aktien haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,4% des Nominalwertes der Klasse

C Aktien;

v. Inhaber von Klasse D Aktien haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,5% des Nominalwertes der Klasse

D Aktien;

vi. Inhaber von Klasse E Aktien haben Anspruch auf eine Dividende in Höhe von 0,6% des Nominalwertes der Klasse

E Aktien; und

vii. Der Restbetrag wird gemäß einer Entscheidung der Hauptversammlung den Inhabern von Stammaktien zugewiesen.
27.3. In Übereinstimmung mit dem Gesetz und der vorliegenden Satzung kann der Verwaltungsrat oder die Hauptver-

sammlung der Aktionäre Zwischendividenden auszahlen unter der Voraussetzung, dass (i) eine Zwischenbilanz erstellt

75307

L

U X E M B O U R G

wurde, nach der genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne
übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert
worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen ent-
nommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die gemäß dem Gesetz oder diesem Gesell-
schaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Rechnungsprüfer der Gesellschaft, falls vorhanden, in seinem
Bericht an den Verwaltungsrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen erfüllt sind.

27.4. Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Beschluss der Aktionären oder Beschluss der Verwaltungsrats-

mitglieder unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche
Rücklage frei an den/die Aktionär ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation.
28.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts
anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte
und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

28.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an

die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 29. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll im Jahr 2016 abgehalten werden.
3. Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die sechsundvierzigtausend (46.000) ausgegebenen Aktien wurden durch AIM Services S.à r.l., vorbenannt, zum Preis

von sechsundvierzigtausend Euro (EUR 46.000) gezeichnet.

Die Einlage für die so gezeichneten Aktien wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in

Höhe von sechsundvierzigtausend Euro (EUR 46.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewie-
sen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von sechsundvierzigtausend Euro (EUR 46.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit, dass er die Einhaltung der Vorschriften, die in Artikel 26 des Gesetzes von

1915 aufgeführt sind und auf die verwiesen wird, geprüft hat und erklärt, dass diese erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf zweitausend Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleinigen Aktionärs

Die Gründerin, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welche auf eine formelle Einberufung ver-

zichtet, hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft ernannt, bis zur Hauptversammlung

der Aktionäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr verabschiedet;

(i) Dr. Michael Theim geboren in Wetzlar, Deutschland, am 17. Mai 1955, geschäftsansässig in Menzelstr.8, 14193

Berlin, als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A;

(ii) Herr Olivier Hamou, geboren in Levallois-Perret, Frankreich, am 19. Dezember 1973, geschäftsansässig in 19, rue

de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B; und

(iii) Frau Sonia Baldan, geboren in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 27. Januar 1960, geschäftsansässig in

19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B.

75308

L

U X E M B O U R G

3. Die folgende Person wird als Rechnungsprüfer der Gesellschaft bis zur Hauptversammlung der Aktionäre, die den

Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr verabschiedet ernannt:

A3T S.A., eine luxemburgische société anonyme mit Sitz in 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Lu-

xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister mit der Nummer B158687.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei,

dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, soll die deutsche Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welche dem Notar mit Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. REIBOLD, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 23. April 2015. Relation: EAC/2015/9255. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-

EUR).

<i>Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015064100/957.
(150073408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Pfizer PFE Pilsa Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 359.077.700,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue JF Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 192.555.

In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of April.
Before Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Pfizer  Shareholdings  Luxembourg  S.à  r.l.,  organized  under  the  laws  of  the  Grand-Duchy  of  Luxembourg,  with  its

regitered office at 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade Register under number B 165.903 (“PSL”),

here represented by Me Sonia BELLAMINE, Avocate à la Cour, residing in Howald, Grand-Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The proxy holder requests the notary to enact that:
By deed enacted by the officiating notary on December 18, 2014, under number 49,393 of his directory, filed at the

Companies and Trade Register of Luxembourg ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg"), on January 12,
2015, reference L150005862, published with the Memorial C Recueil des Sociétés et des Associations, n° 363 page 17390
on February 11, 2015, the share capital of PFIZER PFE PILSA HOLDCO SARL, a société à responsabilité limitée existing
under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, RCS Luxembourg B number 192555 (the "Company"), has been increased by
an amount of USD 359,077,700 (three hundred fifty-nine million seventy-seven thousand seven hundred US Dollars) so
as to raise it from its initial amount of USD 20,000 (twenty thousand US Dollars) to USD 359,097,700 (three hundred fifty-
nine million ninety-seven thousand seven hundred US Dollars) by way of a contribution in kind made by PSL consisting
of all the rights, titles and interests in and to TWO MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND THREE
HUNDRED FIFTY-TWO (2,821,352) shares, having a nominal value of EUR 100 each in the share capital of Pfizer
International Luxembourg SA, existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with its regitered office at 51
avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register
under number B 79.443 (the “Contributed Shares”).

However, it appears that the number of the Contributed Shares was incorrect as a result of a typographical error and that

the correct number of Contributed Shares is TWO MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND THREE
HUNDRED SIXTY (2,821,360).

Consequently, without any other change to the deed, it is resolved to correct the number of the Contributed Shares on

December 18, 2014, to TWO MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY
(2,821,360), so that the first paragraph under SUBSCRIPTION reads as follows:

<i>“Subscription

PFIZER  SHAREHOLDINGS  LUXEMBOURG  SARL,  prenamed,  represented  as  stated  hereabove  has  declared  to

subscribe for the THREE HUNDRED FIFTY-NINE MILLION SEVENTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED

75309

L

U X E M B O U R G

(359,077,700) New Shares, and to pay them a total price of THREE HUNDRED FIFTY-NINE MILLION SEVENTY-
SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 359,077,700.-) together with total issue premium of
THREE BILLION TWO HUNDRED THIRTY ONE MILLION SIX HUNDRED NINETY NINE THOUSAND THREE
HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 3,231,699,300.-) by a contribution in kind consisting of all the rights, titles and interests
in and to TWO MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY (2,821,360)
shares, having the nominal value of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each in the share capital of PFIZER INTER-
NATIONAL LUXEMBOURG SARL (formerly PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA), existing under the
laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 79.443,
(“PIL”). The shares to be contributed in PIL shall hereinafter be referred to as the “Contributed Shares”.”

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le neuvième jour d'avril.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Pfizer Shareholdings Luxembourg S.à r.l., organisée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège

social au 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxebourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.903 («PSL»),

ici représentée par Me Sonia BELLAMINE, Avocat à la Cour résidant professionnellement à Howald, Grand-Duché de

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte aux fins d'enregistrement.

Le mandataire prie le notaire d'acter que:
Par acte reçu par-devant le notaire instrumentant, le 18 décembre 2014, sous le numéro 49.393 de son répertoire, déposé

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015, référence L150005862 et publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, n°363 page 17390 le 11 février 2015, le capital social de PFIZER PFE PILSA
HOLDCO SARL, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 192555 (la «Société»), a été augmenté d'un montant
de 359.077.700 USD (trois cent cinquante-neuf millions soixante-dix-sept mille sept cents Dollars Américains) pour le
porter de son montant initial de 20.000 USD (vingt mille Dollars Américains) à 359.097.700 USD (trois cent cinquante-
neuf millions quatre-vingt- dix-sept mille sept cents Dollars Américains) au moyen d'un apport en nature réalisé par PSL,
consistant en tous les droits, titres et intérêts des DEUX MILLIONS HUIT CENT VINGT-ET-UN MILLE TROIS CENT
CINQUANTE-DEUX (2.821.352) parts sociales, ayant une valeur nominale de 100 EUR chacune dans le capital social de
Pfizer International Luxembourg SA, existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.443 (les «Parts Sociales Apportées»).

Cependant, il apparaît que le nombre de Parts Sociales Apportées était incorrect en raison d'une erreur typographique

et que le nombre réel de Parts Sociales Apportées est de DEUX MILLIONS HUIT CENT VINGT-ET-UN MILLE TROIS
CENT SOIXANTE (2.821.360).

Par conséquent, sans qu'il soit procédé à d'autres modifications de l'acte, il est décidé de corriger le nombre de Parts

Sociales  Apportées  au  18  décembre  2014  à  DEUX  MILLIONS  HUIT  CENT  VINGT-ET-UN  MILLE  TROIS  CENT
SOIXANTE (2.821.360), de sorte que le premier paragraphe sous SOUSCRIPTION se lise comme suit:

<i>«Souscription

PFIZER SHAREHOLDINGS LUXEMBOURG SARL, prénommée, ici représentée comme dit ci-avant a déclaré sou-

scrire  toutes  les  TROIS  CENT  CINQUANTE  NEUF  MILLIONS  SOIXANTE-DIX-SEPT  MILLE  SEPT  CENTS
(359.077.700) nouvelles parts sociales et les libérer pour un prix total de TROIS CENT CINQUANTE NEUF MILLION
SOIXANTE-DIX- SEPT MILLE SEPT CENT DOLLARS AMERICAINS (USD 359,077,700,-) ensemble avec une prime
d’émission de TROIS MILLIARDS DEUX CENT TRENTE ET UN MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT DIX-
NEUF MILLE TROIS CENTS DOLLARS AMERICAINS (USD 3.231.699.300,-), par un apport en nature consistant en
tous les droits, titres et intérêts de DEUX MILLIONS HUIT CENT VINGT-ET-UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE
(2.821.360) parts sociales détenues par PFIZER SHAREHOLDINGS LUXEMBOURG SARL dans la société PFIZER
INTERNATIONAL LUXEMBOURG SARL, ayant une valeur de CENT EUROS (EUR 100.-) chacune, une société à

75310

L

U X E M B O U R G

responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois de Luxembourg PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG
SARL (Anc. PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA), ayant son siège social au 51 avenue JF Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Lu-
xembourg sous le numéro B 79.443, («PIL»). Les parts sociales apportés à PIL seront mentionnés ci-après comme les
«Parts Apportés».

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, passé à Senningerberg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Sonia Bellamine, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 17 avril 2015. 1LAC / 2015/ 11876. Reçu 12.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 avril 2015.

Référence de publication: 2015064229/114.
(150073486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Noble Invest International, Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 69.179.

Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2015.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015064207/14.
(150073839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Meersel Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 58.981.

<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 20 avril 2015

1. Monsieur Hans DE GRAAF a démissionné de son mandat d'administrateur et président du conseil d'administration

avec effet au 20 avril 2015.

2. Madame Karoline WILLOT, administrateur de sociétés, née à Uccle (Belgique), le 11 janvier 1983, demeurante

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme administrateur et présidente du
conseil d'administration avec effet au 20 avril 2015 et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

Veuillez noter que le siège social de la société COMCOLUX S.à r.l., commissaire aux comptes, n° RCS B58545, se

situe désormais au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 avril 2015.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour MEERSEL HOLDING S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015063225/19.
(150071993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2015.

75311

L

U X E M B O U R G

Agat Re, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 78.214.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 22 avril 2015

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'élire Administrateurs:
Monsieur François CREPY,
Monsieur Dominique FAGUET
Madame Etienne CHARPENTIER.
Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2016 et qui statuera sur

les comptes de l'exercice clôturés au 30 juin 2016.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer

Réviseur Indépendant de la société:

KPMG Luxembourg
39, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2016 et qui statuera

sur les comptes de l'exercice clôturés au 30 juin 2016.

<i>Pour la société AGAT RE
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015063590/25.
(150072883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Afcard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 36, Rangwee.

R.C.S. Luxembourg B 170.442.

Les statuts coordonnés au 21 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 avril 2015.

Référence de publication: 2015063588/10.
(150073050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Finagra S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 24.500.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 25 mars 2015

<i>Résolution:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
de transférer le siège social au 44 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 20 mars 2015.
Par ailleurs, le Conseil d'Administration informe que les adresses des administrateurs ont également changé avec effet

au 20 mars 2015 comme suit:

La société JALYNE S.A., 44, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par J. BONNIER 44, avenue J-F

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

J-C THOUAND
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015063892/17.
(150072822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

75312


Document Outline

Abate Constructions S.à r.l.

Acqua Marcia International S.A.

AD &amp; S Alessi Design &amp; Structures S.à r.l.

Afcard S.A.

Agat Re

Alta Design S.à r.l.

Autonomy Iceland

Autonomy Iceland Two S.à r.l

Beausoleil Property S.A.

Chez Nono 2 S.à r.l.

Clearview One

Finagra S.A., SPF

GoldenTree Holdco Lux 1 S.à r.l.

ING Lease Luxembourg

Jargonnant Partners S.à r.l.

Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.

Luxe International S. à r. l.

LVS Hotels &amp; Resorts (Europe) S.A.

Mediacapital Holding S.A.

Meersel Holding S.A.

Mercury Europe Holdings

Millicom Africa International Finance S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.

Molux S.à r.l.

MONO Luxembourg

MONO Luxembourg

Noble Invest International

Pfizer PFE Pilsa Holdco S.à r.l.

Platheg

Prestinvest Holding S.A.

Sofina Multi Strategy

Solartec S.à r.l.

Starpetroleum Oman

Starpetroleum Qatar

Suisscourtage Luxembourg S.A.

Swiss Life (Luxembourg)

Sybaris S.A.

Syren Capitalisation S.A.

Temrex S.à r.l.

Termidor S.A.

TJ Capital S.à r.l. SPF

TMF Corporate Services S.A.

TMF Secretarial Services S.A.

Tomasa Investments S.à r.l.

TPG Merl S.à r.l.

TPG Varnish S.à r.l.

TPL Aschersleben S.à r.l.

TPL Biberach S.à r.l.

Triton Masterluxco 4 S.à r.l.

Trufilux

Universal Care S.à r.l.

Valartis German Residential Health Care

Value Secondary Investments SICAR (S.C.A.)

Vector Investments B S.àr.l.