This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1536
18 juin 2015
SOMMAIRE
Applux S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73683
Arvel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73686
ASR Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73686
Benefuel International Holdings S.à r.l. . . . . .
73682
BIP Participation Partners, S.à r.l. . . . . . . . . .
73685
Blue Planet Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73682
BNP Paribas S.B Ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73685
BO & MIAN Management . . . . . . . . . . . . . . . .
73685
C5 Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73683
CGM Lux 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73687
Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l. . . .
73684
Charger Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l. . . . . .
73684
China Southern Dragon Dynamic Fund . . . . .
73685
CMI Insurance (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . .
73683
Compradore S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73683
DB Platinum Advisors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73687
DB PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73687
DB Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73687
Debt Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73688
Digital Services Holding IV S. à r.l. . . . . . . . . .
73684
Digital Services XLV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
73686
DWS Institutional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73692
DWS Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73693
ECommerce Pay Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
73688
Enerdeal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73688
Entreprise S-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73692
ESMOLUX Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73682
Esselte European Holdings (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73692
FFDC Super 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73689
FFDC Super 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73689
Finanzpress Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
73682
Fléikescht S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73688
Gagfah S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73691
German Hospitality Midco S.à r.l. . . . . . . . . . .
73689
German Hospitality Pledgeco S.à r.l. . . . . . . . .
73690
German Hospitality Topco S.à r.l. . . . . . . . . . .
73691
Green Hope S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73691
Greenvest Private Equity Partners I . . . . . . . .
73690
HDI-Gerling Assurances SA Luxembourg . . .
73728
IDI Gazeley Mannheim 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
73715
Immomod S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73696
JAT concept (JET AERONAUTICAL TECH-
NICS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73694
Jewel HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73694
JKC Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73695
José de Mello International . . . . . . . . . . . . . . .
73694
JTC Signes S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73695
Julius Baer Multiopportunities . . . . . . . . . . . .
73693
Kopperam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73693
K.Y.O. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73693
LM Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73696
Luxembourg Investment Company 48 S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73715
LV Holding S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73711
M Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73712
Moneda Top-Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
73713
Montrica Global Opportunities Master Fund
(Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73713
Mozart HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73715
MP Property Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73717
Skigo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73682
73681
L
U X E M B O U R G
Skigo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 114.411.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015055184/2.
(150062564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.
ESMOLUX Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 30.777.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015059743/11.
(150068723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2015.
Finanzpress Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 42.491.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 avril 2015i>
- la démission de Monsieur Pascal De Graeve de son mandat d'administrateur est acceptée. Monsieur Stéphane Cosco,
employé privé, né le 5 juin 1976 à Villerupt (F) demeurant professionnellement au 3, Place Dargent, L-1413 Luxembourg
est nommé en son remplacement. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2016.
Certifié sincère et conforme
Finanzpress Holding S.A.
Référence de publication: 2015059770/13.
(150068603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2015.
Benefuel International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 189.789.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015061719/9.
(150071105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Blue Planet Group, Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 165.526.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Blue Planet Group S.A.
Référence de publication: 2015061720/10.
(150071060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
73682
L
U X E M B O U R G
Applux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7620 Larochette, 33, rue de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 180.860.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015061668/10.
(150071267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
CMI Insurance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 36, rue Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 67.803.
EXTRAIT
L'assemblée générale des actionnaires de CMI Insurance Luxembourg tenue à Luxembourg le 02 avril 2015 a décidé
de renouveler le mandat des administrateurs suivants, avec effet immédiat pour une période prenant fin lors de l'assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra en 2016:
- Madame Sandrine Puccilli;
- Monsieur James Edward Clatworthy;
- Monsieur David James Walkden; et
- Monsieur Guy Harles.
L'assemblée générale des actionnaires de CMI Insurance Luxembourg tenue à Luxembourg le 02 avril 2015 a décidé
de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, avec effet immédiat pour une période prenant fin lors de l'assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra en 2016.
Il a été également pris note de la nouvelle adresse de PricewaterhouseCoopers au 2 rue Gerhard Mercator, BP 1443
L-1014 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CMI Insurance Luxembourg
i>Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2015061810/24.
(150071206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Compradore S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 29.471.
EXTRAIT
Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 18 février 2015, a nommé en qualité de dépositaire des actions au
porteur de la Société:
- RSM FHG & Associés, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B85099.
Luxembourg, le 27 avril 2015.
<i>Pour COMPRADORE S.A., SPF
i>Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2015061814/15.
(150071179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
C5 Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 163.679.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
73683
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015061822/13.
(150070983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Digital Services Holding IV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 184.702.
Diese Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Han-
delsregister zu aktualiseren.
- Die Denomination und Handelsregisternummer der Teilhaberin der Gesellschaft, Rocket Internet AG, lautet mit so-
fortiger Wirkung wie folgt:
Rocket Internet SE, eine Societas Europaea, eingeschrieben beim Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
unter der Nummer HRB 165662 B.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. April 2015.
Digital Services Holding IV S.à r.l.
Référence de publication: 2015061827/17.
(150071595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Charger Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 130.020,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 138.249.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société du 20 avril 2015i>
En date du 20 avril 2015, l'associé unique de la société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur Stephen Bufano, né le 21 mars 1979 à Fort Lee, New Jersey, Etats-Unis d'Amé-
rique, ayant comme adresse professionnelle 888 Seventh Avenue, 38
th
floor, New York 10019, Etats-Unis d'Amérique,
en tant que gérant de la société avec effet au 1
er
avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2015.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015061768/17.
(150071140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 68.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 138.298.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société du 20 avril 2015i>
En date du 20 avril 2015, l'associé unique de la société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur Stephen Bufano, né le 21 mars 1979 à Fort Lee, New Jersey, Etats-Unis d'Amé-
rique, ayant comme adresse professionnelle 888 Seventh Avenue, 38
th
floor, New York 10019, Etats-Unis d'Amérique,
en tant que gérant de la société avec effet au 1
er
avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
73684
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 20 avril 2015.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015061769/17.
(150071139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
China Southern Dragon Dynamic Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 157.189.
Monsieur Steve Bernat a démissionné de son poste d'administrateur le 17 avril 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 27 avril 2015.
<i>Pour le compte de China Southern Dragon Dynamic Fund
i>Citibank International Limited, Luxembourg Branch
Référence de publication: 2015061771/12.
(150070970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
BO & MIAN Management, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 145.975.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015061750/10.
(150071524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
BNP Paribas S.B Ré, Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 145.794.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 19 mars 2015i>
<i>Résolution 3: Gouvernancei>
3.1: Composition des instances de gouvernance
Le Conseil reçoit la démission de Madame Barbara Bavay de ses fonctions d'administrateur délégué à la gestion jour-
nalière avec effet au 31 mars 2015.
Le Conseil décide pour la remplacer et terminer son mandat, de coopter comme Administrateur et Administrateur délégué
à la gestion journalière Madame Marleen Van Malderen, demeurant professionnellement au 16, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg avec effet au 31 mars 2015.
La prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2015 confirmera cette cooptation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Extrait sincère et conforme
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015061749/19.
(150070880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
BIP Participation Partners, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.
R.C.S. Luxembourg B 172.959.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
73685
L
U X E M B O U R G
BIP Participation Partners, S.à r.l.
Référence de publication: 2015061744/10.
(150071033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Arvel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 179.998.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance en date du 8 avril 2015i>
Il résulte des décisions du conseil de gérance que le siège social de Arvel S.à r.l. a été transféré au 47, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 31 mars 2015.
Luxembourg, le 27 avril 2015.
<i>Pour la société Arvel S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015061707/14.
(150071682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
ASR Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 109.355.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 avril 2015i>
L'Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs suivants:
- Mme Fleur Rieter
- M. Jack Julicher
- M. Marco Lavooi
- M. Marnix Arickx
pour un terme d'un an qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016
L'Assemblée décide de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, Rue Gerhard Mercator,
L-1014 Luxembourg, en sa qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société pour un terme d'un an devant expirer à la
prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016
Référence de publication: 2015061708/17.
(150071104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Digital Services XLV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 194.453.
Diese Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Han-
delsregister zu aktualiseren.
- Die Denomination und Handelsregisternummer der Teilhaberin der Gesellschaft, Rocket Internet AG, lautet mit so-
fortiger Wirkung wie folgt:
Rocket Internet SE, eine Societas Europaea, eingeschrieben beim Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
unter der Nummer HRB 165662 B.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. April 2015.
Digital Services XLV S.à r.l.
Référence de publication: 2015061837/17.
(150071194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
73686
L
U X E M B O U R G
CGM Lux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 125.073.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2015.
Référence de publication: 2015061803/10.
(150071617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
DB Platinum Advisors, Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 85.829.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 24 avril 2015 a décidé:
- et de renouveler le mandat de:
Mr. Roger-Marc NOIROT Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB,
ROYAUME-UNI
Mr. Matthias LIERMANN Deutsche Bank AG, Mainzer Landstr. 178-180, 60327 Frankfurt am Main, ALLEMAGNE
Mr. Ben O'BRYAN Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, ROY-
AUME-UNI
M. Werner BURG, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2 Boulevard Konrad Adenauer, L 1115 Luxembourg,
Mme Barbara POTOCKI-SCHOTS, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lu-
xembourg,
en leur qualité d'administrateur pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2016;
- de renouveler le mandat de:
Ernst & Young Luxembourg, 7 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2016.
<i>Pour DB PLATINUM ADVISORS
i>Société Anonyme
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015061864/27.
(150070921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
DB PWM, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 163.660.
Die Bilanz zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2015061865/11.
(150070793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
DB Re, Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 53.295.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Jährlichen Generalversammlung vom 15. April 2015i>
1. Die Generalversammlung bestätigt Herrn Dirk Wegener, Mitglied des Verwaltungsrates, als Vorsitzenden der Ge-
sellschaft mit Wirkung vom 1. Januar 2015.
73687
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Dirk Wegener als Verwaltungsratsmitglied bis zur
ordentlichen Gesellschafterversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.Dezember 2016 endende Ge-
schäftsjahr entscheidet, zu verlängern.
1. Die Generalversammlung beschließt, die KPMG Luxembourg, Société coopérative, geschäftsansässig in 39, Avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2015 zu ernennen. Das Mandat endet anlässlich der jährlichen Gesellschafterversammlung 2016, die über
den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr, welches am 31. Dezember 2015 endet, abstimmt.
Référence de publication: 2015061866/17.
(150071417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Debt Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Fléikescht S.à r.l.).
Siège social: L-7243 Bereldange, 64, rue du X octobre.
R.C.S. Luxembourg B 158.424.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le lundi 27 avril 2015.
<i>Pour la société
i>Me Martine DECKER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015061867/13.
(150071418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
ECommerce Pay Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 182.324.
Diese Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Han-
delsregister zu aktualiseren.
- Die Denomination und Handelsregisternummer der Teilhaberin der Gesellschaft, Rocket Internet AG, lautet mit so-
fortiger Wirkung wie folgt:
Rocket Internet SE, eine Societas Europaea, eingeschrieben beim Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
unter der Nummer HRB 165662 B.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. April 2015.
ECommerce Pay Holding S.à r.l.
Référence de publication: 2015061891/17.
(150071479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Enerdeal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 60, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 149.547.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 2 avril 2015, tenue au siège de la sociétéi>
Les mandats des Administrateurs, à savoir Monsieur François NEU, né le 28/06/1968 à Arlon (Belgique), résidant au
2 rue Floréal, B-6700 Arlon (Belgique), VERBOVEN CONSULTING BVBA, société de droit belge ayant son siège au
190 Krijgslaan, B-9000 GENT, immatriculée à la Banque Carrefours des Entreprises sous le numéro 0822 630 769 et
SMART FUTURE SPRL, société de droit belge ayant son siège au 84A Grand-Route, B-1775 Ways, immatriculée à la
Banque Carrefours des Entreprises sous le numéro 0832 689 075, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en
2021. Le mandat du commissaire aux Comptes, à savoir ACCOUNTIS Sàrl, ayant son siège au 63 -65 rue de Merl, L-2146
Luxembourg, immatriculée au RCSL sous le numéro B60219, anciennement Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie S.à.r.l.,
immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B60219, est également reconduit jusqu'à l'Assemblée
qui se tiendra en 2021.
Suite au changement de nom du Commissaire aux comptes, il y aura lieu de modifier la dénomination auprès du registre
du commerce et des sociétés.
73688
L
U X E M B O U R G
Il est rappelé que SMART FUTURE SPRL société de droit belge ayant son siège au 84A Grand-Route, B-1775 Ways,
immatriculée à la Banque Carrefours des Entreprises sous le numéro 0832 689 075 est également reconduit pour son poste
d'administrateur-délégué pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015061893/24.
(150070865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
FFDC Super 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 192.876.
EXTRAIT
L'actionnaire unique, par résolutions écrites datées du 9 mars 2015, a décidé d'accepter la démission de Monsieur Han
Lu en tant que gérant de la Société ainsi que la nomination, avec effet immédiat, de Madame Fan Lixia, demeurant pro-
fessionnellement 37-39, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une période
indéfinie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FFDC Super 1 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015062174/15.
(150071226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
FFDC Super 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 192.901.
EXTRAIT
L'actionnaire unique, par résolutions écrites datées du 9 mars 2015, a décidé d'accepter la démission de Monsieur Han
Lu en tant que gérant de la Société ainsi que la nomination, avec effet immédiat, de Madame Fan Lixia, demeurant pro-
fessionnellement 37-39, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une période
indéfinie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FFDC Super 2 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015062175/14.
(150071225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
German Hospitality Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 194.926.
Die koordinierte Satzung vom 09/04/2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27/04/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notari>
Référence de publication: 2015062195/12.
(150071114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
73689
L
U X E M B O U R G
German Hospitality Pledgeco S.à r.l., Société Anonyme Unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 196.268.
EXTRAIT
Il résulte de la première décision de l'associé unique de la Société en date du 22 avril 2015 que la société BRE/Mana-
gement 7 S.A. a démissionné en tant que Geschäftsführer de la Société avec effet au 22 avril 2015.
L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société BRE/Management 8 S.A., société anonyme de droit
Luxembourgeois, ayant son siège social au 35 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 195.140, en tant que Geschäftsführer de la Société, avec effet au 22 avril
2015 pour une durée indéterminée.
La Société est désormais gérée par la société BRE/Management 8 S.A. en qualité de Geschäftsführer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015062196/20.
(150071250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Greenvest Private Equity Partners I, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 196.345.
<i>Extract of the memorandum of association in the form of a private deed for the Luxembourg limited partnership Greenvesti>
<i>Private Equity Partners Ii>
1. A société en commandite special was formed (hereafter the Company) on the 27
th
of April 2015.
2. The name of the Company is “GREENVEST PRIVATE EQUITY PARTNERS I”.
3. Designation of the General Partner: CAIBUO CAPITAL S. à R.L, a private limited company incorporated under the
laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 57 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg registered
with the Register of Commerce and Companies, under number B179292.
4. The Company's sole object is the investment in a private equity investment Fund, Blackstone Capital Partners VII
L.P., with registered office at 345 Park Avenue, New York, New York 10154.
5. The registered office of the Company is established in Mamer/Capellen at the following address:
89
e
, Parc d'activités - L-8308 Capellen
6. The Company is established as from the 27
th
of April 2015 and for a maximum duration of 10 years.
7. The Company is managed jointly by two managers.
On the 27
th
April 2015, the following parties has been appointed as managers for an indefinite period:
1. Mr Stéphane BALESTON, born in Angoulème (France), on 30 December 1973, residing at 17, Agate Road, London
W6 0AJ (United Kingdom)
2. Mr Marc BECKER, born in Paris (France), on 21 August 1972, residing at 34, Rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris
(France)
Suit la version en langue française du texte qui précède:
<i>Extrait des statuts de la société en commandite Speciale Greenvest Private Equity Partners Ii>
1. Il a été constitué en date du 27 avril 2015 une société en commandite spéciale (ci-après la Société).
2. La dénomination de la Société est “GREENVEST PRIVATE EQUITY PARTNERS I”.
3. Désignation de l'associé commandité: CAIBUO CAPITAL S. à R.L, une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, dont le siège social est situé au 57 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B179292.
4. L'objet de la Société est l'investissement dans un Fonds d'investissement de private equity, Blackstone Capital Partners
VII LP, dont le siège social est situé au 345 Park Avenue, New York, New York 10154.
5. Le siège de la Société est établi à Mamer/Capellen, à l'adresse suivante:
89
e
, Parc d'activités - L-8308 Capellen
73690
L
U X E M B O U R G
6. La Société a été constituée le 27 avril 2015 pour une durée maximum de 10 ans.
7. La Société est gérée conjointement par deux gérants:
En date du 27 avril 2015, sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Stéphane BALESTON, né à Angoulème (France), le 30 décembre 1973, demeurant au 17, Agate Road,
Londres W6 0AJ (Royaume-Uni)
2. Monsieur Marc BECKER, né à Paris (France), le 21 août 1972, demeurant au 34, Rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris
(France)
Référence de publication: 2015062221/43.
(150071677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Green Hope S.A., Société Anonyme Soparfi.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2555 Luxembourg, 14, rue de Strassen.
R.C.S. Luxembourg B 147.943.
Il résulte des résolutions de l'administrateur unique de Green Hope S.A. prises le 30 septembre 2014 que le siège de la
Société est établi au 14 rue de Strassen à 2555 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2015.
Rutsaert Legal
<i>Un mandataire
i>14 rue de Strassen
L-2555 Luxembourg
Référence de publication: 2015062219/16.
(150070856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Gagfah S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 109.526.
EXTRAIT
En date du 13 avril 2015, KPMG Luxembourg, une société coopérative ayant son siège social au 39, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 149133, a été nommée aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle
devant approuver les comptes de 2015.
En date du 17 avril 2015, Dr. Pierre Berna, né le 17 avril 1947 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et résidant
professionnellement au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé en tant que
membre indépendant du conseil d'administration de la Société avec effet au 17 avril 2015 jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de la Société qui se tiendra en 2020.
En date du 17 avril 2015, Monsieur Rolf Buch, né le 2 avril 1965 à Weidenau, Allemagne et résidant professionnellement
au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, a été nommé en tant que membre du conseil d'ad-
ministration de la Société avec effet au 17 avril 2015 jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en
2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2015.
Référence de publication: 2015062190/22.
(150071343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
German Hospitality Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 194.888.
Die koordinierte Satzung vom 09/04/2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
73691
L
U X E M B O U R G
Luxemburg, den 27/04/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notari>
Référence de publication: 2015062198/12.
(150071050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Esselte European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 157.470.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 07 avril 2015i>
1. Monsieur William LUNDREGAN a démissionné de son mandat de gérant de classe A avec effet immédiat.
2. Monsieur Roger AXELSSON a démissionné de son mandat de gérant de classe A avec effet immédiat.
3. Madame Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat de gérante de classe B avec effet immédiat.
4. Monsieur Walter THOMAS, né à Mineral Wells, Etats-Unis d'Amerique, le 15 avril 1966, demeurant professionnel-
lement à Waterside House, Cowley Business Park, Uxbridge, UB8 2HP, Royaume-Uni, a été nommé comme gérant de
classe A pour une durée indéterminée avec effet immédiat.
5. Monsieur David NORTH, né à Bromley, Royaume-Uni, le 14 avril 1958, demeurant professionnellement à Waterside
House, Cowley Business Park, Uxbridge, UB8 2HP, Royaume-Uni, a été nommé comme gérant de classe A pour une durée
indéterminée avec effet immédiat.
6. Madame Ingrid CERNICCHI, administrateur de sociétés, née à Metz, France, le 18 mai 1983, demeurant profes-
sionnellement à 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a été nommée comme gérante de classe B pour une durée
indéterminée avec effet immédiat.
7. Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Andrew O'Shea se situe désormais au L-2453 Luxembourg,
6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 24 avril 2015.
Pour extrait sincère et conforme
Esselte European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015061883/26.
(150070760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Entreprise S-D, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 7, rue Lankelz.
R.C.S. Luxembourg B 124.881.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2015061881/10.
(150071304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
DWS Institutional, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 38.660.
Die Bilanz zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2015061875/11.
(150070846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
73692
L
U X E M B O U R G
DWS Select, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 171.521.
Die Bilanz zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DWS Investment S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2015061876/11.
(150070849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Julius Baer Multiopportunities, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 107.692.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015062291/10.
(150071672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Kopperam S.A., Société Anonyme,
(anc. K.Y.O. S.A.).
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 41.031.
L'an deux mille quinze, le vingt-trois avril
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "K.Y.O. S.A.", établie et ayant son siège
social à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, alors notaire
de résidence à Remich en date du 31 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 552 de 1992, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 41.031.
La séance est ouverte à 15.45 heures, sous la présidence de Monsieur Yves SCHMIT, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony THILLMANY, demeurant professionnellement
à Esch-sur-Alzette.
Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE DEUX
CENT-CINQUANTE (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de
TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (EUR 31.000.-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la dénomination sociale de «K.Y.O. S.A.» en «KOPPERAM S.A.» et modification subséquente du
premier alinéa de l'article 1
er
des statuts.
2.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de «K.Y.O. S.A.» en «KOPPERAM S.A.» et de mo-
difier en conséquence le premier alinéa de l'article 1
er
des statuts lequel aura désormais la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «KOPPERAM S.A.».".
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.
73693
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,
états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: SCHMIT, THILLMANY, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24/04/2015. Relation: EAC/2015/9376. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 27 avril 2015.
Référence de publication: 2015062292/46.
(150071130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Jewel HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 646.466,83.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 173.021.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2015.
Référence de publication: 2015062283/10.
(150071095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
José de Mello International, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 167.420.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 24 avril 2015, a renouvelé les mandats des gérants, pour une durée indéterminée:
- Mr Luis Eduardo BRITO FREIXIAL DE GOES, rua do Quelhas, 30, 1200-781 Lisbonne, Portugal, gérant.
- Mr Pedro Jácome DA COSTA MARQUES HENRIQUES, Rua Dr. Alfredo da Costa, n°13-1A, 1495-130 Algés,
Miraflores, Portugal, gérant.
- Mrs Paula Helena ROSEIRA DIAS AI QUINTAS NUNES, rua Antonio Ferro, 80-D, 2765-517 Estoril, Portugal,
gérant.
L'associé unique, dans ses résolutions du 24 avril 2015, a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015.
Luxembourg, le 24 avril 2015.
<i>Pour JOSE DE MELLO INTERNATIONAL
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2015062284/21.
(150070978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
JAT concept (JET AERONAUTICAL TECHNICS), Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5412 Canach, 2, rue Bellevue.
R.C.S. Luxembourg B 183.893.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
73694
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2015062287/11.
(150070890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
JKC Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 144.551.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 16 avril 2015i>
L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Fabrice Jacob, Alex King Yue Leung et Jean-Luc Neyens, en qualité d'administrateurs, pour le
terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016,
2. de nommer Madame Pascale Auclair avec adresse professionnelle au 173, Boulevard Haussmann à F-75008 Paris-
France en qualité d'administrateur, pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016,
3. de réélire KPMG Luxembourg, Société Coopérative., en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour le terme d'un an,
prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.
Luxembourg, le 24 avril 2015.
<i>Pour JKC FUND
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2015062288/19.
(150071308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
JTC Signes S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 196.344.
La Société a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2015
EXTRAIT
1. Raison sociale. La Société a été formée sous la dénomination de «JTC Signes S.C.S.».
2. Durée de la société. La Société a été formée pour une durée illimitée.
3. Objet social. L'objet de la Société est l'acquisition de participations, à Luxembourg ou à l'étranger, dans toute société
ou entreprise, de quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut, en particulier, acquérir par
l'achat, la souscription, l'échange ou de toute autre manière que ce soit, des actions, obligations, créances, titres et autres
dettes ou instruments financiers de toute nature, et de manière générale, tout type de titres et instruments financiers émis
par des entités publiques ou privées, y compris des véhicules de titrisation.
La Société peut, dans le cadre des activités susmentionnées, louer ou sous-louer des bureaux et acquérir, détenir et vendre
les titres qu'elle détient dans des sociétés et entreprises au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que gérer ces titres.
La Société peut accorder des prêts ainsi que tout autre moyen de financement, ou accorder des garanties et des sûretés
de quelque forme que ce soit, au bénéfice des sociétés et entreprises qui l'ont partie du groupe auquel la Société appartient,
ou à toute autre société ou entreprise filiale.
La Société peut réaliser des emprunts de quelque manière ou forme que ce soit, et émettre des obligations, dettes ou tout
autre instrument de financement, ainsi que des warrants et droits de souscription de parts.
4. Siège social. Le siège social de la Société est établi au 68-70, boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
5. Identification de l'associé commandité. L'associé commandité de la Société est JTC Signes GP S.à r.l. une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 195640, et ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg (l'Associé Commandité).
6. Gérance de la société. L'Associé Commandité a été nommé gérant de la Société.
7. Pouvoir de signature. La Société est valablement engagée par la seule signature de l'Associé Commandité.
73695
L
U X E M B O U R G
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCÈRE
JTC Signes GP S.à r.l.
Représenté par Eric Biren
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015062289/35.
(150071648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Immomod S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8088 Bertrange, 14, Domaine des Ormilles.
R.C.S. Luxembourg B 96.932.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015062271/10.
(150070882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
LM Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 170.004.
In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of April,
before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of LM Holdings S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies (RCS) under number B 170.004 (the Company), incorporated following a deed of
Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on June 14, 2012, published
in the official journal of the Grand Duchy of Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Memorial)
number 1975 of August 8, 2012. The articles of association of the Company have been amended on August 14, 2012 by a
deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Memorial number
2326 of September 19, 2012.
There appeared:
LM Intermediate Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its registered office at 101, Huntington Avenue, USA-MA 02199 Boston,
United States of America, registered with the Division of Corporations of the State of Delaware, under number 5159996
(the Sole Shareholder),
here represented by Mr. Henri DA CRUZ, notary clerk, with professional address in Junglinster, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder(s) of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company,
has requested the undersigned notary to record that:
I. The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid
up.
II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of any convening notice requirement;
2. Creation of classes of shares of the Company, namely the class A shares, the class B shares, the class C shares, the
class D shares, the class E shares, the class F shares, the class G shares, the class H shares, the class I shares, and the class
J shares, all in registered form and having a nominal value of one euro (EUR 1) each, which shall have such rights and
features as stated in the articles of association of the Company, which will be amended and restated pursuant to the item 6
of this agenda;
3. Re-designation of the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal
value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) class A shares in registered form, having a
nominal value of one euro (EUR 1) each;
73696
L
U X E M B O U R G
4. Increase of the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500) up to six hundred and fifteen thousand five hundred and seventy euro (EUR 615,570) by way of issuance of:
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) new class A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class D shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class E shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class F shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class G shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class H shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class I shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each; and
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class J shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
all in registered form, fully subscribed and paid-up;
5. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 4. above including the payment of a share
premium;
6. Full restatement of the articles of association of the Company (without amendment of the corporate object) in order
to, inter alia, reflect the creation and issuance of new class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E
shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares and the share capital increase, as
proposed above;
7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes, with power and
authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
redesignation of shares, the registration of the share capital increase and the newly issued classes of shares, in the register
of shareholders of the Company; and
8. Miscellaneous.
III. The Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice require-
ments, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to create classes of shares of the Company, namely the class A shares, the class B shares, the class
C shares, the class D shares, the class E shares, the class F shares, the class G shares, the class H shares, the class I shares,
and the class J shares, all in registered form and having a nominal value of one euro (EUR 1) each, which shall have such
rights and features as stated in the articles of association of the Company as amended and restated pursuant to the sixth
resolution below.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to re-designate the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form,
having a nominal value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) class A shares in registered
form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500) up to six hundred and fifteen thousand five hundred and seventy euro (EUR 615,570), by way
of issuance of:
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) new class A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class D shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class E shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class F shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class G shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class H shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class I shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each; and
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class J shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
73697
L
U X E M B O U R G
all in registered form.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting accepts and records the following subscriptions for and full payment of the share capital increase above
as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
LM Intermediate Holdings, LLC, prenamed, declares to subscribe to:
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) new class A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class D shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class E shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class F shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class G shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class H shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class I shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each; and
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class J shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
all in registered form, and to fully pay them up by way of a contribution in cash consisting of an amount of six hundred
and three thousand and seventy-six euro and seventy-seven cents (EUR 603,076.77), it being understood that (i) an amount
of six hundred and three thousand and seventy euro (EUR 603,070) shall be allocated to the nominal share capital of the
Company, and (ii) an amount of six euro and seventy-seven cents (EUR 6.77) shall be allocated to the share premium
account of the Company.
The aggregate amount of six hundred and three thousand and seventy-six euro and seventy-seven cents (EUR
603,076.77) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it, by way of a blocking certificate.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to fully restate the articles of association of the Company (without amendment to the corporate
object) in order to, inter alia, reflect the creation and issuance of new class A shares, class B shares, class C shares, class
D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares and the share capital
increase, as proposed above.
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “LM Holdings S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
73698
L
U X E M B O U R G
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at to six hundred and fifteen thousand five hundred and seventy euro (EUR 615,570)
represented by to six hundred and fifteen thousand five hundred and seventy (615,570) shares in registered form, having
a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up, which are divided into:
- seventy-two thousand eight hundred and seven (72,807) class A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class D shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class E shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class F shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class G shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class H shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand three hundred and seven (60,307)class I shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each; and
- sixty thousand three hundred and seven (60,307) class J shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence, save as otherwise provided for in the Articles.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior approval
of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
6.6. The share capital of the Company may be reduced through the repurchase and the cancellation of shares including
by the cancellation of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares issue
in such class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares, such cancellations and repurchases of
shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with class J).
6.7. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the
order provided for here above), such class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class
73699
L
U X E M B O U R G
to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount (as defined under 6.9.)) and the
holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the
cancellation value per share for each share of the relevant class held by them and cancelled.
6.8. The cancellation value per share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of
shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.
6.9. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the single manager or, as the case may be, the
board of managers and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The
Total Cancellation Amount for each of the classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the
relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of
shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount
shall never be higher than such Available Amount.
6.10. Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the cancellation value per share will
become due and payable by the Company.
6.11. For the purpose of article 6, the following definitions shall apply:
Available Amount
means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to
the extent the shareholders would have been entitled to dividend distributions according to
these Articles, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be
by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class
of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and
(ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of
doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
class of shares to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
Articles
Interim Accounts
means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date
means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant class of shares.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1 The Company is managed by a board of managers of one or more class A manager(s) and one or more class B
manager(s) appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term
of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time ad nutum (without any reason) by a resolution of the shareholder(s).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
8.2. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the Board, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's object.
8.3. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the Board or by one class A manager and one class B manager acting jointly.
Art. 9. Procedure.
9.1. The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of
the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the convening notice of the meeting of the Board.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the Board are present or represented at the meeting and
if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be
waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the Board.
9.4. Any manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing another manager as his proxy.
73700
L
U X E M B O U R G
9.5. The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board shall be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that if the
shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes
signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The parti-
cipation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if passed
at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature. Such signatures may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters (i) by the joint signatures of
any class A manager together with any class B manager, and (ii) by the sole or joint signature(s) of any persons to whom
special powers have been delegated in accordance with article 8.3 of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. Each shareholder may participate in any general meeting of the shareholders (the General Meeting) irrespective
of the numbers of shares which he owns. Each share entitles to one (1) vote.
12.2. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the General Meetings.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile (the Written Shareholders' Resolutions).
13.2. The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
13.3. Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
13.4. General Meetings are held at such place and time which in principle, is in Luxembourg specified in the notices.
13.5. If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
13.6. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
13.7. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
13.8. Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 14. Sole shareholder. Where the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 15. Financial Year and approval of annual accounts.
15.1. The financial year begins on the first (1) of April and ends on the thirty-first (31) of March of each year.
15.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Board must prepare the balance sheet and the profit
and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and
73701
L
U X E M B O U R G
liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor
(s) (if any) and shareholders towards the Company.
15.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
15.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders'
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
(iii) The annual General Meeting (if held) shall be held at the registered office or at any other place within the municipality
of the registered office, as specified in the notice, on the date decided by the Board. If that day is not a business day in
Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.
Art. 16. Auditors.
16.1 When so required by law the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
16.2 If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be su-
pervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved
external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General
Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 17. Allocation of Profits.
17.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
17.2. The General Meeting has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to
the payment of a dividend or transfer it to a reserve or carry it forward.
17.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the Board;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased
by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the Board within two (2) months as of the date of the interim
accounts;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and
(v) If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right
to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
17.4. In the event of a dividend distribution and to that extent that there are sufficient distributable funds, such dividend
shall be allocated and paid as follows:
(i) an amount equal to 0.25% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro rata
to their class A shares;
(ii) an amount equal to 0.30% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro rata
to their class B shares;
(iii) an amount equal to 0.35% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro
rata to their class C shares;
(iv) an amount equal to 0.40% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro
rata to their class D shares;
(v) an amount equal to 0.45% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro rata
to their class E shares;
(vi) an amount equal to 0.50% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro
rata to their class F shares;
(vii) an amount equal to 0.55% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro
rata to their class G shares;
(viii) an amount equal to 0.60% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro
rata to their class H shares;
(ix) an amount equal to 0.65% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro
rata to their class I shares;
73702
L
U X E M B O U R G
(x) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse
alphabetical order (i.e. first class J shares, then if no class J shares are in existence, class I shares and in such continuation).
VI. Dissolution - Liquidation
18.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the shareholders which will determine their powers and
remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be vested
with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.
18.2. After payment of all debts and charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions in article 17.4.
VII. General provisions
19. 1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.
19.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
19.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
19.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the changes specified
under the resolutions above, with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to
proceed on behalf of the Company with the registration of the share capital increase and the newly issued classes of shares,
in the register of shareholders of the Company.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of divergences between the English
and the French version, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative(s)/proxyholder(s) of the appearing parties, said representative(s)/
proxyholder(s) signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le septième jour du mois d'avril,
par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de LM Holdings S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ayant un capital social de EUR 12.500 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
(RCS) sous le numéro B 170.004 (la Société), constituée suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 14 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (le Memorial) numéro 1975, le 8 août 2012. Les statuts de la Société ont été modifié le 14 août 2012 suivant un
acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro
2326 le 19 septembre 2012
A COMPARU:
73703
L
U X E M B O U R G
LM Intermediate Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 101, Huntington Avenue, USA-MA 02199 Boston, Etats-Unis d'Améri-
que, enregistrée avec le Division of Corporations of the State of Delaware, sous le numéro 5159996 (l'Associé Unique),
ici représentée par M. Henri DA CRUZ, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cent euro (EUR 12.500), représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Création de classes de parts sociales de la Société, à savoir les parts sociales de classe A, les parts sociales de classe
B, les parts sociales de classe C, les parts sociales de classe D, les parts sociales de classe E, les parts sociales de classe F,
les parts sociales de classe G, les parts sociales de classe H, les parts sociales de classe I, et les parts sociales de classe J,
toutes sous forme nominative et ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, lesquelles auront les mêmes droits
et caractéristiques tel que mentionnés dans les statuts de la Société, lesquels seront modifiés et reformulés en vertu du point
6 de l'ordre du jour;
3. Réallocation des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société, sous forme nominative et ayant une
valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A, sous forme
nominative et ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
4. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500),
pour le porter à un montant de six cent quinze mille cinq cent soixante-dix euros (EUR 615.570) par l'émission de:
- soixante mille trois cent sept (60.307) nouvelles parts sociales de classe
A ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe D ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe E ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe F ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe G ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe H ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe I ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
et
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe J ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
toutes sous forme nominative, entièrement souscrites et libérées.
5. Souscription à, et libération de l'augmentation de capital spécifiée au point 4. ci-dessus;
6. Refonte intégrale subséquente des statuts de la Société (sans modification de l'objet social) afin de refléter, entre autre,
la création et l'émission de nouvelles parts sociales de classe A, de parts sociales de classe B, de parts sociales de classe C,
de parts sociales de classe D, de parts sociales de classe E, de parts sociales de classe F, de parts sociales de classe G, de
parts sociales de classe H, de parts sociales de classe I et de parts sociales de classe J, tel qu'indiqué ci-dessus;
7. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus, et de donner pouvoir
et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder au nom de la Société à l'inscription
de la réallocation des parts sociales, de l'augmentation du capital social et des classes de parts sociales nouvellement émises,
dans le registre des associés de la Société; et
8. Divers.
III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé
Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de créer des classes de parts sociales de la Société, à savoir parts sociales de classe A, les parts
sociales de classe B, les parts sociales de classe C, les parts sociales de classe D, les parts sociales de classe E, les parts
sociales de classe F, les parts sociales de classe G, les parts sociales de classe H, les parts sociales de classe I, et les parts
73704
L
U X E M B O U R G
sociales de classe J, toutes sous forme nominative et ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, lesquelles
auront les mêmes droits et caractéristiques tel que mentionnés dans les Statuts, tels que modifiés et reformulés en vertu de
la sixième résolution ci-après.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de réallouer les douze mille cinq cent (12.500) parts sociales de la Société, sous forme nominative
et ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A,
sous forme nominative et ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500), pour le porter à un montant de six cent quinze mille cinq cent soixante-dix euros (EUR 615.570) par l'émission
de:
- soixante mille trois cent sept (60.307) nouvelles parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de un euro (EUR
1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe D ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe E ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe F ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe G ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe H ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe I ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
et
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe J ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
toutes sous forme nominative, entièrement souscrites et libérées.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée accepte et enregistre la souscription suivante aux actions et la libération intégrale de l'augmentation du
capital social ci-dessus comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
LM Intermediate Holdings, LLC, préqualfié, déclare souscrire à:
- soixante mille trois cent sept (60.307) nouvelles parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de un euro (EUR
1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe D ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe E ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe F ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe G ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe H ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe I ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
et
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe J ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
toutes sous forme nominative, et les libérer entièrement par un apport en espèce consistant en un montant de six cent
trois mille trois soixante-seize euros et soixante-dix-sept cents (EUR 603.076,77), étant entendu (i) qu'un montant de six
cent trois mille soixante-dix euros (EUR 603.070) sera alloué au compte du capital social nominal de la Société, et (ii)
qu'un montant de six euros et soixante-dix-sept cents (EUR 6,77) sera alloué au compte de prime d'émission de la Société.
Le montant total de un montant de six cent trois mille trois soixante-seize euros et soixante-dix-sept cents (EUR
603.076,77) est immédiatement à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément, par un certificat de blocage.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide en conséquent de modifier et de reformuler intégralement les statuts de la Société (sans modification
de l'objet social), afin de refléter, entre autre, la création et l'émission de nouvelles parts sociales de classe A, de parts
sociales de classe B, de parts sociales de classe C, de parts sociales de classe D, de parts sociales de classe E, de parts
73705
L
U X E M B O U R G
sociales de classe F, de parts sociales de classe G, de parts sociales de classe H, de parts sociales de classe I et de parts
sociales de classe J, tel qu'indiqué ci-dessus.
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est «LM Holdings S.à r.l.» (ci-après la Société). La Société est une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'as-
semblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou
bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que
des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évènements
seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit
du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de
ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en
faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée
du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à six cent quinze mille cinq cent soixante-dix euros (EUR 615.570), représenté par six cent
quinze mille cinq cent soixante-dix (615.570) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un euro
(EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, divisées en:
- soixante-douze mille huit cent sept (72.807) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1)
chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe D ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe E ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe F ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
73706
L
U X E M B O U R G
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe G ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe H ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe I ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
et
- soixante mille trois cent sept (60.307) parts sociales de classe J ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes, sauf si les Statuts en disposent autrement.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
6.6 Le capital social de la Société pourra être réduit par le rachat et l'annulation d'actions, en ce compris par l'annulation
d'une, ou de plusieurs classes entières d'actions, par le rachat et l'annulation de toutes les actions qui ont été émises dans
cette ou ces classe(s). Dans le cas d'un rachat et de l'annulation de classes d'actions, ces rachats et annulation d'actions
devront être fait par ordre alphabétique inversé (en débutant par la classe J).
6.7 Dans le cas d'une réduction de capital social par le biais du rachat et de l'annulation d'une classe d'actions (dans
l'ordre indiqué ci-dessus), cette classe d'actions donnera droit à ses détenteurs, au prorata de leur détention dans cette classe,
à un Montant Disponible (dans les limites toutefois du Montant Total Annulé (tel que défini sous le point 6.9.) et les
détenteurs des classes d'actions rachetées et annulées recevront de la Société un montant équivalent à la valeur d'annulation
par action pour chacune des actions des classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été annulées.
6.8 La valeur d'annulation par action sera calculée en divisant le Montant Total Annulé par le nombre d'actions existant
dans la classe d'actions faisant l'objet du rachat et de l'annulation.
6.9 Le Montant Total Annulé sera le montant déterminé par l'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'ad-
ministration et approuvé par l'assemblée générale des associés sur base des comptes intérimaires correspondants. Le
Montant Total Annulé pour chacune des classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible dans la classe
correspondante au moment de son annulation, à moins qu'une décision de l'assemblée générale des associés, prise selon le
formalisme requis pour le changement des Statuts de la Société en décide autrement, sous réserve toutefois que le Montant
Total Annulé n'excède jamais le montant disponible.
6.10 Suite au rachat et à l'annulation des actions d'une classe concernée, la valeur d'annulation par action sera due et
payable par la Société.
6.11 Dans le cadre de l'article cinq, les définitions suivantes s'appliquent:
73707
L
U X E M B O U R G
Montant Disponible
Signifie le montant total des profits nets de la Société (en ce co... les profits reportés) dans
la mesure ou les associés auraient bénéfici... droit à une distribution de dividendes
conformément aux Statuts, augm... de (i) des réserves librement distribuables et (ii) le cas
échéant des mo... de la réduction du capital social et de la partie correspondante de la r...
légale mais diminués par (i) toute perte (en ce compris les pertes repo... et (ii) tout montant
placé en réserve conformément aux dispositions de... et des Statuts, le tout tel que déterminé
sur base des Comptes Intérim... (sans, pour éviter tout doute sur la question, double
comptabilisations sorte que:
AA = (NP+P+CR) - (L+LR)
Ou
AA = Montant Disponible
NP = profits nets (en ce compris les profits nets reportés)
P = toute réserve librement distribuable
CR = le montant de la réduction de capital et de la réserve rela... la classe d'actions à annuler
L = pertes (en ce compris les pertes reportées)
L = pertes (en ce compris les pertes reportées)
LR = toute somme à affecter à des réserves conformément dispositions de la loi ou des
Statuts;
Comptes Intérimaires
Signifie les comptes intérimaires de la Société à la date des co... intérimaires concernés.
Date des Comptes
Intérimaires
Signifie la date ne précédant pas de plus de huit (8) jours la date de rac... d'annulation de la
classe d'actions concernée.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé de un ou plusieurs gérant(s) de classe A et de un ou plusieurs
(1) gérant(s) de classe B qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés,
lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil).
8.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du Conseil, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes
à l'objet social de la Société.
8.3. Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, pour des tâches
spécifiques, par le Conseil ou par un gérant de classe A et un gérant de classe B, agissant conjointement.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le Conseil se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des deux (2) gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du Conseil au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés
brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de la Société
sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.
Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par
écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à la condition
que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérant de classe B, au moins un (1)
gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées
dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du Conseil par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de
communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler.
La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) seront considérées
comme étant valablement adoptées comme si une réunion du Conseil dûment convoquée avait été tenue. Les signatures
73708
L
U X E M B O U R G
des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers (i) par la signature conjointe
d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B, et (ii) par la signature unique ou conjointe de toutes personnes à
qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués conformément à l'article 8.3 de ces Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs - Droits de vote.
12.1. Chaque associé peut participer à toute assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) quel que soit le
nombre de parts qui lui appartient. Chaque part sociale donne droit à un vote.
12.2. Tout associé pourra se faire représenter aux Assemblées Générales en désignant par écrit, soit par lettre, télé-
gramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax (les
Résolutions Ecrites des Associés).
13.2. Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative du Conseil. Le
Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.
13.3. Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
13.4. Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations qui en principe, seront tenues
à Luxembourg.
13.5. Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
13.6. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés
sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée
Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
13.7. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
13.8. Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 14. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 15. Exercice social.
15.1. L'exercice social commence le premier (1) avril et se termine le trente-et-un (31) mars de chaque année.
15.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le Conseil, doit préparer le bilan et les comptes de profits
et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une
annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas),
et associés envers la Société.
15.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
15.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue) soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des
Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle;
73709
L
U X E M B O U R G
(iii) l'Assemblée Générale annuelle (si elle a lieu) se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la
municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, à la date décidé par le Conseil. Si ce jour n'est pas un
jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.
Art. 16. Commissaires / réviseurs d'entreprises.
16.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat.
16.2 Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés Les commissaires sont sujets
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 17. Affectation des bénéfices.
18.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
17.2. L'Assemblée Générale décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle
pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à une réserve ou le reporter.
17.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par Conseil;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à
la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des
comptes intérimaires;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,
le Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
17.4 En cas de distribution de dividende et dans la mesure où il existe suffisamment de fonds distribuables, ce dividende
devra être alloué et payé de la façon suivante:
(i) un montant égal à 0,25% de la valeur nominale de chaque part sociale devra être distribué en parts égales à tous les
associés au prorata de leurs parts sociales de classe A;
(ii) un montant égal à 0,30% de la valeur nominale de chaque part sociale devra être distribué en parts égales à tous les
associés au prorata de leurs parts sociales de classe B;
(iii) un montant égal à 0,35% de la valeur nominale de chaque part sociale devra être distribué en parts égales à tous les
associés au prorata de leurs parts sociales de classe C;
(iv) un montant égal à 0,40% de la valeur nominale de chaque part sociale devra être distribué en parts égales à tous les
associés au prorata de leurs parts sociales de classe D;
(v) un montant égal à 0,45% de la valeur nominale de chaque part sociale devra être distribué en parts égales à tous les
associés au prorata de leurs parts sociales de classe E;
(vi) un montant égal à 0,50% de la valeur nominale de chaque part sociale devra être distribué en parts égales à tous les
associés au prorata de leurs parts sociales de classe F;
(vii) un montant égal à 0,55% de la valeur nominale de chaque part sociale devra être distribué en parts égales à tous
les associés au prorata de leurs parts sociales de classe G;
(viii) un montant égal à 0,60% de la valeur nominale de chaque part sociale devra être distribué en parts égales à tous
les associés au prorata de leurs parts sociales de classe H;
(ix) un montant égal à 0,65% de la valeur nominale de chaque part sociale devra être distribué en parts égales à tous les
associés au prorata de leurs parts sociales de classe I; et
(x) le solde du montant distribuable sera alloué dans son intégralité aux associés de la dernière classe par ordre alpha-
bétique inversé (c'est-à-dire en premier lieu les parts sociales de classe J et si le cas échéant ces dernières sont inexistantes,
les parts sociales de classe I et ainsi de suite).
VI. Dissolution - Liquidation
18.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la
résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation
des actifs et le paiement des dettes de la Société.
73710
L
U X E M B O U R G
18.2. Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et des frais de liquidation, le boni de liquidation sera
distribué aux associés de manière à réaliser sur une base globale un résultat identique au résultat économique découlant
des règles de distribution implémentées pour les distributions de dividendes à l'article 17.4.
VI. Disposition générale
19.1 Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.
19.2 Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions
du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
19.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
19.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements indiqués aux
résolutions ci-dessus, et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour
procéder au nom de la Société à l'inscription de l'augmentation du capital social et des classes de parts sociales nouvellement
émises, dans le registre des associés de la Société.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des parties com-
parantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, rédigé et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent
acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 avril 2015. Relation GAC/2015/3185. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015062346/833.
(150071037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
LV Holding S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 702.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 175.916.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 avril 2015i>
L'Assemblée accepte la démission Madame Astrid Levy, Administrateur de sociétés, résidant professionnellement à
CH-1206 Genève; 28, rue de l'Athénée de son mandat de gérante de la Société avec effet au 2 avril 2015.
Pour extrait
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015062360/13.
(150070813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
73711
L
U X E M B O U R G
M Agency, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 183.763.
L'an deux mille quinze, le dix avril.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «M Agency» ayant son siège social à L-8399 Windhof, 4,
rue d'Arlon, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 183.763,
avec un capital souscrit fixé à trente-et-un mille euros (31.000,-EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 21 janvier 2014,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 717 du 19 mars 2014,
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Claire Marie-Claude RIDREMONT, employée, demeurant à
F-55600 Avioth (France), 5, Chemin de Vaux.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Christophe MAROTTE,
directeur de société, demeurant professionnellement à L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social vers L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey;
2. Dissolution et mise en liquidation volontaire de la société;
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
4. Nomination d'un commissaire-vérificateur;
5. Révocation des administrateurs ainsi que du commissaire aux comptes et décharge pour l'exercice de leur mandat
respectif;
6. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide transférer le siège social L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey et de modifier le premier alinéa
de l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:
« Art. 4. (premier alinéa). Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée désigne comme liquidateur Madame Claire Marie-Claude RIDREMONT, employée, née à Virton (Belgi-
que) le 23 décembre 1979 et demeurant au 5, Chemin de Vaux F-55600 Avioth (France).
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la
loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation
est normalement requise.
73712
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-vérificateur à la liquidation Monsieur Thibaut CHEVRIER, em-
ployé, né à la Louvière (Belgique) le 12 novembre 1978 et demeurant au 36, Lesagestraat B-1820 Steenokkerzeel.
Le commissaire-vérificateur aura la mission de contrôler le rapport du liquidateur avec ses annexes et de faire rapport
à l'assemblée, convoquée entre autres à ces fins
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer l'administrateur unique et le commissaire aux comptes et leur confère, pleine et entière
décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de 1.100,- EUR, sont à la charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Claire Marie-Claude RIDREMONT, Jean-Christophe MAROTTE, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 avril 2015. Relation GAC/2015/3234. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015062361/73.
(150071563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Moneda Top-Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 184.776.
Diese Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Han-
delsregister zu aktualiseren.
- Die Denomination und Handelsregisternummer der Teilhaberin der Gesellschaft, Rocket Internet AG, lautet mit so-
fortiger Wirkung wie folgt:
Rocket Internet SE, eine Societas Europaea, eingeschrieben beim Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
unter der Nummer HRB 165662 B.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. April 2015.
Moneda Top-Holding S.à r.l.
Référence de publication: 2015062376/17.
(150071478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Montrica Global Opportunities Master Fund (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.020.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the eighth of April.
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary public, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Montrica Global Opportunities Master Fund, an exempted company incorporated and governed by the laws of Caymans
Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands and registered with the Monetary Authority under number 11832,
here represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, professionally residing in Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal.,
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the party appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
73713
L
U X E M B O U R G
The appearing party is currently the sole shareholder of of the private limited liability company (société à responsabilitié
limitée) existing in Luxembourg under the name of Montrica Global Opportunities Master Fund (Luxembourg) S.à r.l.,
having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert., L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.020, incorporated by a deed of Me Joseph Elvinger,
then notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on May 22, 2008, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1553 on June 24, 2008.
The share capital of the Company presently amounts two hundred fifty thousand US Dollars (USD 250,000.-) represented
by two hundred fifty thousand (250,000) shares of one US Dollar (USD 1.-).
The appearing party is currently the sole owner of all the shares of the Company.
The appearing party, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated disso-
lution of the Company.
The appearing party, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have been
settled.
The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to its sole shareholder, who is
personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually unknown, in the same way as the
latter was liable; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.
The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of today.
The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the Com-
pany's former registered office.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which will be borne by the Company as a result
of the present shareholder meeting, are estimated at approximately nine hundred fifty Euro (EUR 950.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, they signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le huit avril.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg.
A comparu:
Montrica Global Opportunities Master Fund, une société exemptée constituée et régie selon les lois des Îles Caïmans,
ayant son siège social au PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Caïman, Les Îles Caïmans
BWI, et enregistrée auprès de l'Autorité Monétaire sous le numéro 11832,
dûment représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être soumise aux formalités d'enregistrement avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
La comparante est actuellement la seule associée de Montrica Global Opportunites Master Fund (Luxembourg) S.à r.l.
(la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 139.020, constituée suivant acte
reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1553 du 24 juin 2008.
La Société a actuellement un capital social deux cent cinquante mille US Dollars (USD 250.000) représenté par deux
cent cinquante mille (250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune..
La comparante est actuellement propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la Société.
Par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif connu de la Société est réglé.
L'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous les
engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle, de la même manière que celle-ci y était tenue; partant la
liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
L'associée unique donne décharge pleine et entière aux gérants pour leur mandat jusqu'à ce jour.
73714
L
U X E M B O U R G
Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à l'ancien siège social de la
Société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 avril 2015. Relation GAC/2015/3226. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015062377/87.
(150071264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Mozart HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 178.740.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 24 avril 2015i>
L'actionnaire unique de la Société a pris en date du 24 avril 2015 la résolution de nommer M. Raymond Hilbert, né le
17 février 19471947 à Luxembourg (Luxembourg) demeurant professionnellement à 25 rue Pierre Federspiel, L-1512
Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Partant, la Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de ses deux gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 27 avril 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015062378/16.
(150071656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
IDI Gazeley Mannheim 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Luxembourg Investment Company 48 S.à.r.l.).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 195.070.
In the year two thousand fifteen, on the tenth of April;
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
BSREP Europe Logistics Lux S.à r.l., with registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté and
registered with the Luxembourg trade and companies registry, under number B177803,
here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal;
Such proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
The appearing party, through its mandatory, has declared and requested the officiating notary to act the following:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under
the name of “Luxembourg Investment Company 48 S.à. r.l.”, (hereafter the “Company”) with registered office in L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre du com-
merce et des sociétés) under number B195070, incorporated pursuant to a deed of Maître Francis KESSELER, then notary
residing in Esch-sur-Alzette, of January 12
th
, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
73715
L
U X E M B O U R G
- That the appearing party, represented as said before, as the sole shareholder of the said company, has taken, through
its mandatory, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to transfer the registered office to L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves change the name of the Company to IDI Gazeley Mannheim 1 S.à r.l. and to amend Article
4 of the Articles of the Company as follows:
“ Art. 4. The company will assume the name of “IDI Gazeley Mannheim 1 S.à r.l.” a private limited liability company.”
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder acknowledges the resignation of Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. as manager and
decides to grant it discharge for the execution of its mandate.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint as Managers for an unlimited period:
- Mr Francesco ABBRUZZESE, manager of companies, born on June 7
th
, 1971 in Luxembourg, residing professionally
in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Mr Douwe TERPSTRA, manager of companies, born on October 31
st
, 1958 in Leeuwarden (Netherlands), residing
professionally in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Mr Andrew O'SHEA, manager of companies, born on August 31
th
, 1981 in Dublin (Ireland), residing professionally
in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend the third paragraph of Article 12 of the Articles of the Company as follows:
“ Art. 12. (third paragraph). The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of
plurality of managers, by the joint signature of any two managers.”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the cor-
poration incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred and fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglisnter, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix avril.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
BSREP Europe Logistics Lux S.à r.l., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 177803,
ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une
procuration sous seing privé lui délivrée;
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte
afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter les suivant:
- Que la société à responsabilité limitée «Luxembourg Investment Company 48 S.à. r.l.», (ci-après la «Société»), ayant
son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B195070, constituée suivante acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 janvier 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
73716
L
U X E M B O U R G
- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité d'associé unique de la Société a pris, par son
mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société vers L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de changer la dénomination de la société en IDI Gazeley Mannheim 1 S.à r.l. et de modifier
l'article 4 des statuts comme suit:
« Art. 4. La société prend la dénomination de «IDI Gazeley Mannheim 1 S.à r.l.», société à responsabilité limitée.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique a pris note de la démission du gérant Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. et décide de lui
donner décharge pour l'exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de nommer comme gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Francesco ABBRUZZESE, gérant de sociétés, né le 7 juin 1971 à Luxembourg, demeurant professionnel-
lement à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Douwe TERPSTRA, gérant de sociétés, né le 31 octobre 1958 à Leeuwarden (Pays-Bas), demeurant pro-
fessionnellement à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Andrew O'SHEA, gérant de sociétés, né le 13 août 1958 à Dublin (Irelande), demeurant professionnellement
6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier le troisième alinéa de l'article 12 des statuts comme suit:
« Art. 12. (troisième alinéa). La société est engagée par la signature de son gérant unique et, en cas de pluralité de gérants,
par la signature conjointe de deux gérants.»
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante
euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 20 avril 2015. Relation GAC/2015/3275. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015062336/111.
(150071687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
MP Property Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 196.339.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fourteenth day of the month of April;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
APPEARED:
73717
L
U X E M B O U R G
The public limited company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “FINEX.LU
S.A. SOPARFI”, with registered office in L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, registered with the Trade and
Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 144705,
here represented by: Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne
varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded
with it.
Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association of a
private limited liability company („Gesellschaft mit beschränkter Haftung“) to establish as follows:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There is hereby established a private limited company („Gesellschaft mit beschränkter
Haftung“) under the name “MP Property SARL”, (hereinafter the “Company”), governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles”).
Art. 2. Purpose.
2.1 The object of the Company is the administration of the Company's own assets, the acquisition of participations,
interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests
and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2 The Company may borrow and raise funds in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private
placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds
including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities such as, among others, the providing of loans and
the granting of guarantees or securities in any kind or form, to its subsidiaries or companies in which it has a direct or
indirect interest, even not substantial, or to any company being a direct or indirect corporate unit holder of the Company
or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Affiliated Companies”).
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Affiliated Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create securities over all or over
some of its assets.
2.3 Furthermore, the Company may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
2.5 The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect invest-
ments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting,
dividing, exhausting, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6 The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not restrictive.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of corporate unit
holders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg).
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of corporate unit holders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of asso-
ciation.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
73718
L
U X E M B O U R G
B. Corporate capital - Corporate units
Art. 5. Corporate Capital.
5.1 The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by twelve thousand
five hundred (12,500) corporate units with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each.
5.2 The Company's capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of corporate unit holders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own corporate units.
Art. 6. Corporate units.
6.1 The Company's capital is divided into corporate units, each of them having the same nominal value.
6.2 The corporate units of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several corporate unit holders, with a maximum of forty (40) corporate unit holders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the corporate unit holders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of corporate units - Transfer of corporate units.
7.1 A register of corporate unit holders shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available
for inspection by any corporate unit holder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates
of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant corporate unit holder.
7.2 The Company will recognise only one holder per corporate unit. In case a corporate unit is owned by several persons,
they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to
suspend the exercise of all rights attached to that corporate unit until such representative has been appointed.
7.3 The corporate units are freely transferable among corporate unit holders.
7.4 Inter vivos, the corporate units may only be transferred to new corporate unit holders subject to the approval of such
transfer given by the corporate unit holders at a majority of three quarters of the corporate capital.
7.5 Any transfer of corporate units shall become effective towards the Company and third parties through the notification
of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the corporate units of the deceased corporate unit holder may only be transferred to new
corporate unit holders subject to the approval of such transfer given by the surviving corporate unit holders at a majority
of three quarters of the corporate capital. Such approval is, however, not required in case the corporate units are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased corporate unit holder.
C. Decisions of the corporate unit holders
Art. 8. Collective decisions of the corporate unit holders.
8.1 The general meeting of corporate unit holders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
8.2 Each corporate unit holder may participate in collective decisions irrespective of the number of corporate units which
he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) corporate unit holders, collective decisions
otherwise conferred on the general meeting of corporate unit holders may be validly taken by means of written resolutions.
In such case, each corporate unit holder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded
and shall cast his vote in writing.
8.4 In the case of a sole corporate unit holder, such corporate unit holder shall exercise the powers granted to the general
meeting of corporate unit holders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In
such case, any reference made herein to the “general meeting of corporate unit holders” shall be construed as a reference
to the sole corporate unit holder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting
of corporate unit holders shall be exercised by the sole corporate unit holder.
Art. 9. General meetings of corporate unit holders. In case the Company has more than twenty-five (25) corporate unit
holders, at least one general meeting of corporate unit holders shall be held within six (6) months of the end of each financial
year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening
notice of such meeting. Other meetings of corporate unit holders may be held at such place and time as may be specified
in the respective convening notices of meeting. If all of the corporate unit holders are present or represented at a general
meeting of corporate unit holders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior
notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each corporate unit holder is entitled to as many votes as he holds corporate units.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
corporate unit holders are only validly taken in so far as they are adopted by corporate unit holders holding more than half
73719
L
U X E M B O U R G
of the corporate capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the corporate unit
holders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time
by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast
whichever is the fraction of the corporate capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The corporate unit holders may change the nationality of the Company only by unanimous
consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of corporate unit holders (ii) representing three quarters of the corporate capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of corporate unit holders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of corporate unit holders which shall determine their
remuneration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the corporate unit holders representing more than half of the Company's corporate capital.
14.3 The general meeting of corporate unit holders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being
class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the
relevant corporate unit holders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of corporate unit holders which shall resolve on
the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of corporate unit holders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
73720
L
U X E M B O U R G
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of corporate unit holders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
corporate unit holders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such
minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman, if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of corporate unit holders has appointed
different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by
one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of corporate unit holders has appointed different classes of managers (namely class A ma-
nagers and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature
of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of
such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) corporate unit holders, the operations of the
Company shall be supervised by one or several internal auditors (Rechnungskommissar(e)). The general meeting of cor-
porate unit holders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of corporate unit holders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the corporate unit holders of the Company appoint one or more independent qualified auditors (unabhängige(r)
qualifizierte(r) Wirtschaftsprüfer) in accordance with article 69 of the law of December 19, 2002 regarding the trade and
companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor
(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of corporate unit holders with cause or with
its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the corporate capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a corporate unit holder may also be allocated to the legal reserve
if the contributing corporate unit holder agrees with such allocation.
73721
L
U X E M B O U R G
22.4 In case of a corporate capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the corporate capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of corporate unit holders shall determine
how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the corporate unit holders in proportion to the number of corporate units they hold
in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the corporate
unit holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of corporate unit
holders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise pro-
vided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities
of the Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the corporate unit holders in proportion to the number of corporate units of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and ends on December 31, 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the twelve thousand five hundred (12,500) corporate units have been sub-
scribed by the sole shareholder, the company “FINEX.LU S.A. SOPARFI”, pre-designated and represented as said before,
and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros
(12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by
a bank certificate, who expressly attests thereto.
<i>Verificationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of
the amended law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the
subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:
1) The registered office of the Company is established at 25A, Boulevard Royal in L-2449 Luxembourg.
2) Mr. Robert Stanis³aw KRÓL, companies' director, born in Szczecin (Poland), on January 9, 1961, residing in 71-051
Szczecin, Zabuzanska 38 (Poland) is appointed as manager of the Company for an unlimited term.
3) According to article 19 of the Articles, the Company is validly bound in all circumstances by the sole signature of
the manager.
<i>Costs and expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand and ten Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
73722
L
U X E M B O U R G
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name and residence, the said Proxyholder has signed with Us the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am vierzehnten Tag des Monats April;
Vor dem unterzeichnenden Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Aktiengesellschaft „FINEX.LU S.A.
SOPARFI”, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25A, Boulevard Royal, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 144705,
hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean
Engling, (der „Bevollmächtigte“), auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht, nach
„ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen
bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu gründ-
enden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Gegründet wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung
„MP Property SARL“, (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung (die „Statuten“) unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen
und Anteilsscheinen in jeglicher Form in Luxemburg oder im Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile
und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien,
Anteile und andere Genussscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und ganz
allgemein alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen gleich
welcher Art begeben wurden.
2.2 Die Gesellschaft kann Mittel in jeglicher Form, außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot, aufnehmen und
beschaffen. Sie kann - ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung - Notes, Anleihen und Schuldverschreibungen sowie
Schuldtitel und/oder Aktienwerte emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen
und/oder Emissionen von Schuldtiteln, unter anderem die Gewährung von Darlehen, Garantien oder Sicherheiten in jeg-
licher Art und Weise, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesell-
schafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind
(nachfolgend als die „verbundenen Unternehmen“ bezeichnet). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicher-
heiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu
besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder
in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.
2.3 Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder sons-
tigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.
2.4 Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des
effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen
Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.
2.5 Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten
Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb, Ei-
gentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Erschließung,
Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise
von beweglichem Vermögen oder Immobilien.
2.6 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
73723
L
U X E M B O U R G
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-EUR), eingeteilt in zwölftausendfünfhun-
dert (12.500) Anteile zu je ein Euro (1,-EUR), welche voll eingezahlt sind.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustim-
mung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen
werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
73724
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-
lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit
statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in
einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die
Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schrift-
lichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
73725
L
U X E M B O U R G
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore
ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie
B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B),
werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens
eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii)
durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschrifts-
befugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
73726
L
U X E M B O U R G
E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung ernennt die
Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige qualifizierte Wirtschaftsprüfer ernennen, entfällt die Funktion des
Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von
1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
73727
L
U X E M B O U R G
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile durch
„FINEX.LU S.A. SOPARFI“, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt worden,
so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was
dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich be-
stätigt.
<i>Beglaubigungi>
Der unterzeichnende Notar gibt hiermit an, beglaubigt und ausdrücklich vermerkt zu haben, dass die aufgezählten
Bedingungen des Artikels 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hier erfüllt
worden sind.
<i>Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterini>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienen Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird auf 25A, Boulevard Royal in L-2449 Luxemburg festgelegt.
2) Herr Robert Stanis³aw KRÓL, Gesellschaftsverwalter, geboren in Szczecin (Polen), am 9. Januar 1961, wohnhaft in
71-051 Szczecin, Zabuzanska 38 (Polen), wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer ernannt.
3) In Einklang mit Artikel 19 der Statuten wird die Gesellschaft rechtmäßig durch die alleinige Unterschrift des Ge-
schäftsführers vertreten.
<i>Kosten und Auslageni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendzehn Euro.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben
genannten erschienen Partei, die vorliegenden Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Fassung; gemäß dem Wunsch derselben erschienen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
deutschen Text, ist die English Fassung maßgebend.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, handelnd wie zuvor er-
wähnt, dem Notar mit Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte mit Uns,
dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré a Luxembourg A.C. 2, le 21 avril 2015. 2LAC/2015/8497. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 24 avril 2015.
Référence de publication: 2015062396/599.
(150071466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2015.
HDI-Gerling Assurances SA Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 30.015.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 avril 2015.i>
L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Harald Peter RAUW jusqu'à l'assemblée
générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2015.
Référence de publication: 2015059809/12.
(150068343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
73728
Applux S.à.r.l.
Arvel S.à r.l.
ASR Fonds
Benefuel International Holdings S.à r.l.
BIP Participation Partners, S.à r.l.
Blue Planet Group
BNP Paribas S.B Ré
BO & MIAN Management
C5 Holdings
CGM Lux 3 S.à r.l.
Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l.
Charger Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l.
China Southern Dragon Dynamic Fund
CMI Insurance (Luxembourg) S.A.
Compradore S.A. SPF
DB Platinum Advisors
DB PWM
DB Re
Debt Investments S.à r.l.
Digital Services Holding IV S. à r.l.
Digital Services XLV S.à r.l.
DWS Institutional
DWS Select
ECommerce Pay Holding S.à r.l.
Enerdeal S.A.
Entreprise S-D
ESMOLUX Spf S.A.
Esselte European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
FFDC Super 1 S.à r.l.
FFDC Super 2 S.à r.l.
Finanzpress Holding S.A.
Fléikescht S.à r.l.
Gagfah S.A.
German Hospitality Midco S.à r.l.
German Hospitality Pledgeco S.à r.l.
German Hospitality Topco S.à r.l.
Green Hope S.A.
Greenvest Private Equity Partners I
HDI-Gerling Assurances SA Luxembourg
IDI Gazeley Mannheim 1 S.à r.l.
Immomod S.A.
JAT concept (JET AERONAUTICAL TECHNICS)
Jewel HoldCo S.à r.l.
JKC Fund
José de Mello International
JTC Signes S.C.S.
Julius Baer Multiopportunities
Kopperam S.A.
K.Y.O. S.A.
LM Holdings S.à.r.l.
Luxembourg Investment Company 48 S.à.r.l.
LV Holding S.à r.l
M Agency
Moneda Top-Holding S.à r.l.
Montrica Global Opportunities Master Fund (Luxembourg) S.à r.l.
Mozart HoldCo S.à r.l.
MP Property Sàrl
Skigo S.A.