This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1508
16 juin 2015
SOMMAIRE
Conference S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72347
Corvette S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72347
Crèche l'Ile au Trésor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
72348
Crossen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72348
Crossen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72348
CR PropCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72347
Dandelion Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
72349
Dasos FS Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72338
DCE DC1.3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72349
Defilippi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72350
Deltainvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72351
Delta Lloyd L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72350
Delta Lloyd L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72350
Delta Lloyd Privilege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72350
Deluxe Café Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
72351
Digital Services XLIV (GP) S.à.r.l. . . . . . . . . .
72349
DNCA Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72352
Dofleini S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72352
Dofleini S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72351
Dreadnought Investments Limited S.à r.l. . . .
72352
Dreams Concept Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72353
Dreams Concept Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72353
Duke Investments & Participations S.A. . . . . .
72349
Dya Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72353
Dynamic Investment GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
72363
Dynasty SICAV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72363
Dynasty SICAV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72363
Eagle Europe Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
72364
Edge I Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72373
Elutions Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
72374
Elwalux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72374
Eridan Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72374
Eurofinance Corp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72375
European Credit X S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
72375
European Credit X S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
72380
European Credit Y S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
72380
Euro Properties Investments S.à r.l. . . . . . . . .
72375
Euro Properties Investments S.à r.l. . . . . . . . .
72375
Jefferies LoanCore (Luxembourg) S.à r.l. . . .
72384
Johnson Controls Luxembourg BE S.A. . . . . .
72384
72337
L
U X E M B O U R G
Dasos FS Management, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 196.284.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth of April.
Before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Dasos Capital Oy Ltd, a Finnish limited company incorporated and governed by the laws of Finland with registered
office at Itämerentori 2, 00180, Helsinki, Finland and registered with the Finnish trade register under number 1988078-1,
here represented by Victorien Hémery, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Luxembourg, on 7 April 2015.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of
association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the
name “Dasos FS Management” (the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
CONSTITUTION du 17 avril 2015 Me Delosch No 11.002 commercial companies, as amended (the “Law”), as well as
by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations
of any Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
72338
L
U X E M B O U R G
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be
specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general
meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or
publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
72339
L
U X E M B O U R G
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Convening meetings of the board of managers.
15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
16.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 18. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers, or
72340
L
U X E M B O U R G
(ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 19. Auditor(s).
19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
19.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
19.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
19.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 20. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
21.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
21.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities
of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 24. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on thirty-first of
December two thousand fifteen.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Dasos Capital Oy Ltd, aforementio-
ned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
72341
L
U X E M B O U R G
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR
1,100.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Mr. Olli Haltia, acting as chairman, manager, born on 13 January 1963, in Helsinky, Finland and having his profes-
sional address at Itämerentori 2, 00180, Helsinki, Finland;
(ii) Mr. Sami Veijalainen, manager, born on 10 November 1972, in Jaala, Finland and having his professional address
at Itämerentori 2, 00180, Helsinki, Finland; and
(iii) Mr. Godfrey Abel, manager, born on 2 July 1960, in Brixworth, United Kingdom and having his professional address
at 30 Rue de Crecy, L-1364, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède.
L'an deux mille quinze, le dix-septième jour d'avril
Par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Dasos Capital Oy Ltd, une société constituée et régie par les lois de Finlande, ayant son siège social à Itämerentori 2,
00180, Helsinki, Finlande et enregistrée auprès du registre de commerce finlandais sous le numéro 1988078-1,
dûment représentée par Victorien Hémery, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Luxembourg, le 7 avril 2015, et
Ladite procuration, paraphées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
Le comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée
qu'ils souhaitent constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Dasos FS Management» (ci-
après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties,
et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
72342
L
U X E M B O U R G
2.4 La Société a également la possibilité d'agir en tant qu'associé ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée pour
les dettes et les obligations de n'importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.
2.5 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique
ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous
réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des survivants.
Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants,
descendants ou au conjoint survivant.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
72343
L
U X E M B O U R G
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures
indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés
à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convo-
cation ou publication préalable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement
unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et
la durée de son (leur) mandat.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par
une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
72344
L
U X E M B O U R G
16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres
du conseil de gérance.
16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue
au siège social de la Société.
16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.
16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.
Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par
deux (2) gérants.
17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
Art. 18. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii)
par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 19. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
19.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 20. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
21.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
72345
L
U X E M B O U R G
21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-
néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation. En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation
sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette disso-
lution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs
disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 24. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente-et-un décembre
deux mille quinze.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par Dasos Capital Oy Ltd, susmentionnée,
pour un prix de souscription de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le
montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Résolutions des associési>
Les associés fondateurs, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de
convocation, ont adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg.
2. Le(s) personne(s) suivante(s) est (sont) nommée(s) gérant pour une durée indéterminée:
(i) M. Olli Haltia, en qualité de président, gérant, né le 13 janvier 1963, à Helsinky, Finlande, et dont l'adresse profes-
sionnelle est à Itämerentori 2, 00180, Helsinki, Finlande;
(ii) M. Sami Veijalainen, gérant, né le 10 novembre 1972, à Jaala, Finlande, et dont l'adresse professionnelle est à
Itämerentori 2, 00180, Helsinki, Finlande; et
(iii) M. Godfrey Abel, gérant, né le 2 juillet 1960, à Brixworth, Royaume-Uni, et dont l'adresse professionnelle est au
30 Rue de Crecy, L-1364, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la comparante que le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la comparante et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. HEMERY, DELOSCH.
72346
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 20 avril 2015. Relation: DAC/2015/6349. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 23 avril 2015.
Référence de publication: 2015060420/489.
(150069463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Conference S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 173.805.
EXTRAIT
Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 3 novembre 2014, a nommé en qualité de dépositaire des actions au
porteur de la Société:
- RSM FHG & Associés, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B85099.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
<i>Pour CONFERENCE S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2015060412/15.
(150069506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Corvette S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 178.783.
EXTRAIT
Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 3 novembre 2014, a nommé en qualité de dépositaire des actions au
porteur de la Société:
- RSM FHG & Associés, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B85099.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
<i>Pour CORVETTE S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2015060413/15.
(150069505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
CR PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 130.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 151.419.
EXTRAIT
Il résulte lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 22 avril 2015 la décision suivante:
- Nommer Monsieur Benedikt von Schoeler demeurant professionnellement au 3 Salvatorstrasse 80333 Munich Alle-
magne en tant que administrateur de Advent et gérant de classe A de la Société, avec effet immédiat et pour une durée
illimitée.
- Révoquer Monsieur Arvid von zur Muhlen demeurant professionnellement au 3 Salvatorstrasse 80333 Munich Alle-
magne de son mandat d'Administrateur de Advent et gérant de classe A de la Société avec effet immédiat.
- Reconnaître que le conseil de gérance est dès lors constitué de:
Mme Nadia Dziwinski administratrice de Hg et gérant catégorie B;
Mr Francois Champon administrateur de Hg et gérant de catégorie B;
Mr Benedikt von Schoeler administrateur de Advent et gerant de classe A;
Mr Dirk van de Maat gérant catégorie A;
72347
L
U X E M B O U R G
Mr Philipp Schwalber administrateur de ERISA et gérant catégorie A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015060415/23.
(150069245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Crèche l'Ile au Trésor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2162 Luxembourg, 12, rue Am Haff.
R.C.S. Luxembourg B 163.204.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015060416/10.
(150069482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Crossen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 81.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 155.016.
<i>Décisions de l'actionnaire unique - 15 avril 2015i>
The sole Partner decides to elect as Independent Auditor of the Company:
DELOITTE AUDIT, registered at RCS Luxembourg under the number B-67.895 and with head office at 560 rue de
Neudorf, L - 2220 Luxembourg
The mandate of the Independent Auditor will expire upon the Annual General Meeting which will approve the accounts
for the year ended December 33, 2015.
Version française
L'Associé unique décide de renommer en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société:
DELOITTE AUDIT, inscrit au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B-67.895 ayant son siège social au 560, rue de
Neudorf, L - 2220 Luxembourg
Le mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera
les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2015.
Pour copie conforme
D. GUILLOU / L. JANSEN
Référence de publication: 2015060417/22.
(150069382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Crossen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 81.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 155.016.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
44, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015060418/13.
(150069615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
72348
L
U X E M B O U R G
Dandelion Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 155.290.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015060419/11.
(150069043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Digital Services XLIV (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 194.469.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 21 avril 2015, que Digital Services XLIV S.à r.l.,
a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:
- Digital Services XXXVIII (GP) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B194356, ayant son siège social à l'adresse suivante: 5, Heienhaff, L-1736 Sennigerberg.
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
Digital Services XXXVIII (GP) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2015.
Digital Services XLIV (GP) S.à r.l.
Référence de publication: 2015060424/18.
(150069215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Duke Investments & Participations S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 177.210.
Par la présente, nous vous informons que nous avons dénoncé, avec effet immédiat, le contrat de domiciliation conclu
avec la société sous rubrique, qui avait son siège au 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 avril 2015.
<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
i>Wim Ritz / Gérry Mullen
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2015060425/13.
(150069208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
DCE DC1.3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 4, rue Alexander Graham Bell.
R.C.S. Luxembourg B 183.632.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23/04/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015060431/12.
(150069637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
72349
L
U X E M B O U R G
Defilippi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.822.
Veuillez noter que M. Michael WEISE a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 8 janvier 2015.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DEFILIPPI S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015060432/12.
(150069625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Delta Lloyd L, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 24.964.
Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015060433/11.
(150069411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Delta Lloyd L, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 24.964.
<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2015i>
L'Assemblée Générale nomme:
- Theodoor Jacques MATERS, Président et Administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015.
L'Assemblée Générale renomme:
- DELTA LLOYD BANK S.A., Administrateur;
- Fernand REINERS, Administrateur;
- Nico THILL, Administrateur;
- Cornelis van DIEPEN, Administrateur;
- Rob van MAZIJK, Administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2015.
L'Assemblée nomme aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé pour une période d'un an la société ERNST & YOUNG
avec siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Munsbach, en remplacement de la société PricewaterhouseCoopers
avec siège social au , 2, Rue Gerhard Mercator, L-2182, Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
Référence de publication: 2015060434/25.
(150069774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Delta Lloyd Privilege, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 96.850.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 17 avril 2015i>
En date du 17 avril 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Alex OTTO en qualité d'administrateur avec effet au 15 juillet 2014.
72350
L
U X E M B O U R G
- de ratifier la cooptation en date du 15 juillet 2014 de Monsieur Rob VAN MAZIJK en qualité d'administrateur en
remplacement de Monsieur Alex OTTO, démissionnaire,
- d'accepter la démission de Monsieur Peter KNOEFF en qualité d'administrateur le 29 août 2014,
- d'accepter la démission de Monsieur Emiel ROOZEN en qualité de président et administrateur le 12 décembre 2014.
- de ratifier la cooptation en date du 12 décembre 2014 de Monsieur Jacco MATERS en qualité d'administrateur en
remplacement de Monsieur Emiel ROOZEN, démissionnaire,
- de nommer Monsieur Cornelis VAN DIEPEN, Laag Nieuwkoop, 28 3628 GC KOCKENGEN, en qualité d'adminis-
trateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.
- de renouveler les mandats de Monsieur Rob VAN MAZIJK, de Monsieur Jacco MATERS et de Delta Lloyd Bank
représenté par Monsieur Wim Antoons en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2016.
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, 2 rue Gerhard Mercator L-1014 Luxem-
bourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Delta Lloyd Privilege
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2015060435/27.
(150069664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Deltainvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 169.573.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 mars 2015i>
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 44, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg avec effet immédiat
Pour copie conforme
JALYNE S.A. / -
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015060436/14.
(150069325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Deluxe Café Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 76.742.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
<i>Pour: DELUXE CAFE HOLDINGS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015060437/14.
(150069714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Dofleini S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.821.
Les comptes annuels au 30 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
72351
L
U X E M B O U R G
<i>Pour DOFLEINI S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015060445/11.
(150069640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
DNCA Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 125.012.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenu au siège social de la société lei>
<i>22 avril 2015 à 15 heuresi>
<i>Résolution 4i>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivant pour un terme d'un an devant expirer à la
prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016:
- M. Jean-Charles Meriaux, Président
- M. Luigi Crosti, Administrateur
- M. Grégoire Scheiff, Administrateur
- M. Benoni Dufour, Administrateur
<i>Résolution 5i>
L'Assemblée reconduit le mandat de la société Deloitte Audit en sa qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société
pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.
Référence de publication: 2015060443/19.
(150069612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Dofleini S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.821.
Veuillez noter que M. Michael WEISE a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 8 janvier 2015.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DOFLEINI S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015060444/12.
(150069601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Dreadnought Investments Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 86.179.
<i>Rectificatif de la publication L-140232080 en date du 24 décembre 2014i>
Suite à une erreur sur la publication L-140232080, il est à noter que le contrat de cession de 1.625 parts de la société a
été conclu le 2 septembre 2014 au lieu du 3 septembre 2014 et que le contrat a été souscrit entre la société Lombard
International Assurance S.A. et la société Roman PTC Limited enregistrée au Guernsey Registry sous le numéro 52414 et
dont le siège social est comme suit: 1
st
and 2
nd
Floors, Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St Peter Port, Guernsey,
GY1 1EW au lieu de la société Ditson Holding Limited.
Ainsi Roman PTC Limited est l'associé unique de la société depuis le 2 septembre 2014.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015060446/17.
(150069283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
72352
L
U X E M B O U R G
Dreams Concept Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 141.218.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015060447/10.
(150069141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Dreams Concept Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 141.218.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015060448/10.
(150069142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Dya Investment, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 196.292.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth of April.
Before us, Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Mckiny (Hong Kong) Limited, a limited company incorporated and existing under the laws of Hong Kong Special
Administrative Region, Peoples' Republic of China, registered with the Hong Kong Companies' Registry under number
2199875, having its registered office at 4/F, 5/F &1602, Central Tower, No.28 Queen's Road Central, Hong Kong,
here represented by Christophe Nicolay, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Frankfurt am Main,
Germany, on 8 April 2015.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which they wish to incorporate with the following articles of association:
A . Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
“DYA Investment” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, 2.2 grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations
of any Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
72353
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
72354
L
U X E M B O U R G
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers composed of at least one (1) A manager and one (1) B manager.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's 15.2 sole manager, such vacancy must be filled without
undue delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
72355
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company. The board of managers may
deliberate or act validly 17.5 only if at least one A manager and one B manager are present or represented at a meeting of
the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by an A and a B manager. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or an A and a B
manager.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of an A and a B manager,
or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company 20.4 appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
72356
L
U X E M B O U R G
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium 23.2 or other distributable reserve may be freely distributed to the
shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have all been subscribed by Mckiny (Hong Kong) Limited,
aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR
1,300.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Mr. Yang Zeng, born in Beijing on 19 January 1960, professionally residing at Building 16, Gate 1, Appartment 502,
Guanying Garden West Part, Xicheng District, Beijing, China; as A manager and
(ii) Mr. Olivier Hamou, born in Levallois-Perret, on 19 December 1973, professionally residing at 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg as B manager.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
72357
L
U X E M B O U R G
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausend fünfzehn, am dreizehnten April.
Vor uns, Maître Jean-Paul Meyers, Notar mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Mckiny (Hong Kong) Limited, eine limited company gemäß den Gesetzen von Hong Kong, mit Sitz in 4/F, 5/F &1602,
Central Tower, No.28 Queen's Road Central, Hong Kong, eingetragen im Handelsregister von Hong Kong mit der Nummer
2199875,
hier vertreten durch Christophe Nicolay, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 8. April 2015, ausgestellt
in Frankfurt am Main, Deutschland.
Besagte Vollmacht, welche von den erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurden,
wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
dem Namen “DYA Investment” (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafter/Aktionär für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxembur-
gischen und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500.-), bestehend aus
zwölftausendfünfhundert (12,500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.
72358
L
U X E M B O U R G
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung der
überlebenden Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln der von Ihnen gehaltenen Rechte übertragen werden.
Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehe-
partner/in übertragen werden. oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich ge-
fasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt
sein Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesell-
schafter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesell-
schafterversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten
werden, wie in der Einberufung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden
an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesell-
schafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben,
kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
72359
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat bestehend aus zumindest einem A Geschäftsführer und einem
B Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche
Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Ein-
klang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen
finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum
zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dring-
lichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Geschäftsführer
schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben,
wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen
des Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäfts-
führungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen
Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.
72360
L
U X E M B O U R G
17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest ein A Geschäftsführer
und ein B Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden, hat
im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme.
17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls
vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokoll-
führer oder von einem A Geschäftsführer und einem B Geschäftsführer unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher
Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden
des Geschäftsführungsrates (falls vorhanden), oder von einem A Geschäftsführer und einem B Geschäftsführer unter-
zeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-
schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige
Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift
des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame
Unterschrift von einem A Geschäftsführer und einem B Geschäftsführer, oder durch (ii) die gemeinsame Unterschrift oder
die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat
übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend
das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen in seiner ge-
änderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschlussgewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz
von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.
72361
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer Rücklage
zugeführt werden müssen, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2015
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden alle durch Mckiny (Hong Kong) Limited, vorbe-
nannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) wird vollständig dem Gesellschafts-
kapital zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf ein tausend fünf hundert Euro (EUR 1.500,-) geschätzt.
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Die Gründer, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren und welche auf eine formelle Einberufungsbe-
kanntmachung verzichten, haben folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
(i) Herr Yang Zeng, geboren am 19 Januar 1960 in Beijing, geschäftsansässig in Building 16, Gate 1, Appartment 502,
Guanying Garden West Part, Xicheng District, Beijing, China; als A Geschäftsführer und
(ii) Herr Olivier Hamou, geboren am 19 Dezember 1973 in Levallois-Perret, Frankreich, geschäftsansässig in 19, rue
de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg als B Geschäftsführer.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Parteien, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit
Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: Nicolay, Jean-Paul Meyers.
72362
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 avril 2015. Relation: EAC/2015/8698. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique Halsdorf.
AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Ein-
tragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, den 16. April 2015.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2015060450/535.
(150069797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Dynamic Investment GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 173.425.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
Référence de publication: 2015060451/10.
(150069368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Dynasty SICAV S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 188.656.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le 16 avrili>
<i>2015i>
<i>Résolution 4:i>
L'assemblée prend note de la démission de M. Pierre Bruyant en date du 31 décembre 2014.
L'assemblée décide de ratifier la co-optation de M. Dimitri Boismare, résidant professionnellement au 203 rue de Neu-
dorf, L-2221 Luxembourg, en remplacement de M. Pierre Bruyant au 2 mars 2014.
L'assemblée prend note de la démission de M. Claude Chambre en date du 28 février 2015.
L'assemblée décide de ratifier la co-optation au 02 mars 2015 de M. Lorenzo Raffaghello, résidant professionnellement
au 28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en remplacement de M. Claude Chambre sous réserve de l'acceptation
de la CSSF.
L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs en fonction pour un terme venant à échéance lors de la
prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016, soit:
- M Philippe Halb
- M Dimitri Boismare
- M Lorenzo Raffaghello
<i>Résolution 5:i>
L'assemblée décide de reconduire le mandat de Ernst & Young, Société Anonyme, en sa qualité de réviseur d'entreprises
agréé de la Société pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.
Référence de publication: 2015060452/25.
(150069270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Dynasty SICAV S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 188.656.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
Référence de publication: 2015060453/10.
(150069271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
72363
L
U X E M B O U R G
Eagle Europe Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1880 Luxembourg, 183, rue Pierre Krier.
R.C.S. Luxembourg B 196.270.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth of April.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Bourse Trust Company Limited, a Guernsey limited liability company having its registered address at Havelet House,
South Esplanade, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3JS, whose company number is 34890, acting as trustee for the following
Guernsey Trusts: Gail Irene Legacy, APEX Trust, Sandy Bulloch Trust, Elsie Bulloch Trust, Elspeth Revie Trust, Linda
Lind 2014 Trust, Chelsea Trust,
here represented by Peggy Simon, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on 16 April 2015, given by Bourse Trust Company Limited acting
as trustee for the Trusts.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy-holder of the company appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing company, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration.
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the Company), which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).
The Company is initially composed of one shareholder, subscribers of all the shares. The Company may however at any
time be composed of additional shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer
of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Object. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies
or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire,
by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of
any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect
itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real
estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name of Eagle Europe Capital S.à r.l..
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
72364
L
U X E M B O U R G
Chapter II. Capital, Shares.
Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at eleven thousand and ten British pounds (GBP 11,010.-) represented
by eleven thousand and ten (11,010) shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be increased, or decreased, in one or several times at any
time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting voting with the quorum and majority
rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.
Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at
the general meetings of shareholders. Ownership of one or several shares carries implicit acceptance of the Articles of the
Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible towards the Company.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares
may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares may
be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing at least
three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
accordance with article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the
death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Chapter III. Manager(s)
Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several managers. If several managers
have been appointed, they will constitute a board of managers.
The managers do not need to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without legitimate
cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders holding a majority of votes.
Each manager will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their number
and the duration of their mandate.
Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the manager or the board of managers will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's object and provide that the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager or the board of managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager. In case of plurality of
managers, the Company shall be bound by the sole signature of any one manager for any transaction up to a threshold of
twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) and by the joint signatures of all the managers for any transaction whose amount is
above such threshold.
If the manager or the board of managers is temporarily unable to act, the Company's affairs may be managed by the sole
shareholder or, in case the Company has several shareholders, by the shareholders acting under their joint signatures.
The manager or board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more
proxy-holders, selected from its members or not, either shareholders or not.
Art. 12. Day-to-day Management. The manager or the board of managers may delegate the day-to-day management of
the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager's / agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers.
Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The meetings of the board of managers are held within the Grand Duchy
of Luxembourg.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place
will be taken by election among the/those managers present at the meeting.
72365
L
U X E M B O U R G
The board of managers may elect a secretary from among its members.
A manager may be represented by another member of the board of managers.
The meetings of the board of managers may be convened by any two managers by any means of communication including
telephone or email, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting.
The board of managers can only validly debate and make decisions if all its members are present or represented by
proxies. Any decisions made by the board of managers shall be unanimously adopted.
In case of a conflict of interest as defined in article 15 hereafter, the quorum requirement shall apply and for this purpose
the conflicting status of the affected manager(s) is disregarded.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of commu-
nication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
and deliberate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a
decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all
members having participated.
A written decision, signed by all managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board
of managers, which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all members of the board of managers.
Art. 14. Liability - Indemnification. The manager or the board of managers assumes, by reason of its position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.
The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages
or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company
is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which
he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or willful mis-
conduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by
the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such manager or
officer may be entitled.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any
transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the board of managers such personal
interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest
therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of Shareholders.
Chapter IV. Shareholder(s)
Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the
powers granted by Law to the general meeting of shareholders.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be
taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to the
shareholders by any means of communication. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a
delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the
Company.
Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in
compliance with Law by the board of managers, failing which by the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will
specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by any means of communication as
his proxy another person who need not be a shareholder.
72366
L
U X E M B O U R G
Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of
managers, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted shareholders' meeting of the Company re-
presents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the manager or the board of managers by the Law or the Articles and subject
to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject
by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of the
Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.
The general meeting shall adopt resolutions by a simple majority of votes cast, provided that the number of shares
represented at the meeting represents at least one half of the share capital. Blank and mutilated ballots shall not be counted.
One vote is attached to each share.
Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits.
Art. 19. Financial Year. The Company's accounting year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 20. Adoption of Financial Statements. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the
general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Appropriation of Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs,
amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund
is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward
or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Interim Dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the statutory reserve.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one
or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remune-
ration.
Chapter VII. Applicable Law.
Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December
2015.
<i>Subscription / Paymenti>
Bourse Trust Company Limited, pre-named, acting as trustee for the benefit of the trusts listed below through its proxy-
holder, declared to subscribe the issued shares for the benefit of the trusts and in the following way:
- the Gail Irene Legacy to seven hundred thirty four (734) shares;
- the APEX Trust to seven hundred thirty four (734) shares;
- the Sandy Bulloch Trust to one thousand four hundred sixty eight (1,468) shares;
- the Elsie Bulloch Trust to one thousand four hundred sixty eight (1,468) shares;
72367
L
U X E M B O U R G
- the Elspeth Revie Trust to two thousand two hundred and two (2,202) shares;
- the Linda Lind 2014 Trust to two thousand two hundred and two (2,202) shares;
- the Chelsea Trust to two thousand two hundred and two (2,202) shares.
Bourse Trust Company Limited declared to subscribe to all the eleven thousand and ten (11,010) shares for the benefit
of the Trusts and have them fully paid up in the amount of eleven thousand and ten British pounds (GBP 11,010.-) by
contribution in kind consisting of the assignment of a certain, unquestionable and undisputed Receivable in the total amount
of eleven thousand and ten British pounds (GBP 11,010.-), dated 16 April 2015. The copy of above- mentioned document
will remain annexed to the present deed.
<i>Effective implementation of the contributioni>
Bourse Trust Company Limited, prenamed, through its proxy-holder, declared that:
- it is the sole unrestricted owner of the Receivable and possesses the power to dispose of it, it is being legally and
conventionally freely transferable;
- the transfer of the Receivable is effective today without qualification; and
- all further formalities are in course in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective
anywhere and toward any third party.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand one hundred Euro (EUR 1.100.-).
<i>Resolutions of the shareholderi>
The shareholder resolves to:
1. Determine the number of managers at one (1).
2. Appoint the following person as Company manager:
- Mr. Jean-Philippe Bill, chartered accountant, born on April 22, 1979 in Luxembourg, residing professionally at L-1880
Luxembourg, 183, rue Pierre Krier.
The duration of the manager’s mandate is unlimited.
3. Determine the address of the Company at 183, rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the Company appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le seize avril.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Bourse Trust Company Limited, une société à responsabilité limitée de droit Guernsey, ayant son siège au Havelet
House, South Esplanade, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3JS, inscrite sous le numéro d’entreprise 34890, agissant en tant
que fiduciaire («trustee») pour les Trusts suivants: Gail Irene Legacy, APEX Trust, Sandy Bulloch Trust, Elsie Bulloch
Trust, Elspeth Revie Trust, Linda Lind 2014 Trust, Chelsea Trust,
représentée par Peggy Simon, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 16 avril 2015 par Bourse Trust Company Limited,
agissant en tant que fiduciaire des Trusts.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
72368
L
U X E M B O U R G
La Société comporte initialement un actionnaire, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à
toute époque, comporter des associés supplémentaires, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de
cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés
ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société peut emprunter sous
quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à
l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut
prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société
mère et société soeur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l’autorisation requise.
La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements
et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «Eagle Europe Capital S.à r.l.».
Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre II. Capital, Parts Sociales.
Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à onze mille et dix livres sterling (GBP 11,010) représenté par onze
mille et dix (11,010) parts sociales d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et
dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une ou de plusieurs parts sociales
emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent
être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital
social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont
opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à
l'article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
72369
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un Associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la sus-
pension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Chapitre III. Gérant(s).
Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés,
ils constitueront un conseil de gérance.
Les gérants ne doivent pas être obligatoirement associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justi-
fication légitime, par décision de l'associé unique ou des associés représentant une majorité des voix.
Chaque gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée
de leur mandat.
Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir
pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération confor-
mément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la
compétence du gérant ou du conseil de gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique. En cas de pluralité de gérants,
la Société est valablement engagée par la signature d'un seul gérant pour toute transaction jusqu'à un montant de vingt mille
Euros (20.000,-EUR) et par la signature conjointe de tous les gérants pour toute transaction dont le montant est supérieur
à ce seuil.
Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par
l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.
Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires,
sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.
Art. 12. Gestion Journalière. Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un
ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/man-
dataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la
gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de
financement et refinancement doit être préalablement approuvé par le gérant ou le conseil de gérance.
Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera
élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Un gérant peut en représenter un autre au conseil.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n'importe quel moyen de communication
incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de la
réunion.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si tous ses membres sont présents ou
représentés par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être prise à l'unanimité.
En cas de conflit d'intérêts tel que défini à l'article 15 ci-après, les exigences de quorum s'appliqueront et, à cet effet, il
ne sera pas tenu compte de l'existence d'un tel conflit dans le chef du ou des gérants concernés pour la détermination du
quorum.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout
autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et
délibérant au conseil puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être
documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les
participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise
à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.
Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même
contenu, signé(s) par tous les participants.
Art. 14. Responsabilité, Indemnisation. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages
ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui/elle,
en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être partie en
72370
L
U X E M B O U R G
raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société, de toute
autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela
concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action, procès ou pro-
cédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse d'une
transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société a été
avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-
dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel gérant ou mandataire pourrait
prétendre.
Art. 15. Conflit d'Intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté
ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en
seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé de
pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé
d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas,
pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou
d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de
la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre part
aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du gérant ou
du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la
prochaine assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Associé(s)
Art. 16. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs
qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout
moyen de communication. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux
conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s'il existe,
ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi
qu'une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'as-
semblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un mandataire,
lequel n'est pas obligatoirement associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.
Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente
l'ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément à
l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de
la Société.
Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise
par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts
sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
L'assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts
sociales représentées à l'assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin
secret ne devront pas être pris en compte.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chapitre V. Année Sociale, Répartition
Art. 19. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 20. Approbation des Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont
établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
72371
L
U X E M B O U R G
Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas,
des associés.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 21. Affectation des Résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges
et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider
qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou
transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Dividendes Intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du
respect des conditions suivantes:
- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un
bénéfice,
- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Chapitre VII. Loi Applicable
Art. 24. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.
<i>Souscription / Libérationi>
Bourse Trust Company Limited, pré-qualifiée, agissant en tant que fiduciaire pour le compte des Trusts ci-dessous,
représentée en vertu d’une procuration donnée à Peggy Simon, a déclaré souscrire aux parts sociales émises pour le compte
des Trusts dans les proportions indiquées:
- the Gail Irene Legacy pour sept cent trente-quatre (734) parts sociales;
- the APEX Trust pour sept cent trente-quatre (734) parts sociales;
- the Sandy Bulloch Trust pour mille quatre cent soixante-huit (1,468) parts sociales;
- the Elsie Bulloch Trust pour mille quatre cent soixante-huit (1,468) parts sociales;
- the Elspeth Revie Trust pour deux mille deux cent et deux (2,202) parts sociales;
- the Linda Lind 2014 Trust pour deux mille deux cent et deux (2,202) parts sociales;
- the Chelsea Trust pour deux mille deux cent et deux (2,202) parts sociales;
Bourse Trust Company Limited, susmentionnée, par son mandataire, a déclaré souscrire à l’entièreté du capital social
de la Société pour le compte des Trusts, soit onze mille et dix (11,010) parts sociales et les libérer intégralement pour le
montant de onze mille et dix livres sterling (11,010,- GBP) par apport en nature consistant en la cession d'une Créance
certaine, liquide et exigible, d'un montant total de onze mille et dix livres sterling (11,010,- GBP), datée du 16 avril 2015.
La copie de ladite déclaration demeurera annexée au présent acte.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Bourse Trust Company Limited, prénommée, par son mandataire, a déclaré que:
- elle est la seule propriétaire de la Créance et possède les pouvoirs d'en disposer;
- le transfert de la Créance est effectivement réalisé sans réserve aujourd'hui; et
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation, aux fins d'effectuer la cession de la Créance et de la rendre effective
partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
72372
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent Euros (EUR 1.100.-).
<i>Décisions de l'associéi>
L'associé décide de:
1. Déterminer le nombre de gérant à un (1).
2. Nommer la personne suivante en tant que gérant de la Société:
- Monsieur Jean-Philippe Bill, expert-comptable, né le 22 avril 1979 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-1880 Luxembourg, 183, rue Pierre Krier
La durée du mandat du gérant est illimitée.
3. Déterminer l'adresse du siège social de la Société à 183, rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 21 avril 2015. Relation: GAC/2015/3368. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 22 avril 2015.
Référence de publication: 2015060454/512.
(150069044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Edge I Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.126.928,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 181.415.
EXTRAIT
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 20 avril 2015, les actionnaires ont décidé de:
- Nommer comme réviseur d'entreprises, Deloitte Audit, avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social
se clôturant au 31 mars 2015 et qui se tiendra en 2015;
- Révoquer Monsieur Martin Block de son mandat de gérant de classe A de la Société avec effet immédiat.
- Reconnaître que le conseil de gérance est des lors constitué de:
Mme Nadia Dziwinski
Mr Francois Champon
Mr Justin Von Simson
Mr Kai Romberg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015060456/21.
(150069702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
72373
L
U X E M B O U R G
Elutions Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 186.101.
Statuts coordonnés, suite à de l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 17 décembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 10 mars 2015.
Référence de publication: 2015060457/11.
(150069561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Elwalux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 131.850.
Il résulte de la assemblée générale des actionnaires du 19 décembre 2014 que:
- Monsieur Jerry Wagner, né le 08/05/1985 à Ettelbrück (Luxembourg) et demeurant professionnellement à L-2557
Luxembourg, 9, rue Robert Stümper est nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Luc Tapella, démis-
sionnaire.
- La société G.T. Fiduciaires S.A., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et inscrite au RCSL
sous le numéro B121820 est nommée nouveau commissaire aux comptes de la société en remplacement de G.T. Experts
Comptables S.à.r.l., démissionnaire.
- Les mandats du nouvel administrateur ainsi que du nouveau commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
G.T. Experts Comptables S.à.r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2015060458/20.
(150069842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Eridan Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 42.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 163.851.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 23 avril 2015 que:
- M. Alexander SINIGIBSKIY a été révoqué de son poste de gérant de type A de la Société avec effet immédiat;
- La personne suivante a été nommée gérant de classe A de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indé-
terminée:
* M. Sergey GLUKHENKIY, né le 14 septembre 1963 à Vladivostok, URSS, résidant professionnellement au 22,
Leninskiy prospect, 119071 Moscou, Russie.
La Société prend acte du changement d'adresse de Monsieur Magsud AHMADKHANOV, gérant de classe B de la
Société, au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
Référence de publication: 2015060459/19.
(150069929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
72374
L
U X E M B O U R G
Euro Properties Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 87.630.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2015i>
Transfert de siège social
L'associé unique décide de transférer le siège social de EURO PROPERTIES INVESTMENTS S.à RL du L-1118
Luxembourg, 19, rue Aldringen au L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015060460/13.
(150069404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Euro Properties Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 87.630.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015060461/9.
(150069520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Eurofinance Corp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 175.257.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 30 décembre 2014i>
Il a été décidé:
De transférer le siège social du 29, Rue du Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg au 278, route d'Esch L-1471 Luxembourg,
à compter du 1
er
janvier 2015.
Ces décisions n'emportent pas de modification statutaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015060462/16.
(150069581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
European Credit X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 163.733.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of February,
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Wells Fargo International Banking Corporation, a company governed by the laws of the United States of America,
having its principal office at 301 South College Street, Charlotte, North Carolina 28288, United States of America (the
“Shareholder”),
hereby represented by Maître Claire Prospert, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 10 February 2015.
The said proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the
purpose of registration.
72375
L
U X E M B O U R G
The Shareholder requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of European
Credit X S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, allée
Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), having been incorporated following a deed
of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 September 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2821 of 18 November 2011, and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163733.
The articles of the Company have not been amended since its incorporation.
The Shareholder, represented as above mentioned, declares having recognised to be fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda.
<i>Agendai>
1 To modify the election wording in relation to the members of the board of managers and to amend paragraph 2 of
Article 9 of the Articles of Incorporation of the Company accordingly.
2 To remove the jurisdictional limitations in relation to the members of the board of managers and to amend paragraphs
2, 10 and 11 of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company accordingly.
3 To clarify the reference made to the board of managers and to amend paragraph 4 of Article 10 of the Articles of
Incorporation of the Company accordingly.
4 To modify the quorum requirements for the deliberations of the board of managers and to amend paragraph 7 of Article
10 of the Articles of Incorporation of the Company accordingly.
5 To acknowledge the resignation of Mr Patrick Zurstrassen and Mr Yves Wagner acting as managers of the Company
with effect as of 20 February 2015 at 11.59 p.m. Luxembourg time.
6 To appoint Mr Jürgen Meisch, Mr Richard Goddard and Mr Michael Hogan as new managers of the Company with
effect as of 21 February 2015.
7 Miscellaneous.
The Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to modify the election wording in relation to the members of the board of managers of the
company with immediate effect and to amend paragraph 2 of Article 9 of the Articles of Incorporation of the Company so
that it shall read as follows:
“The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting (if any), which will determine
their number, whether they shall be appointed for a limited or an unlimited period and, if applicable, the duration of their
mandate, and they will hold office until their successors are elected. They are eligible for re-election, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by the shareholders’ meeting (if
any).”
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to remove the jurisdictional limitations in relation to the members of the board of managers
of the Company with immediate effect and to amend paragraphs 2, 10 and 11 of Article 10 of the Articles of Incorporation
of the Company accordingly.
Paragraph 2 of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company shall from now on read as follows:
“Subject to the provisions of these Articles, the Board of Managers may regulate its proceedings as it thinks fit.”
Paragraph 10 of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company shall from now on read as follows:
“A person entitled to be present at a meeting of the Board of Managers or of a committee of the Board of Managers
shall be deemed to be present for all purposes if he is able (directly or by electronic means) to speak to and be heard by all
those present or deemed to be present simultaneously. A Manager so deemed to be present shall be entitled to vote and be
counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed to take place where it is convened to be held or (if no
Manager is present in that place) where the largest group of those participating is assembled, or, if there is no such group,
where the chairman of the meeting is.”
Paragraph 11 of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company shall from now on read as follows:
“A resolution in writing executed by all the Managers shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting
of the Board of Managers or (as the case may be) a committee of the Board of Managers duly convened and held. For this
purpose:
(a) a resolution may be in hard copy form or in electronic form sent to the registered office; and
(b) a resolution may consist of several documents in hard copy form or electronic form, each executed by one or more
Managers, or a combination of both.”
72376
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to clarify the reference made to the board of managers and to amend paragraph 4 of Article
10 of the Articles of Incorporation of the Company so that it shall read as follows:
“The chairman shall preside at all general meetings of shareholders (if any) and all meetings of the Board of Managers,
but in his absence the general meeting of shareholders or the Board of Managers will appoint another person as chairman
pro tempore of such general meeting of shareholders or meeting of the Board of Managers by a majority vote of those
present at the general meeting of shareholders or the meeting of the Board of Managers.”
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to modify the quorum requirements for the deliberations of the board of managers of the
Company with immediate effect and to amend paragraph 7 of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company
so that it shall read as follows:
“The quorum for the transaction of the business of the Board of Managers may be fixed by the Board of Managers, but
shall not be less than two (2) Managers.”
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder resolved to acknowledge the resignation of Mr Patrick Zurstrassen and Mr Yves Wagner acting as
managers of the Company with effect as of 20 February 2015 at 11.59 p.m. Luxembourg time and resolved to grant all of
them full discharge for the performance of their duties as far as legally possible.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholder resolved to appoint the following persons as new managers of the Company with effect as of 21 February
2015 for a period ending at the annual general meeting of the shareholders approving the Company’s annual accounts as
of 31 December 2015:
(i) Mr Jürgen Meisch, manager, born on 3 April, 1961, in Reutlingen, Germany, with professional address at Achalm
Capital, Marienburger Str. 24, D-50968 Köln, Germany;
(ii) Mr Richard Goddard, manager, born on 5 December, 1959 in Fareham, United Kingdom, with professional address
at The Directors Office, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
(iii) Mr Michael Hogan, manager, born on 4 February, 1959 in Saint Paul, Minnesota, United States of America, with
professional address at Wells Fargo Funds Management, LLC, 2001 North Main Street, Suite 600, Walnut Creek, California
94596, United States of America.
As a result, the Company will forthwith be managed as of 21 February 2015 by a board of managers composed of:
- Ms Hélène Botteri;
- Mr John Ward;
- Mr Jürgen Meisch;
- Mr Richard Goddard; and
- Mr Michael Hogan.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated
at one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxyholder of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder and in case
of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by surname, first
name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de février,
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Wells Fargo International Banking Corporation, une société régie par les lois des États-Unis d’Amérique, ayant son
siège principal à 301 South College Street, Charlotte, Caroline du Nord 28288, États-Unis d’Amérique (l’“Associé”),
ici représentée par Maître Claire Prospert, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 février 2015.
72377
L
U X E M B O U R G
Ladite procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, sera annexée au présent acte à des fins d’enregis-
trement.
L’Associé a demandé au notaire instrumentant d’acter que l’Associé est l’associé unique de European Credit X S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (la «Société») constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2821 en date du 18 novembre 2011 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 163733.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis sa constitution.
L’Associé, représenté tel que précédemment mentionné, reconnait être parfaitement au courant des décisions à intervenir
sur base de l’ordre du jour suivant.
<i>Ordre du jouri>
1 Modification des termes de la réélection des membres du conseil de gérance de la Société et modification du paragraphe
2 de l’article 9 des statuts de la Société en conséquence.
2 Suppression des limitations juridictionnelles concernant les membres du conseil de gérance de la Société et modifi-
cation des paragraphes 2, 10 et 11 de l’article 10 des statuts de la Société en conséquence.
3 Clarification de la référence au conseil de gérance de la Société et modification du paragraphe 4 de l’article 10 des
statuts de la Société en conséquence.
4 Modification du quorum nécessaire pour les délibérations des réunions du conseil de gérance et modification du
paragraphe 7 de l’article 10 des statuts de la Société en conséquence.
5 Acceptation de la démission de Monsieur Patrick Zurstrassen et Monsieur Yves Wagner en leur fonction de gérants
de la Société avec effet au 20 février 2015 à 23h59, heure de Luxembourg.
6 Nomination de Monsieur Jürgen Meisch, Monsieur Richard Goddard et Monsieur Michael Hogan en tant que nouveaux
gérants de la Société avec effet au 21 février 2015.
7 Divers.
L’Associé a demandé au notaire instrumentant soussigné d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé a décidé de modifier les termes de réélection des membres du conseil de gérance de la Société et de modifier
le paragraphe 2 de l’article 9 des statuts de la Société comme suit:
«Les Gérants seront nommés par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera
leur nombre, s’ils seront nommés pour une durée limitée ou illimitée, et selon le cas, la durée de leur mandat, et ils resteront
en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont éligibles pour une réélection et ils peuvent être révoqués
à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou l’assemblée générale des associés.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé a décidé de supprimer les limitations juridictionnelles concernant les membres du conseil de gérance de la
Société et de modifier avec effet immédiat les paragraphes 2, 10 et 11 de l’article 10 des statuts de la Société en conséquence.
Le paragraphe 2 de l’article 10 des statuts de la Société est modifié comme suit:
«Sous réserve des dispositions des présents statuts, le Conseil de Gérance peut déterminer les procédures le concernant
qu'il juge appropriées.».
Le paragraphe 10 de l’article 10 des statuts de la Société est modifié comme suit:
«Une personne dont la présence est admise à une réunion du Conseil de Gérance ou d’un comité du Conseil de Gérance
est réputée être présente à toutes fins si elle est capable (directement ou par voie électronique) de parler et d’être entendue
de façon simultanée par toutes personnes présentes ou réputées être présentes. Un Gérant ainsi réputé présent est autorisé
à voter et par conséquent est pris en compte dans le calcul du quorum. Une telle réunion est réputée avoir lieu à l’endroit
spécifié dans la convocation ou (si aucun Gérant n’est présent à un tel lieu) là où le groupe le plus important de participants
est réuni, ou, s'il n'existe pas de groupe, là où le président de la réunion se trouve.»
Le paragraphe 11 de l’article 10 des statuts de la Société est modifié comme suit:
«Une résolution écrite signée par l'ensemble des Gérants est valable et exécutoire de la même façon que si elle avait été
adoptée lors d’une réunion du Conseil de Gérance ou (le cas échéant) d’un comité du Conseil de Gérance dûment convoquée
et tenue. A cette fin:
a) une résolution peut être émise sous forme papier ou sous forme électronique envoyée au siège social; et
b) une résolution peut se composer de plusieurs documents sous forme papier ou sous forme électronique, chaque
document étant signé par un ou plusieurs Gérants, ou une combinaison des deux.»
72378
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé a décidé de clarifier la référence faite au conseil de gérance et de modifier avec effet immédiat le paragraphe
4 de l’article 10 des statuts de la Société comme suit:
«Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés (s’il y en a) et toutes les réunions du Conseil de
Gérance («Board of Managers»), mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil de Gérance
désignera une autre personne, à la majorité des personnes présentes à l’assemblée générale des associés ou au Conseil de
Gérance, comme président pro tempore.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé a décidé de modifier le quorum nécessaire pour les délibérations des réunions du conseil de gérance et de
modifier le paragraphe 7 de l’article 10 des statuts de la Société comme suit:
«Le quorum pour les transactions des affaires du Conseil de Gérance peut être fixé par le Conseil de Gérance, mais ne
peut être inférieur à deux (2) Gérants.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé a décidé d’accepter la démission de Monsieur Patrick Zurstrassen et Monsieur Yves Wagner en tant que
gérants de la Société avec effet au 20 février 2015 à 23h59, heure de Luxembourg et a décidé de leur donner décharge pour
l’exécution de leurs devoirs dans la mesure légalement possible.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société, avec effet au 21
février 2015, pour la période se terminant à l’assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes annuels de
la Société en date du 31 décembre 2015:
(i) Monsieur Jürgen Meisch, gérant, né le 3 avril, 1961, à Reutlingen, Allemagne, avec adresse professionnelle à Achalm
Capital, Marienburger Str. 24, D- 50968 Cologne, Allemagne;
(ii) Monsieur Richard Goddard, gérant, né le 5 décembre, 1959 à Fareham, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle
à The Directors Office, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
(iii) Monsieur Michael Hogan, gérant, né le 4 février, 1959 à Saint Paul, Minnesota, États-Unis d’Amérique, avec adresse
professionnelle à Wells Fargo Funds Management, LLC, 2001 North Main Street, Suite 600, Walnut Creek, Californie
94596, États-Unis d’Amérique.
Il en résulte que la Société sera gérée avec effet au 21 février 2015 par le conseil de gérance composé comme suit:
- Madame Hélène Botteri;
- Monsieur John Ward;
- Monsieur Jürgen Meisch;
- Monsieur Richard Goddard; et
- Monsieur Michael Hogan.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la
comparante ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même
mandataire, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Prospert, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 23 février 2015. GAC/2015/1500. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 21 avril 2015.
Référence de publication: 2015060463/222.
(150069028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
72379
L
U X E M B O U R G
European Credit X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 163.733.
La convention de domiciliation conclue entre l'agent domiciliataire Caceis Bank Luxembourg, société anonyme imma-
triculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B91985 dont le siège social est
situé au 5 Allée Scheffer, 2520 Luxembourg, et European Credit X Sàrl, société à responsabilité limitée, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B163733 dont le siège social est situé au 5 Allée Scheffer, 2520
Luxembourg, a été résiliée avec effet au 31 mars 2015.
Luxembourg, le 21 avril 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CACEIS Bank Luxembourgi>
Référence de publication: 2015060464/15.
(150069603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
European Credit Y S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 163.671.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of February,
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
EVEREN Capital Corporation, a Delaware Corporation, having its principal office at 301 South College Street, Char-
lotte, North Carolina 28288, United States of America (the “Shareholder”),
hereby represented by Maître Claire Prospert, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 10 February 2015.
The said proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the
purpose of registration.
The Shareholder requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of European
Credit Y S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, allée
Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), having been incorporated following a deed
of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 September 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2791 of 16 November 2011, and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163671.
The articles of the Company have not been amended since its incorporation.
The Shareholder, represented as above mentioned, declares having recognised to be fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda.
<i>Agendai>
1 To modify the election wording in relation to the members of the board of managers and to amend paragraph 2 of
Article 9 of the Articles of Incorporation of the Company accordingly.
2 To remove the jurisdictional limitations in relation to the members of the board of managers and to amend paragraphs
2, 10 and 11 of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company accordingly.
3 To clarify the reference made to the board of managers and to amend paragraph 4 of Article 10 of the Articles of
Incorporation of the Company accordingly.
4 To modify the quorum requirements for the deliberations of the board of managers and to amend paragraph 7 of Article
10 of the Articles of Incorporation of the Company accordingly.
5 To acknowledge the resignation of Mr Patrick Zurstrassen and Mr Yves Wagner acting as managers of the Company
with effect as of 20 February 2015 at 11.59 p.m. Luxembourg time.
6 To appoint Mr Jürgen Meisch, Mr Richard Goddard and Mr Michael Hogan as new managers of the Company with
effect as of 21 February 2015.
7 Miscellaneous.
The Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolutions:
72380
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to modify the election wording in relation to the members of the board of managers of the
company with immediate effect and to amend paragraph 2 of Article 9 of the Articles of Incorporation of the Company so
that it shall read as follows:
“The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting (if any), which will determine
their number, whether they shall be appointed for a limited or an unlimited period and, if applicable, the duration of their
mandate, and they will hold office until their successors are elected. They are eligible for re-election, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by the shareholders’ meeting (if
any).”
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to remove the jurisdictional limitations in relation to the members of the board of managers
of the Company with immediate effect and to amend paragraphs 2, 10 and 11 of Article 10 of the Articles of Incorporation
of the Company accordingly.
Paragraph 2 of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company shall from now on read as follows:
“Subject to the provisions of these Articles, the Board of Managers may regulate its proceedings as it thinks fit.” Para-
graph 10 of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company shall from now on read as follows:
“A person entitled to be present at a meeting of the Board of Managers or of a committee of the Board of Managers
shall be deemed to be present for all purposes if he is able (directly or by electronic means) to speak to and be heard by all
those present or deemed to be present simultaneously. A Manager so deemed to be present shall be entitled to vote and be
counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed to take place where it is convened to be held or (if no
Manager is present in that place) where the largest group of those participating is assembled, or, if there is no such group,
where the chairman of the meeting is.”
Paragraph 11 of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company shall from now on read as follows:
“A resolution in writing executed by all the Managers shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting
of the Board of Managers or (as the case may be) a committee of the Board of Managers duly convened and held. For this
purpose:
(a) a resolution may be in hard copy form or in electronic form sent to the registered office; and
(b) a resolution may consist of several documents in hard copy form or electronic form, each executed by one or more
Managers, or a combination of both.”
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to clarify the reference made to the board of managers and to amend paragraph 4 of Article
10 of the Articles of Incorporation of the Company so that it shall read as follows:
“The chairman shall preside at all general meetings of shareholders (if any) and all meetings of the Board of Managers,
but in his absence the general meeting of shareholders or the Board of Managers will appoint another person as chairman
pro tempore of such general meeting of shareholders or meeting of the Board of Managers by a majority vote of those
present at the general meeting of shareholders or the meeting of the Board of Managers.”
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to modify the quorum requirements for the deliberations of the board of managers of the
Company with immediate effect and to amend paragraph 7 of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company
so that it shall read as follows:
“The quorum for the transaction of the business of the Board of Managers may be fixed by the Board of Managers, but
shall not be less than two (2) Managers.”
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder resolved to acknowledge the resignation of Mr Patrick Zurstrassen and Mr Yves Wagner acting as
managers of the Company with effect as of 20 February 2015 at 11.59 p.m. Luxembourg time and resolved to grant all of
them full discharge for the performance of their duties as far as legally possible.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholder resolved to appoint the following persons as new managers of the Company with effect as of 21 February
2015 for a period ending at the annual general meeting of the shareholders approving the Company’s annual accounts as
of 31 December 2015:
(i) Mr Jürgen Meisch, manager, born on 3 April, 1961, in Reutlingen, Germany, with professional address at Achalm
Capital, Marienburger Str. 24, D-50968 Köln, Germany;
(ii) Mr Richard Goddard, manager, born on 5 December, 1959 in Fareham, United Kingdom, with professional address
at The Directors Office, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
72381
L
U X E M B O U R G
(iii) Mr Michael Hogan, manager, born on 4 February, 1959 in Saint Paul, Minnesota, United States of America, with
professional address at Wells Fargo Funds Management, LLC, 2001 North Main Street, Suite 600, Walnut Creek, California
94596, United States of America.
As a result, the Company will forthwith be managed as of 21 February 2015 by a board of managers composed of:
- Ms Hélène Botteri;
- Mr John Ward;
- Mr Jürgen Meisch;
- Mr Richard Goddard; and
- Mr Michael Hogan.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated
at one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxyholder of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder and in case
of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by surname, first
name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de février,
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
EVEREN Capital Corporation, une société du Delaware, ayant son siège principal à 301 South College Street, Charlotte,
Caroline du Nord 28288, États-Unis d’Amérique (l’«Associé»),
ici représentée par Maître Claire Prospert, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 février 2015.
Ladite procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, sera annexée au présent acte à des fins d’enregis-
trement.
L’Associé a demandé au notaire instrumentant d’acter que l’Associé est l’associé unique de European Credit Y S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (la «Société») constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2791 en date du 16 novembre 2011 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 163671.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis sa constitution.
L’Associé, représenté tel que précédemment mentionné, reconnaît être parfaitement au courant des décisions à intervenir
sur base de l’ordre du jour suivant.
<i>Ordre du jouri>
1 Modification des termes de la réélection des membres du conseil de gérance de la Société et modification du paragraphe
2 de l’article 9 des statuts de la Société en conséquence.
2 Suppression des limitations juridictionnelles concernant les membres du conseil de gérance de la Société et modifi-
cation des paragraphes 2, 10 et 11 de l’article 10 des statuts de la Société en conséquence.
3 Clarification de la référence au conseil de gérance de la Société et modification du paragraphe 4 de l’article 10 des
statuts de la Société en conséquence.
4 Modification du quorum nécessaire pour les délibérations des réunions du conseil de gérance et modification du
paragraphe 7 de l’article 10 des statuts de la Société en conséquence.
5 Acceptation de la démission de Monsieur Patrick Zurstrassen et Monsieur Yves Wagner en leur fonction de gérants
de la Société avec effet au 20 février 2015 à 23h59, heure de Luxembourg.
6 Nomination de Monsieur Jürgen Meisch, Monsieur Richard Goddard et Monsieur Michael Hogan en tant que nouveaux
gérants de la Société avec effet au 21 février 2015.
7 Divers.
L’Associé a demandé au notaire instrumentant soussigné d’acter les résolutions suivantes:
72382
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’Associé a décidé de modifier les termes de réélection des membres du conseil de gérance de la Société et de modifier
le paragraphe 2 de l’article 9 des statuts de la Société comme suit:
«Les Gérants seront nommés par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera
leur nombre, s’ils seront nommés pour une durée limitée ou illimitée, et selon le cas, la durée de leur mandat, et ils resteront
en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont éligibles pour une réélection et ils peuvent être révoqués
à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou l’assemblée générale des associés.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé a décidé de supprimer les limitations juridictionnelles concernant les membres du conseil de gérance de la
Société et de modifier avec effet immédiat les paragraphes 2, 10 et 11 de l’article 10 des statuts de la Société en conséquence.
Le paragraphe 2 de l’article 10 des statuts de la Société est modifié comme suit:
«Sous réserve des dispositions des présents statuts, le Conseil de Gérance peut déterminer les procédures le concernant
qu'il juge appropriées.».
Le paragraphe 10 de l’article 10 des statuts de la Société est modifié comme suit:
«Une personne dont la présence est admise à une réunion du Conseil de Gérance ou d’un comité du Conseil de Gérance
est réputée être présente à toutes fins si elle est capable (directement ou par voie électronique) de parler et d’être entendue
de façon simultanée par toutes personnes présentes ou réputées être présentes. Un Gérant ainsi réputé présent est autorisé
à voter et par conséquent est pris en compte dans le calcul du quorum. Une telle réunion est réputée avoir lieu à l’endroit
spécifié dans la convocation ou (si aucun Gérant n’est présent à un tel lieu) là où le groupe le plus important de participants
est réuni, ou, s'il n'existe pas de groupe, là où le président de la réunion se trouve.»
Le paragraphe 11 de l’article 10 des statuts de la Société est modifié comme suit:
«Une résolution écrite signée par l'ensemble des Gérants est valable et exécutoire de la même façon que si elle avait été
adoptée lors d’une réunion du Conseil de Gérance ou (le cas échéant) d’un comité du Conseil de Gérance dûment convoquée
et tenue. A cette fin:
a) une résolution peut être émise sous forme papier ou sous forme électronique envoyée au siège social; et
b) une résolution peut se composer de plusieurs documents sous forme papier ou sous forme électronique, chaque
document étant signé par un ou plusieurs Gérants, ou une combinaison des deux.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé a décidé de clarifier la référence faite au conseil de gérance et de modifier avec effet immédiat le paragraphe
4 de l’article 10 des statuts de la Société comme suit:
«Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés (s’il y en a) et toutes les réunions du Conseil de
Gérance («Board of Managers»), mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil de Gérance
désignera une autre personne, à la majorité des personnes présentes à l’assemblée générale des associés ou au Conseil de
Gérance, comme président pro tempore.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé a décidé de modifier le quorum nécessaire pour les délibérations des réunions du conseil de gérance et de
modifier le paragraphe 7 de l’article 10 des statuts de la Société comme suit:
«Le quorum pour les transactions des affaires du Conseil de Gérance peut être fixé par le Conseil de Gérance, mais ne
peut être inférieur à deux (2) Gérants.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé a décidé d’accepter la démission de Monsieur Patrick Zurstrassen et Monsieur Yves Wagner en tant que
gérants de la Société avec effet au 20 février 2015 à 23h59, heure de Luxembourg et a décidé de leur donner décharge pour
l’exécution de leurs devoirs dans la mesure légalement possible.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société, avec effet au 21
février 2015, pour la période se terminant à l’assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes annuels de
la Société en date du 31 décembre 2015:
(i) Monsieur Jürgen Meisch, gérant, né le 3 avril, 1961, à Reutlingen, Allemagne, avec adresse professionnelle à Achalm
Capital, Marienburger Str. 24, D- 50968 Cologne, Allemagne;
(ii) Monsieur Richard Goddard, gérant, né le 5 décembre, 1959 à Fareham, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle
à The Directors Office, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
(iii) Monsieur Michael Hogan, gérant, né le 4 février, 1959 à Saint Paul, Minnesota, États-Unis d’Amérique, avec adresse
professionnelle à Wells Fargo Funds Management, LLC, 2001 North Main Street, Suite 600, Walnut Creek, Californie
94596, États-Unis d’Amérique.
72383
L
U X E M B O U R G
Il en résulte que la Société sera gérée avec effet au 21 février 2015 par le conseil de gérance composé comme suit:
- Madame Hélène Botteri;
- Monsieur John Ward;
- Monsieur Jürgen Meisch;
- Monsieur Richard Goddard; et
- Monsieur Michael Hogan.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la
comparante ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même
mandataire, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire
par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Prospert, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 23 février 2015. GAC/2015/1501. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 21 avril 2015.
Référence de publication: 2015060465/220.
(150069032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2015.
Jefferies LoanCore (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 190.106.
Statuts coordonnés, suite à de l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 3 février 2015 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 10 mars 2015.
Référence de publication: 2015056391/11.
(150064519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.
Johnson Controls Luxembourg BE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.493.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 14 janvier 2015 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 10 mars 2015.
Référence de publication: 2015056392/11.
(150064240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
72384
Conference S.A.
Corvette S.A.
Crèche l'Ile au Trésor S.à r.l.
Crossen S.à r.l.
Crossen S.à r.l.
CR PropCo S.à r.l.
Dandelion Investment S.à r.l.
Dasos FS Management
DCE DC1.3 S.à r.l.
Defilippi S.à r.l.
Deltainvest S.A.
Delta Lloyd L
Delta Lloyd L
Delta Lloyd Privilege
Deluxe Café Holdings S.A.
Digital Services XLIV (GP) S.à.r.l.
DNCA Invest
Dofleini S.à r.l.
Dofleini S.à r.l.
Dreadnought Investments Limited S.à r.l.
Dreams Concept Sàrl
Dreams Concept Sàrl
Duke Investments & Participations S.A.
Dya Investment
Dynamic Investment GP S.à r.l.
Dynasty SICAV S.A.
Dynasty SICAV S.A.
Eagle Europe Capital S.à r.l.
Edge I Holding S.à r.l.
Elutions Holdings S.à r.l.
Elwalux SA
Eridan Finance S.à r.l.
Eurofinance Corp S.A.
European Credit X S.à r.l.
European Credit X S.à r.l.
European Credit Y S.à r.l.
Euro Properties Investments S.à r.l.
Euro Properties Investments S.à r.l.
Jefferies LoanCore (Luxembourg) S.à r.l.
Johnson Controls Luxembourg BE S.A.