This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1454
10 juin 2015
SOMMAIRE
Cameron Balloons Luxembourg . . . . . . . . . . .
69792
Compagnie Aéronautique du Grand-Duché de
Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69792
Defi3 Alpha Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69775
Deltatrans International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
69775
Deltatrans International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
69775
Deltatrans International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
69775
Desideratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69775
Deutsche Mexico Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
69766
Dialogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69776
Dialogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69776
Diga Consulting SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69773
Direct Marketing Services S.A. . . . . . . . . . . . .
69773
DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A. . . . .
69774
DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A. . . . .
69774
Diy-Tech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69774
DMA Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69776
DSP Hydrolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69776
Dumark Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69777
Dynamic Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69772
ECEF-IHV SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69781
ECL German Logistics Holding No. 1 . . . . . . .
69781
ECommerce Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
69780
E-Connect Online Marketing S.à r.l. . . . . . . . .
69792
Edelweiss Caesar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69788
EDI - Européenne de Développement et d'In-
vestissement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69788
Edmond de Rothschild Fund . . . . . . . . . . . . . .
69788
EIG Fund XV Lux Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
69788
EIG Manabi Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
69789
Entaulux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69789
Essential Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69790
Esso Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69790
Esstex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69789
Eura-Audit Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . .
69790
EUR-ASIA Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69789
European Credit X S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
69777
European Credit Y S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
69777
European Infrastructure Investments 1 . . . . .
69778
European Infrastructure Investments 3 . . . . .
69778
European Motorway Investments 2 . . . . . . . . .
69779
European Motorway Investments 3 . . . . . . . . .
69779
Europe Trade Shows Consulting S.à r.l. . . . . .
69777
Eversholt Investment Group (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69780
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foun-
dation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69746
Kairos Investissements S.à r.l. SPF . . . . . . . . .
69792
Koch Business Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
69791
LEOX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69792
69745
L
U X E M B O U R G
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation, Fondation.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg G 194.
<i>Annual Accounts andi>
<i>Report of the Réviseur d'Entreprises agrééi>
<i>for the year-endi>
<i>December 31, 2014i>
<i>Table of Contentsi>
MANAGEMENT REPORT
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
ANNUAL ACCOUNTS
- Balance Sheet
- Surplus and Loss Account
- Notes to the Annual Accounts
RAPPORT DE GESTION 2014
A. Gouvernance de la Fondation
Le Conseil d'Administration de la Fondation Grameen Crédit Agricole s'est réuni à deux reprises au cours de l'année
2014, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Sander.
La première réunion du Conseil s'est tenue le 24 février 2014 à Paris au siège de la Fédération Nationale du Crédit
Agricole.
Suite à la démission d'Yves Couturier, administrateur de la Fondation depuis sa création, un nouvel administrateur a été
coopté en la personne de Bernard Lepot, ancien Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi
Pyrénées. Bernard Lepot a également été nommé membre du Comité de Projets en remplacement d'Yves Couturier. Par
ailleurs, Pierre Deheunynck, administrateur de la Fondation, a été nommé membre du Comité d'Ethique, de la Conformité
et de l'Audit, que préside Christian Talgorn.
Le Conseil a pris connaissance des décisions du Comité de Projets, présidé par Raphaël Appert, intervenues depuis la
dernière réunion.
Le Conseil a approuvé les comptes et le rapport d'activité de l'exercice 2013 de la Fondation et a validé le budget pour
l'année 2014. Le mandat du Cabinet Deloitte (Luxembourg) comme réviseur d'entreprises agréé a été renouvelé pour l'année
2014.
Le Conseil a entendu le rapport des travaux du Comité d'Ethique, de la Conformité et de l'Audit présenté par Pierre
Deheunynck.
Le Délégué Général a rendu compte de l'état d'avancement du fonds d'investissement Grameen Crédit Agricole dédié
au social business. Il a également présenté le rapport intermédiaire du Groupe de travail du Conseil sur les perspectives
stratégiques et financières à moyen terme de la Fondation, qui a donné lieu à une discussion approfondie.
Enfin, le Conseil a décidé de reporter au mois de mars 2015 le voyage d'étude au Kenya initialement prévu à l'automne
2014.
Par voie de résolutions circulaires, en date du 1
er
juillet 2014, le Conseil d'Administration a approuvé le transfert des
participations détenues par la Fondation dans des entreprises de Social Business vers le Grameen Crédit Agricole Fund, à
hauteur de 4 millions d'Euros, sans attendre l'arrivée d'investisseurs tiers.
Le Conseil d'Administration s'est réuni à nouveau le 27 octobre 2014 à Luxembourg.
Les mandats d'administrateur de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse du Luxembourg, du professeur Muhammad
Yunus, du Professeur Huzzatul Islam Latifee et de Monsieur Raphaël Appert ont été renouvelés jusqu'à la clôture de la
réunion statuant sur les comptes de l'exercice 2017.
Le Conseil a pris connaissance du rapport du Président du Comité de Projets sur les investissements approuvés depuis
la dernière réunion du Conseil. Il a approuvé le principe d'un investissement en capital de la Fondation en Inde dans une
structure locale lui permettant de refinancer en monnaie locale des institutions de microfinance correspondant à ses critères
de sélection.
Le Conseil a également pris connaissance de l'avancement du Fonds Grameen Crédit Agricole et a pris acte du report
de la date de la première levée de fonds.
Un point budgétaire au 30 juin 2014 ainsi qu'une prévision d'atterrissage des comptes au 31 décembre 2014 ont été
présentés.
Le projet de voyage d'étude au Kenya a été validé et sa date fixée du 7 au 12 mars 2015.
69746
L
U X E M B O U R G
La dernière partie de cette réunion a été consacré à la présentation par le Délégué Général du rapport final du Groupe
de travail du Conseil sur les perspectives stratégiques et financières à moyen terme de la Fondation et du projet de plan de
développement stratégique 2014-2018 de la Fondation. Le Groupe de travail, composé de cinq administrateurs et du Dé-
légué Général, s'est réuni à cinq reprises, dont 4 fois en 2014.
Le plan proposé réaffirme la mission sociale de la Fondation: lutter contre la pauvreté et l'exclusion financière en
accompagnant des institutions de microfinance et des entreprises de social business qui, dans les pays les plus pauvres,
placent cette lutte au cœur de leur stratégie, tout en recherchant l'équilibre et la pérennité de leur modèle économique. Sans
modifier le positionnement de la Fondation, ni ses priorités géographiques et sociales, le plan propose d'amplifier son action
dans les quatre domaines où elle a déjà démontré la pertinence de son action: l'accompagnement financier et technique
d'institutions de microfinance, le développement de l'assurance agricole en faveur des petites exploitations familiales, le
développement d'entreprises de social business, une action de recherche et de plaidoyer sur ces différents thèmes. Le
business plan associé à ce plan stratégique prévoit un accroissement de 50 millions d'Euros des ressources mises à la
disposition de la Fondation d'ici 2018, et un excédent annuel de gestion de 1% de sa dotation à partir de 2016.
Le Délégué Général a attiré l'attention du Conseil sur le fait que la dotation actuelle de la Fondation serait totalement
engagée d'ici la fin 2015, au rythme actuel de développement du portefeuille, et sur l'urgence de mobiliser des ressources
supplémentaires. Celles-ci pourront revêtir plusieurs formes: augmentation de la dotation, lignes de crédit à long terme,
investissements dans un nouveau compartiment du Grameen Crédit Agricole Fund, lignes de crédit et de subvention d'ins-
titutions financières internationales.
Après de nombreux échanges, le plan 2014-2018 a été approuvé à l'unanimité.
Le Comité de Projets a été particulièrement actif: il s'est réuni à sept reprises au cours de l'année 2014 et a approuvé 39
financements (contre 30 en 2013 et 31 en 2012) sous forme de prêts, garanties, prises de participation, dettes convertibles,
comptes courant ou avances d'actionnaires.
Le montant cumulé des nouvelles opérations approuvées en 2014 s'est élevé à 27,15 millions d'euros, contre 14,48
millions d'euros en 2013 et 15,8 millions en 2012.
Par ailleurs, deux transferts d'actifs, validés par la résolution circulaire du 1
er
juillet 2014, ont été mis en œuvre à hauteur
de 3,028 millions d'euros.
En cumul, depuis l'origine, le Comité de Projets a approuvé 144 investissements, pour un montant total de 90,93 Millions
d'Euros.
Huit dossiers relevant de la Facilité Africaine de décollage ont été approuvés en 2014, portant à 15 le nombre de
financements approuvés dans le cadre de ce dispositif innovant, pour un montant cumulé de 4,97 millions d'euros. A fin
décembre 2014 la Fondation a 3,37 millions d'euros d'engagements auprès de 11 institutions.
Dix investissements Social Business ont été approuvés en 2014, en faveur de 7 entreprises de Social Business, sous
forme soit de prises de participation, soit de comptes courants d'associés ou de financements senior, pour un montant total
de 1,68 million euros. Au 31/12/2014, la Fondation est présente au capital de 12 entreprises de Social Business directement
ou à travers le Fonds Grameen Crédit Agricole
1
(1 La Fondation à transféré en 2014 huit de ses participations au GCA
Fund dont elle est le seul actionnaire au 31-12-2014).
En tenant compte tenu des nouvelles opérations mises en place en 2014, la Fondation est active dans 23 pays en déve-
loppement dont 5 nouveaux pays ouverts en 2014: Ouganda, Malawi, Géorgie, Inde, Jordanie.
Le Comité de Projets consacre une partie de ses réunions à examiner l'état du portefeuille, ainsi qu'à donner des orien-
tations sur des questions transversales.
Le Comité d'Ethique, de la Conformité et de l'Audit s'est réuni le 24 février 2014 à Paris, sous la présidence de Christian
Talgorn. Il a pris connaissance du rapport du consultant chargé par la Direction des Risques Groupe du contrôle interne de
la Fondation, ainsi que du rapport de Pascal Webanck sur le respect des procédures de conformité. Il a entendu le rapport
du Réviseur d'entreprise sur les comptes 2013 et n'a émis aucune réserve ni objection sur ces comptes et les provisions.
B. Contexte de l'activité de la Fondation en 2014
1. Evolution du paysage de la Microfinance. La Campagne pour le Sommet Mondial du Microcrédit, qui s'est réunie en
septembre 2014 au Mexique, évalue à 204 millions le nombre d'emprunteurs actifs dans le monde au 31-12-2012, à comparer
à 195 millions au 31-12-2011 et 205 millions au 31-12-2010.
[graphique: Figure 1: Growth of Total and Poorest Clients (Decmber 31, 1997 to December 31, 2012)
Source: Resilience, State of the Microcredit Summit Campaign Report 2014]
Le même rapport de la Campagne Mondiale estime à 116 millions le nombre de pauvres
2
(2 Il s'agit des foyers dont
les revenus sont dans les 50% de la population vivant en dessous du niveau de pauvreté de leur pays, ou des familles vivant
avec moins de 1,25 USD par jour par personne, ajusté à la parité pouvoir d'achat.) qui sont emprunteurs actifs en microcrédit,
à comparer à 125 millions fin 2011 et 138 millions fin 2010.
Le développement de la microfinance reste très inégal entre les régions du monde, comme le montrent les données du
Mix Market
3
(3 Le MIX Market n'intègre pas les IMF les moins matures ni les groupes informels, tels que les Self-Help
Groups indiens. C'est ce qui explique en partie la différence de nombre d'emprunteurs entre le MIX Market (94,5 million)
69747
L
U X E M B O U R G
et le Sommet Mondial du Microcrédit (204 million)) au 31-12-2012, fournies par 1.173 IMF
4
(4 Données du MIX Market
au 31-12-2012 hors Afrique du Sud et Chine, dont les chiffres, en termes de nombre d'emprunteurs rapporté à l'encours de
crédit, révèlent une définition différente du microcrédit.), qui servent 94 millions d'emprunteurs dans le monde, avec un
encours de prêts de 76 milliards de dollars.
[graphiques: Number of Active Borrowers - Gross Loan Portfolio]
L'Afrique sub-saharienne, qui ne représente que 8% des emprunteurs et 6% de l'encours, apparaît à tous égards comme
le «parent pauvre». L'Asie du Sud représente 54% des emprunteurs actifs mais seulement 26% de l'encours global de
microcrédit. La Région MENA, avec 2% des emprunteurs et 2% de l'encours apparaît également peu pénétrée par le
microcrédit.
Afrique Sub-Saharienne, MENA et Asie du Sud sont précisément les trois régions retenues comme prioritaires par la
politique d'investissement de la Fondation depuis l'origine.
La microfinance ne se résume pas au microcrédit. Même si les données chiffrées manquent, on assiste à un fort déve-
loppement des services financiers d'épargne, d'assurance et de paiement, soutenu par la diffusion des nouvelles technologies
de communication, en particulier le mobile banking.
2. Evolution du paysage du Social Business. Mettre le modèle de l'entreprise et ses capacités d'innovation au service de
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et non au service de l'enrichissement des actionnaires, telle est l'ambition du Social
Business. Conçue et testée avec succès par le Prof. Yunus, l'approche «Social business» a été popularisée et illustrée par
un nombre croissant de projets. Le Global Social Business Summit, qui s'est tenu à Mexico en novembre et le Social
Business Day en juin à Dacca, réunissent des centaines de participants. Plusieurs grandes entreprises ont attaché leur nom
et leur réputation à des joint-ventures avec Grameen, répondant à la définition du social business du Prof. Yunus: Danone,
Véolia, BASF, McCain, Uniqlo, Intel ... Mais le Social Business n'est pas réservé aux grandes entreprises, il peut s'appliquer
à une grande variété d'entreprises, en termes de taille, de statut juridique ou de secteur. Une entreprise de social business
peut être créée à l'initiative d'une grande entreprise, elle peut l'être aussi à l'initiative d'un entrepreneur local ou d'une ONG.
Cette approche intéresse de plus en plus les grandes agences de coopération (USAID, AFD, DFID) et les institutions
financières multilatérales (Banque Africaine de Développement, Banque Interaméricaine de développement). En 2014 elle
a été officiellement adoptée par l'Agence Française de Développement, qui a décidé de s'équiper d'outils complémentaires
pour accompagner des initiatives de social business, en particulier un fonds de fonds.
L'approche social business rejoint, sans se confondre avec lui, un mouvement plus vaste qui s'est fait jour depuis une
dizaine d'années sous le nom d'impact investing que JP Morgan définit dans un rapport de 2010
5
(5 Voir http://
www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/2b053b2b-8feb-46ea-adbd-l89068d59785-impact.pdf) comme une nouvelle
classe d'actifs consistant en «investments intended to create positive social impact beyond financial return». Le retour
financier espéré peut varier depuis le remboursement du montant nominal du capital investi jusqu'à une rémunération proche
du marché. Le social business se situe bien sûr à l'extrême du spectre ainsi décrit puisqu'il donne une archi-priorité à l'impact
social et limite le retour financier au remboursement du montant nominal investi.
En juin 2013, à l'initiative du Premier Ministre Britannique, une Task Force a été créée dans le cadre du G8 pour faire
des recommandations sur l'impact investing. Cette Task Force, que préside Sir Ronald Cohen, a remis son rapport le 15
septembre 2014
6
(6 Tous les rapports de fa TasK force sont disponibles sur www.socialimpactinvestment.org). Un Comité
français de la Task Force, dont le Délégué Général a été un membre actif, a été également mis en place et a remis à la même
date ses recommandations à la Ministre chargée de l'économie sociale et solidaire.
Le succès grandissant des concepts de social business et d'impact investing leur fait courir le risque d'une définition de
plus en plus vague ou accommodante. Comme en microfinance, le rôle de la Fondation est de jouer un rôle pionnier en
coalisant des investisseurs socialement motivés dans le cadre du Grameen Crédit Agricole Fund, à la croisée des chemins
entre l'impact investing et la philanthropie traditionnelle.
C. Activités de la Fondation en 2014
1. Financements en faveur d'institutions de microfinance. L'année 2014 a été marquée par un très fort développement
du portefeuille microfinance. La Fondation a approuvé des opérations avec 17 nouveaux partenaires (15 en microfinance
et 2 social business) et est devenue active dans 5 nouveaux pays: Ouganda, Malawi, Géorgie, Inde et Jordanie.
Le portefeuille Microfinance de la Fondation a presque doublé, passant de 16,0 millions d'Euros à 31,9 millions d'Euros
d'engagements.
31 financements ont été mis en œuvre pour un montant total de 24 500 852 Euros au bénéfice de 30 institutions, dont
15 nouveaux partenaires.
- 29 financements sous forme de prêts senior, pour un montant de 23 364 141 Euros
- 1 financement sous forme de prêt subordonné, pour un montant de 513 992 Euros
- 1 garantie en faveur de I'IMF Komida en Indonésie à hauteur 622 719 Euros
7
(7 La Fondation a également augmenté
la garantie déjà accordée à l'IMF BMI au Sri Lanka, d'un montant complémentaire de 190 000 Euros - augmentation
considérée comme constituant une seule et même opération avec la première tranche mise en place en juillet 2011.).
69748
L
U X E M B O U R G
Au total, au 31 décembre 2014, la Fondation est active auprès de 43 institutions de microfinance
8
(8 Y compris les IMF
ACAD-Finance (Palestine) et Chamroeun (Cambodge), dont la Fondation est actionnaire et qui sont de ce fait incluses
dans le portefeuille de social business.) dans 20 pays en développement.
L'ensemble des IMF partenaires de la Fondation compte 2,6 millions d'emprunteurs actifs
9
(9 chiffres au 30 septembre
2014), dont 84% sont des femmes. 80% des emprunteurs vivent en zone rurale et 24% en Afrique Sub-Saharienne. Ces
chiffres sont à rapprocher de ceux observes en moyenne dans les fonds spécialisés en microfinance, soit respectivement
67% de femmes et 51% de bénéficiaires en zone rurale. Le montant moyen du prêt accordé par les partenaires de la Fondation
s'élevait fin 2014 à 388 euros, montant également à rapprocher du prêt moyen observé dans les IMF financées par les fonds
d'investissement spécialisés qui est de 1 573 euros, soit un montant 4 fois supérieur. Ces chiffres font clairement ressortir
le positionnement spécifique de la Fondation
Le dispositif de la «Facilité africaine de décollage de la microfinance agricole et rurale» mis en place au printemps 2013
s'est largement développé en 2014. Ce dispositif pilote permet à des IMF africaines de taille réduite, présentant un profil
de risque plus élevé mais un potentiel et une mission sociale incontestable, d'être éligibles à des financements de la Fon-
dation, dans la limite de 500 000 euros. Ce financement est couplé avec un plan d'assistance technique, élaboré en étroite
concertation avec l'IMF partenaire. L'assistance technique est financée par une subvention de 1,32 millions d'euros de
l'Agence Française de Développement (AFD), abondée à hauteur de 0,3 millions d'Euros par la Fondation à partir de son
Fonds de partenariat. La Facilité Africaine de Décollage est mise en oeuvre avec le concours de deux experts senior, basés
l'un à Dakar, l'autre à Kigali.
Au total ce sont 15 institutions dans 7 pays qui sont soutenues fin 2014 dans le cadre de la Facilité Africaine. Onze
d'entre elles ont reçu un prêt, avec un encours de 3 millions d'Euros et 32 missions d'assistance technique ont été initiées
pour appuyer leur renforcement institutionnel.
Au 31 décembre 2014, les dépenses pour des missions d'assistance technique dans le cadre de la Facilité Africaine
s'élèvent à 148 K€,
La performance du portefeuille Microfinance de la Fondation a été globalement très satisfaisante, à l'exception notable
de l'IMF mutualiste TIAVO à Madagascar, placée au mois d'août 2014 sous administration provisoire, en raison d'une
grave crise de solvabilité, de liquidité et de gouvernance. L'échéance du prêt subordonné accordé par la Fondation, d'un
montant équivalent à 500.000 Euros, n'a pas été honorée, conduisant la Fondation à provisionner son exposition sur ce
dossier, nette des garanties, soit 170.000 Euros. Aucun autre impayé ni retard de remboursement n'a été constaté sur les
autres lignes du portefeuille Microfinance de la Fondation.
2. Social Business.
La Fondation a poursuivi en 2014 le développement de son activité en social business, en parallèle à ses efforts pour le
lancement du Grameen Crédit Agricole Fund, qui sera à l'avenir l'outil dédié à cette activité.
a) Nouveaux investissements
Au cours de l'exercice, 8 opérations ont été effectivement mises en place pour un montant total de 1 844 164 euros. La
plupart de ces opérations sont des financements complémentaires en faveur d'entreprises déjà partenaires.
En 2014 deux nouveaux partenaires sont entrés dans le portefeuille social business:
- ACRE-AFRICA, est un projet de micro-assurance agricole qui a été porté par la Fondation Syngenta pendant 4 ans au
Kenya sous le nom de Kilimo Salama et transformé en 2014 en entreprise de social business, sous le nom d'Agriculture
and Climatic Risk Enterprise Ltd (ACRE). La Fondation, approchée par la Syngenta Foundation for Sustainable Agricul-
ture, a accepté d'investir 369 786 euros au capital de cette nouvelle entreprise, dont elle détient 8,6%, aux côtés de la
Fondation Syngenta, majoritaire, de la Fondation Adolf Lundin et de LGT Venture Philanthropy. ACRE conçoit des pro-
duits d'assurance permettant à des petits agriculteurs de se protéger contre les risques de perte de récolte ou de perte de
bétail. Ces produits sont basés sur des indices météorologiques ou des indices de rendement, qui déclenchent automati-
quement une indemnisation, si l'agriculteur est exposé à des conditions naturelles défavorables. Les produits sont distribués
par des «agrégateurs», qui associent l'assurance à la fourniture d'intrants (engrais, semences), ou à l'octroi d'un crédit de
campagne. ACRE agit à la fois comme un consultant et un courtier et ne supporte elle-même aucun risque assurantiel. Fin
2014, les assurances proposées par ACRE bénéficiaient à 232.000 exploitants agricoles dans trois pays: Kenya, Rwanda
et Tanzanie.
- Green Village Ventures (GVV), nouvelle entreprise de social business en Inde, spécialisée dans la distribution de
lampes solaires dans les villages de l'Uttar Pradesh, en partenariat avec un entrepreneur social indien et GDF-Suez Ras-
sembleur d'énergies. La Fondation a investi 200 000 euros fin 2014 au capital de cette entreprise de social business, dont
elle détient 13%. Le modèle économique de GVV repose sur un accord de partenariat avec l'administration indienne des
Postes: GVV équipe les bureaux de poste ruraux avec des panneaux solaires et une station de charge de lampes solaires.
Les lampes sont louées aux villageois pour un prix sensiblement égal à la moitié de leur dépense pour alimenter des lampes
à kérosène. Les lampes sont déposées le matin par les villageois au bureau de poste pour être mises en charge et sont
récupérées le soir. Le postier rural reçoit une rémunération complémentaire à son salaire pour son action technique et
commerciale et pour l'encaissement des loyers. 20 villages ont été équipés à titre expérimental, 250 devraient l'être grâce
aux financements apportés par les trois actionnaires. Ce modèle de distribution pourrait demain s'appliquer à d'autres
69749
L
U X E M B O U R G
services, tels que la fourniture d'eau potable, dans une région où l'eau souterraine est fréquemment empoisonnée par l'ar-
senic.
Par ailleurs, des investissements complémentaires ont été réalisés dans 6 entreprises de social business déjà partenaires:
- Biotropical (Cameroun), entreprise spécialisée dans la production, la transformation et l'exportation de fruits tropicaux
sous label d'agriculture biologique: 130 000 euros en capital, complétés en 2014 par 105 000 euros en compte courant
d'associés.
- Chamroeun (Cambodge), institution de microfinance, créée par l'ONG Entrepreneurs du Monde, dédiée aux popula-
tions les plus pauvres: 65 000 euros d'investissement supplémentaires en capital ont été déboursés en 2014 sous forme de
compte-courant, en attente d'une augmentation de capital.
- Grameen Danone Foods Ltd (Bangladesh), entreprise de social business développée en partenariat avec Danone et
Grameen: un nouvel investissement de 240 000 euros équivalent a été réalisé, dans le cadre d'une augmentation de capital
à laquelle a également souscrit Grameen Telecom Trust.
- Sénégalaise des Filières Alimentaires (Sénégal): un investissement complémentaire de 200 000 euros a été déboursé
en janvier 2014 en compte courant d'actionnaires rémunéré, pour permettre à cette entreprise de social business, dont ta
Fondation détient 20% du capital aux côtés de Durabilis, de financer la construction d'une rizerie à Ndiouga Mbéres, dans
la Vallée du fleuve.
- Philéol-Madagascar: l'échéance du compte courant d'actionnaire a été reportée au 30 juin 2016.
- Laiterie du Berger (Sénégal): l'investissement complémentaire de 157 022 euros, qui avait été décaissé en compte
courant dans un premier temps en avril 2013, a été converti en capital le 15 octobre 2014.
Par ailleurs, la Fondation a autorisé un prêt de 350 000 USD et une augmentation de capital de 35 000 USD pour Phare
Performing Social Enterprise (PPSE), société cambodgienne de production et de diffusion de spectacles vivants, créée sous
forme de social business en partenariat avec l'ONG Phare Ponleu Selpak (PPSA). Cette double opération vise à permettre
l'acquisition d'un terrain pour une installation pérenne du chapiteau exploité par PPSE à Siem Riep, à proximité des temples
d'Angkor. En raison des difficultés juridiques de mise en place, le déboursement de ce prêt est reporté à 2015.
b) Fonds d'investissement Social Business. Grameen Crédit Agricole Fund
Pour donner plus de visibilité à son approche social business et attirer plus de ressources pour le développement de son
activité en faveur des entreprises de social business, la Fondation s'est engagée dans la voie innovante de la création du
Grameen Crédit Agricole Fund. Le Fonds existe juridiquement sous la forme d'un Fonds d'investissement spécialisé et a
reçu le visa de la Commission Luxembourgeoise de Contrôle du Secteur Financier. Au 31 décembre 2014, il n'est pas
opérationnel, faute d'avoir levé le montant minimum de ressources auprès d'investisseurs publics ou privés.
Un accord de principe a été donné par le Groupe AFD-Proparco en vue d'un investissement de 3 millions d'Euros dans
Le Fonds, complété par une subvention d'exploitation et d'assistance technique d'un million d'Euros. Les espoirs mis dans
un investissement du Fonds d'impact investing de la Banque Européenne d'Investissement dédié aux pays ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique) ont finalement été déçus: après 18 mois d'échanges, la BEI a informé la Fondation de son intention
de ne pas poursuivre l'instruction de notre dossier. De ce fait, il n'a pas été possible de réaliser un 1
er
closing du Grameen
Crédit Agricole Fund à hauteur de 12 millions d'Euros au cours de l'exercice.
L'équipe de la Fondation poursuit ses efforts auprès d'investisseurs motivés par l'approche proposée par la Fondation:
investir au capital d'entreprises dont la raison d'être est de donner aux plus pauvres accès à des biens et services essentiels
dont ils sont privés, et dont les actionnaires acceptent de réinvestir les profits dans l'entreprise ou au service d'une cause
sociale.
Le Conseil d'administration du Fonds s'est réuni à deux reprises en 2014, le 24 février à Paris et le 29 juin à Dacca, sous
la présidence du Professeur M. Yunus. Le conseil du 29 juin a approuvé l'ouverture d'une période de souscription pour la
Fondation par apport de ses titres et comptes courants d'associés dans les entreprises de social business. Par résolution
circulaire en date du 1
er
juillet 2014, le conseil d'administration de la Fondation a autorisé le transfert des participations
détenues par la Fondation dans des entreprises de social business et des financements associés au Grameen Crédit Agricole
Fund, dans la limite de 4 millions d'Euros.
Ce processus, pour lequel la Fondation bénéficie du conseil de la Direction des Affaires Juridiques de Crédit Agricole
SA, s'est avéré long et complexe.
Au 31 décembre 2014, huit participations ont effectivement été transférées pour une valeur totale de 3 028 828 euros:
- ACRE-Africa
- ACAD-Finance
- Chamroeun
- Laiterie du Berger
- SFA
- Phileol-Madagascar
- Grameen Danone Foods Ltd
- UV+ Solaire
69750
L
U X E M B O U R G
En contrepartie de ces apports, la Fondation a reçu 200,751 parts A et 1 021,313 parts B du Fonds.
Il est rappelé qu'au 31 décembre 2014, la Fondation est le seul actionnaire du Grameen Crédit Agricole Fund.
En consolidé avec le Fonds, au 31 décembre 2014, la Fondation a des engagements à hauteur de 3 947 658 euros dans
des activités de social business.
Montant des engagements et des encours au 31 décembre 2014
Au 31/12/2014, le montant total des engagements de la Fondation s'élève à 37 754 999 Euros, contre 21 035 123 Euros
à fin 2013, soit une augmentation de 80%.
Le portefeuille d'engagements de la Fondation se décompose comme suit:
- microfinance: 31 937 590 euros.
- social business: 3 947 658 euros en consolidant la Fondation et le Fonds Social Business
- autres: à ces investissements s'ajoute la participation dans TCX (1,869 million d'euros en valeur historique).
L'encours de la Fondation s'élève quant à lui à 35 337 568 Euros au 31/12/2014, soit une progression de 84% par rapport
à fin 2013. La différence entre engagements et encours s'explique par les engagements en garantie et par les tranches non
tirées de certains prêts ainsi des participations non décaissées.
Le solde de la dotation de la Fondation est placé selon un échéancier relativement court en dépôts à terme ou en sou-
scription de titres émis par le groupe Crédit Agricole dans le respect des règles approuvées par le Conseil d'administration.
3. Micro-assurance agricole. Il existe environ 450 millions d'exploitations agricoles de moins de deux hectares dans les
pays en voie de développement. L'immense majorité de ces exploitations, sauf en Inde, ne bénéficient d'aucune protection
contre les risques naturels, notamment la sécheresse, qui peuvent détruire leur récolte ou leur bétail et entraîner la ruine de
leur outil de travail. En effet les techniques traditionnelles d'assurance, basées sur une indemnisation à dire d'expert, sont
économiquement et pratiquement inabordables pour ces petites exploitations.
Les progrès faits par les techniques d'assurance indicielle, qui déclenchent une indemnisation totale ou partielle lorsque
les indices révèlent des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables ou un rendement anormalement fai-
ble, sans qu'un expert ait à se déplacer sur l'exploitation, changent la donne, Couplée avec des innovations technologiques
- exploitation de l'imagerie satellitaire, utilisation du téléphone portable - et des innovations marketing, l'assurance indicielle
ouvre la possibilité de proposer une assurance-récolte à un prix supportable pour des montants assurés de 100 dollars ou
moins. En retour, l'agriculteur qui est assuré contre les risques naturels à hauteur du coût des intrants (engrais, semences)
ou du montant du crédit de campagne qui lui est consenti par une institution de microfinance, est incité à investir et produire
davantage. La micro-assurance agricole constitue de ce fait un puissant levier d'intensification agricole des exploitations
familiales et de renforcement de la sécurité alimentaire dans les pays du Sud.
Conformément à l'orientation stratégique approuvée par le conseil d'administration en octobre 2010, la Fondation s'est
engagée dans la voie du soutien aux initiatives de micro-assurance agricole.
En 2014, la Fondation a poursuivi son appui au projet Assurance Récolte Sahel, projet pilote de déploiement de l'assu-
rance-récolte dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest (Sénégal, Mali, Burkina Faso et Bénin), dirigé par Planet-Guarantee, et
bénéficiant du soutien financier de la SFI dans le cadre de la Global Index Insurance Facility. En 2014 la Fondation a
apporté un soutien financier au projet par une subvention de 25 108 euros, ainsi qu'un soutien technique, surtout sur le volet
marketing. Le projet Assurance Récolte Sahel a permis en 2014 d'assurer 33 000 agriculteurs à partir d'indices météoro-
logiques ou d'indices de rendement pour des cultures de coton, d'arachide et de maïs. La distribution des polices d'assurance
passe par des coopératives ou des groupements d'agriculteurs ou des IMF.
L'engagement de la Fondation en micro-assurance agricole a franchi une étape importante en 2014 avec son investis-
sement de 369 786 euros au capital d'ACRE-AFRICA, mentionné plus haut dans le cadre des investissements social
business. ACRE-AFRICA prend la suite du projet Kilimo Salama développé pendant 4 ans par la Fondation Syngenta avec
le soutien de la SFI, au travers de la Global Index Insurance Facility.
La Fondation a poursuivi en 2014 sa participation dans l'initiative de recherche sur l'assurance agricole indicielle, en
partenariat avec Pacifica, filiale d'assurance dommages du Crédit Agricole, l'Institut Europlace de Finance, Airbus, et les
Universités de Paris-Dauphine et Nanterre. Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation bénéficie gratuitement pendant 2
à 3 ans de la présence à temps partiel en son sein d'une chercheuse sur l'assurance indicielle pour la protection des agri-
culteurs et d'un chercheur sur les Partenariats Public - Privés (PPP) en assurance indicielle.
Par ailleurs, la Fondation joue toujours un rôle actif pour diffuser le savoir-faire en matière d'assurance indicielle des
récoltes, et promouvoir une micro-assurance responsable. Dans le cadre du Réseau International de Micro-assurance (MIN),
qui regroupe 70 organisations, la Fondation a été particulièrement active en 2014 en co-facilitant le groupe de discussion
des investisseurs en micro-assurance, et en participant au Groupe de Travail du MIN sur la micro-assurance agricole. Elle
a pris l'initiative d'organiser un voyage d'étude sur l'assurance agricole au Mexique en amont de la conférence internationale
sur la micro-assurance, avec le soutien du Multilateral Investment Fund (FOMIN) et en collaboration avec l'organisation
mexicaine de microfinance AMUCSS. Le voyage de 4 jours a réuni 25 participants de toutes nationalités.
La Fondation a pris une part active dans différentes conférences consacrées à l'assurance indicielle et son impact sur la
sécurité alimentaire, notamment une table-ronde co-organisée au Salon de l'agriculture à Paris en février 2014 avec Planet
69751
L
U X E M B O U R G
Guarantee et la Fondation FARM, et la Conférence organisée par le Ministère allemand de la Coopération à Berlin en
novembre 2014.
4. Initiatives de plaidoyer pour une microfinance responsable et le social business. La Fondation prend une part active
dans des plateformes et organisations professionnelles et auprès des institutions nationales et internationales pour faire
entendre la voix d'une microfinance responsable et promouvoir l'approche social business.
La Fondation est membre des plateformes ou partie prenante des initiatives suivantes:
- Convergences 2015 (www.convergences2015.org). plateforme d'échange et de débat présidée par Jean-Michel Sévé-
rino, réunit un large éventail d'acteurs français publics (AFD, Ville de Paris, Ministère des Affaires Etrangères ...), privés
(entreprises, banques, HEC ...) et solidaires (Handicap International, ACTED, Groupe SOS ...) pour lutter contre la pauvreté,
l'exclusion et la précarité dans les pays du Nord et du Sud. La Fondation en est membre depuis sa création et son Délégué
Général en est Vice-Président. Les problématiques abordées sont la microfinance, l'économie sociale et solidaire, le social
business, la coopération internationale et les objectifs post 2015 du développement durable et équitable. Le Forum Mondial
de Convergences a réuni 6 700 participants en septembre à Paris.
- La Plate-forme européenne de microfinance (www.emfp.org) réunit les principaux acteurs européens de la microfi-
nance dans les pays du Sud: ONG, fonds d'investissement, sociétés de conseil, universitaires. La Semaine de la microfinance
en novembre au Luxembourg en constitue la principale manifestation. Dans le cadre de la plateforme européenne, la
Fondation anime un groupe de travail des investisseurs spécialisés dans le financement des IMF de taille petite (Tier 3) ou
intermédiaire (Tier 2).
- InFiNe est une association Luxembourgeoise (Asbl), créée en juin 2014 pour réunir les principaux acteurs de la finance
inclusive du Grand-Duché. Elle joue essentiellement un rôle de plaidoyer et d'échanges des meilleures pratiques et a été
chargée par le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg d'organiser le Prix Européen de la Microfinance.
- Réseau International de Micro-assurance (www.microinsurancenetwork.org). La Fondation co-facilite le groupe de
travail des investisseurs en micro-assurance et facilitera à partir de 2015 le groupe de travail sur la micro-assurance agricole.
- European Venture Philanthropy Association (www.evpa.eu.com). L'EVPA partage avec la Fondation la vision d'une
philanthropie agissant sur le mode entrepreneurial pour répondre aux problèmes sociaux de précarité, d'exclusion et de
pauvreté.
- Social Performance Task Force (SPTF): cette instance mondiale, dont Jürgen Hammer, Chief Investment Officer de
la Fondation, a été élu administrateur, a élaboré les «standards universels de gestion de la performance sociale», qui ont
vocation à constituer le référentiel commun aux Institutions de microfinance, aux bailleurs de fonds, aux investisseurs et
aux agences de rating. La Fondation joue un rôle actif dans la diffusion de ces standards auprès des IMF partenaires.
- Groupe des Experts de la Commission en Entrepreneuriat Social (GECES): le Délégué Général est membre de ce
Groupe d'Experts, chargé par la Commission Européenne de donner des avis sur la mise en œuvre de sa Social Business
Initiative. Le GECES a approuvé en 2014 le rapport sur la mesure de l'impact social, appelé à servir de référence pour la
mise en oeuvre des Fonds européens d'entrepreneuriat social.
- Famille Grameen: la Fondation est bien sûr partie prenante des débats et des rencontres organisés à l'initiative du
Professeur Yunus. Ainsi la Fondation était présente au Social Business Day à Dacca fin juin, ainsi qu'au Sommet Mondial
du Microcrédit au Mexique en septembre 2014,
- Social Business Score Card (CERISE): durant l'année 2014 la Fondation a participé (avec Investisseurs&Partenaires,
AfD, EdM ...) dans le groupe de travail pour le développement d'une «grille d'analyse» pour le Social Business. L'objectif
est d'établir les principes sur lesquels se construit un social business, d'identifier les pratiques et les modes d'intervention
de ce type d'entreprises et de proposer des indicateurs et méthodes d'évaluation et d'accompagnement. Le groupe a testé la
grille auprès de 10 organisations dans 5 pays sur 3 continents des principes de construction d'un social business.
Par ailleurs, le Délégué Général de la Fondation a été nommé par la Ministre française en charge du Développement
membre du Conseil National du Développement et de la Solidarité Internationale. Il a également pris une part active aux
travaux du Comité Français de la Task force du G8 sur l'Impact Investing, qui a remis son rapport en septembre 2014.
5. Gestion des risques et contrôle interne. L'ensemble des limites, fixées par la politique d'investissement, ont été res-
pectées au cours de l'exercice 2014 et le Comité de projets a été régulièrement tenu informé de la qualité du portefeuille.
Le Comité de Contrôle Interne de la Fondation s'est réuni le 4 décembre 2014. La stratégie risque de la Fondation validée
en décembre 2013 pour l'exercice 2014 a été reconduite jusqu'en juin 2015 en attendant sa refonte en cohérence avec le
plan de développement stratégique 2014-2018 adopté par le Conseil le 27 octobre. Deux modifications ont été approuvées
par le Conseil concernant la politique de provisionnement et la limite d'exposition au risque de change:
la Fondation renonce à un provisionnement ex ante de son portefeuille d'engagements en microfinance au profit d'une
politique de provisionnement spécifique des créances douteuses et/ou litigieuses.
La limite d'exposition au risque de change est portée à 8 Millions d'euros (contre 6 précédemment) dont 7 en Franc CFA
(contre 4 précédemment). Il s'agit principalement de permettre à la Fondation de remplir son mandat en Afrique sub-
Saharienne dans une devise dont le risque de dépréciation contre Euro est considéré comme faible.
Les chantiers de mises à jour de la cartographie des risques de la Fondation et du pian de contrôle de ses activités n'ont
pas pu être totalement menés à bien du fait d'un turn-over élevé dans les équipes de la Fondation. Un planning de ces travaux
69752
L
U X E M B O U R G
sur 2015 a été validé par le Comité de Contrôle Interne ainsi que la poursuite des chantiers prévus en matière de conformité.
Il est également convenu de réviser et le cas échéant d'amender à la lumière de l'expérience la convention de fonctionnement
en matière de risques et contrôles permanents, de conformité et d'audit, signée entre Crédit Agricole SA et la Fondation en
juin 2011.
D. Comptes de l'exercice 2014
1. Les produite de l'exercice. Les revenus de l'exercice 2014 s'élèvent à 2 950 K€, dont 175 K€ de subvention de l'AFD
pour la Facilité Africaine qui n'avait pas été budgétée. Hors subvention AFD, les produits s'élèvent à 2 775 K€, soit 143 K
€ de plus que la prévision budgétaire de 2 632 K€.
[graphique: Total 2 305 K€ - 2013 réel; Total 2 632 K€ - 2014 budget; Total 2 950 K€ - 2014 réel]
Ils sont constitués à hauteur de:
- 1 772 K€ de revenus sur les prêts et garanties consentis aux partenaires (contre 1,666 K€ budgétés)
- 652 K€ du revenu de placement de la trésorerie disponible (contre 581 K€ budgétés).
- 44 K€ de dividendes versés par TCX
- 175 K€ de subvention de l'AFD pour financer les dépenses d'assistance technique déployées dans le cadre de la Facilité
Africaine, et 50 K€ de subvention de Crédit Agricole SA pour les actions de communication de la Fondation.
- 257 K€ d'un produit à recevoir correspondant à la refacturation au fonds d'investissement des charges supportées par
la Fondation et des frais engagés par la Fondation dans le cadre de son mandat de conseil pour un total de 257 K€ contre
335 K€ budgétés.
Le quasi doublement des encours du portefeuille Microfinance de prêts et garanties en 2014 a permis de dépasser à 1
772 K€ le niveau de revenus budgété à 1 666 K€ (+6%). Par rapport à 2013, la croissance des revenus de l'activité Micro-
finance est de 40%.
La gestion au plus près, toujours dans le strict respect des règles de prudence fixées par le Conseil d'Administration, de
la trésorerie disponible de la Fondation a permis de dépasser en 2014 l'objectif de rendement fixé par Le budget à 652 K€
(+12% par rapport à un budget de 581 K€). La rémunération moyenne obtenue sur ces placements a été en 2014 de 2,91
% (comparée à 2,72% en 2013).
Ainsi, les revenus de la Fondation tirés de ses activités de prêts, garanties et prise de participations ainsi que la gestion
de la trésorerie disponible sont en nette progression et passent de 2 030 K€ à 2 468 K€ soit une croissance de 21,6% par
rapport à 2013 alors que le budget prévoyait une croissance de 10,7%.
La refacturation des frais au titre du Fonds d'investissement (GCA Fund) s'élève à 257 K€, contre le montant budgété
de 336 K€. Comme pour la clôture de l'exercice 2013, ce montant est intégralement provisionné dans les comptes car le
Fonds n'est pas encore en mesure de supporter une refacturation de ces frais. Des efforts ont été faits pour réduire au
maximum cette facture et donc in fine le coût pour la Fondation, en particulier le non remplacement depuis septembre du
collaborateur mis à disposition par Amundi pour la conception et de la promotion du Fonds d'investissement.
Crédit Agricole SA a renouvelé en 2014 la subvention de 50 K€ qui avait été accordée en 2013, au titre des actions de
communication de la Fondation.
Enfin, la Fondation a perçu en 2014 un dividende de 44 K€ au titre de sa participation en capital dans le fonds TCX. Ce
montant n'était pas budgété.
2. Les charges de l'exercice. Les charges courantes d'exploitation se sont élevées à 2 869 K€, contre 2 619 K€ au budget,
et 2 553 K€ en 2013. Ces charges incluent des dépenses d'assistance technique réalisée dans le cadre du fonds de partenariat
et de la Facilite africaine pour un montant total de 331 K€, et qui n'avaient pas fait l'objet de prévisions budgétaires. Le
montant des dépenses opérationnelles imputables sur les revenus de l'exercice s'élève ainsi à 2 538 K€, à comparer à un
budget de 2 619 K€, soit une économie de 81K€.
2014
budget
2014
réel
Frais de gouvernance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
60
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 693 1 635
Consultants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
63
Location de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
228
Frais de mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
146
Prestations de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
142
Bureautique, fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
106
Communication, Cotisations, Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
82
Autres charges opérationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
76
Total hors Facilité Africaine et Fonds de Partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 619 2 538
Dépenses Facilité Africaine, Fonds de Partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
331
69753
L
U X E M B O U R G
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 619 2 869
Les principaux postes de dépenses sont les suivants:
- Les dépenses liées à l'organisation des réunions du Conseil, des Comités et des groupes de travail de la Fondation se
sont élevées à 60 K€ contre 100 K6 budgétés. L'économie provient de la décision du Conseil de reporter à 2015 le voyage
d'étude initialement prévu en 2014.
- La masse salariale s'est élevée à 1 635 K€ contre 1 693 K€ prévus, soit une économie de 58 K€ par rapport au montant
budgété. Cette économie est réalisée malgré un turn-over important avec 4 congés de maternité dont 3 suivis de congé
parental, et dont le remplacement s'est traduit par un surcoût de l'ordre de 50K€. Au 31 décembre 2014, l'équipe de la
Fondation comptait 19 salariés y compris son Délégué Général, dont 3 en congé parental (contre 17 à fin 2013).
- Les dépenses de consultants s'élèvent à 356 K€. Déduction faite des dépenses imputées sur le fonds de partenariat et
la subvention AFD, les dépenses de consultants se sont élevées à 63 K€, en ligne avec le budget.
- La location de bureaux s'élève à 228 K€ pour un montant budgété de 230 K€.
- Les frais de mission se sont élevés à 146 K€ contre 200 K€ budgétés et en réduction par rapport à 2013 (198 K€).
L'équipe de la Fondation est très attentive à voyager aux conditions les plus économiques possibles.
- Les prestations de service dont CACEIS Bank Luxembourg, auditeurs, avocats et autres traducteurs, se sont élevées
à 142 K€ en dépassement du budget prévu de 83 K€.
- Le poste bureautique à 106 K€ s'est avéré également plus élevé que prévu (77 K€).
- Les dépenses de communication, formation et cotisations aux différents organismes dont la Fondation est membre ont
été plus importantes que prévu, 82 K€ au lieu des 40 K€ budgétés.
- L'ensemble des autres postes (commissions de garanties, frais financiers, écarts de change, TVA non déductible ...)
atteignent 113 K€ au lieu des 134 K€ budgétés.
Comme indiqué précédemment, les dépenses d'assistance technique et de soutien à nos partenaires se sont élevées à 331
K€. Il s'agit tout d'abord de frais engagés dans le cadre de la Facilité Africaine, couverts à la fois par la subvention reçue
de l'AFD (175 K€) et par le Fonds de partenariat (93 K€). Par ailleurs, la Fondation poursuit son soutien (financier et en
expertise) au projet d'assurance récolte au Sahel de Planet Guarantee, ainsi que le cofinancement de missions d'assistance
technique au profit d'IMF ou d'entreprises partenaires et enfin une contribution financière à des manifestations de référence
sur la microfinance et le social business. Bien que l'ensemble de ces dépenses soit comptabilisé en charges sur l'exercice,
elles sont couvertes par le Fonds de partenariat, doté de 1 million d'euros par le conseil d'administration sur le résultat de
l'exercice 2008-2009. Le solde du Fonds de partenariat s'élève à 321 K€ au 31 décembre 2014.
Les dépenses de la Fondation liées à l'activité de conseil du fonds d'investissement Social Business sont incluses dans
les charges courantes de l'exercice, à hauteur de 257 K€. Il s'agit des salaires de deux collaborateurs dédiés au fonds, l'un
à temps complet jusqu'en septembre 2014 et l'autre à temps partiel, des frais de mission liés essentiellement à la recherche
d'investisseurs potentiels et à la tenue de 2 conseils d'administration du Fonds, ainsi que des frais de marketing et de
communication.
3. Evolution du résultat opérationnel. Pour permettre une comparaison du résultat opérationnel de la Fondation en 2013
(réalisé), et 2014 (budget, réalisé), il convient de faire les retraitements suivants:
- Retirer des revenus
* La subvention AFD qui a sa contrepartie en charges, et qui ne fait pas l'objet d'une prévision budgétaire
* La refacturation des coûts de gestion et de promotion au GCA Fund, dans la mesure où ce revenu est totalement annulé
par une provision
- Retirer des charges les dépenses d'assistance technique et de partenariat imputées sur la subvention AFD et sur le Fonds
de partenariat.
Sur ces bases, le résultat opérationnel retraité s'élève à -20 K€ a comparer à -269 K€ en 2013, et un budget de -322 K€.
données en '000 euros
REALISE
2013
BUDGET
2014
REALISE
2014
Revenus nets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 305
2 632
2 950
- Subvention AFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-5
0
-175
- Refacturation au Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-215
-335
-257
Revenus d'exploitation courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 086
2 297
2 518
Charges totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2 553
-2 619
-2 869
- Charges imputables à la subvention AFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
0
175
- Charges imputables au Fonds de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
0
156
Charges d'exploitation courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2 354
-2 619
-2 538
Résultat Opérationnel retraité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-269
-322
-20
69754
L
U X E M B O U R G
4. Les éléments exceptionnels. Le résultat comptable de l'exercice prend en compte une dotation nette aux provisions
d'un montant de 262 K€ qui se décompose de la façon suivante:
- Un provisionneraient net sur le portefeuille de prêts d'un montant de 14 K€ résultant:
* D'une part de l'abandon de la politique de provisionnement ex ante de 1% et de la reprise consécutive de 157 K€,
* Du provisionnement des encours de prêt et garantie, nets des garanties reçues, à l'IMF Malgache TIAVO pour un
montant total de 171 K€.
- Un provisionnement d'intérêts à recevoir de Grameen Danone Foods Ltd, entreprise social business bangladaise, à
hauteur de 44 K€.
- Un provisionnement de 50 K€ sur les titres de participation de Biotropical, social business au Cameroun, soit 25% des
titres détenus.
- Un provisionnement de la refacturation au Fonds Grameen Crédit Agricole des dépenses engagées en 2014 d'un montant
de 281 K€ pour la préparation, la constitution et le lancement du Grameen Crédit Agricole Fund. Comme pour la clôture
de l'exercice 2013, en l'absence de souscription à la clôture de l'exercice 2014, le principe de prudence commande de
provisionner ces frais et dépenses. Pour mémoire, un montant de 335 K€ avait été budgété pour 2014 en produits pour la
Fondation.
- Compte tenu de conditions de taux de change favorables, la Fondation a repris les provisions pour pertes de change
latentes à hauteur de 127 K€ (notamment sur des titres de participations).
Par ailleurs, la Fondation enregistre un résultat exceptionnel de 87 K€ correspondant aux résultats de change cumulés
réalisés sur les transferts le 10 novembre et le 8 décembre 2014 des 8 participations de la Fondation vers le Fonds.
5. Evolution du résultat net de la Fondation. Le tableau ci-après présente les résultats des 6 premiers exercices de la
Fondation:
montants en '000€
2008-
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Résultat avant provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 288
19
213
(85) (248)
81
Provisions
- Provision ex-ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(61)
(32)
(24)
(61)
22
156
- Provisions spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(355) (326) (128)
128 (170)
- Prov. social business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
(41) (105)
(95)
- Prov. pour pertes de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(35)
35
(81)
127
- Prov. refacturation au fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
(671) (281)
Résultat exceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Résultat net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 227 (368) (172) (280) (955)
(94)
E. Portefeuille de la Fondation au 31/12/2014
Depuis sa création, le Comité de Projets de la Fondation a approuvé 144 projets pour un montant total de 90 925 424
euros auprès de partenaires (y compris TCX et le Grameen Crédit Agricole Fund).
<i>Localisation des opérations en portefeuille au 31 décembre 2014i>
[graphique]
<i>Répartition des engagements i>
<i>10i>
<i> (10 Y compris l'investissement dans TCX) par région au 31 décembre 2014i>
Montant des engagements
en EUR en %
Afrique Sub-saharienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 268 707 25%
Amérique du Sud et Centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
0%
Asie du Sud et du Sud-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 874 061 37%
Europe de l'Est et Asie Centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 087 772 19%
Moyen Orient et Afrique du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 389 098
6%
Europe Occidentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 135 362 14%
37 754 999
[graphique]
La part de l'Afrique sub-saharienne dans le portefeuille d'engagements de la Fondation représente 25% en valeur, mais
46% en nombre de partenaires soutenus, reflétant la priorité mise par la Fondation sur cette zone mais aussi le plus faible
niveau unitaire des engagements, en raison de la moindre maturité des IMF. L'Asie du Sud et du Sud-Est représente quant
à elle 27% des institutions partenaires de la Fondation pour 37% des engagements en valeur.
69755
L
U X E M B O U R G
<i>Répartition des engagements par instrument au 31 décembre 2014i>
Type d'instruments
en EUR en %
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
967 731 2,6%
Prêt senior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 206 925 80%
Prise de participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 476 789 15%
Compte courant actionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340 620
1%
Dette subordonnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
513 992
1%
Dette convertible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248 942 0,7%
37 754 999
[graphique]
Au 31 décembre 2014, les prêts senior représentent 80% des engagements contre 75% à fin 2013, et les prises de
participations 15% contre 19%. Ce changement de répartition est majoritairement dû à la forte progression de l'activité en
microfinance en 2014.
<i>Répartition des engagements par devise hors couverturei>
La Fondation poursuit sa politique de prêts en devises locales et compte dans son portefeuille 17 devises hors euro, grâce
à des opérations de couverture de change.
Conformément à l'orientation approuvée par le conseil d'administration, l'équipe de la Fondation s'est efforcée dès le
début de ses opérations à rechercher des solutions pour minimiser ou supprimer le risque de change pour les IMF partenaires
en proposant:
- des garanties émises en devises fortes mais qui permettent aux IMF de bénéficier de prêts en devise locale accordés
par des banques locales,
- des structures back to back dans lesquelles la Fondation fait un prêt en devise forte qui est déposé par l'IMF dans une
banque locale, en sûreté d'un prêt en devise locale d'un montant équivalent ou supérieur,
- des prêts en devise locale couverts par des swaps de taux et de change délivrés par CA-CIB ou par TCX pour les
devises plus exotiques,
- des prêts en devise locale sans couverture, quand celle-ci n'est pas disponible ou pas compétitive, dans la limite d'une
enveloppe de position de change ouverte pour la Fondation, validée par le Conseil d'Administration.
<i>Gestion du risque de changei>
Risque de Change
Montant
d'engagement
Neutralisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 610 169
81%
A la charge de la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 144 830
19%
A la charge du Partenaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
0%
37 754 999 100%
Le risque de change est totalement neutralisé pour 81% du portefeuille, c'est à dire qu'il n'est porté ni par l'IMF, ni par
la Fondation (prêts en devise couverts par des swaps ou bien structurés en back to back).
La Fondation porte un risque de change sur un montant équivalent à EUR 7,1 millions d'euros, soit 19% de son porte-
feuille (engagements). C'est le cas lorsqu'elle a un encours de prêt en devise locale non couvert par un swap, ou lorsqu'elle
prend des participations en capital en devise non couvertes dans des entreprises sociales.
Ainsi à fin 2014, ce risque est réparti comme suit:
Position de change ouverte PRETS
Limite
11
Disponible % utilisé
Prêts en F CFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 944 110
7 000 000
3 055 890
56%
Prêt senior en JOD (Jordanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
825 000
Compte courant actionnaires USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164 541
Autres devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
989 541
2 000 000
1 010 459
49%
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 933 651
8 000 000
4 066 349
62%
Position de change ouverte PRISES DE PARTICIPATION
Limite Disponible % utilisé
Prise de participation XAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 740
Prise de participation KHR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 687
Prise de participation INR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 000
Prise de participation USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 869 751
69756
L
U X E M B O U R G
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 211 179 10 000 000
7 788 821
22%
11 par décision du Conseil d'Administration en date du 27 octobre 2014, la limite d'exposition globale au risque de
change a été relevée de 6 à 8 millions d'Euros et la sous-limite Franc CFA de 4 à 7 millions Euros.
Nota: le risque de change est porté par l'IMF lorsque la Fondation lui propose un prêt en devise forte. C'est le cas par
exemple d'une IMF au Cambodge qui bénéfice d'un prêt en USD mais dont les clients ont une bonne partie de leurs revenus
en USD.
<i>Profil des institutions de microfinance partenairesi>
Profil des IMF partenaires
Global
Afrique
Sub-saharienne
Asie
du Sud
et du
Sud-Est
Europe
de l'Est
et Asie
Centrale
MENA
Nombre d'IMF partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
21
11
8
3
Encours de crédit total en Mns d'euros . . . . . . . . . . .
1 027
245
550
143
89
Nombre d'emprunteurs actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 648 744
620 866 1 731 209
157 265
139 404
% Femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83,6%
80,1%
88,9%
39,9%
84,0%
% Rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79,7%
60,5%
91,8%
74,5%
20,1%
Prêt moyen (EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
387,51 €
393,87 €
317,68 € 911,64 € 635,14 €
<i>Perspectives 2015i>
En 2015, la Fondation intensifiera ses efforts pour promouvoir la microfinance responsable et le social business dans
les régions prioritaires de son action:
- Développement du portefeuille microfinance, conformément aux priorités et aux critères financiers et sociaux fixés
par le Conseil d'Administration.
- Première levée de fonds à hauteur de 12 millions d'euros et lancement opérationnel du Grameen Crédit Agricole Fund.
- Intensification des initiatives en matière de micro-assurance agricole, en partenariat avec des acteurs reconnus.
Toutefois le Conseil d'administration doit être conscient qu'en l'absence de décisions sur un apport de ressources nou-
velles à la Fondation, pour financer le développement du portefeuille microfinance conformément aux orientations du plan
stratégique 2014-2018, l'équipe de la Fondation sera amenée à fortement réduire la prospection et l'instruction de nouveaux
dossiers à partir de la mi-2015.
J'ai l'honneur de soumettre ce rapport d'activité et de gestion à l'approbation du Conseil d'Administration.
Au Conseil d'administration de
GRAMEEN CREDIT AGRICOLE MICROFINANCE FOUNDATION
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Luxembourg
Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
To the Board of Directors of
GRAMEEN CREDIT AGRICOLE MICROFINANCE FOUNDATION
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
<i>Report of the réviseur d'entreprises agrééi>
Report on the annual accounts
Following our appointment by the Board of Directors on February 24, 2014, we have audited the accompanying annual
accounts of GRAMEEN CREDIT AGRICOLE MICROFINANCE FOUNDATION, which comprise the balance sheet as
at December 31,2014 and the surplus and loss account for the year then ended, and a summary of significant accounting
policies and other explanatory information.
Responsibility of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance
with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts, and for such internal
control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
Responsibility of the réviseur d'entreprises agréé
Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in
accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du
69757
L
U X E M B O U R G
Secteur Financier. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance whether the annual accounts are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual
accounts. The procedures selected depend on the réviseur d'entreprises agréé's judgement, including the assessment of the
risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the
réviseur d'entreprises agréé considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the annual
accounts in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors, as well as eval-
uating the overall presentation of the annual accounts.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the annual accounts give a true and fair view of the financial position of GRAMEEN CREDIT AGRI-
COLE MICROFINANCE FOUNDATION as of December 31, 2014, and of the results of its operations for the year then
ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report, which is the responsibility of the Board of Directors, is consistent with the annual accounts.
March 9, 2015.
<i>For Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé
i>Philippe Lenges
<i>Réviseur d'entreprises agrééi> / <i>Partneri>
GRAMEEN CREDIT AGRICOLE MICROFINANCE FOUNDATION
<i>Balance sheeti>
<i>As at December 31, 2014i>
<i>(expressed in Euro)i>
ASSETS
Note
2014
2013
A. FIXED ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 102 973 45 609 640
1. Financial assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 29 441 975 15 081 898
Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
3 000 000
8 000 000
Deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
8 021 545 18 674 729
Equities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
5 411 880
3 360 928
Debts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5
227 573
492 085
B. CURRENT ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 599 660
5 007 967
I. Debtors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
549 707
677 233
Other debtors
becoming due in one year or less . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
549 707
677 233
II. Cash at bank and in hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 049 953
4 330 734
C. PREPAID EXPENSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 021
13 249
TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 714 654 50 630 856
LIABILITIES
Note
2014
2013
A. GRANTS AND RESULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 49 359 646 49 453 507
I. Initial Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 001 000 50 001 000
II. Surplus/(loss) carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(547 493)
407 432
III. Loss for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(93 861)
(954 925)
B. PROVISIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 986
156 018
I. Other provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
21 986
156 018
C. CREDITORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 072 772
583 783
I. Tax and social security debts
a) Social security and other social agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 626
51 321
b) Accrued charges payable for holiday pay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 881
79 976
c) Other accrued charges payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 136
107 286
II. Amount owed to credit institutions
becoming due and payable after more than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
509 596
-
69758
L
U X E M B O U R G
becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 142
-
III. Other creditors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
326 391
345 200
D. DEFERRED INCOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260 250
437 548
TOTAL LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 714 654 50 630 856
The accompanying notes are an integral part of these annual accounts.
<i>Surplus and loss accounti>
<i>For the year ended December 31, 2014i>
<i>(expressed in Euro)i>
A. CHARGES
Note
2014
2013
1 Staff costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1 047 488
978 491
a) Wages and salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
703 846
689 077
b) Social security costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343 642
289 414
2 Value adjustments
Value adjustments on financial assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
220 420
104 527
Depreciation on current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325 341
552 294
3 Other external charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1 803 552 1 688 231
4 Financial charges
Foreign currency exchange losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 922
86 462
Other interest and financial expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 652
-
Total charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 442 375 3 410 005
B. INCOME
Income from financial assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2 095 522 1 595 849
Other financial income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
882 277
709 447
Reversal of value adjustments on financial assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
283 378
149 784
Realized gain in respect of financial assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 337
-
Total Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 348 514 2 455 080
Loss for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(93 861) (954 925)
The accompanying notes are an integral part of these annual accounts.
<i>Note to the annual accounts as at December, 31, 2014i>
Note 1. General. Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation (the “Foundation”) was created on September 24,
2008 when it was approved by the relevant authorities of Luxembourg.
The registered office of the Foundation is established in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. The Foundation was
created under the modified Law of April 21, 1928 on associations and non-profit foundations. It is placed under scrutiny
from the Justice Ministry of the Grand Duchy of Luxembourg.
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation, founded by Grameen Trust and Credit Agricole S.A., was granted
EUR 50 001 000 (EUR 50 000 000 from Crédit Agricole S.A. and EUR 1 000 from Grameen Trust) with the objective to
fight against poverty and financial exclusion in emerging countries by supporting the development of MicroFinance In-
stitutions (MFIs) and by assisting social business projects.
The Foundation aims to provide financial support to MFIs through loans, guarantees or equity, and to offer technical
assistance adapted to their stage of development, focusing on MFIs encouraging the agriculture and rural activities.
The Foundation intends to be active mainly in the following 3 regions:
- Sub-Saharan Africa
- The Middle East and North Africa
- South and South-East Asia
The Foundation financial year starts on January 1 and ends on December 31 of each calendar year. The first financial
period started on September 24, 2008 and ended on December 31, 2009.
The Foundation offers at the time of this report loans in EUR, USD, XOF, KHR, IDR, LKR, THB, AZN, JOD, MGA,
MWK, UGX, KES and TJS depending on the currency area of the partner institution, and retains the objective to offer
loans in any another currency (subject to hedging through currency and interest rate swap transactions with third parties).
The Foundation is managed by the Board of Directors and the two specialized committees that have been created with
some members of the Board of Directors:
- The Project Committee which makes decisions on the MFI and Social Business financing deals proposed by the
Managing Director, within the limits decided by the Board of Directors;
69759
L
U X E M B O U R G
- The Ethics, Compliance and Audit Committee which ensures that deontology and conformity of the Foundation's social
mandate are adhered to.
A Managing Director has been appointed and has a delegation of powers for the day to day management and running
of the Foundation.
The articles of incorporation were published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on October 30, 2008.
The Foundation is recorded at the Luxembourg Trade Register under the number R.C.S. Luxembourg: G 194.
Note 2. Accounting policies.
General principles
The annual accounts have been prepared in accordance with the laws and regulations in force in Grand Duchy of
Luxembourg. The layout of the balance sheet and of the surplus and loss account has been adapted to the particularities of
the Foundation.
The preparation of the annual accounts requires the Board of Directors of the Foundation to make estimates and as-
sumptions that affect certain amounts reported in the annual accounts. Although these estimates are subject to uncertainties,
they are based on the Board of Directors' best knowledge of current events and actions. It is reasonably possible, on the
basis of the existing knowledge that outcomes within the next financial year may differ from these estimates.
The significant accounting policies are as follows:
2.1. Financial assets
Financial assets are recorded at acquisition cost. Where there is a permanent diminution in value of the financial assets,
a value adjustment is made accordingly.
2.2. Debtors
Debtors are stated at their nominal value reduced by appropriate value adjustments for unrecoverable amounts. These
value adjustments are determined as deemed appropriate by management.
2.3. Provisions
Provisions to cover foreseeable liabilities and charges are determined at the end of each year. Provisions set up in previous
years are reviewed regularly and may be written back to the Surplus and Loss account.
2.4. Creditors
Amounts owned are recorded at their repayable amount or due.
2.5. Interest income
Interest income is recognised on a time-proportionate basis. It includes interest income from cash and cash equivalents
and interest income on debt securities.
2.6. Foreign Currency Translation
The Foundation maintains its accounting records in EUR and the Balance Sheet and the Surplus and Loss account are
expressed in this currency. Balances denominated in foreign currencies are translated into EUR as follows:
- all assets, other than financial assets, are stated at the lower of their countervalue translated into EUR at historical rates
and at the rate prevailing at the year-end. The cost of financial assets is translated into EUR at historical rates;
- all liabilities are stated at the higher of their countervalue translated into EUR at historical rates and at the rate prevailing
at the year-end;
- income and charges denominated in foreign currencies are translated into EUR at the rate ruling at the transaction date.
Consequently, only realized exchange gains and losses and unrealized exchanges losses are reflected in the Surplus and
Loss account.
2.7. Cross-Currency interest rate swaps
MFI loans denominated in a currency other than EUR or XOF are hedged by cross-currency interest rate swap agreements
(except one loan in MGA and part of a loan in JOD) and then recorded following the fixed euro rate as agreed. As, the
hedging is fully effective, the fair value of the Cross-Currency interest rate swaps is not recorded. All swaps are disclosed
in the note 14.
Note 3. Financial fixed assets. Financial assets held by the Foundation as at December 31, 2014 can be detailed as
follows:
3.1. Loans
The following loans have been granted to Micro Finance Institutions
N° IMF Name
CCY
Amount
granted as at
31/12/14 in
CCY
Amount
granted
in EUR
Net Amount
outstanding
as at 31/12/14
Income on
oustanding
loans as at
31/12/14
1
RENACA Benin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XOF
320 000 000
487 837
203 265
19 596
2
Alidé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XOF
400 000 000
609 796
121 959
20 489
69760
L
U X E M B O U R G
3
Juhudi Kilimo Company Ltd . . . . . . . . . . .
KES
55 000 000
482 170
482 170
9 078
4
Bimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KES
58 000 000
520 715
520 715
2 902
5
Kenya Women Finance Trust . . . . . . . . . .
KES
216 303 700
2 000 000
923 400
53 564
6
Micro Fund for Women Ltd . . . . . . . . . . .
JOD
1 500 000
1 650 000
1 132 375
8 418
7
RMCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XOF
300 000 000
457 347
457 347
18 199
8
Coopec Sifa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XOF
100 000 000
152 449
114 337
7 277
9
Wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XOF
500 000 000
762 245
190 561
32 014
10 Asiena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XOF
150 000 000
228 674
101 633
9 475
11 ACFIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XOF
130 000 000
198 184
198 184
2 119
12 PAMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XOF
500 000 000
762 245
762 245
41 288
13 Uganda ECLOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGX
850 000 000
245 469
245 469
7 585
14 Uganda Micro-Credit Foundation Ltd . . . .
UGX
1 000 000 000
300 000
293 423
2 739
15 ENCOT Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGX
880 000 000
257 362
257 362
2 372
16 Paidek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD
300 000
221 951
166 463
12 966
17 Phoenix / Ravnaq . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TJS
1 500 000
240 365
96 146
10 209
18 IMF Hekima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD
340 000
250 000
271 435
2 904
19 MEC FADEC NJAMBUR . . . . . . . . . . . .
XOF
100 000 000
152 449
88 929
7 762
20 CAURIE Microfinance . . . . . . . . . . . . . . .
XOF
1 200 000 000
1 829 388
1 117 959
44 147
21 Finca Malawi Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MWK
480 000 000
882 037
882 037
28 825
22 Hattha Kaksekar Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD
1 250 000
937 031
187 406
24 440
KHR
7 900 000 000
1 518 026
1 518 026
14 850
23 Thaneakea Phum Cambodia . . . . . . . . . . .
THB
100 000 000
2 353 119
1 575 291
131 276
24 AMK Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KHR
13 000 000 000
2 413 289
1 624 801
90 013
25 Tuba Rai Metin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD
400 000
298 730
248 942
11 199
26 Koperasi Mitra Dhu'Afa . . . . . . . . . . . . . .
IDR
13 100 000 000
933 708
595 300
39 576
27 Mitra Bisnis Keluarga . . . . . . . . . . . . . . . .
IDR
45 500 000 000
3 007 548
2 429 305
119 042
28 Bina Artha Ventura . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IDR
10 000 000 000
633 029
572 215
16 293
29 LOLC Microcredit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR
3 300 000
3 300 000
1 897 143
146 993
30 Vision Fund Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LKR
91 000 000
1 100 000
633 148
5 156
31 Chamroeun Microfinance Ltd . . . . . . . . . .
KHR
5 250 000 000
977 969
789 644
40 349
32 Kreditimi Rural I Kosoves LLC . . . . . . . .
EUR
1 000 000
1 000 000
600 000
66 456
33 JSC MFO Crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR
1 500 000
1 500 000
1 500 000
11 375
34 Finance for Development . . . . . . . . . . . . .
AZN
500 000
499 650
199 860
23 960
EUR
1 000 000
1 000 000
1 000 000
39 667
35 Viator Mikrokredit Azerbaijan LLC . . . . .
AZN
2 039 500
1 975 123
1 365 973
83 435
36 OXUS Microfinance Tadjikistan . . . . . . . .
TJS
2 900 000
458 064
183 225
9 310
37 OXUS Microfinance RDC . . . . . . . . . . . . .
USD
800 000
630 418
630 418
18 143
38 Arvand LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TJS
10 000 000
1 519 115
1 199 795
67 628
39 LLC MLO Humo &Partner . . . . . . . . . . . .
TJS
9 000 000
1 396 385
942 774
71 963
40 Palestine for Credit & Development . . . . .
USD
1 000 000
739 098
739 098
13 869
41 TIAVO
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MGA
1 600 000 000
509 596
382 197
40 285
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103 818 633 200 41 390 581
29 441 975
1 429 206
12 Due to a risk of default on payment on the MFI TIAVO, the outstanding balance on the loan has been depreciated
for 25% of the total exposure and the accrued Interest was depreciated for 50% of the total exposure (Note 4). The depre-
ciation amounts to EUR 127 399 for the principal on the loan and to EUR 21 106 for the accrued interest. It is accounted
for in the account “value adjustments on financial assets”.
As of December 31, 2014, an income of EUR 37 914 was received on loans that arrived to maturity during the year.
The total income on loans as at 31/12/14 amounted to EUR 1 467 120.
Loans in USD, KHR, THB, IDR, AZN, PHP, KES, MWK, UGX, LKR and TJS are covered by a cross-currency interest
rate swap. For loans covered by cross-currency interest rate swaps (CCIRS), margins related to CCIRS are included in
interest received and / or accrued interest.
3.2. Bonds
3.2.1. Medium-Term Negotiable bonds (French Bons à Moyen Terme Négociables)
The Foundation has invested in the following Crédit Agricole S.A. BMTN as of December 31, 2014:
69761
L
U X E M B O U R G
N°
Amount
(in EUR)
Residual amount
after repayment
(in EUR)
Start date
Maturity
date
Rate
Interest
received
(in EUR)
Accrued
interest
(in EUR)
Total
(in EUR)
1
3 000 000
3 000 000
25.10.11
26.10.15
3.83%
114 900
21 091
135 991
3.2.2. Euro Medium Term Note (French Titre de créance à moyen terme)
The Foundation has invested in the following Credit Agricole Corporate & Investment Bank EMTN during the year
2014. Although the position was cleared on November 18, 2014, revenues for the year are depicted as follows:
N°
Amount
(in EUR)
Residual amount
after repayment
(in EUR)
Start date
Maturity
date
Rate
Interest
received
(in EUR)
Accrued
interest
(in EUR)
Total
(in EUR)
1
5 000 000
-
04.03.11
18.11.14
3.62%
159 677
-
159 677
3.3. Term Deposit Placement
N°
Amount
(in EUR)
Deposit Period
Valuation as of
Dec 31, 2014
Nb. of days
Rate %
Accrued
interest
(in EUR)
1
1 500 000
24.10.11 - 24.10.15
1 500 000
1 461
3.78
11 806
2
3 050 000
03.02.12 - 03.02.16
3 050 000
1 461
3.71
101 716
3
500 000
28.04.14 - 28.04.15
500 000
365
0.51
1 757
4
36 313
13.02.14 - 13.04.16
36 313
790
0.40
148
5
1 996 000
13.02.13 - 31.12.14
1 996 000
686
3.00
61 513
6
199 600
28.05.13 - 31.12.14
199 600
582
2.67
5 428
7
499 200
14.08.13 - 31.12.14
499 200
504
2.67
13 486
7 781 113
7 781 113
195 854
As of December 31, 2014, the amount of EUR 240 432 has been capitalised. The nominal of Term Deposit Placement
amounted also to EUR 8 021 545.
3.4. Equities
The Foundation has invested in the following participations as of December 31, 2014:
Name
Acquisition
cost in currency
Acquisition
cost in EUR
Valuation as of
Dec. 31, 2014
Babyloan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 205 765
EUR 205 765
EUR 164 500
TCX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD 2 395 144 EUR 1 869 751 EUR 1 869 751
Grameen CA Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 3 059 846 EUR 3 059 846 EUR 3 059 846
Phare Performing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KHR 260 000 000
EUR 47 687
EUR 47 687
Biotropical
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XAF 61 490 000
EUR 93 741
EUR 70 306
Green Village Ventures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INR 15 468 264
EUR 199 790
EUR 199 790
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 5 476 580 EUR 5 411 880
1 Due to a risk of default on payment, the outstanding balance on the debt receivable has been depreciated for 25% of
the total exposure. The depreciation of the principal amounts to EUR 26 493. It is accounted for in the account “value
adjustments on financial assets”.
3.5. Debts receivable
In accordance with the memorandum of understanding concluded as at November 16, 2013 the Foundation as shareholder
of “Phare Ponleu Selpak Association” has agreed to make an advance on current account (See point 1 below).
In accordance with the memorandum of understanding concluded as at April 9, 2014 the Foundation as shareholder of
“Biotropical Agricultural Development Company” has agreed to make an advance on current account (See point 2 below).
Name
Amount
(in Currency)
Amount
(in EUR)
Income
from debt
receivable at
closing date
(in EUR)
1
Phare Performing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD 200 000 EUR 148 094
EUR 1 254
2
Biotropical
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XAF 69 513 928
EUR 79 479
EUR 4 312
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 227 573
EUR 5 566
69762
L
U X E M B O U R G
1 Due to a risk of default on payment, the outstanding balance on the debt receivable has been depreciated for 25% of
the tolal exposure. The depreciation of the principal amounts to EUR 26 493, It is accounted for in the account “value
adjustments on financial assets”.
Note 4. Debtors. As of December 31, 2014, the debtors consist of:
Accrued Interest on Loans
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 311 383
Accrued Interest on Debts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 5 565
Accrued Interest on Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 21 090
Accrued Interest on Deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 195 854
Value added tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 5 346
Management fees invoiced to the Fund
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 367 650
Invoices issued to the Fund
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 475 318
Others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 10 469
Doubtful receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR (842 968)
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 549 707
13 As at December 31, 2014, the board of Directors has decided to book a provision on the exposure that the Foundation
has on the IMF TIAVO. Due to a risk of default on payment, its exposure has to be depreciated for 50% of the accrued
interest on the loan (EUR 21 106).
14 The Foundation has paid fees in the name of Grameen Credit Agricole Fund (the “Fund”). The fees are related to the
constitution and the day-to-day management since the inception of the Fund. At December 31, 2014, the Foundation has
commenced the transfer of its Social Business portfolio into the Fund although no capital contributions were made. Thus,
the Foundation's exposure to the Fund's risks on all expenses and creditors has been reduced by reinvoicing some of these
expenses to the Fund. As at December 31, 2014, the total risk equals to the total liabilities, amounting to EUR 842 968.
This Loss amount has been recorded as doubtful receivables and is included in the caption “Depreciation on current assets”
in the Surplus and accounts.
Note 5. Cash at bank and in hand. The foundation has opened a 1.5% yield savings book with EUR 3 378 772. It also
has a EUR 260 433 balance on a special bank account dedicated to the grants provided by the French Development Agency
(Agence française de développement).
As of December 31, 2014 the Foundation held a total of EUR 4 049 953 of Cash at bank and in hand.
Note 6. Grants and result. This amount includes the initial grants from Crédit Agricole S.A. and Grameen Trust of EUR
50 001 000.00 received by the Foundation as well as the result of the financial year EUR (93 861) and the loss carried
forward of EUR (547 493).
Note 7. Other provisions. As at December 31, 2014, the Board of Directors has decided to book a provision on the
exposure that the Foundation has on the IMF TIAVO. Due to a risk of default on payment, its exposure has to be depreciated
for 50% of the value of the guarantee granted for the loan (EUR 21 986). The impact on Surplus & Loss has been classified
on the caption “Value adjustments on financial assets”.
Note 8. Other creditors. As of December 31, 2014, the other creditors consist of:
Domiciliary fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 2 300
Custodian fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 40 750
Accounting fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 25 300
Tax declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 3 392
Audit fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 16 994
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 109 935
Salary provisions for personnel seconded to the entity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 127 720
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 326 391
These amounts are due in one year or less.
Note 9. Staff costs. During the year ended 2014 the average number of employees of the Foundation was 15 (Vs. 14 in
2013). In addition to the 15 employees, the Foundation had at its disposal 4 more external employees. The cost of the 4
external employees amounts to EUR 569 560 (note 10).
Note 10. Other external charges. As of December 31, 2014, other external charges consist of:
Honoraries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 439 977
Financial services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 74 572
Professional fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 68 598
Real property rental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 228 025
69763
L
U X E M B O U R G
Office equipment rental and office supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 106 177
Journeys and business travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 186 854
External Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 569 560
Other charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 129 789
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 803 552
Note 11. Income from other transferable securities and from loans forming part of the fixed assets. As of December 31,
2014, income from other transferable securities and from loans forming part of the fixed assets consists of:
Income from interest on loan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 467 120
Income from interest on bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 298 645
Income from setting up commissions on loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 198 815
Income from debts receivable
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 86 837
Income from participating interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 44 105
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 095 522
15 This includes accrued interest on the debt receivable Grameen Danone Food which were entirety depreciated fol-
lowing a Board of Directors' decision (EUR 44 716).
Note 12. Other financial income. As of December 31, 2014, other financial income consists of:
Cash interest received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 291
Cash interest received / term deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 352 845
Exchange gains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 440
Grant from Crédit Agricole S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 50 000
Grant from Agence Française de Développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 175 174
Income from guarantees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 17 467
Reinvoicing to the Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 99 005
Management fees from the Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 158 311
Other income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 28 744
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 882 277
Note 13. Off balance.
Partially disbursed loans.
Moreover, other loan agreements have been partially drawn. The Foundation has still to issue the remaining amount to
Asiena for an amount of XOF 50 000 000 (EUR 76 247), to Vision Fund Lanka for an amount of LKR 91 000 000 (EUR
573 314), to MFW for an amount of JOD 500 000 (EUR 584 659) as well as to Reneca for an amount XOF 120 000 000
(EUR 182 992).
Partially disbursed debts
Moreover, debts receivable have been partially drawn. The Foundation has still to issue the remaining amount to Bio-
tropical for an amount of XAF 45 986 070 (EUR 70 126).
Guarantee
The Foundation provided the bank Standard Chartered Bank Indonesia with a loan guarantee for Komida for an amount
of EUR 533 759, the BNI Madagascar with a loan guarantee for TIAVO for an amount of EUR 87 192 and the Development
Finance Corporation of Ceylon (DFCC Bank) with two loan guarantees for a total amount of EUR 390 000.
Collaterals
The Foundation has collateralised its Medium-Term Negotiable bond of EUR 3 000 000 in order to mobilise guarantees
through CA-CIB (stand-by letters of credit) to the benefit of its partner MFI.
It has also collateralised its term deposit of EUR 500 000 at CADIF as guarantee on the MGA 1 600 000 000 loan it
took at BNI in Madagascar.
Note 14. Cross-currency interest rate swaps. As of December 31, 2014, the Foundation entered into cross-currency
interest rate swap agreements to hedge the currency and the interest rate exposure on interest on loans.
Contract
Nominal
amount
Currency Maturity
date
Counterpart
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 000 000
KHR
15/04/15
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 250 000
USD
15/04/15
CA-CIB
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 000 000
TJS
15/10/15
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 000 000
TJS
15/10/15
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
489 500
AZN
15/10/15
TCX
69764
L
U X E M B O U R G
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 000 000
THB
15/10/15
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 000
AZN
15/10/15
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 500 000
TJS
15/10/15
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 100 000 000
IDR
15/10/15
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 900 000
TJS
15/10/15
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 500 000 000
IDR
15/10/15
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 000
AZN
15/04/16
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 000
AZN
15/04/16
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 000
USD
15/04/16
CA-CIB
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000 000
KHR
18/04/16
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 000
KHR
18/04/16
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 000 000
IDR
17/10/16
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
850 000 000
UGX
17/10/16
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 000 000
KES
17/10/16
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 000 000
KES
17/10/16
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 000 000
IDR
17/10/16
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 000 000
THB
15/12/16
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 000
USD
15/12/16
CA-CIB
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 000
USD
15/04/17
CA-CIB
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 000 000
KHR
18/04/17
TCX
The cross-currency interest rate swap agreements outstanding consisted of:
Contract
Nominal
amount
Currency Maturity
date
Counterpart
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000 000 000
IDR
18/04/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000 000
IDR
18/04/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
480 000 000
MWK
18/04/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 750 000 000
KHR
15/06/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 000 000
USD
15/06/17
CA-CIB
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750 000
AZN
16/06/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340 000
USD
15/10/17
CA-CIB
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216 303 700
KES
16/10/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 000 000
TJS
16/10/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
880 000 000
UGX
16/10/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 000
UGX
16/10/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 000
JOD
16/10/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 000 000
KES
16/10/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 900 000 000
KHR
17/10/17
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 000 000
TJS
16/04/18
TCX
Cross-Currency Interest Rate Swap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104 000 000
LKR
18/06/18
TCX
Note 15. Advances and loans granted to the members of the administrative, managerial and supervisory body. There
were no advances or loans granted to the members of the administrative, managerial and supervisory body during the year
ended on December 31, 2014.
Note 16. Subsequent events. There were no significant events occurring after the Balance Sheet date, which could require
revision or disclosure in the annual accounts.
<i>Budget 2015i>
EUR milliers
Réalisé 2013
2013 Actual
Réalisé 2014
2014 Actual
BUDGET
2015
Revenus d'investissements auprès des partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 264
1 772
2 391
Prêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1227
1 667
2 373
Garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
87
0
Placement de la liquidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
720
652
240
Revenu dividendes TCX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
44
69765
L
U X E M B O U R G
Revenus de l'activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 030
2 468
2 631
Subvention AFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
175
Subvention Crédit Agricole SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
50
Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
0
Facturation au fonds d'Investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
257
Revenus nets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 305
2 950
2 681
Charges
Frais liés aux réunions du CA et comités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
60
100
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 576
1 635
1 566
Consultants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
356
100
Location de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
228
170
Frais de mission (hors gouvernance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
146
160
Prestations de service (CACEIS, traduction, avocats, audit ...) . . . . . . . . . . .
83
142
150
Bureautique, fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
106
110
Communication, Cotisations, Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
82
70
Commissions (CA-CIB, AFD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
68
158
Frais financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
30
Ecarts de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
-8
0
Impact TVA non déductible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
11
10
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
15
15
Charges totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 553
2 869
2 639
RESULTAT HORS PROVISIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-248
81
42
RESULTAT APRES AFFECTATION AUX RESERVES
Imputation fonds de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
156
0
RESULTAT OPERATIONNEL HORS ASSISTANCE TECHNIQUE . . . .
-54
237
42
Provisions pertes de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-81
127
Provisions portefeuille de prêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
-14
Provisions social business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-95
Provisions facturation au Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-648
-281
Transfert actifs au Fond GCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
RESULTAT COMPTABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-955
-94
42
Référence de publication: 2015057404/1123.
(150065280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2015.
Deutsche Mexico Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 197.336.
STATUTEN
Im Jahr zwei tausend fünfzehn, am neunundzwanzigsten Mai.
Vor der unterzeichnenden Notarin Karine Reuter, mit Amtssitz in Luxembourg (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Das Unternehmen unter Delaware Recht (Vereinigte Staaten von Amerika), „Deutsche Bank Americas Holding Corp.“,
mit Sitz in 19801 Wilmington, Delaware, 1209 Orange Street, Corporation Trust Center (Vereinigte Staaten von Amerika),
hier vertreten durch Herrn Marco HIRTH, beruflich ansässig in 2, boulevard Konrad Adenauer , L-1115 Luxemburg,
kraft einer Vollmacht vom 26. Mai 2015.
Diese Vollmacht bleibt, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienene erklärt andurch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen und deren Satzung folgende
ist:
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft“) nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie
abgeändert, sowie der vorliegenden Satzung.
69766
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen
Gesellschaften und sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb und die Veräußerung von Finanzinstrumenten jeder
Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf
andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen und Transaktionen mittels einer
Sacheinlage.
Die Gesellschaft kann ferner Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der
gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Kredite gewähren, für diese Gesellschaften bürgen, zu ihren
Gunsten Garantien geben und Sicherheiten stellen oder sie auf andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann für sich selbst alle Tätigkeiten vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke förderlich er-
scheinen oder direkt oder indirekt mit diesen in Verbindung stehen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Deutsche Mexico Holdings S.à r.l.“ gegründet.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Sitz kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter in jedwede Gemeinde des Großher-
zogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss
des Rates der Geschäftsführer, verlegt werden. Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen oder Geschäftsstellen können
sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer errichtet werden.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt 12,500 Euro (EUR zwölf tausend fünfhundert) aufgeteilt in 125 (einhundert
fünfundzwanzig) Anteile mit einem Nennwert von je 100 Euro (EUR einhundert).
Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei den Generalversammlungen der Gesellschafter.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall einer Bareinlage haben die Gesellschafter ein Vor-
zugsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu,
so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschaft-
santeilen an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit von wenigstens drei
Vierteln des Gesellschaftskapitals.
Art. 10. Die Gesellschaft wird weder durch die Geschäftsunfähigkeit, noch die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit
oder ein ähnliches Ereignis, das den Alleingesellschafter oder einen anderen Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
Art. 11. Die Geschäftsführung obliegt dem Rat der Geschäftsführer, welcher aus mindestens zwei (2) Personen besteht,
welche nicht Gesellschafter sein müssen.
Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter bestellt, welche die Dauer ihres Man-
dates bestimmt. Ein Geschäftsführer kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Generalversammlung der
Gesellschafter widerrufen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer oder durch einen Geschäfts-
führer gemeinschaftlich mit einer Person, der der Rat der Geschäftsführer Zeichnungsbefugnisse übertragen hat, rechts-
verbindlich verpflichtet, wobei dies bei letzterer jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.
Art. 12. Der Rat der Geschäftsführer wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden aus. Er kann außerdem
einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der
Geschäftsführung und der Generalversammlung der Gesellschafter verantwortlich ist.
Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Die Sitzungen
des Rats der Geschäftsführer finden am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einladung
bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs statt.
Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung wahr, jedoch kann in seiner Abwesenheit
der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden
pro tempore ernennen.
Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt
ein schriftliches Einladungsschreiben per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), außer in dringenden Fällen, in denen
Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann
durch schriftliche Zustimmung, durch Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein
gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung
in einem vorangegangenen Beschluss des Rates der Geschäftsführer festgesetzt wurden.
69767
L
U X E M B O U R G
Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer
mittels einer schriftlich, per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder durch ein vergleichbares Kommuni-
kationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.
Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel teilnehmen, das den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander er-
laubt. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.
Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung
anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit auf den jeweiligen Sitzungen durch die an-
wesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form
von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die Zustimmung schriftlich, per E-Mail oder Fax, oder durch ein vergleich-
bares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Diese werden schriftlich bestätigt, so dass die Gesamtheit der Unterlagen
das Protokoll bildet, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.
Art. 13. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig
vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Art. 14. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die Au-
flösung der Gesellschaft.
Art. 15. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen
der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als
solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen
teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.
Art. 17. Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zu-
mindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Jede Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung einer Mehrheit
von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Im F alle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Generalversammlung der Gesellschafter
gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert, aus.
Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt
ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesell-
schafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 21. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren genehmigten Wirtschaftsprüfern (réviseur(s) d'en-
treprises agréé(s)) welche(r) von der Generalversarmmlung der Gesellschafter bestellt wird (werden).
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn
Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Generalversammlung der Gesellschafter
zur freien Verfügung.
Der Rat der Geschäftsführer kann nicht entscheiden, Vorabdividenden auszuzahlen. Die Emissionsprämie kann den
Gesellschaftern durch die Generalversammlung der Gesellschafter oder durch den Rat der Geschäftsführer frei ausge-
schüttet werden.
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Generalver-
sammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Generalver-
sammlung der Gesellschafter bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse
zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Der Überschuss, der
aus der Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu
den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend
Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
Art. 25. Die gegenwärtige Satzung ist in deutscher Sprache verfasst, gefolgt von einer Übersetzung in englischer Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist die deutsche Fassung maßgebend.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015
69768
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitalsi>
Das Gründungskapital der Gesellschaft wurde wie folgt gezeichnet:
Deutsche Bank Americas Holding Corp., Alleingesellschafter, wie oben definiert, hat einhundertfünfundzwanzig (125)
Gesellschaftsanteile mit einem Nominalwert von hundert Euros (EUR 100,00) je Anteil gezeichnet.
Alle Anteile wurden komplett eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euros (EUR 12.500,00) zur
freien Verfügung der Gesellschaft steht, wie es dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Gesetzgebung und Erklärung betreffend Geldwäschei>
Die Parteien erklären gemäß dem Gesetz vom 12.November 2004, so wie dieses Gesetz nachträglich abgeändert wurde,
dass sie die alleinigen Nutznießer und Empfänger gegenwärtiger Transaktion sind, und bescheinigen, dass die Gelder, die
für die Einzahlung des Kapitals der Gesellschaft genutzt wurden, weder aus dem Handel von Rauschgiftmitteln, noch aus
einer durch Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches respektiv Artikel 8-1 des abgeänderten Gesetzes vom 19.Februar 1973
sowie auch nicht aus einer von Artikel 135-1 (Finanzierung terroristischer Aktivitäten) vorgesehenen Straftaten herrühren.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Abgaben , gleich welcher Art, die sich auf die von der Gesellschaft oder die im
Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde angelastet werden sollen getragen werden , haben in etwa eine tausend-
dreihundert Euro ( EUR 1.300,-) geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft, hat die alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Als Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit werden ernannt:
Herr Eric KONG, am 13. Februar 1982 geboren in Taiwan, wohnhaft in
Herr Michael Roy BICE JR, der am 24. Juli geboren 1969 in New York (Vereinigte Staaten von Amerika), wohnhaft
in
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer, Großherzogtum Lu-
xemburg.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Anfrage der oben erschienenen Partei,
die vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist mit einer englischen Version; auf Antrag derselben erschienenen
Partei, ist im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung, die deutsche Version mass-
gebend.
Worüber Urkunde, in Luxemburg, an dem Tag oben angegeben.
Es folgt die englische Übersetzung des vorangehenden Textes:
In the year two thousand fifteen, on the twenty-ninth of May.
Before the undersigned Maitre Karine REUTER, a notary resident in Luxemburg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
The company under Delaware law (United States of America), “Deutsche Bank Americas Holding Corp.”, with regis-
tered office in 19801 Wilmington, Delaware, 1209 Orange Street, Corporation Trust Center (United States of America),
here represented by Mr. Marco HIRTH, professionally residing in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
by virtue of a power of attorney signed on May 26, 2015.
Said proxy, after having been initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. There exists a société à responsabilité limitée (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding and disposal of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the transfer by sale, exchange or otherwise of financial instruments
of any kind, as well as the transfer of securities by purchase and disposal, subscription or in any other manner, and the
administration, control and development of its portfolio and transactions by means of a contribution in kind.
The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which
it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company or assist them
in an other manner.
69769
L
U X E M B O U R G
The Company may carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or
which are related directly or indirectly to its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 4. The Company will be incorporated under the name of “Deutsche Mexico Holdings S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other borough in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general
meeting of shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the board
of managers. Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
through resolution of the board of managers.
Art. 6. The Company's share capital is set at 12,500 euros (EUR twelve thousand five hundred) represented by 125
shares (one hundred twenty five) shares with a nominal value of 100 euros each (EUR one hundred).
The Company may establish one or several share premium accounts (the “Share Premium Accounts”) into which any
premium paid on any share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Accounts are to be taken by
the board of managers.
The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other securities in
consideration for the contribution, which can be made by share or any other assets, and may credit such contributions to
one or more capital surplus accounts (the “Capital Surplus Accounts”). Decisions as to the use of such Capital Surplus
Accounts are to be taken by the board of managers. For the avoidance of doubt, any such decision need not allocate any
amount or asset contributed to the contributor.
The funds in the Share Premium Account and the Capital Surplus Account may, inter alia, be used by the board of
managers to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other
distribution.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. The transfer of shares to new shareholders is
subject to the approval given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital.
Art. 10. The Company is neither dissolved by the legal incapacity or bankruptcy, nor insolvency or a similar event
affecting the single shareholder or any other shareholder.
Art. 11. The Company is managed by a board of managers composed of at least two (2) persons, who do not need to be
shareholders. The board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition on behalf of the Company in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by
the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely by the general meeting of shareholders at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two managers or by the signature of any
person (the “Attorney”) to whom the board of managers has delegated legally binding signature authority, which, however,
applies to such Attorney only within the delegated powers.
Art. 12. The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and
of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by any manager.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty- four (24) hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature) or facsimile, or any other
similar means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency
shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager (or by an authorised
representative of such manager) in writing, which may be given at any time by electronic mail (without electronic signature)
or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers or for any
69770
L
U X E M B O U R G
meeting where all managers are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda
thereof.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without
electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his co-managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Such meeting will
be deemed to be held in Luxembourg if such call, video-conference call or a meeting organized by another means of
communication was initiated from Luxembourg. The participation in a meeting by these means is equivalent to a partici-
pation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. If the board of managers consists of two managers, both managers shall be present
at the meeting.
Decisions shall be taken by a simple majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The board
of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing
its approval in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety of such
resolutions will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution. Such resolutions will be valid and
effective as if passed at the meeting duly convened and held.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be
signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares. Each shareholder may delegate any
of its powers to any person in writing or by electronic mail (without electronic signature) or facsimile on such terms as it
deems appropriate.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general
meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies,
as amended.
Art. 19. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 20. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the board of managers prepares an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a legal reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
The board of managers may declare interim dividends at any time.
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which
do not need to be shareholders. The general meeting of shareholders determines their powers and fees. The liquidators shall
have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of
the Company held by them.
Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
Art. 24. The present articles of incorporation are worded in German followed by an English version. In case of divergence
between the German and the English text, the German version shall prevail.
<i>Transitory Provisionsi>
The Company's year starts today and ends on the 31
st
of December, 2015.
69771
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription - Paymenti>
The share capital of the Company has been subscribed as follows:
Deutsche Bank Americas Holding Corp., Sole Shareholder, as defined above, has subscribed to one hundred twenty
five (125) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each.
All these Shares have been paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.00) is forthwith
at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Legislation and Declaration on money launderingi>
The parties declare in accordance with the Law of 12 November 2004 as this law was subsequently changed, that they
are the sole beneficiaries and recipients of current transaction, and certify that the funds that were used for the payment of
the capital of the company, neither resulting from the trade of narcotics agents, even from a respektiv by Article 506-1 of
the Criminal Code article 8-1 of the amended law of 19 February 1973 and not from one of Article 135-1 (financing of
Terrorism) intended offenses.
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand and three hundred euros
(EUR 1,300.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder adopted the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
Mr. Eric KONG, born on 13 February 1982 in Taiwan, professionally residing in 60 Wall Street, 010005-2836, New
York, USA.
Mr. Michael Roy BICE JR, born on 24 July 1969 in New-York (United States of America), professionally residing in
60 Wall Street, 010005-2836, New York, USA.
The registered office of the Company is located at L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, Grand Duchy
of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in German, followed by an English version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the German and the English text, the German version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above, in witness whereof We, the
undersigned notary, have signed on the date and year above mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Signé: M. HIRTH, K. REUTER.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils 2, le 2 juin 2015. Relation: 2LAC/2015/12079. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Luxembourg, le 4 juin 2015.
Référence de publication: 2015083863/325.
(150096416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.
Dynamic Finance SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 46.857.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 13 avrili>
<i>2015i>
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> résolution:i>
En remplacement de l'ensemble des administrateurs en fonction, l'Assemblée nomme aux fonctions d'administrateur
pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2020:
- Monsieur Yves MERTZ, administrateur de sociétés, né le 19/09/1957 à Arlon, Belgique, domicilié professionnellement
au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg;
69772
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Olivier DIFFERDANGE, administrateur de sociétés, né le 12/01/1973 à Arlon, Belgique, domicilié profes-
sionnellement au 1, rue de Steinfort, L-8371 Hobscheid.
- Monsieur Maurice HOUSSA, administrateur de sociétés, né le 25/04/1959 à Luluabourg (RD Congo), domicilié pro-
fessionnellement au 1, rue de Steinfort, L-8371 Hobscheid.
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> résolution:i>
En remplacement du commissaire aux comptes en fonction, l'Assemblée nomme aux fonctions de commissaire aux
comptes pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2020:
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 37.039, avec siège social au 15, Rue
des Carrefours, L-8124 Bridel.
<i>3 i>
<i>èmei>
<i> résolution:i>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 12, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,
au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015058033/28.
(150066496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Diga Consulting SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 81.383.
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 avril 2015 que la convention de dépositaire
entre la société DIGA CONSULTING S.A. et
CF Corporate Services
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 165872
est résiliée en date de ce jour.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 20 avril 2015.
Référence de publication: 2015058024/17.
(150066851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Direct Marketing Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 60.568.
EXTRAIT
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire du
17 avril 2015 à 14h30
le siège social et les bureaux sont déplacés vers l'adresse
5 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg
à effet immédiat du 17 avril 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DIRECT MARKETING SERVICES SA
Anton M.A.M. VAN KREIJ
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2015058025/17.
(150066435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
69773
L
U X E M B O U R G
DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 24.157.
Les comptes annuels au 30.06.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Cette
version remplace la première version déposée en date du 03.05.2013 et portant la référence de publication L130070003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2015.
<i>Pour: DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015058026/15.
(150066490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 24.157.
Les comptes annuels au 30.06.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Cette
version remplace la première version déposée en date du 03.05.2013 et portant la référence de publication L130070004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2015.
<i>Pour: DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015058027/15.
(150066491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Diy-Tech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 75.071.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme Diy-Tech S.A. tenue
extraordinairement en date du 1
er
avril 2015 à (L-8070) Bertrange, 33, rue du Puits Romain, que:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux compte ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra en 2020.
<i>Conseil d'Administrationi>
Simon Baker
Jay Vallabh
Corinne Néré
<i>Commissaire aux comptesi>
REVEX S.à r.l.
Pour extrait conforme
S.W. BAKER
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015058028/21.
(150066722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
69774
L
U X E M B O U R G
Defi3 Alpha Lux, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 129.348.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 7 avril 2015, a pris note des démissions de Messieurs Mohammed DIAB et
Eric Matteo CORRADIN de leurs fonctions de gérants de la société, avec effet au 10 avril 2015, et a nommé comme
nouveaux gérants, avec effet à la même date:
- Monsieur Michel GALEAZZI, Schiffbauplatz 5, CH-8005 Zurich, Suisse, gérant de catégorie A,
- Monsieur Felix ACKERMANN, Schiffbauplatz 5, CH-8005 Zurich, Suisse, gérant de catégorie A.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
Luxembourg, le 15 avril 2015.
<i>Pour DEFI 3 ALPHA LUX
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2015058017/18.
(150066181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Deltatrans International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.
R.C.S. Luxembourg B 99.706.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015058018/10.
(150066400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Deltatrans International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.
R.C.S. Luxembourg B 99.706.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015058019/10.
(150066401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Deltatrans International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.
R.C.S. Luxembourg B 99.706.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015058020/10.
(150066402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Desideratum, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 67.810.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance tenue le 18 mars 2015i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg
vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.
69775
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 18 mars 2015.
Signature
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015058021/13.
(150066412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Dialogiques, Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 59.514.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015058022/11.
(150067009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Dialogiques, Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 59.514.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 20.04.2015i>
L'assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat du commissaire pour une nouvelle période de six années
c'est à dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020.
<i>Commissaire:i>
Mme Paula KALLAS, ayant son adresse professionnelle au 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015058023/14.
(150067010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
DMA Holdings S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
R.C.S. Luxembourg B 108.914.
Par la présente nous vous informons que nous dénonçons le siège social de votre société et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 avril 2015.
UHY Fibetrust S.àr.l.
Référence de publication: 2015058029/9.
(150065637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
DSP Hydrolux S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 156.023.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1 i>
<i>eri>
<i> avril 2015i>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social avec effet immédiat de L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de
la Liberté à L-2314 Luxembourg, 2, Place de Paris.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015058030/12.
(150066992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
69776
L
U X E M B O U R G
Dumark Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9696 Winseler, 53, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 188.986.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ARBO S.A.
Signature
Référence de publication: 2015058031/11.
(150066991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
European Credit X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 163.733.
A partir du 1
er
avril 2015, le siège social de la société sera transféré du 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 2-8,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 avril 2015.
Référence de publication: 2015058052/10.
(150066779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
European Credit Y S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 163.671.
A partir du 1
er
avril 2015, le siège social de la société sera transféré du 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 2-8,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 avril 2015.
Référence de publication: 2015058053/10.
(150066778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Europe Trade Shows Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5826 Hesperange, 40, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 143.830.
L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de mars;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
Monsieur Aristoteles KARVELLAS, commerçant, né à Athènes (Grèce), le 24 novembre 1960, demeurant à L-5826
Hesperange, 40, rue de Gasperich.
Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “Europe
Trade Shows Consulting S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1880 Luxembourg, 179, rue Pierre Krier, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 143830, (la “Société”), a été constituée
suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en
date du 19 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 163 du 24 janvier 2009,
et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Emile SCHLESSER, en date du 10
novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3131 du 20 décembre 2011;
- Que le comparant est le seul associé actuel (l'“Associé Unique”) de la Société et qu'il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social à L-5826 Hesperange, 40, rue de Gasperich, et de modifier sub-
séquemment l'article 4 des Statuts afin de lui donner les teneurs suivantes:
“ Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (GrandDuché de Luxembourg). L'adresse du siège
social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.
69777
L
U X E M B O U R G
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant
comme en matière de modification des statuts.
Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs
aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.”
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de supprimer dans l'article 6 des Statuts toute référence à l'attribution et à la libération des
parts sociales.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant
a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. KARVELLAS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 31 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/7020. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré à la société.
Luxembourg, le 15 avril 2015.
Référence de publication: 2015058051/45.
(150066241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
European Infrastructure Investments 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 185.776.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 30 mars 2015, a renouvelé les mandats des gérants:
- Mme Karen DEAL, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y4QU Londres, Royaume-Uni, gérant de catégorie
A,
- Mr Stéphane KOFMAN, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y4QU Londres, Royaume-Uni, gérant de
catégorie A,
- Mr Manuel HACK, Maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant de catégorie B,
- Mr Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant
de catégorie B,
- Mme Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant de caté-
gorie B.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
Luxembourg, le 20 avril 2015.
<i>Pour EUROPEAN INFRASTRUCTURE INVESTMENTS 1
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2015058054/23.
(150067026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
European Infrastructure Investments 3, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 143.755.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 30 mars 2015, a renouvelé les mandats des gérants:
- Mr Bryn JONES, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y4QU Londres, Royaume-Uni, gérant de catégorie
A,
69778
L
U X E M B O U R G
- Mme Karen DEAL, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y4QU Londres, Royaume-Uni, gérant de catégorie
A,
- Mr Stéphane KOFMAN, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y4QU Londres, Royaume-Uni, gérant de
catégorie A,
- Mr Manuel HACK, Maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant de catégorie B,
- Mr Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant
de catégorie B,
- Mme Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant de caté-
gorie B.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
Luxembourg, le 20 avril 2015.
<i>Pour EUROPEAN INFRASTRUCTURE INVESTMENTS 3
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2015058055/25.
(150067027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
European Motorway Investments 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 148.122.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 30 mars 2015, a pris note du non-renouvellement de mandat de Monsieur Bryn
JONES aux fonctions de gérant de la société et a nommé comme nouveau gérant.
- Mr Stéphane KOFMAN, gérant de catégorie A, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU Londres,
Royaume-Uni.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
L'associé unique, dans ses résolutions du 30 mars 2015 a renouvelé les mandats des gérants.
- Mrs Karen DEAL, gérant de catégorie A, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU Londres, Royaume-
Uni.
- Mrs Stéphanie GRISIUS, gérant de catégorie B, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxem-
bourg.
- Mr Manuel HACK, gérant de catégorie B, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
- Mr Laurent HEILIGER, gérant de catégorie B, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
Luxembourg, le 20 avril 2015.
<i>Pour EUROPEAN MOTORWAY INVESTMENTS 2
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2015058056/26.
(150066842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
European Motorway Investments 3, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 185.819.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 30 mars 2015, a renouvelé les mandats des gérants.
- Mrs Karen DEAL, gérant de catégorie A, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU Londres, Royaume-
Uni.
- Mr Stéphane KOFMAN, gérant de catégorie A, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y4QU Londres,
Royaume-Uni.
- Mrs Stéphanie GRISIUS, gérant de catégorie B, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxem-
bourg.
69779
L
U X E M B O U R G
- Mr Manuel HACK, gérant de catégorie B, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
- Mr Laurent HEILIGER, gérant de catégorie B, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
Luxembourg, le 20 avril 2015.
<i>Pour EUROPEAN MOTORWAY INVESTMENTS 3
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2015058058/23.
(150067025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Eversholt Investment Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 102.805,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 156.116.
Il résulte de contrats signés sous seing privé en date du 16 avril 2015 que 100.002 parts sociales A de et 1.350 parts
sociales B ont été cédées à CK Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 194634 (l'Acquéreur), réparties comme suit:
- Clive Lewis Thomas, associé de la Société, a cédé l'ensemble des 449 parts sociales B qu'il détenait dans la Société à
l'Acquéreur;
- Mary Bridget Kenny, associé de la Société, a cédé l'ensemble des 901 parts sociales B qu'elle détenait dans la Société
à l'Acquéreur; et
- Eversholt Investment Group S.C.S., a cédé l'ensemble des 100.002 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à
l'Acquéreur.
En conséquence de quoi, avec effet au 16 avril 2015, CK Investments S.à r.l. détient désormais 100.002 parts sociales
A et 1.350 parts sociales B dans la Société.
Pour extrait conforme et sincère
Eversholt Investment Group (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015058059/24.
(150066228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
ECommerce Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.613,00.
Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 177.435.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg.
Suite à une fusion, la dénomination de l'associé de la Société, Al Lendico Holdings LLC, a changé et doit désormais se
lire comme suit:
- Al ZENCAP HOLDINGS LLC
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2015.
ECommerce Holding II S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015058060/17.
(150066532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
69780
L
U X E M B O U R G
ECEF-IHV SA, Société Anonyme de Titrisation.
Capital social: EUR 31.003,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 146.903.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2015:i>
- Est nommé administrateur de classe B de la société pour une période indéterminée Mons. Kailash Ramassur, employée
privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement l'adminis-
trateur démissionnaire Mme. Anja Wunsch, avec effet au 17 avril 2015.
Luxembourg, le 17 avril 2015.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015058061/15.
(150067022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
ECL German Logistics Holding No. 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 196.190.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the second day of April,
Before Maître Pierre PROBST, notary residing in Ettelbrück (Grand Duchy of Luxembourg)
There appeared:
“Eagle Capital Logistics No.1 S.A., société anonyme.“, a public limited liability company, not yet registered at the
Registrar of Companies of Luxembourg with registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg here represented by
Ms. Nadine Closter, professional address in L-9087 ETTELBRUCK, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy
given dated 31
th
March 2015;
The proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact these Articles of Association
of a société à responsabilité limitée, which it declares to incorporate between themselves:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name " ECL
German Logistics Holding No. 1" which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"),
and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by
the present articles of association (hereafter the "Articles").
Art. 2. The Company's corporate object is to take participations, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, in any
form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other companies or enterprises; to acquire by way of sub-
scription, purchase, exchange or in any other manner any stock, units and/or other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and more generally any securities and/or financial instru-
ments issued by any public or private entity whatsoever; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any
assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operations which is directly or indirectly related to its
purpose.
The Company may carry out any activities in relation to the management of any commercial, industrial, financial or
other companies or enterprises, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven in the Grand Duchy of
Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for the amendments to the Articles.
However, the Board of Managers (as defined below in article 10 of the Articles) of the Company is authorised to transfer
the registered office of the Company within the same municipality.
69781
L
U X E M B O U R G
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Lu-
xembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 4. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. Capital - Units
Art. 5. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) units. Each unit has a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one unitholder)
or by a decision of the general meeting of unitholders (in case of plurality of unitholders), in accordance with article 16 of
the Articles.
In addition to the issued corporate capital, a premium account into which a premium paid on any unit in addition to its
value may be transferred and a capital reserve account 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres» may
be set up by a decision of the unitholders’ meeting or by a decision of the sole unitholder.
Art. 7. Each unit entitles the holder thereof to a portion of the Company's assets and profits, in direct proportion to the
number of units in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely transferable.
In case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the requirements
of articles 189 and 190 of the Law.
In addition, each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any unit without the prior written
consent of the Board of Managers (as defined below).
Chapter III. Management
Art. 10. The Company is managed by a board of managers (the "Board of Managers" and each member a "Manager")
of at least two (2) members. The members of the Board of Managers need not be unitholders.
The Managers are appointed for an unlimited period of time. Each Manager may be removed at any time, regardless of
the method of their appointment, for legitimate reasons only, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.
Art. 11. In dealing with third parties and without prejudice to articles 10 and 12 of the present Articles, the Board of
Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all
administration and disposition acts and operations consistent with the Company's objects.
All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of unitholders fall within the com-
petence of the Board of Managers.
Art. 12. Towards third parties, the Company shall be validly bound by the joint signature of any two Managers or by
the signature of a Manager and any person to whom such power shall be delegated by the Board of Managers.
Art. 13. Any Manager may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents. Any Manager will
determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of its agency.
Art. 14. The meetings of the Board of Managers are convened by at least one Manager. In case all the Managers are
present or represented, they may waive all convening requirements and formalities. Meetings of the Board of Managers
shall be held at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as the Manager or the Board of
Managers may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or
email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to
be confirmed in writing at a later stage.
The resolutions of the Board of Managers are validly adopted if approved by a majority of the members of the Board
of Managers, present or represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member
of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by telephone.
69782
L
U X E M B O U R G
Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members
of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram
or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers' meetings, physically
held.
Votes may also be cast by mail, fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is
confirmed in writing.
The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting.
Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any two Managers or during a meeting of the
Board of Managers.
Chapter IV. General Meeting of Unitholders
Art. 15. Each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of units which he owns. Each
unitholder has voting rights commensurate with his unit holding.
In case of one unitholder owning all the units, it assumes all powers conferred to the general meeting of unitholders and
its decisions are recorded in writing.
Art. 16. Unitholders meetings may always be convened by any Manager, failing which by unitholders representing more
than half of the capital of the Company.
The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of unitholders does not exceed twenty-five.
In such a case, each unitholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted
and shall give his vote in writing.
Should the Company have more than twenty-five unitholders, at least one annual general meeting must be held each
year.
Whatever the number of unitholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the unitholders
for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Managers.
Collective decisions of unitholders are only validly taken insofar as unitholders owning more than half of the corporate
capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the unitholders shall be
convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast,
regardless of the portion of capital represented.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least three-
quarters of the Company's corporate capital in accordance with any provisions of the Law.
Moreover, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its unitholders may be increased
only with the unanimous consent of all the unitholders and in compliance with any other legal requirement.
Chapter V. Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year.
Art. 18. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers prepares
an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated
to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's corporate capital.
To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by Law
and by the Articles, the Board of Managers shall propose that funds available be distributed.
The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the general
meeting of the unitholders.
The Board of Managers may however decide to pay interim dividends. In such case, the general meeting of unitholders
shall ratify the interim dividends and shall, upon proposal from the Board of Managers and within the limits provided by
Law and the Articles decide to distribute what has not been paid as interim dividends or otherwise.
Chapter VI. Dissolution - Liquidation
Art. 20. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of one of the unitholders.
Art. 21. The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the unitholders representing
three-quarters of the Company's corporate capital.
The liquidation will be carried out by one or several liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who
shall determine their powers and remuneration.
69783
L
U X E M B O U R G
Chapter VII. Applicable Law
Art. 22. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate 31
st
of December 2015.
<i>Payment of the unitsi>
All the units have been subscribed by the sole unitholder Eagle Capital Logistics No. 1 S.A., prenamed, and totally paid
up so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the
company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as
a result of its formation, is approximately valued at eight hundred Euros.
<i>Decisions of the sole unit-Owneri>
Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named unit owner took the following resolutions:
1.- The registered office is established at L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
2.- Are appointed as managers of the Board of Managers for an undetermined period:
Mr. Ole Marquardt, employee, having his professional address at L- 1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, born on 15
August 1976, in Rotenburg/Wümme, Germany.
Mr. Fritz Nehrig, employee, having his professional address at D- 20355 Hamburg, Valentinskamp 70, born on 19
January 1970 in Laatzen, Germany.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
1. WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Ettelbrück, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status
and residence, the said appearing party signed together with us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend und fünfzehn, den zweiten April.
Vor dem amtierenden Notar Pierre PROBST, mit Amtswohnsitz in Ettelbrück, Grossherzogtum Luxemburg.
Ist Erschienenen:
Eagle Capital Logistics No. 1 S.A., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit eingetragenem Sitz in 5, Heienhaff,
L-1736 Luxembourg, noch nicht registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg (R.C.S. Luxembourg),
hier vertreten durch Frau Nadine Closter, Angestellte, beruflich ansässig in L-9087 Ettelbruck, auf Grund einer ihr
ausgestellten Vollmacht.
Besagte Vollmacht wird nach gehöriger „ne varietur“ Signatur, durch die Erschienene und den amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen.
Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, welche Sie hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:
Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen „ECL
German Logistics Holding No. 1” gegründet (im Folgenden: die "Gesellschaft"), welche dieser Satzung (im Folgenden:
die "Satzung") und den Gesetzen unterstehen wird, die eine solche juristische Person betreffen, insbesondere dem Gesetz
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung (im Folgenden: das "Gesetz").
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist es, Beteiligungen in jedweder Form an Handels-, Industrie-, Finanz- oder anderen
Gesellschaften oder Unternehmen, im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland, zu erwerben; durch Zeichnung, Kauf,
Austausch oder auf andere Art und Weise insbesondere jegliche Aktien, Anteile und/oder andere Beteiligungswertpapiere,
Schuldverschreibungen, Obligationsanleihen, Hinterlegungszertifikate und/oder andere Schuldtitel sowie im allgemeinen
jegliche Wertpapiere und/oder Finanzinstrumente, die von einer öffentlichen oder privaten Einrichtung begeben werden,
zu erwerben; Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält, jedwede Unterstützung, Darlehen, Vorteile
69784
L
U X E M B O U R G
oder Garantien zu gewähren und schließlich jede Maßnahme durchzuführen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck
verbunden ist.
Die Gesellschaft darf geschäftsführende Tätigkeiten im Zusammenhang mit Handels-, Industrie-, Finanz- oder anderen
Gesellschaften oder Unternehmen, im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland, ausüben.
Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die direkt oder indirekt
mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft wird in der Gemeinde Niederanven, Großherzogtum Luxembourg, errichtet.
Er kann entsprechend der für eine Änderung der Satzung geltenden gesetzlichen Bestimmungen durch Beschluss einer
außerordentlichen Generalversammlung ihrer Anteilinhaber an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.
Der Geschäftsführerrat der Gesellschaft (wie nachstehend in Artikel 10 dieser Satzung definiert) ist hingegen berechtigt
den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde zu verlegen.
Sollte eine Situation entstehen oder als unmittelbar bevorstehend erscheinen, die eine normale Tätigkeit am Sitz der
Gesellschaft aus militärischen, politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Gründen verhindert, darf der Sitz der
Gesellschaft vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis sich die Situation wieder normalisiert; solche zeitlich be-
grenzten Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche unabhängig von einer zeitlich
begrenzten Verlegung des Sitzes eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung zu einer Verlegung des Sitzes
ins Ausland wird vom Geschäftsführerrat getroffen.
Die Gesellschaft darf Büros und Zweigstellen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.
Art. 4. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.
Kapitel II. Kapital - Anteile
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünf-
hundert (12,500) Anteile. Jeder Anteil hat einen Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-).
Art. 6. Das Kapital darf gemäß Artikel 16 dieser Satzung jederzeit durch einen Beschluss des alleinigen Anteilinhabers
(wenn es nur einen Anteilinhaber gibt) oder durch Beschluss der Generalversammlung der Anteilinhaber (wenn es mehrere
Anteilinhaber gibt) verändert werden.
Zusätzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital kann ein Premium-Konto, auf welches eine hinsichtlich einer Aktie
zusätzlich zu deren Wert geleistete Zahlung übertragen werden kann und ein Kapitalrücklagekonto 115 «Apport en capitaux
propres non rémunéré par des titres» durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilsinhaber oder durch Beschluss des
alleinigen Anteilsinhabers eingerichtet werden.
Art. 7. Jeder Anteil gewährt dem jeweiligen Inhaber einen Anteil am Vermögen und am Gewinn der Gesellschaft, im
unmittelbaren Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile.
Art. 8. Da je Anteil nur ein Inhaber zugelassen ist sind die Gesellschaftsanteile gegenüber der Gesellschaft unteilbar.
Mitinhaber müssen eine einzelne Person als Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.
Art. 9. Wenn es nur einen Anteilinhaber gibt, sind die von diesem gehaltenen Gesellschaftsanteile frei übertragbar.
Wenn es mehrere Anteilinhaber gibt, dürfen die Anteile, die von jedem Anteilinhaber gehalten werden, unter Anwen-
dung der Voraussetzungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden.
Zusätzlich willigt jeder Anteilinhaber dazu ein, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Geschäftsführerrates
(wie nachfolgend definiert), kein Sicherungsrecht an einem Anteil einzuräumen oder zu verpfänden.
Kapitel III. Geschäftsführung
Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführerrat (der "Geschäftsführerrat" und jedes Mitglied ein "Ge-
schäftsführer") mit mindestens zwei (2) Mitgliedern geführt. Die Mitglieder des Geschäftsführerrates brauchen keine
Anteilinhaber zu sein.
Die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Zeit ernannt. Jeder Geschäftsführer darf jederzeit, ungeachtet der Art und
Weise seiner Ernennung, nur aus legitimen Gründen durch Beschluss von Anteilinhabern, welche die Mehrheit der Anteile
halten, entlassen werden.
Art. 11. Unbeschadet der Artikel 10 und 12 dieser Satzung hat der Geschäftsführerrat Dritten gegenüber grundsätzlich
unbeschränkte Befugnis unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Verwaltungshandlungen,
Verfügungen und Maßnahmen auszuführen und zu genehmigen die dem Zweck der Gesellschaft entsprechen.
Alle Befugnisse, die weder von Gesetzes wegen noch durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung der
Anteilsinhaber vorbehalten sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführerrates.
Art. 12. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäfts-
führern oder durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers zusammen mit einer Person, der diese Befugnis
durch den Geschäftsführerrat eingeräumt wurde, verpflichtet.
69785
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Jeder Geschäftsführer darf seine Befugnisse für spezifische Aufgaben auf einen oder mehrere eigens zu diesem
Zweck Beauftragte übertragen.
Jeder Geschäftsführer wird die Kompetenzen, das Entgelt (wenn ein solches vereinbart wird), die Dauer der Vertre-
tungsbefugnis und jegliche andere relevanten Bedingungen dieser Beauftragung eines solchen Beauftragten festlegen.
Art. 14. Die Sitzungen des Geschäftsführerrates werden durch mindestens einen Geschäftsführer einberufen. Wenn alle
Geschäftsführer persönlich anwesend oder vertreten sind können sie auf alle Einberufungserfordernisse und -formalitäten
verzichten. Sitzungen des Geschäftsführerrates werden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder einem anderen von
dem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat von Zeit zu Zeit bestimmten Ort in Luxemburg abgehalten.
Jeder Geschäftsführer darf sich bei Sitzungen des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlichen oder durch Tele-
gramm oder Telefax, Email oder Brief erteilten Vollmacht durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen. Ein
Geschäftsführer darf auch einen anderen Geschäftsführer dazu bestimmen, ihn per Telefon zu vertreten, was schriftlich zu
einem späteren Zeitpunkt bestätigt werden muss.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates sind rechtsgültig, wenn sie von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer gefasst werden.
Vorrichtungen für Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen können zulässigerweise verwendet werden, wenn alle
teilnehmenden Geschäftsführer in der Lage sind das Gesprochene zu hören und von allen teilnehmenden Geschäftsführern
gehört zu werden, ob sie selbst diese Technologie verwenden oder nicht. Jeder so teilnehmende Geschäftsführer wird als
persönlich anwesend erachtet und ist befugt per Video oder am Telefon abzustimmen.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch per Umlaufbeschluss gefasst werden, wenn sie schrift-
lich genehmigt und von allen Geschäftsführer unterzeichnet werden. Diese Genehmigung darf in einem gemeinsamen
Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten erfolgen, welche per Fax, Email, Telegramm oder Telex verschickt
werden. Diese Beschlüsse haben dieselbe Gültigkeit wie Beschlüsse die auf Sitzungen des Geschäftsführerrates getroffen
werden, welche körperlich abgehalten werden.
Stimmen dürfen auch per Brief, Fax, Email, Telegramm, Telex oder am Telefon abgegeben werden, vorausgesetzt, dass
im letzteren Fall die Stimmabgabe schriftlich bestätigt wird.
Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführerrates ist von allen bei der Sitzung gegenwärtigen oder vertretenen
Geschäftsführern zu unterzeichnen. Auszüge sollen durch einen beliebigen Geschäftsführer oder durch eine von zwei
beliebigen Geschäftsführern bestellte Person oder während einer Sitzung des Geschäftsführerrates beglaubigt warden.
Kapitel IV. Hauptversammlung der Anteilsinhaber
Art. 15. Jeder Anteilsinhaber darf an gemeinsamen Entscheidungen unabhängig von der von ihm gehaltenen Anzahl
von Anteilen teilnehmen. Jeder Anteilsinhaber hat Stimmrecht entsprechend der von ihm gehaltenen Anteile.
Falls ein Anteilsinhaber alle Anteile hält, übernimmt er alle Befugnisse der Hauptversammlung der Anteilsinhaber, und
seine Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.
Art. 16. Versammlungen der Anteilsinhaber dürfen jederzeit von einem beliebigen Geschäftsführer einberufen werden,
sonst durch Anteilsinhaber, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Solange die Anzahl der Anteilsinhaber fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, besteht keine Verpflichtung zum Abhalten
von Versammlungen der Anteilsinhaber. In so einem Fall soll jeder Anteilsinhaber den genauen Wortlaut der Beschlüsse
oder Entscheidungen erhalten und er soll seine Stimme schriftlich abgeben.
Sollte die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Anteilsinhaber haben, muss mindestens eine jährliche Hauptver-
sammlung der Anteilinhaber abgehalten werden.
Unabhängig von der Anzahl der Anteilsinhaber sind die Konten und die Gewinn- und Verlustrechnung den Anteilsin-
habern für ihre Zustimmung vorzulegen. Die Anteilsinhaber sollen auch ausdrücklich darüber abstimmen, ob dem
Geschäftsführerrat Entlastung erteilt wird.
Gemeinsame Entscheidungen der Anteilsinhaber sind nur dann rechtsgültig getroffen, wenn sie von Anteilsinhabern,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, gebilligt werden. Wenn diese Zahl bei einer ersten Versammlung
oder einer ersten schriftlichen Befragung nicht erreicht wird, sollen die Anteilsinhaber ein zweites Mal einberufen oder per
Einschreiben befragt werden. Entscheidungen können dann mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen werden,
unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital.
Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung können nur von Anteilsinhabern, die gemeinsam drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten, in Übereinstimmungen mit den rechtlichen Vorschriften, gefasst werden.
Darüber hinaus kann die Nationalität der Gesellschaft nur verändert und können die Verbindlichkeiten der Anteilsin-
haber nur erhöht werden durch einstimmigen Beschluss aller Anteilsinhaber und in Übereinstimmung mit jeglichen
rechtlichen Voraussetzungen.
Kapitel V. Geschäftsjahr - Konten.
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden
Jahres.
69786
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Am Ende jeden Geschäftsjahres wird der Jahresabschluss der Gesellschaft festgelegt und der Geschäftsführerrat
fertigt eine Bestandsaufnahme an, welche Angabe über den Wert des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft
beinhaltet.
Jeder Anteilsinhaber darf den Jahresabschluss und die Bestandsaufnahme am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 19. Der Bruttogewinn der Gesellschaft nach dem Jahresbericht nach Abzug allgemeiner Unkosten, Abschreibungen
und Kosten entspricht dem Nettogewinn. Ein Betrag von fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns der Gesellschaft ist bestimmt
für die rechtlich vorgeschriebene Reserve, bis diese Reserve zu einem Betrag von zehn Prozent (10 %) des Gesellschafts-
kapitals angestiegen ist.
In dem Maße wie Geldmittel auf Ebene der Gesellschaft für eine Ausschüttung zur Verfügung stehen und in dem Maße,
in dem das Gesetz und diese Satzung es zulassen, darf der Geschäftsführerrat vorschlagen, dass Geldmittel für eine Aus-
schüttung zur Verfügung stehen.
Die Entscheidung über eine Ausschüttung von Geldmitteln und die Bestimmung des auszuschüttenden Betrages wird
von der Hauptversammlung der Anteilsinhaber getroffen.
Der Geschäftsführerrat darf jedoch entscheiden, zwischenzeitlich Gewinne auszuschütten. In einem solchen Fall muss
die Hauptversammlung der Aktionäre diesen zwischenzeitlichen Gewinnausschüttungen zustimmen und sie soll auf Vor-
schlag des Geschäftsführerrates und innerhalb der gesetzlich und von dieser Satzung vorgeschriebenen Grenzen entschei-
den, ob, was nicht im Rahmen einer zwischenzeitlichen Gewinnausschüttung oder sonst wie ausgezahlt wurde, ausgezahlt
werden soll.
Kapitel VI. Auflösung und Liquidation
Art. 20. Der Tod eines Anteilsinhabers, die Aufhebung seiner staatsbürgerlichen Rechte, seine Insolvenz oder sein
Bankrott, führen nicht die Auflösung der Gesellschaft nach sich.
Art. 21. Die Liquidation der Gesellschaft kann nur durch eine Mehrheit der Anteilsinhaber, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertritt, beschlossen werden.
Die Liquidation der wird von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, welche keine Anteilsinhaber zu sein brau-
chen und welche von den Anteilsinhabern ernannt werden. Die Anteilsinhaber bestimmen auch über die Befugnisse und
das Entgelt der Liquidatoren.
Kapitel VII. Anwendbares Recht
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung speziell geregelt sind, gelten die Regelungen des Gesetzes.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Einzahlung der Anteilei>
Alle Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter Eagle Capital Logistics No. 1 S.A., gezeichnet, und in bar
eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Ver-
fügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt achthundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten
der Gesellschaft.
<i>Beschlussfassung Durch den Alleinigen Gesellschafteri>
Anschliessend hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Adresse des Gesellschaftssitzes befindet sich in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
2.- Zu Geschäftsführern des Geschäftsführerrates werden folgende Personen auf unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Ole Marquardt, Geschäftsführer, mit beruflicher Adresse in L- 1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, geboren am
15.01.1976 in Rotenburg/Wümme, Deutschland;
Herr Fritz Nehrig, Angestellter, mit beruflicher Adresse in D-20355 Hamburg, Valentinskamp 70, Deutschland, geboren
am 19.01.1970 in Laatzen.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch des Komparenten gegenwärtige
Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Ersuchen derselben Person und im Falle von
Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER URKUNDE, Errichtet wurde in Ettelbrück, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
69787
L
U X E M B O U R G
Gezeichnet: Nadine CLOSTER, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 15 avril 2015. Relation: DAC/2015/61. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung
im Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 17. April 2015.
Référence de publication: 2015058062/365.
(150066591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Edelweiss Caesar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 171.048.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Edelweiss Caesar S.à r.l.
i>SGG S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015058065/13.
(150066672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
EDI - Européenne de Développement et d'Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.722.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015058066/9.
(150066495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Edmond de Rothschild Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 76.441.
- Il est noté que:
* Monsieur Pierre-Marie VALENNE a démissionné de sa fonction d'Administrateur de la Sicav Edmond de Rothschild
Fund, avec effet au 31 mars 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015058067/11.
(150066144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
EIG Fund XV Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 26.293,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.652.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2015:i>
- Est nommé gérant de classe B de la société pour une période indéterminée Mons. Kailash Ramassur, employée privée,
résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démis-
sionnaire Mme. Anja Wunsch, avec effet au 17 avril 2015.
Luxembourg, le 17 avril 2015.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015058068/15.
(150066536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
69788
L
U X E M B O U R G
EIG Manabi Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 441.835,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 170.409.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2015:i>
- Est nommé gérant de classe B de la société pour une période indéterminée Mons. Kailash Ramassur, employée privée,
résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démis-
sionnaire Mme. Anja Wunsch, avec effet au 17 avril 2015.
Luxembourg, le 17 avril 2015.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015058071/15.
(150066533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Entaulux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 71.712.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015058078/10.
(150066324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
EUR-ASIA Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 146.240.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 16 mars 2015i>
Aldo TRISCIUOGLIO, demeurant professionnellement à L-4751 Pétange au 161 route de Longwy et Mohammed
KARA, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 60 Grand-rue sont renommés Administrateurs.
MATRICE INTERNATIONAL SA, RCSL n° B 80362 démissionnaire est remplacé par Jeanette BECHT, avec adresse
professionnelle à L-4751 Pétange, 161 Route de Longwy.
Fortunato CAUZZO, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 60 Grand-rue, est renommé commissaire
aux comptes.
Ces mandats viendront à échéance lors de l'assemblée à tenir en 2021.
Pour Extrait conforme et sincère
EASIT SA
Référence de publication: 2015058092/17.
(150067169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Esstex S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 33.000,00.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 139.461.
<i>Extrait des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 16 avril 2015i>
1. L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants jusqu'à la tenue de l'assemblée générale
ordinaire annuelle de la Société en relation avec les comptes clos au 31 décembre 2015:
- Monsieur Ressegaire Serge, Administrateur-Délégué et Président, demeurant au 20 rue Abel Ferry F-88000 Epinal
(France)
- La société SAS Bistextile, dont le siège social est au 1 Allée du Solier F-43220 Dunières (France)
- La société SAS Les Epinettes, dont le siège social est au 96 Chemin des Epinettes F-88400 Gérardmer (France)
69789
L
U X E M B O U R G
2. L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la Société, AAKAPA ADVISORY
BUSINESS SERVICES S.à r.l. en abrégé, A.A.B.S. S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le n° B106680 et ayant son siège social au 40, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, jusqu'à la tenue
de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société en relation avec les comptes clos au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015058091/20.
(150066831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Eura-Audit Luxembourg SA, Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 44.227.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2015i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 30 mars 2015:
- L'Assemblée révoque de sa fonction de Commissaire aux Comptes la société AUDIT CENTRAL SARL et ce, à compter
de l'exercice 2010.
- L'Assemblée nomme en tant que Commissaire aux Comptes:
* Madame Aude GRENOUILLET, née le 28 mars 1982 à Metz, demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston
Diderich L-1420 Luxembourg
à compter de l'exercice 2010 et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale tenue en 2016.
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2015058093/17.
(150066572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Esso Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Luxembourg, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 7.310.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2015.
Référence de publication: 2015058089/10.
(150067141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Essential Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 64.426.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 juin 2014i>
1. Est réélu administrateur Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, demeurant professionnellement 44, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020.
2. Est réélu administrateur Monsieur Natale Capula, comptable, demeurant professionnellement 44, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020.
3. Est réélu commissaire aux comptes, la société F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7
th
Street,
Suite C Las Vegas, NV 89101, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 30 juin 2014.
Référence de publication: 2015058087/17.
(150066853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
69790
L
U X E M B O U R G
Koch Business Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 134.561.
L'an deux mil quinze,
le Pardevant Nous Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) Monsieur Johannes Koch, commerçant, né à Goes (Pays-Bas) le 1
er
juin 1968, demeurant à B-9190 Stekene (Bel-
gique), Hellestraat 205,
agissant en sa qualité de "associé" de la société Koch Business Solutions S.à r.l. ci-après qualifiée.
2) La société ACE LIMITED, société de droit de Guernesey, ayant son siège social à Granary House, The Grange, St.
Peter Port, GY1 2QG, (Guernesey), inscrite auprès du registre de commerce de Guernesey sous le numéro 54 059,
cette société agissant en sa qualité de "associé" de la société Koch Business Solutions S.à r.l. ci-après qualifiée,
représentée aux fins des présentes par Islands Directeurs HMSL Services Limited, en tant que directeurs, respectivement
représentés par Monsieur Andrew PARR et Monsieur Alan NOTHMORE,
tous ici représentés par Madame Carina RODRIGUES, secrétaire, née à Luxembourg le 12 janvier 1990, demeurant
professionnellement à L-9227 Diekirch (Luxembourg), 50, Esplanade,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées le 20 mars 2015,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées "ne varietur" par le notaire instrumentant et le mandataire de la Com-
parante, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle Comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Que les actionnaires présents ou représentés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Koch Business
Solutions S.à r.l., n’ayant actuellement plus de siège social,
constituée et régie selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire Henri Beck de résidence
à Echternach le 12 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 145 du 18 janvier
2008, et dont les statuts n’ont pas été modifiés.
ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le siège social de la société à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant
la teneur suivante:
“ Art. 5. Le siège social est établi à Diekirch.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de
l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.”
<i>Déclaration des comparantsi>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l’objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du
capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction
visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-5 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison du présent
acte sont évalués approximativement à huit cents euros (800,00 €).
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénoms, états
et demeures, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Carina RODRIGUES, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 25 mars 2015. Relation: DAC/2015/4992. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
69791
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 20 avril 2015.
Référence de publication: 2015058273/57.
(150066726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Kairos Investissements S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 183.366.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015058276/10.
(150066498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Compagnie Aéronautique du Grand-Duché de Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6112 Junglinster, 7A, rue de Bourglinster.
R.C.S. Luxembourg B 23.275.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015056809/9.
(150065449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2015.
Cameron Balloons Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6112 Junglinster, 7A, rue de Bourglinster.
R.C.S. Luxembourg B 31.061.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015056813/9.
(150065422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2015.
E-Connect Online Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 180.073.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015056843/10.
(150065097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2015.
LEOX S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-6942 Niederanven, 6, rue Goesfeld.
R.C.S. Luxembourg B 161.953.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015056956/10.
(150065271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
69792
Cameron Balloons Luxembourg
Compagnie Aéronautique du Grand-Duché de Luxembourg S.A.
Defi3 Alpha Lux
Deltatrans International S.A.
Deltatrans International S.A.
Deltatrans International S.A.
Desideratum
Deutsche Mexico Holdings S.à r.l.
Dialogiques
Dialogiques
Diga Consulting SA
Direct Marketing Services S.A.
DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.
DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.
Diy-Tech S.A.
DMA Holdings S.A.
DSP Hydrolux S.A.
Dumark Lux S.A.
Dynamic Finance SA
ECEF-IHV SA
ECL German Logistics Holding No. 1
ECommerce Holding II S.à r.l.
E-Connect Online Marketing S.à r.l.
Edelweiss Caesar S.à r.l.
EDI - Européenne de Développement et d'Investissement S.A.
Edmond de Rothschild Fund
EIG Fund XV Lux Holdings S.à r.l.
EIG Manabi Holdings S.à r.l.
Entaulux S.A.
Essential Finance S.A.
Esso Luxembourg
Esstex S.A.
Eura-Audit Luxembourg SA
EUR-ASIA Invest S.A.
European Credit X S.à r.l.
European Credit Y S.à r.l.
European Infrastructure Investments 1
European Infrastructure Investments 3
European Motorway Investments 2
European Motorway Investments 3
Europe Trade Shows Consulting S.à r.l.
Eversholt Investment Group (Luxembourg) S.à r.l.
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation
Kairos Investissements S.à r.l. SPF
Koch Business Solutions S.à r.l.
LEOX S.à r.l.