logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1396

2 juin 2015

SOMMAIRE

Buildco Warsaw S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66962

Caballo Fello S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66962

Café Beim Marco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66975

Carignan Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66962

Carlo Invest S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66962

Catalyst Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66963

Celanese International Holdings Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66963

Cessna S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66975

Cesto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66975

Cesto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66976

CGI Luxembourg SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66976

Chimica Sospirolo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66976

CHSM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66976

Class Real Estate Investments S.à r.l.  . . . . . . .

66968

Clowns4u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66968

Coditel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66971

Cogetech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66980

Communauté Agricole Soprana . . . . . . . . . . . .

66983

Compagnie Internationale de Participations

Automobiles S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66980

ContourGlobal Development S.à r.l.  . . . . . . . .

66971

ContourGlobal Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

66971

Cournoise Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

66971

Covidien Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66972

Creathor Venture Management Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66972

Credit Opportunity One S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

66972

Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF  . . . . . . . .

66972

Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF  . . . . . . . .

66973

Crystal GP S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66973

Cube Infrastructure Fund  . . . . . . . . . . . . . . . .

66975

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung A

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66994

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung A

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66994

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung B

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66995

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung B

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66995

Dragon Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66985

East&West Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66997

Eclaircie s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66998

EdgeWorth Capital (Luxembourg) S.à r.l.  . . .

66995

EDU Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66998

Entreprise Jacques Streff Services S.A.  . . . . .

66996

Goodhart Partners Longitude Fund Sicav-SIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66998

Grand Shanghai s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67008

Pépinière Weisen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67008

Shaftesbury GP 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66973

66961

L

U X E M B O U R G

Buildco Warsaw S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 170.706.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2014.

Nomination de Monsieur Steven DE BIE, né le 3 février 1974 à Antwerpen (B), adresse 19, Salvialei B-2540 Hove en

tant qu'Administrateur B en remplacement de Monsieur Paul MOUTON Administrateur B décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018

<i>Pour la société
BUILDCO WARSAW S.A.

Référence de publication: 2015054706/13.
(150063179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Caballo Fello S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3333 Hellange, 53, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 150.183.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015054708/10.
(150062692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Carignan Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 166.068.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Carignan Holding S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015054709/12.
(150062781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Carlo Invest S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 1, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 159.708.

<i>Auszug aus dem Protokoll über die ausserordentliche Generalversammlung der Carlo Invest S.A. SPF Abgehalten am Sitz

<i>der Gesellschaft am 26.3.2015

Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf vier (4) festzulegen und dements-

prechende Ernennung von Frau Vivian Hasenclever, geboren am 15. Dezember 1969 in Larvik (Norwegen), wohnhaft in
L-8085 Bertrange, 15, rue Dicks, Herr Gordon Hasenclever, geboren am 24. August 1970 in Bremen (D), wohnhaft in
L-8085 Bertrange, 15, rue Dicks und Herr Jan Petter Thomassen, geboren am 4. September 1964 in Sarpsborg (Norwegen),
beruflich wohnhaft in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur or-
dentlichen Generalversammlung des Jahres 2015.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Mandat von Herrn Karl Andreas Bruun URDSHALS als Verwaltungsrats-

mitglied der Gesellschaft bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016 zu bestätigen.

66962

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 26.03.2015.

Für gleichlautenden Auszug
Hans-Joachim GERNERT
<i>VOLLMACHTNEHMER

Référence de publication: 2015054710/24.
(150062604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Catalyst Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.824.

En date du 8 avril 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Démission de Lawrence King de son poste de gérant A avec effet au 1 

er

 avril 2015;

- Démission de Gérald Welvaert de son poste de gérant B avec effet au 1 

er

 avril 2015;

- Démission de Jean-Jacques Josset de son poste de gérant B avec effet au 1 

er

 avril 2015

- Election de Catalyst GP 2 Limited, société à responsabilité limitée, immatriculée au Companies House sous le numéro

06518354 et ayant son siège social au c/o Hardy &amp; Co, Woodhead House, 44-46 Market Street, Hyde, Cheshire, SK141AH,
Royaume-Uni, au poste de gérant de Classe A avec effet au 1 

er

 avril 2015 et pour une durée indéterminée;

- Election de Manacor (Luxembourg) S.A., société anonyme, immatriculée au Registre des Commerces du Luxembourg

sous le numéro B9098 et ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg, au poste
de gérant de Classe B avec effet au 1 

er

 avril 2015 et pour une durée indéterminée;

- Election de Mutua (Luxembourg) S.A. société anonyme, immatriculée au Registre des Commerces du Luxembourg

sous le numéro B41471 et ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg, au
poste de gérant de Classe B avec effet au 1 

er

 avril 2015 et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TMF Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015054711/24.
(150063070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.365.720.800,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 118.247.

In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of March.
In front of Francis Kesseler, notary public established in the city of Esch-sur-Alzette.

There appeared

Ticona LLC, a limited liability company organized under the laws of the state of Delaware, United States of America,

having its registered office located at 1209, Orange Street, 19801 New Castle, Delaware, United States of America and
registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 2795049 (the “Contributor”), and Celanese
US Holdings LLC, a limited liability company organized under the laws of the state of Delaware, United States of America,
having its registered office located at 1209, Orange Street, 19801 New Castle, Delaware, United States of America and
registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3780476 (the “Shareholders”).

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard,

L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies having been signed “ne varietur' by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties hereby represented as described above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I. The appearers constitute all of the shareholders of “Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.1.”, a Luxem-

bourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 4A, rue Henri
Schnadt,  L-2530  Luxembourg,  Grand-Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies
Register under number B 118.247, incorporated by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary public established in

66963

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, on 18 July 2006, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (the “Mémorial C”)
number 1788, dated 25 September 2006 (the “Company”).

II. The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed enacted on 24 November

2014 by the undersigned notary.

III. That the 22,967,868 (twenty-two million, nine hundred sixty-seven thousand, eight hundred sixty-eight) shares

having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each and representing the whole share capital of the Company,
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Shareholders expressly
state having been duly informed beforehand.

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 68,934,000 (sixty-eight million, nine hundred

thirty-four thousand Euros), so as to increase it from its current amount of EUR 2,296,786,800 (two billion, two hundred
ninety-six million, seven hundred eighty-six thousand, eight hundred Euros) to EUR 2,365,720,800 (two billion, three
hundred sixty-five million, seven hundred twenty thousand, eight hundred Euros) by the issuance of 689,340 (six hundred
eighty-nine thousand, three hundred forty) shares with a nominal value of EUR l00 (one hundred Euros) each;

3. Subscription and payment by Ticona LLC of the new shares by the contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the Shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders ack-

nowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate
and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the
disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow the Shareholders to examine carefully each
document.

<i>Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company with effect as of the date of these resolutions by an amount

of EUR 68,934,000 (sixty-eight million, nine hundred thirty-four thousand Euros) (the “Share Capital Increase”) so as to
raise it from its current amount of EUR 2,296,786,800 (two billion, two hundred ninety-six million, seven hundred eighty-
six thousand, eight hundred Euros) to EUR 2,365,720,800 (two billion, three hundred sixty-five million, seven hundred
twenty thousand, eight hundred Euros) by the issuance of 689,340 (six hundred eighty-nine thousand, three hundred forty)
new shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each (the “New Shares”) in favor of the Contributor,

the subscription price for the New Shares to be fully paid up through a contribution (the “Contribution”) in kind of all

the shares in Celanese Netherlands Holdings B.V., a private company with limited liability organized under Dutch law,
having its registered office in Amsterdam, the Netherlands and its office address at Strawinskylaan 3105 1077 ZX Ams-
terdam, the Netherlands (“DutchCo”).

<i>Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares referred to above by a

contribution in kind with effect as of the date of these resolutions.

<i>Intervention of the contributor - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, pre-named. The Contributor

declares to subscribe the New Shares in the Company and to pay them entirely by a contribution in kind hereafter described.

The subscription price for the New Shares has been fully paid up by the Contributor through the Contribution.

<i>Description of the contribution

All the shares in DutchCo.

<i>Valuation

The net value of the Contribution is of EUR 146,762,386 (one hundred forty-six million, seven hundred sixty-two

thousand, three hundred eighty-six Euros).

Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution dated 27

February 2015, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it with it to the formality of registration.

66964

L

U X E M B O U R G

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene:
- Mr. Jean-François Findling, with professional address at 10-12 Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, manager

of category A;

- Mr. John Sutherland, with a professional address at 4a, rue Henri Schnadt. L-2530 Luxembourg, manager of category

A;

- Mr. Ronnie D. Berry, with a professional address at 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039,

manager of category B; and

- Mr. Jiong (Thomas) Liu, with a professional address at 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039,

manager of category B.

all here represented by Mrs. Sofia Da Chao Conde, pre-named, in accordance with the provisions of the statement of

contribution value established 27 February 2015;

acting in their capacity as managers of the Company, require the notary to act as follows:
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the

Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of the Contribution,
with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

The balance of EUR 77,828,386 (seventy-seven million, eight hundred twenty-eight thousand, three hundred eighty-six

Euros) of the value of the Contribution exceeding the nominal value of the New Shares shall be allocated as follows: EUR
54,171,178 (fifty-four million, one hundred seventy-one thousand, one hundred seventy-eight Euros) to the share premium
account of the Company, and EUR 23,657,208 (twenty-three million, six hundred fifty-seven thousand, two hundred eighty
Euros) to the legal reserve of the Company.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the

shareholding of the Company now composed of:

- Ticona LLC: 20,108,627 (twenty-million, one hundred eight thousand, six hundred twenty-seven) shares; and Celanese

US Holdings LLC: 3,548,581 (three million, five hundred forty-eight thousand, five hundred eighty-one) shares.

The notary acts that the 23,657,208 (twenty-three million, six hundred fifty-seven thousand, two hundred eight) shares,

representing the whole share capital of the Company are presented so that the meeting can validly decide on the resolution
taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, it is resolved to amend the first paragraph of article 6 of the articles of

association of the Company to read as follows:

“ Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 2,365,720,800 (two billion, three hundred sixty-five million,

seven hundred twenty thousand, eight hundred Euros) represented by 23,657,208 (twenty-three million, six hundred fifty-
seven thousand, two hundred eight) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each.”

No other amendment shall be made to this article.

<i>Declaration

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about 7.000 euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de mars.
Par-devant Francis Kesseler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

Ticona LLC, société à responsabilité limitée constituée selon le droit de l’état du Delaware, Etats-Unis d’Amérique,

ayant son siège social sis au 1209, Orange Street, 19801 New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, et enregistrée
auprès du Secrétaire d'Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 2795049 (l'"Apporteur"), et Celanese US Holdings LLC,
une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de l’état du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège

66965

L

U X E M B O U R G

social sis au 1209, Orange Street, 19801 New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, et enregistrée auprès du Secrétaire
d'Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 3780476 (les “Associés”),

ici représentées par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations ayant été paraphée "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes

et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'en-
registrement.

Les parties comparantes, représentées telle que décrit ci-dessus, ont requis du notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I - Les parties comparantes sont les associés de «Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l.», une société à

responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 4A, rue Henri M. Schnadt,
L-2530  Luxembourg,  Grand  Duché  de  Luxembourg,  enregistrée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg sous le numéro B 118.247, constituée par acte pris par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg, en date du 18 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Memorial C») numéro 1788, en date du 25 septembre 2006 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 24 novembre 2014 par un acte du notaire

soussigné.

II - Que les 22.967.868 (vingt-deux million neuf cent soixante-sept mille huit cent soixante-huit) parts sociales ayant

une valeur nominale de 100 Euros (cent Euros) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont repré-
sentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour, dont les Associés
reconnaissent avoir été dûment préalablement informé.

III- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 68.934.000 EUR (soixante-huit million neuf cent trente-

quatre mille Euros) afin de le porter de son montant actuel de 2.296.786.800 EUR (deux milliard deux cent quatre-vingt-
seize million sept cent quatre-vingt-six mille huit cent Euros) à 2.365.720.800 EUR (deux milliard trois cent soixante-cinq
million sept cent vingt mille huit cent Euros) par l’émission de 689.340 (six cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante)
nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 100 Euros (cent Euros) chacune;

3. Souscription et paiement par Ticona LLC des nouvelles parts sociales par un apport en nature;
4. Nouvelle composition du capital de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé que les Associés renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée;

les Associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour et considèrent avoir été valablement con-
voqués et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est en outre décidé
que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition des Associés dans un délai suffisant afin de permettre les
Associés un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société avec effet à compter de la date de ces résolutions d’un montant

de 68.934.000 EUR (soixante-huit million neuf cent trente-quatre mille Euros) (l'«Augmentation du Capital») afin de le
porter de son montant actuel de 2.296.786.800 EUR (deux milliard deux cent quatre-vingt-seize million sept cent quatre-
vingt-six mille huit cent Euros) à 2.365.720.800 EUR (deux milliard trois cent soixante-cinq million sept cent vingt mille
huit cent Euros) par l’émission de 689.340 (six cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante) nouvelles parts sociales
d’une valeur nominale de 100 Euros (cent Euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») en faveur de l'Apporteur.

Le prix de souscription des Nouvelles Parts Sociales devant être entièrement payé par un apport (l'«Apport») en nature

constant en toutes les parts sociales de Celanese Netherlands Holdings B.V., une société à responsabilité limitée constituée
selon le droit des Pays-Bas, ayant son siège social sis au Amsterdam, les Pays-Bas, et ayant son adresse professionnelle
sis à Strawinskylaan 3105 1077 ZX Amsterdam, les Pays-Bas (la «Société Néerlandaise»).

<i>Troisième résolution:

Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par l’Apporteur des Nouvelles Parts Sociales au moyen d'un apport

en nature avec effet à compter de la date de ces résolutions.

66966

L

U X E M B O U R G

<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Paiement

Intervient alors l'Apporteur, représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée. L'Apporteur déclare sou-

scrire aux Nouvelles Parts Sociales et de les payer entièrement au moyen de l' Apport.

La souscription des Nouvelles Parts Sociales a été entièrement payée par l'Apporteur au moyen de l'Apport.

<i>Description de l'apport

Toutes les parts sociales de la Société Néerlandaise.

<i>Evaluation

La valeur nette de l'Apport s’élève à 146.762.386 EUR (cent quarante-six million sept cent soixante-deux mille trois

cent quatre-vingt-six d'Euros).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'Apport

datée du 27 février 2015, qui devra rester annexée à cet acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l’enregistre-
ment.

<i>Intervention des gérants

Interviennent alors:
- M. Jean-Francois Findling, avec adresse professionnelle au 10-12 Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand

Duché de Luxembourg, gérant de catégorie A;

- M. John Sutherland, avec adresse professionnelle au 4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duché

de Luxembourg, gérant de catégorie A;

- M. Ronnie D. Berry, avec adresse professionnelle au 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039,

gérant de catégorie B; and

- M. Jiong (Thomas) Liu, avec adresse professionnelle au 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039,

gérant de catégorie B;

tous représentés par Mme Sofia Da Chao Conde, précitée, en vertu des provisions de la déclaration sur la valeur de

l'apport datée du 27 février 2015;

agissant en leur qualité des gérants de la Société, requièrent le notaire d'acter comme suit:
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement responsables en tant que

gérants de la Société en raison de l'apport en nature tel que décrit ci-dessus, sont expressément en accord avec la description
de l'Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

Le solde de 77.828.386 EUR (soixante dix-sept million huit cent vingt-huit mille trois quatre-vingt-six Euros) de la

valeur de l'Apport qui dépasse la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales est alloué comme suite: 54.171.178 EUR
(cinquante-quatre million cent soixante-onze mille cent soixante-dix-sept Euros) au compte de prime d'émission de la
Société, et 23.657.208 EUR (vingt-trois million six cent cinquante-sept mille deux cent huit Euros) à la réserve légale de
la Société.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport qui a été entièrement réalisé, l’actionnariat de

la Société est maintenant composée de:

- Ticona LLC: 20.108.627 (vingt million cent huit mille six cent vingt-sept) parts sociales; et Celanese US Holdings

LLC: 3.548.581 (trois million cinq cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-un) parts sociales.

Le notaire constate que les 23.657.208 (vingt-trois million six cent cinquante-sept mille deux cent huit) parts sociales

représentant  la  totalité  du  capital  social  de  la  Société  sont  représentées  de  sorte  que  l’assemblée  peut  valablement  se
prononcer sur la résolution à prendre ci-dessus.

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des résolutions précédentes, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des statuts de

la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital de la Société est fixé à 2.365.720.800 EUR (deux milliard trois cent soixante-cinq million sept cent

vingt mille huit cent Euros), représentés par 23.657.208 (vingt-trois million six cent cinquante-sept mille deux cent huit)
parts sociales d’une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune.»

Aucune autre modification doit être faite à cet article.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés

par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à environ 7.000 euros.

66967

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document au comparant, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent acte notarié.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante

les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 mars 2015. Relation: EAC/2015/5932. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015054712/246.
(150063050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Class Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.586.

CLOSURE OF LIQUIDATION

La liquidation de la société Class Real Estate Investments S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Léonie Grethen en

date du 23 décembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 30
mars 2015.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg.

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents à la clôture de la liquidation

et dont la remise n'aurait pu leur être faite seront déposées à la Caisse de consignation de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2015.

Référence de publication: 2015054713/18.
(150063076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Clowns4u, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3468 Dudelange, 13, rue des Fleurs.

R.C.S. Luxembourg F 10.359.

STATUTS

Entre les soussignés:
- Catherine RIES
65, Beschmontsbongert
L-7526 Mersch
1961110924881
Luxembourgeoise
Présidente
- Simone LAZZARETTI
16, rue Sigefroi
3280 Bettembourg
1975060330387
Luxembourgeoise
Vice-Présidente
- Blandine MOLITOR
13, rue des fleurs
L-3468 Dudelange
19751001048
Luxembourgeoise
Secrétaire

66968

L

U X E M B O U R G

- Mike KICKERT
13, rue des fleurs
L-3468 Dudelange
19740112
Luxembourgeois
Trésorier
- Carine KAYSER
29, rue Auguste Trémont
L-2624 Luxembourg
19651006263
Luxembourgeoise
Membre fondateur
- Sarah STEFFEN
Köllner Allee 5
66606 St. Wendel
57150279L508
Allemande
Membre fondateur
- Daniela HEINKI
Moselstrasse 20
66706 Besch
1968092570708
Allemande
Membre fondateur
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21

avril 1928 modifiée.

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination Clowns4u

Art. 2. L'association a pour objet de planifier et de réaliser toutes sortes de projets, visant à offrir, par l'action des clowns,

des moments de joie et d'émotions à toutes personnes, petites ou grandes dans des lieux privés et publics divers.

Afin de pouvoir accomplir cet objectif, l'association aura notamment pour objet de percevoir des dons, legs et subventions

lesquels seront utilisés dans le strict respect de l'objet social décrit au présent article,

L'association est neutre sur un point de vue politique, idéologique et confessionnel.

Art. 3. Le siège social de l'association est fixé à L-3468 Dudelange, 13 rue des fleurs.
Le siège social pourra être transféré à tout endroit au Grand-Duché, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. L'association est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le nombre minimum de membres est de 3.

Art. 6. Peut devenir membre effectif de l'association:
Toute personne physique ou morale présentant une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède

à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil
d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le
cas échéant, été refusée.

Peut devenir membre donateur, toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement de l'association, lui

prête une aide financière annuelle selon une cotisation fixée et modifiable annuellement par l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'administration peut conférer le titre de membre honoraire à toute personne s'intéressant à l'activité de

l'association soit en y apportant sa compétence, ses relations soit son soutien matériel ou moral.

Art. 7. L'admission et la radiation des membres est prononcée par le Conseil d'Administration à la majorité simple des

voix.

Art. 8. Perdent la qualité de membre:
- les personnes qui ont donné leur démission par lettre recommandée, adressée aux administrateurs,
- les personnes exclues pour motif grave, notamment des actes ou paroles portant atteinte à l'honorabilité de l'association

et aux buts qu'elle s'est fixée,

- Le non-paiement de la cotisation,

66969

L

U X E M B O U R G

- Les personnes décédées.
La démission et l'exclusion des membres sont réglées par l'article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les

fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Art. 9. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration régulièrement une fois par an.
L'Assemblée Générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément accordés par la Loi ou par les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence: les modifications aux statuts, la nomination ou la révocation des administra-
teurs, l'approbation des comptes et budgets et la dissolution volontaire de l'Association.

Les convocations à l'Assemblée Générale contenant l'ordre du jour sont adressées, par courrier ordinaire ou électronique,

à chaque Membre quinze (15) jours au moins avant la réunion.

L'Assemblée Générale inclura dans son ordre du jour toute proposition écrite signée d'un dixième au moins des Membres

figurant sur la dernière liste annuelle.

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration autant de fois que néces-

saire. Elle doit l'être lorsque 1/5 des Membres en font la demande par écrit, en précisant le ou les points à porter à l'ordre
du jour.

Pour les votes, il sera loisible aux membres, de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Art. 10. L'association est gérée par un conseil d'administration, composé de 3 membres au moins et de 9 membres au

plus, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 2 ans.
La majorité des membres du conseil d'administration doit avoir une formation de clown reconnue et doit exercer son

activité de clown les derniers 24 mois, au moins.

Les membres du conseil d'administration désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de

président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des membres du conseil d'administration sont ceux résultant de la loi et des présents statuts.
Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 11. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil

d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 12. Le conseil d'administration représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'association soit

valablement engagée à l'égard de ceux-ci, 2 signatures des administrateurs en fonction est nécessaire. Par dérogation à la
règle imposant la double signature, le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière en matière bancaire
à 1 seul de ses administrateurs.

Art. 16.  Les  membres  fondateurs,  de  même  que  tout  nouveau  membre  de  l'Association,  seront  tenus  de  payer  une

contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Le montant de la cotisation ne peut dépasser 150 euros.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

Art. 17. Les ressources de l'association comprennent les cotisations des membres, les subventions de l'Etat et des com-

munes, des établissements publics ou de tout organisme privé ou public, national ou international, les dons et les legs, toutes
sommes perçues à l'occasion d'activités ou de manifestations organisées par l'association en vue de la réalisation de ses
objectifs.

De manière générale, toutes autres ressources autorisées par la loi.
L'énumération est non limitative.

Art. 18. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour appro-

bation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci

sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de

la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 21. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du

21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association de droit luxembourgeois, à

désigner par l'assemblée générale.

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux

dispositions de la loi du 21 avril 1928 modifiée.

66970

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Catherine RIES / Simone LAZZARETTI / Blandine MOLITOR / Carine KAYSER /

Savah STEFFEN / Daniela HEINKI / Mike KICKERT.

Référence de publication: 2015054714/135.
(150063114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Coditel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.067.

Monsieur Wim DE NAEYER a démissionné de son mandat de gérant de la société avec effet au 31 janvier 2015.
Monsieur Cyril DUKIC, né le 7 novembre 1969 à Annaba (Algérie), avec adresse au 32, Place du Grand Sablon, B-1000

Bruxelles, est le gérant unique de la société depuis le 31 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015054715/13.
(150063034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

ContourGlobal Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 155.446.

Les comptes annuels de la société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2015.

Référence de publication: 2015054717/11.
(150063175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

ContourGlobal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 140.282.

Les comptes annuels de la société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2015.

Référence de publication: 2015054718/11.
(150063069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Cournoise Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 166.133.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Cournoise Investments S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015054720/12.
(150062852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

66971

L

U X E M B O U R G

Covidien Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 61.111.

Les comptes annuels au 26 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015054721/10.
(150062924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Creathor Venture Management Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 155.288.

Veuillez prendre note du changement de l'adresse professionnelle des deux gérants A:
Monsieur
Gert KÖHLER
Schwedenpfad 24
D-61348 Bad Homburg v. d. Höhe
Monsieur
Cédric KÖHLER
Schwedenpfad 24
D-61348 Bad Homburg v. d. Höhe

Luxembourg, le 10 avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Creathor Venture Management Luxembourg
United International Management S.A.

Référence de publication: 2015054722/20.
(150062759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Credit Opportunity One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 166.085.

<i>Rectificatif du dépôt effectué le 30/12/2014 sous le numéro L140234227

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10/04/2015.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015054724/12.
(150062728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 126.910.

L'assemblée générale ordinaire du 8 avril 2015 a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Dominique Délèze,

Josef H.M. Hehenkamp, Rudolf Kömen, Guy Reiter et Fernand Schaus.

Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale

ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016:

- Dominique Délèze, Membre du Conseil d'Administration
Kalanderplatz 1, CH-8045 Zurich
- Josef H.M. Hehenkamp, Membre du Conseil d'Administration
Kalanderplatz 1, CH-8045 Zurich

66972

L

U X E M B O U R G

- Rudolf Kömen, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Fernand Schaus, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
PricewaterhouseCoopers a été réélu comme réviseur d'entreprises, et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale

ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016. Il est par ailleurs noté que l'adresse de PricewaterhouseCoopers a été
modifiée au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Référence de publication: 2015054725/28.
(150062817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 126.910.

Le bilan au 31 octobre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Référence de publication: 2015054726/12.
(150062834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Shaftesbury GP 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Crystal GP S.à.r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 195.641.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Shafestbury Asset Management (Luxembourg) S.A., a société anonyme, incorporated under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Registry (the “RCS”) under number B 104884 (the “Sole Shareholder”),

hereby represented by Mrs Marie-Madeleine Achouche, with professional address in Luxembourg, pursuant to a proxy

given on 25 March 2015,

The proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this document

to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary

to act that it represents the entire share capital of Crystal GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability
company) duly organized and existing under the laws of Luxembourg with its registered office at 23, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro),
incorporated pursuant of a deed of the undersigned notary, dated 17 March 2015 in the process of being registered with
the RCS (the “Company”).

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that the agenda of

the meeting is as follows:

(1) Change of the name of the Company to "Shaftesbury GP 2 S.à r.l.";
(2) Subsequent amendment of article 4 of the Company’s articles of association (the “Articles of Association”) to reflect

such change of name;

The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record its resolutions as fol-

lows*

66973

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to change the Company’s name into “Shaftesbury GP 2 S.à r.l.”.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to subsequently amend article 4 of the Articles of Association so that article 4 shall

henceforth be read as follows in its English version:

Art. 4. Name. The Company has the name "Shaftesbury GP 2 S.à r.l.”.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the

appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the proxyholder of
the appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party which is known by the undersigned notary

by his surname, name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with Us, the notary,
the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A Comparu:

Shafestbury Asset Management (Luxembourg) S.A., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg («RCS») sous le numéro B 104884 («l’Associé Unique»),

ici représentée par Madame Marie-Madeleine Achouche, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d'une procuration datée du 25 mars 2015.

Ladite procuration, après signature ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être soumise à l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l’Associé Unique de Crystal GP S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, et un capital social de EUR 12 500.- (douze mille cinq cent euros), constitué suivant un acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 mars 2015 (la «Société»), en cours d’immatriculation auprès du RCS.

La partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire d’acter que l’Ordre du jour est le suivant:
(1) Changement de nom de la Société en «Shaftesbury GP 2 S.à r.l.»;
(2) Par conséquent, modification de l'article 4 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d’y refléter ce changement

de nom de la Société;

Ceci ayant été déclaré, l’Associé Unique représenté comme indiqué ciavant, a requis le notaire soussigné de prendre

acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique a décidé de changer le nom de la Société en «Shaftesbury GP 2 S.à r.l.».

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique a décidé en conséquence de modifier l'article 4 des Statuts, de sorte que cet article 4 aura désormais

la teneur suivante dans la version française des Statuts:

« Art. 4. Dénomination. La société est dénommée «Shaftesbury GP 2 S.à r.l.»;
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la requête du mandataire des parties compa-

rantes, le présent acte a été établi en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête de ce même mandataire
des parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date des présentes, au Grand-Duché de Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’original

du présent acte.

Signé: M.-M. ACHOUCHE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 1 

er

 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/10134. Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

66974

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015054727/85.
(150063186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Cube Infrastructure Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.234.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu en date du 23 Février 2015

En date du 23 février 2015, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Norbert Schradd en qualité d'Administrateur avec effet au 2 février 2015.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Cube Infrastructure Fund
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2015054728/14.
(150063227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Café Beim Marco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6971 Grevenmacher, 16, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 154.768.

Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015054729/10.
(150062770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Cessna S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 187.602.

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

et par décision du Conseil d' Administration en date du 13 avril 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au porteur
de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

<i>Pour: CESSNA S.A.
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015054736/16.
(150062739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Cesto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.586.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 24 mars 2015, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Charlotte Bastin, avec adresse professionnelle au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg
- Alexandre Van Damme, avec adresse au 51, rue de l'Amazone, 1060 Bruxelles, Belgique
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social

se clôturant au 31 décembre 2017 et qui se tiendra en 2018;

66975

L

U X E M B O U R G

2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes d'Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017 et qui se tiendra en 2018;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 avril 2015.

Référence de publication: 2015054737/19.
(150062711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Cesto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 avril 2015.

Référence de publication: 2015054738/10.
(150063081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

CGI Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 35.212.

EXTRAIT

- Il résulte du conseil d'administration de la Société, du 8 janvier 2015, que le mandat d'administrateur-délégué à la

gestion journalière de la Société de Monsieur Sébastien Genesca a été renouvelé pour une durée indéterminé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CGI Luxembourg SA

Référence de publication: 2015054739/12.
(150062588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Chimica Sospirolo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 92.745.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales intervenue en date du 4 octobre 2013 entre la société FRIENDO AG et THE

FOUR PLUS ONE LIMITED, Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques) que cette dernière est
devenu associée pour 463 parts sociales.

Luxembourg, le 10 avril 2015.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LA GERANCE
Signature

Référence de publication: 2015054740/15.
(150062761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

CHSM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5495 Wintrange, 38, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 196.028.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.
Den zweiten April.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

1. - Herr Achim Hermann MEIER, Geschäftsführer, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, Großjungenwald, 12.

66976

L

U X E M B O U R G

2. - Herr Christian PARAMAN, Geschäftsführer, wohnhaft in D-66663 Merzig, Menninger Straße, 36.
3. - Die Kommanditgesellschaft deutschen Rechts SBN Wälzlager GmbH &amp; Co. KG, mit Sitz in D-66901 Schönenberg-

Kübelberg, Jan-Hutzel-Weg, 1, eingetragen beim Handelsregister A des Amtsgerichts Zweibrücken unter der Nummer
HRA 30445,

vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

deutschen Rechts SBN Verwaltungs GmbH, mit Sitz in D-66901 Schönenberg-Kübelberg, Jan-Hutzel-Weg, 1, eingetragen
beim Handelsregister B des Amtsgerichts Zweibrücken unter der Nummer HRB 31201,

welch Letztgenannte vertreten ist durch ihre beiden Geschäftsführer nämlich:
- Herr Wolfgang Eugen Hermann HUTZEL, Geschäftsführer, wohnhaft in D-66901 Schönenberg-Kübelberg, Zur Weide

18.

- Herr Arno RECH, Geschäftsführer, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, Im Loß, 13.
Die vorgenannte Kommanditgesellschaft deutschen Rechts SBN Wälzlager GmbH &amp; Co. KG, ist hier vertreten durch

Herrn Christian PARAMAN, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 1. April 2015,

welche Vollmacht von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben, der gegenwär-

tigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchten, fol-

gende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile

werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutref-
fenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "CHSM S.à r.l.".

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wintrange (Gemeinde Schengen).
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt

werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Computertechnik, die elektronische Datenverarbeitung und Daten-

kommunikation jeglicher Art. Gegenstand der Gesellschaft ist ebenfalls die Entwicklung und der Verkauf von Software
jeglicher Art, die Beratung im Umfeld der Software-Entwicklung sowie der Handel mit Hardware.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Gesellschaften zu beteiligen, deren Unternehmenszweck ähnliche oder

ergänzende Aktivitäten umfasst.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-

Transaktionen  zu  tätigen,  welche  mit  dem  Gesellschaftszweck  verbunden  werden  können  und  der  Entwicklung  der
Gesellschaft förderlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in ein

hundert (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-).

Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
Zur Abtretung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der General-

versammlung, in welcher wenigstens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten sein müssen.

Die Übertragung der Gesellschaftsanteile an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls bedarf der Zustimmung von Ge-

sellschaftern, welche drei Viertel (3/4) der den Überlebenden zustehenden Rechte vertreten.

Die laut Absatz 3 vorgesehene Zustimmung ist nicht erfordert, wenn die Anteile, sei es an Reservaterben, sei es an den

überlebenden Ehegatten oder, soweit dies durch die Statuten vorgesehen ist, an die andern gesetzlichen Erben übertragen
werden.

Die Erben sowie die durch Verfügung von Todeswegen eingesetzten Vermächtnisnehmer, welche obige Zustimmung

nicht erhalten, sowie auch keinen Abnehmer gefunden haben, welcher die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, können
die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft veranlassen und zwar drei Monate nach einer Inverzugsetzung, die den Ge-
schäftsführern durch den Gerichtsvollzieher zugestellt und den Gesellschaftern durch Einschreibebrief durch die Post zur
Kenntnis gebracht wird.

Innerhalb  der  besagten  Frist  von  drei  Monaten  können  die  Gesellschaftsanteile  des  Verstorbenen  jedoch  erworben

werden, entweder durch die Gesellschafter, unter Vorbehalt der Bestimmungen des letzten Satzes von Artikel 199, oder
durch einen von ihnen genehmigten Dritten, oder auch durch die Gesellschaft selbst, wenn sie die Bedingungen erfüllt,
welche von einer Gesellschaft zum Erwerb ihrer durch sie verausgabten Wertpapiere verlangt werden.

66977

L

U X E M B O U R G

Der Rückkaufpreis der Gesellschaftsanteile wird auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten Jahre, und wenn

die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre aufzuweisen hat, auf Grund der Bilanz des letzten oder derjenigen der zwei
letzten Jahre berechnet.

Wenn kein Gewinn verteilt worden ist, oder wenn keine Einigung über die Anwendung der im vorhergehenden Absatz

angegebenen Rückkaufgrundlagen zustande kommt, wird der Preis im Uneinigkeitsfalle gerichtlich festgesetzt.

Die den Gesellschaftsanteilen des Erblassers zustehenden Rechte können nicht ausgeübt werden, bis deren Übertragung

der Gesellschaft gegenüber rechtswirksam ist.

Die Abtretungen von Gesellschaftsanteilen müssen durch notariellen oder Privatvertrag beurkundet werden.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie, gemäß Art. 1690 des

bürgerlichen Gesetzbuches, der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht
übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine

Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und
gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht wor-
den,  so  werden  die  Gesellschafter  ein  zweites  Mal  durch  Einschreibebrief  zusammengerufen  oder  befragt  und  die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Die Satzungen können nur mit einer Dreiviertelmehrheit der stimmberechtigten Anteile abgeändert werden.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist und jeder Anteil gibt Anrecht

auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesell-

schaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschaf-

terversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen

bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates
verantwortlich.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-

versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Ungeachtet der Bestimmungen des vorherigen Artikels kann die Gesellschafterversammlung auf Vorschlag des Ein-

zelgeschäftsführers oder bei mehreren Geschäftsführern, der einfachen Mehrheit der Geschäftsführer, vor dem Ende des
laufenden Geschäftsjahres die Ausschüttung von Zwischendividenden genehmigen, soweit aufgrund eines Zwischenabs-
chlusses belegt ist, dass ausreichende finanzielle Mittel für die Ausschüttung zur Verfügung stehen. Der auszuschüttende
Betrag darf die seit Ende des vergangenen Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss genehmigt wurde, angefallenen
Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und Rücklagen, vermindert durch vorgetragene Verluste
oder Beträge, welche nach den Regelungen dieser Satzung und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in der jeweils aktuellen Fassung einer Rücklage zugeführt werden müssen, nicht übersteigen.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Verstor-

benen weitergeführt.

Titel V. Auflösung und Liquidation

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit

beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

66978

L

U X E M B O U R G

<i>Zeichnung und Einzahlung des Gesellschaftskapitals

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€

12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.

Die EIN HUNDERT (100) Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

1. - Herr Achim Hermann MEIER, Geschäftsführer, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, Großjungenwald,
12, dreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2. - Herr Christian PARAMAN, Geschäftsführer wohnhaft in D-66663 Merzig, Menninger Straße, 36,
zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3. - Die Kommanditgesellschaft deutschen Rechts SBN Wälzlager GmbH &amp; Co. KG, mit Sitz in D-66901
Schönenberg-Kübelberg, Jan-Hutzel-Weg, 1, eingetragen beim Handelsregister A des Amtsgerichts Zweibrücken
unter der Nummer HRA 30445, sechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Total: EIN HUNDERT Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2015.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).

<i>Erklärung

Die Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis

erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, welche das gesamte Gesellschaftska-

pital  vertreten,  in  einer  ausserordentlichen  Generalversammlung  zusammengetreten,  und  haben  einstimmig  und  laut
entsprechender Tagesordnung nachfolgende Beschlüsse gefasst:

a) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Christian PARAMAN, Geschäftsführer, geboren in Dillingen/Saar (Deutschland), am 5. Mai 1972, wohnhaft in

D-66663 Merzig, Menninger Straße, 36.

b) Zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Achim Hermann MEIER, Geschäftsführer, geboren in Merzig (Deutschland), am 22. März 1976, wohnhaft in

D-66679 Losheim am See, Großjungenwald, 12.

c) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer rechtsgültig

vertreten und verpflichtet.

d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5495 Wintrange, 38, route du Vin.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.

Signé: A. H. MEIER, C. PARAMAN, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 07 avril 2015. Relation: GAC/2015/2871. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 10. April 2015.

Référence de publication: 2015054741/166.

(150062547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

66979

L

U X E M B O U R G

Compagnie Internationale de Participations Automobiles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 54.823.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 avril 2015

Le Conseil d'administration accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,

avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg avec effet immédiat.

En date du 3 avril 2015, le Conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Luigi Maula, employé privé,

avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Le Conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle

procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:
- Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Lux Konzern Sàrl, employé privé, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Luigi Maula, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 avril 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015054749/22.
(150062826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Cogetech, Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 196.032.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le trente et un mars.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,

ONT COMPARU:

Monsieur Yves MERCIER, cadre, né le 25 janvier 1957 à Villerupt (France) demeurant à F-54500 Vandoeuvre, 7,

Square de Liège (France), représenté par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg
en vertu d’une procuration délivrée sous seing privé en date du 9 mars 2015; et

Monsieur Claude SOURDOT, directeur, né le 26 janvier 1963 à Mirecourt (France) demeurant à F-54600 Villers-Les-

Nancy, 3, Boulevard Cattenoz, représenté par Monsieur Mustafa NEZAR, précité, en vertu d’une procuration délivrée sous
seing privé en date du 9 mars 2015.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme ci-avant, ont demandé au notaire instrumentant d'acter comme suit les

statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «COGETECH».

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré dans les limites de cette commune sur simple décision du Conseil d'Administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, à Luxembourg et à l’étranger, toute activité commerciale ainsi que la fourniture de services

de conseil dans le domaine de la construction à l’exclusion de toutes autres activités notamment réglementées.

La société pourra prendre des intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou

étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que

66980

L

U X E M B O U R G

l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration,
la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au développement
de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de
garantie ou autrement.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la constitution, l’enregistrement et le dépôt, la valorisation,

la vente, l’usage dans le cadre de son activité et la concession de l’usage de tous noms de domaines, de tous droits de
propriété intellectuelle et de tous droits de propriété industrielle, notamment de tous droits d'auteur, de tous brevets, de
toutes marques de fabrique ou de commerce, ainsi que de tous dessins et de tous modèles.

La société peut réaliser toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt aux sociétés faisant partie de son groupe, ainsi qu'émettre des

obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association

en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille

se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets,
les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder
aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître né-

cessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000,-EUR) représenté par MILLE (1.000)

actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit

la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. En cas de pluralité d’actionnaires, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique, ou si, à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires de la

société, il est constaté que celle-ci n’a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être
limitée à un (1) seul administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus
d’un actionnaire.

Les administrateurs ou l’administrateur unique sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour un terme qui

ne peut dépasser six (6) ans jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En  cas  de  vacance  d'une  place  d'administrateur  nommé  par  l’assemblée  générale,  les  administrateurs  restants  ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles à

l’objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée des actionnaires
relèvent de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. En l’absence du président un autre administrateur peut

présider la réunion. L'administrateur unique remplira de fait les fonctions de président.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée. Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier élec-
tronique un autre administrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d'un de ses collègues.

L'administrateur empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Dans l’un

comme dans l’autre cas, l’administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.

En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision expresse du Président, tout administrateur peut participer à une

réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéo conférence, ou par tout autre moyen de com-
munication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette réunion puissent s'entendre et se parler
mutuellement. Dans ce cas, l’administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent à la réunion et sera habilité
à prendre part au vote.

66981

L

U X E M B O U R G

Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et

approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces conditions auront
les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Les écrits, télégrammes, télé-
copies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président est

prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de  la  société  en  ce  qui  concerne  cette  gestion  à  un  ou  plusieurs  administrateurs,  directeurs,  gérants  ou  autres  agents,
actionnaires ou non.

Art. 10. La société se trouve engagée, en cas d’administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,

ou, en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs. Si un administrateur-délégué
est nommé, la société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement la
signature de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d'actions doit

en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne
ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le conseil d'administration

est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures à Lu-

xembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation, le premier exercice commencera à la date de signature des présents statuts, et se terminera au 31 décembre

2015.

La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2016.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentés comme ci-avant, déclarent souscrire les

actions comme suit:

Monsieur Yves MERCIER, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

Monsieur Claude SOURDOT, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions

Les actions ont été partiellement libérées à concurrence de 25% par des versements en espèce, de sorte que la somme

de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

66982

L

U X E M B O U R G

1) Les personnes suivantes sont nommées administrateurs jusqu'à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se

tiendra en 2020:

- Monsieur Yves MERCIER, cadre, né le 25 janvier 1957 à Villerupt (France), résidant à F-54500 Vandoeuvre, 7, Square

de Liège (France);

- Monsieur Claude SOURDOT, directeur, né le 26 janvier 1963 à Mirecourt (France), résidant à F-54600 Villers-Les-

Nancy (France), 3, Boulevard Cattenoz; et

- Monsieur Marc SANTOLINI, gérant, né le 21 août 1955 à Algrange (France), résidant à L-3813 Schifflange, 39, rue

Basse.

2) Le siège social est fixé à L-2314 Luxembourg, 2A, Place de Paris.
3) Est nommé commissaire aux comptes:
- La société anonyme de droit luxembourgeois FID-EUROPE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 2a,

Place de Paris, L-2314 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 145.543.

La durée de son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2020.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom état

et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/10499. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 10 avril 2015.

Référence de publication: 2015054747/171.
(150062705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Communauté Agricole Soprana, Société Civile.

Siège social: L-8542 Lannen, 2, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg E 72.

L'an deux mille quinze, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Léon LAMBORELLE, retraité, né à Lannen le 4 mars 1939 et son épouse Madame Marie MUNHOVEN,

sans profession, née à Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 1932, demeurant ensemble à L-8542 Lannen, 6, rue de Hostert,

détenteurs ensemble de deux mille cinq cent soixante-trois (2.563) parts sociales.
2.- Madame Monique SCHLEICH, employée privée, née à Ettelbruck le 20 septembre 1971, demeurant à L-8540 Ospern,

1, Um Ewend,

détentrice de trois mille quatre cent vingt-deux (3.422) parts sociales.
3.- Monsieur Nico SCHLEICH, cultivateur, né à Luxembourg le 17 avril 1965, demeurant à L-8542 Lannen, 2, rue de

l’Eglise,

détenteur de douze mille quatre cent quatre (12.404) parts sociales.
4.- Monsieur Jean-Paul HILBERT, cultivateur, né à Luxembourg, le 8 octobre 1960, demeurant à L-8526 Colpach-Bas,

15, Kierchestrooss,

détenteur de deux mille quarante (2.040) parts sociales.
Les comparants préqualifiés sub 1.- à 4.-, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile "COMMUNAUTE

AGRICOLE SOPRANA" (numéro d’identité 1994 70 01 119), avec social à L-8542 Lannen, 2, rue de l’Eglise, inscrite au
R.C.S.L. sous le numéro E 72, constituée suivant acte reçu par le notaire Urbain THOLL, alors de résidence à Redange-

66983

L

U X E M B O U R G

sur-Attert, en date du 18 novembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 91 du 6 mars 1995 et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 mars 2014, publié au Mémorial C,
numéro 1432 du 4 juin 2014,

ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Observation préliminaire

Les associés déclarent que suite à un acte de partage reçu par le notaire instrumentant en date du 19 janvier 2015, les

sept mille sept cent vingt et une virgule cinquante (7.721,50) parts sociales détenues précédemment ensemble par les époux
Monsieur  Nico  SCHLEICH  et  Madame  Hélène  SCHREIBER  ont  été  attribuées  pour  la  totalité  à  Monsieur  Nico
SCHLEICH, préquafié sub 3.-.

En conséquence de ce qui précède, les vingt mille quatre cent vingt-neuf (20.429) parts sociales sont actuellement

réparties comme suit:

1) Monsieur et Madame Léon LAMBORELLE-MUNHOVEN,
ensemble deux mille cinq cent soixante-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.563

2) Madame Monique SCHLEICH,
trois mille quatre cent vingt-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.422

3) Monsieur Nico SCHLEICH,
douze mille quatre cent quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.404

4) Monsieur Jean-Paul HILBERT,
deux mille quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.040

Total: vingt mille quatre cent vingt-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.429

<i>Première résolution

Les associés décident de d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille cinq cent soixante et onze euros

soixante cents (€ 50.571,60.-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent six mille quatre cent trente-quatre euros
quatre-vingt-onze cents (€ 506.434,91.-) à cinq cent cinquante-sept mille six euros cinquante et un cents (€ 557.006,51.-)
par la création et l’émission de deux mille quarante (2.040) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-quatre
euros soixante-dix-neuf cents (€ 24,79.-) chacune.

<i>Souscription et paiement

Tous les associés actuels ont déclaré renoncer expressément à souscrire à la susdite augmentation de capital et admettre

à ladite souscription Monsieur Michel JAAQUES, cultivateur, né à Luxembourg, le 10 mars 1966, demeurant à L-8545
Niederpallen, 6, Chemin de Beckerich.

Est ensuite intervenu aux présentes Monsieur Michel JAAQUES, préqualifié, lequel déclare souscrire la totalité des

deux mille quarante (2.040) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents
(€ 24,79.-) chacune et les libérer intégralement par l’apport des éléments mobiliers suivants:

- bétail;
- un (1) tracteur JOHN DEERE 6610;
- un (1) tracteur JOHN DEERE 6300;
- un (1) tracteur téléscopique SCHÄFFER 570T;
- un (1) tracteur téléscopique SCHÄFFER 3045;
- une (1) pirouette LELY;
- une (1) pirouette KUHN;
- deux (2) broyeurs;
- deux (2) remorques;
- une (1) épandeuse LUCAS RAPTOR M.
Monsieur Michel JAAQUES déclare estimer la valeur des prédits éléments immobiliers objet de l’apport à cinquante

mille cinq cent soixante et onze euros soixante cents (€ 50.571,60.-).

<i>Répartition du capital social

Suite à l’augmentation de capital qui précède, les parts sociales sont désormais réparties comme suit:

1) Monsieur et Madame Léon LAMBORELLE-MUNHOVEN,
ensemble deux mille cinq cent soixante-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.563

2) Madame Monique SCHLEICH,
trois mille quatre cent vingt-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.422

3) Monsieur Nico SCHLEICH,
douze mille quatre cent quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.404

66984

L

U X E M B O U R G

4) Monsieur Jean-Paul HILBERT,
deux mille quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.040

5) Monsieur Michel JAAQUES,
deux mille quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.040

Total: vingt-deux mille quatre cent soixante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.469

<i>Deuxième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

« Art. 4. Das Gesellschaftskapital in Höhe von fünfhundertsiebenundfünfzigtausend sechs Euro einundfünfzig Cent (€

557.006,51.-) ist eingeteilt in zweiundzwanzigtausendvierhundertneunundsechzig (22.469) Anteilscheine von je vierundz-
wanzig Euro neunundsiebzig Cent (€ 24,79.-).

Das Gesellschaftskapital kann durch einstimmigen Beschluß der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden.„
En application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite,
a) les comparants sub 1.- à 4. déclarent être les bénéficiaires réels de la société et agir pour leur propre compte et certifient

que la société ne se livre pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la
loi  modifiée  du  19  février  1973  concernant  la  vente  de  substances  médicamenteuses  et  la  lutte  contre  la  toxicomanie
(blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme);

b) Monsieur Michel JAAQUES déclare être le bénéficiaire réel de l’augmentation de capital faisant l’objet des présentes

et agir pour son propre compte et certifie que les éléments mobiliers servant à la libération de la prédite augmentation de
capital ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre pas à des activités constituant une infraction visée aux
articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal
(financement du terrorisme).

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille cent euros (€ 1.100.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: LAMBORELLE, MUNHOVEN, M. SCHLEICH, N. SCHLEICH, HILBERT, JAAQUES, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/10238. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 9 avril 2015.

Référence de publication: 2015054748/112.
(150062542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Dragon Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 196.040.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of March.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

acting in replacement of Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to
whom remains the present deed.

THERE APPEARED:

CVC Capital Partners VI Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its registered office at

1 Waverley Place, Union Street, St. Helier, Jersey JE1 1SG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 111863,

hereby represented by Mr Manuel MOUGET, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

established on 17 March 2015.

66985

L

U X E M B O U R G

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10 

th

August,  1915,  on  commercial  companies,  as  amended  (hereafter  the  “Law”),  as  well  as  by  the  articles  of  association
(hereafter the “Articles”), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member
company.

Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, deve-
lopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

2.3 The Company may also enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any

contracts or obligations of the Company or of group companies.

2.4 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures

and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.5 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

2.6 The Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be

considered as a regulated activity of the financial sector.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “Dragon Holdings S.à r.l.”

Art. 5. Registered office.
5.1 The registered office is established in Luxembourg-City.
5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole director

(gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gérance).

5.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed Share Capital
6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by

1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand) shares (parts sociales) of EUR 0.01 (one Euro cent) each, all fully
subscribed and entirely paid up.

6.1.2 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In such case Articles 200-1 and 200-2 of the Law,
among others, will apply, entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him
and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders'

meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3 - Profit Participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of Shares
6.5.1 In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

66986

L

U X E M B O U R G

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters

of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of
Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance

with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and Removal
7.1.1 The Company is managed by a sole director (gérant) or more directors (gérants). If several directors (gérants) have

been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not to be
shareholder(s).

7.1.2 The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3 A director (gérant) may be dismissed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted

by the shareholders.

7.1.4 The sole director (gérant) and each of the members of the board of directors (conseil de gérance) shall not be

compensated for his/their services as director (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders.
The Company shall reimburse any director (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office,
including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of directors
(gérants).

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors (conseil de
gérance).

7.3 - Representation and Signatory Power
7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors

(gérants), the board of directors (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the
terms of this Article

7.3 shall have been complied with.
7.3.2 The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of directors

(gérants), by the joint signature of any two member of the board of directors (conseil de gérance).

7.3.3 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)

may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents and determine this agent's responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures
7.4.1 The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It

may also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meeting of the board of directors and of the shareholders.

7.4.2 The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the

chairman and the secretary (if any), and recorded in the corporate book of the Company. Copies or extracts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any
director (gérant).

7.4.3 Decisions of the sole director (gérant) shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director

(gérant). Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed
by the sole director (gérant).

7.4.4 The board of directors (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors

(gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance).

7.4.5 In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors

(gérants) present or represented at such meeting.

7.4.6 Any director (gérant) may act at any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by appointing in writing

another director (gérant) as his proxy. A director (gérant) may also appoint another director (gérant) to represent him by
phone to be confirmed at a later stage.

7.4.7 Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) shall have the same effect as resolutions

passed at the directors' (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents. The date of
such resolutions shall be the date of the last signature.

66987

L

U X E M B O U R G

7.4.8 Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by

telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.

7.5 - Liability of Directors (gérants)
Any director (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders' meeting.
8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous

vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital,
subject to the provisions of the Law.

8.4 The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to
be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting.
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of shareholders shall be

held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 25 

th

 day of the month of June, at 10.a.m.

9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director
(gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance), exceptional circumstances
so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be

supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal Year
The Company's fiscal year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
11.2 - Annual Accounts
11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board

of directors (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and
liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be
made.

11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered

office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits.
12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit.

12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
13.1 The board of directors (conseil de gérance) may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial

statements prepared by the board of directors (conseil de gérance) showing that sufficient funds are available for distribution.
The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits
carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve
which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

13.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

66988

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Dissolution - Liquidation.
14.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

14.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to

a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to
the Articles.

14.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 15. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

Art. 16. Modification of articles. The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders,

by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

<i>Transitional dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31 December

2015.

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe the entire share capital as follows:

Subscriber

Number

of shares

Subscribed

amount
in EUR

%

CVC Capital Partners VI Limited, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250,000

12,500.-

100%

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250,000

12,500.-

100%

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount

of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,300.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

1. The Company will be administered by the following directors (gérants) appointed for an undetermined period:
a. Mrs. Emanuela Brero, private employee, born on 25 May 1970 in Bra (Italy), having her professional address at 20,

avenue Monterey, L- 2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

b. Mr. Manuel Mouget, private employee, born on 6 January 1977 in Messancy (Belgium), having his professional

address at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

c. Mrs Stella Le Cras, private employee, born 23 July 1965 in St Saviour (United Kingdom), having his professional

address at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

2. The registered office of the Company shall be established at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le dix-huit du mois de mars.

66989

L

U X E M B O U R G

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, agissant

en remplacement de Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, lequel
dernier restera dépositaire de la présente minute.

A COMPARU:

CVC Capital Partners VI Limited, une limited company ayant son siège social au 1 Waverley Place, Union Street, St.

Helier, Jersey JE1 1SG, Iles Anglo-Normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 111863,

ici représentée par Monsieur Mr Manuel MOUGET, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée le 17 mars 2015.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après

la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi»”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8
et 11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social.
2.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange
ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la
propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des parti-
cipations dans des sociétés de personnes.

2.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles

(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

2.3 La Société peut aussi contracter toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté pour l'exécution de tous contrats

ou obligations de la Société ou d'une société du groupe.

2.4 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

2.5 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers.

2.6 La Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait consi-

dérée comme une activité réglementée du secteur financier.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «Dragon Holdings S.à r.l.»

Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social est établi à Luxembourg - Ville.
5.2 Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand - Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou

en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) représenté par 1.250.000 (un million deux

cent cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d'Euros) toutes entièrement souscrites et
libérées.

6.1.2 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par
lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199
de la Loi.

6.3 - Participation aux Profits

66990

L

U X E M B O U R G

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre

des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect

des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non - associés qu'après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Les transferts de parts sociales doivent s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts ne

peuvent être opposables à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de
leur acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés

conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-

tueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par

les associés.

7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n'est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/leurs

services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra
rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de
pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature

conjointe de deux des membres du conseil de gérance.

7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour

des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et déterminera les responsabilités du mandataire et sa
rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes
de ce mandat.

7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et le

secrétaire (le cas échéant), seront déposées dans les livres de la Société. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui
pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.

7.4.3 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.

7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

66991

L

U X E M B O U R G

7.4.6 Tout gérant pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son

représentant. Un gérant pourra également désigner un autre gérant pour le représenter par téléphone, cela sera confirmé
par écrit par la suite.

7.4.7 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.
La date de ces décisions sera la date de la dernière signature.

7.4.8 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par “conference call” via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
8.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre

de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital.

8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra
son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée générale des associés doit être tenue,

conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé
dans la convocation de l'assemblée, le 25 

ème

 jour du mois de juin, à 10.00 heures.

9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable

suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de
pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société

sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice Social
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
11.2 - Comptes Annuels
11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse

un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social

de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits.
12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi

longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital

de la Société.

Art. 13. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
13.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être

66992

L

U X E M B O U R G

distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

13.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-

formément à la Loi et aux présents statuts.

Art. 14. Dissolution - Liquidation.
14.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

14.2 Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

14.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 15. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux

dispositions de la Loi.

Art. 16. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des associés

selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand - Duché de Luxembourg.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 Décembre 2015.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ainsi établis, la partie comparante déclare souscrire l'intégralité du capital comme suit:

Souscripteur

Nombre de

parts sociales

Montant

souscrit

EUR

% du capital

social

CVC Capital Partners VI Limited, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

12.500,-

100%

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

12.500,-

100%

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de 12.500,- EUR

(douze mille cinq cents Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.300,-.

<i>Résolutions de l'associé unique

1. La Société est administrée par les gérants suivants nommés pour une période indéterminée:
a. Madame Emanuela Brero, employée privée, née le 25 mai 1970 en Bra (Italie), ayant son adresse professionnelle au

20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg;

b. Monsieur Manuel Mouget, employé privé, né le 6 Janvier 1977 à Messancy (Belgique), ayant son adresse profes-

sionnelle au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg;

c. Madame Stella Le Cras, employé privé, né le 23 juillet 1965 à St Saviour (Royaume-Uni), ayant son adresse profes-

sionnelle au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg;

2. Le siège social de la Société est établi au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante a requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la prédite partie comparante, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le prédit mandataire a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: M. MOUGET, M. SCHAEFFER.

66993

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8604. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015054776/458.
(150062839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.687.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 08. April 2015

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 08. April 2015 haben sich mit Wirkung zum 08. April

2015 folgende Änderungen in der Teilhaberstruktur der Gesellschaft ergeben:

- Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen Recht

mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerceset
des Sociétés) unter der Nummer B 172.676 hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile.
- Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen Recht

mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerces et
des Sociétés) unter der Nummer B 172.683 hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile.
- SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen

Recht mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Com-
merces et des Sociétés) unter der Nummer B 165.834 hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile.
- Tivolino Anstalt, eine Anstalt gegründet nach liechtensteinischem Recht mit Sitz in Äulestraße 5, 9490 Vaduz, Liech-

tenstein, eingetragen im Amt für Justiz unter der Nummer FL-0002.488.173.6 hält nunmehr an der Gesellschaft:

12.500 Anteile.
Référence de publication: 2015054773/26.
(150062524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.687.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 07. April 2015

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 07. April 2015 haben sich folgende Änderungen in der

Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Christian Bäumer, geboren am 11. Juli 1974 in Dortmund (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr Bernhard Jost, geboren am 07. Oktober 1973 in Gramsbach (Österreich), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr Gregg Blackstock, geboren am 24. September 1974 in Mbabane (Swasiland), geschäftlich ansässig in 7 Old Park

Lane, Mayfair, London, W1K 1QR, Vereinigtes Königreich wurde mit Wirkung zum 07. April 2015 als gemeinschaftlich
vertretungsbefugter Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

- Frau Lindie Fourie, geboren am 25. August 1981 in Uitenhage (Südafrika), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff,

L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 07. April 2015 als gemeinschaftlich vertretungsbefugte Geschäftsführerin
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2015054772/19.
(150062524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

66994

L

U X E M B O U R G

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.693.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 07. April 2015

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 07. April 2015 haben sich folgende Änderungen in der

Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Christian Bäumer, geboren am 11. Juli 1974 in Dortmund (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr Michael Robert, geboren am 14. August 1980 in Hermeskeil ( Deutschland) , wurde mit sofortiger Wirkung

abberufen.

- Herr Gregg Blackstock, geboren am 24. September 1974 in Mbabane (Swasiland), geschäftlich ansässig in 7 Old Park

Lane, Mayfair, London, W1K 1QR, Vereinigtes Königreich wurde mit Wirkung zum 07. April 2015 als gemeinschaftlich
vertretungsbefugter Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

- Frau Lindie Fourie, geboren am 25. August 1981 in Uitenhage (Südafrika), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff,

L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 07. April 2015 als gemeinschaftlich vertretungsbefugte Geschäftsführerin
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2015054774/20.
(150062525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.693.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 08. April 2015

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 08. April 2015 haben sich mit Wirkung zum 08. April

2015 folgende Änderungen in der Teilhaberstruktur der Gesellschaft ergeben:

- Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen Recht

mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerce et
des Sociétés) unter der Nummer B 172.676 hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile.
- Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen Recht

mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerce et
des Sociétés) unter der Nummer B 172.683 hält nunmehr an der Gesellschaft:

12.500 Anteile.
- SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen

Recht mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Com-
merce et des Sociétés) unter der Nummer B 165.834 hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile.
Référence de publication: 2015054775/23.
(150062525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

EdgeWorth Capital (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 157.531.

<i>Extrait des résolutions de l'associée unique prises en date du 25 mars 2015

- Transfert de siège du 16 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg, avec effet au 01/04/2015;

-  Démission  de  Messieurs  Marc  AMBROISIEN,  Frédéric  SICCHIA  et  de  Madame  Elise  LETHUILLIER  de  leurs

fonctions de gérants, avec effet immédiat;

- Nomination de trois nouveaux gérants, avec effet immédiat, pour une durée illimitée:
* Monsieur Philippe VANDERHOVEN, né le 02/07/1971 à Rocourt (Belgique), résidant professionnellement au 63-65

rue Merl, L-2146 Luxembourg

66995

L

U X E M B O U R G

*  Monsieur  Jean-Marc  FABER,  né  le  07/04/1966  à  Luxembourg,  résidant  professionnellement  au  63-65  rue  Merl,

L-2146 Luxembourg

* La société DALMORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED, société des Iles Vierges Britanniques, ayant son

siège au Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée au RCS des Iles Vierges Britan-
niques sous le numéro 1786065

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
EDGEWORTH CAPITAL (Luxembourg) Sàrl

Référence de publication: 2015054801/23.
(150063270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Entreprise Jacques Streff Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, Zone d'Activités Gadderscheier.

R.C.S. Luxembourg B 157.993.

L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de mars;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire (l’“Assemblée”) des actionnaires de “Entreprise Jacques Streff Services S.A.”, une

société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-4501 Differdange,
Zone d'Activités Gadderscheier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 157993, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 décembre 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 380 du 25 février 2011,

et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Paul ZIMMER, industriel, demeurant à L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy.
Le Président désigne comme secrétaire et l’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Jacques ZIMMER,

inspecteur de chantier, demeurant à L-8165 Bridel, 3, Op den Scheppen.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l’exercice de leurs mandats

respectifs;

3. Nomination de Monsieur Jean-Jacques ZIMMER en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la

Société (le “Liquidateur”);

4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
5. Divers.
B) Que l’actionnaire unique (l’“Actionnaire Unique”), dûment représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il possède,

sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par l’actionnaire unique présent ou le mandataire
qui le représente, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l’Actionnaire Unique représenté, signée “ne varietur” par les membres du bureau de l’Assem-

blée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et que l’Actionnaire Unique, dûment

représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée
et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l’exer-

cice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

66996

L

U X E M B O U R G

L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les

administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de
renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Jacques ZIMMER, inspecteur de chantier, né à Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg), le 10 août 1960, demeurant à L-8165 Bridel, 3, op den Scheppen, en tant que liquidateur (le
“Liquidateur”) de la Société.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de

la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation,

afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de
la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous verse-

ments d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l’article
148 de la Loi.

Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a

ensuite clôturé l’Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cent cinquante euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. ZIMMER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 31 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/7036. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré à la société.

Luxembourg, le 8 avril 2015.

Référence de publication: 2015054803/81.

(150062607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

East&amp;West Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal-Wincrange, Maison 14.

R.C.S. Luxembourg B 140.846.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EAST&amp;WEST FINANCES S.A.

Référence de publication: 2015054808/10.

(150062512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

66997

L

U X E M B O U R G

Eclaircie s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 4-6, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 121.861.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique en date du 1 

<i>er

<i> février 2015

- Le siège social de la société est transféré de son adresse actuelle au 13, Gruuss-Strooss, L-9991 Weiswampach au 4-6,

Duarrefstrooss, L-9990 Weiswampach, et ceci avec effet immédiat.

Weiswampach, le 1 

er

 février 2015.

Certifié sincère et conforme
ECLAIRCIE S.à.r.l.
<i>Associé Unique
Représenté par Monsieur Jacques VERCAUTEREN
<i>Gérant Unique

Référence de publication: 2015054809/17.
(150062507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

EDU Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 36.556,48.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 153.763.

EXTRAIT

Il est à noter que l'adresse d'un des associés de la Société a changé:
- M. William Thayer ETHRIDGE JR demeure désormais au PO BOX 51. York Harbor. ME 03911, Etats-Unis d'Amé-

rique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015054812/16.
(150063196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Goodhart Partners Longitude Fund Sicav-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 147.360.

In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Goodhart Partners Longitude Fund SICAV-SIF,

an investment company with variable capital-specialised investment fund specialised investment fund (société d’investis-
sement à capital variable-fonds d’investissement spécialisé) formed as a corporate partnership limited by shares (société
en commandite par actions), having its registered office at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 147.360 (the SIF), incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary, on 21 July 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1523 on 8 August 2009. The articles of association of the SIF (the Articles) haven not been amended since.

The Meeting was chaired by Mrs Cecile Leroy, private employee, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Jean-Baptiste Simba, private employee, with professional address in Luxem-

bourg.

The Meeting elected as scrutineer Mrs Solveig Giovanardi, private employee, with professional address in Luxembourg.
The chairman, the secretary and the scrutineer form together the board of the meeting (the Bureau).
The Bureau having thus been constituted, the chairman declares that:

66998

L

U X E M B O U R G

I. the shareholders present or represented (collectively referred to as the Shareholders) and the number of their shares

are shown on an attendance list. The proxies, if any, signed ne varietur by the proxyholder(s), the members of the Bureau
and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes;

II. the general meeting of the Shareholders convened on 15 December 2014 could not validly deliberate due to lack of

quorum and the present Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered letters to all shareholders
on 19 January 2015 and published in the Mémorial, the «Luxemburger Wort» and the «Tageblatt» on 29 December 2014
and 19 January 2015.

III. it appears from the attendance list that out of 569,605 outstanding shares, 246,623 shares are represented at the

Meeting. The present Meeting being convened as a second general meeting as foreseen in Article 67-1 paragraph 2 under
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, it can validly deliberate irrespective of any quorum.

IV. the agenda of the Meeting is the following:
1. full restatement of the Articles;
2. approval of the modifications to the issuing document of the SIF; and
3. miscellaneous.
After deliberation, the general meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to amend and fully restate the Articles, which will henceforth read as follows:

I. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There exists among the managing general partner, “associé gérant commandité” (the General Partner)

and the limited partners, “associés commanditaires” (the Shareholders), a Luxembourg partnership limited by shares in the
form of a “société en commandite par actions” organised as a “société d’investissement à capital variable” qualifying as a
“fonds d’investissement spécialisé” under the name of GOODHART PARTNERS LONGITUDE FUND SICAV-SIF (he-
reafter the Fund), governed by the Luxembourg law of 10 August 1915 relating to commercial companies, as amended (the
1915 Law), the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as may be amended (the
2007 Law) and the present Articles.

Art. 2. Duration. The Fund is established for an unlimited duration. The Fund may not be dissolved until the end of the

term of its last Sub-fund.

Art. 3. Object.
3.1 The purpose of the Fund is to invest the funds available to it in any kind of assets eligible under the 2007 Law with

the aim of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its assets.

3.2 The Fund may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted under the 2007 Law.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Fund is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the General Partner. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

4.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the General Partner. Where the General Partner determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal
activities of the Fund at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circums-
tances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Fund, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

II. Share capital - Shares - Net asset value

Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital of the Fund shall be represented by fully paid up shares (the Shares) of no par value and shall at

any time be equal to the total net assets of the Fund as defined in Article 12 hereof. The initial capital of the Fund is USD
45,100 (forty-five thousand one hundred United States dollars) divided into 1 (one) management share (the Management
Share) subscribed by the General Partner and 450 (four hundred and fifty) class A USD shares (the Class A USD Shares)
of no par value, entirely subscribed and partly paid-up.

5.2 The minimum capital of the Fund shall be the United States dollar (USD) amount equivalent to EUR 1,250,000 (one

million two hundred fifty thousand euro). The Fund shall be required to establish this level of minimum capital within
twelve months after the date on which the Fund has been registered as an undertaking for collective investment on the

66999

L

U X E M B O U R G

official  list  of  specialised  investment  funds  subject  to  the  supervision  of  the  Commission  de  Surveillance  du  Secteur
Financier in accordance with the 2007 Law.

5.3 The General Partner is authorized without any limitation to issue additional fully paid up Shares at any time in

accordance with Article 8 hereof at an offer price to be determined by the General Partner, without having to reserve to the
existing Shareholder(s) a preferential right to subscription of the Shares to be issued.

Art. 6. Classes of shares - Sub-Funds.
6.1 The General Partner may, at any time, issue different classes of Shares (each a Class or Classes as appropriate),

which carry different obligations inter alia with regard to the income and profit entitlements (distribution or capitalisation
shares), redemption features, and/or fee and cost features or of the relevant investor. Those Shares shall be issued, in
accordance with Article 8 hereof, on terms and conditions as shall be decided by the General Partner.

6.2 The General Partner may, at any time, establish different pools of assets, each constituting a separate sub-fund (each

a Sub-fund), within the meaning of Article 71 of the 2007 Law (which may as the General Partner may determine, be
denominated in different currencies) as further set out in the issuing document (the document d’émission in the sense of
the 2007 Law) of the Fund, as amended and updated from time to time (the Issuing Document). Each such pool of assets
shall be invested pursuant to Article 3 hereof for the exclusive benefit of the Shareholders of the relevant Sub-fund. Each
Sub-fund may have different specific features (including, but not limited to, specific fee structures, permitted investments,
investment restrictions and distribution policies) as the General Partner shall from time to time determine in respect of each
Sub-fund. The terms and conditions shall each time be set forth in the Sub-fund Supplements (as defined below).

6.3 The Fund is one single legal entity. However, by way of derogation to Article 2093 of the Luxembourg Civil Code,

the assets of one given Sub-fund are only available for the satisfaction of the debts, obligations and liabilities, which are
attributable to such Sub-fund. Amongst the Shareholders, each Sub-fund is treated as a separate entity.

6.4 For the purpose of determining the share capital of the Fund, the net assets attributable to each Sub-fund shall, if not

denominated in USD, be converted into USD and the capital shall be the aggregate of the net assets of all the Sub-funds.

6.5 The Fund shall prepare consolidated accounts in USD.

Art. 7. Form of shares.
7.1 The Fund shall issue Shares in registered form only.
7.2 All issued registered Shares of the Fund shall be registered in the register of Shareholders which shall be kept by

the Fund or by one or more persons designated thereto by the Fund, and such register shall contain the name of each owner
of registered Shares, his residence or elected domicile as indicated to the Fund, the number of registered Shares held by
him and the amount paid up on each fractional Share.

7.3 The inscription of the Shareholder’s name in the register of Shareholders evidences his right of ownership on such

registered Shares. The Fund will not issue certificates for such inscription, but each Shareholder shall receive a written
confirmation of his shareholding.

7.4 Transfer of registered Shares shall be effected by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of

Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act
on their behalf. Subject to the provisions of Articles 7 and 11 hereof, any transfer of registered Shares shall be entered into
the  register  of  Shareholders;  such  inscription  shall  be  signed  by  any  officer  of  the  Fund  or  by  any  other  person  duly
authorized thereto by the General Partner.

7.5 Shareholders shall provide the Fund with an address to which all notices and announcements may be sent. Such

address will also be entered in the register of Shareholders.

7.6 In the event that a Shareholder does not provide an address, the Fund may permit a notice to this effect to be entered

into the register of Shareholders and the Shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the Fund,
or such other address as may be so entered into by the Fund from time to time, until another address shall be provided to
the Fund by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his address as entered in the register of Shareholders
by means of a written notification to the Fund at its registered office, or at such other address as may be set by the Fund
from time to time.

7.7 The Fund recognizes only one owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of such

Shares(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) must appoint a sole attorney to represent such shareholding
in dealings with the Fund. The failure to appoint such attorney shall result in a suspension of all rights attached to such
Shares(s). Moreover, in the case of joint Shareholders, the Fund reserves the right to pay any redemption proceeds, distri-
butions or other payments to the first registered holder only, whom the Fund may consider to be the representative of all
joint holders, or to all joint Shareholders together, at its absolute discretion.

7.8 The Fund may decide to issue fractional Shares for up to three decimals. Such fractional Shares shall not be entitled

to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Class of Shares on a pro rata basis.

7.9 Payments of dividends, if any, will be made to Shareholders by bank transfer or by cheque sent to their addresses

as indicated in the register of Shareholders.

67000

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Issue of shares.
8.1 The General Partner is authorized, without limitation, to issue at any time Shares of no par value fully paid up, in

any Class and in any Sub-fund, without having to reserve to the existing Shareholders a preferential right to subscribe for
the Shares to be issued.

8.2 The General Partner may impose conditions on the issue of Shares (including without limitation the execution of

such subscription documents and the provision of such information as the General Partner may determine to be appropriate)
and may fix a minimum subscription level. The General Partner may also, in respect of a particular Sub-fund, levy a
subscription charge and has the right to waive partly or entirely this subscription charge. Any conditions to which the issue
of Shares may be submitted shall be detailed in the Sub-fund specific supplement to the Issuing Document (the Sub-fund
Supplements).

8.3 To the extent the Issuing Document will not directly include the information to be provided to prospective investors,

particularly pursuant to Article 23 of the directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June
2011 on alternative investment fund managers and amending directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC)
No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (the AIFMD) respectively Article 21 of the Luxembourg law dated 12 July 2013
on alternative investment fund managers, as amended from time to time (the 2013 Law), before they invest in the Fund,
such information will be made available at the Fund's or the Manager's (as defined below) registered office and the Issuing
Document will indicate how and where the information can be obtained.

8.4 Unless otherwise determined by the General Partner in the Sub-fund Supplements, the issue price of Shares to be

issued is based on the applicable net asset value per Share of the relevant Class in the relevant Sub-fund, as determined in
compliance with Article 12 hereof plus any additional premium or fees as determined by the General Partner and as further
disclosed in the Issuing Document. By exception to the foregoing, Shares of each Class issued on the first closing date of
the relevant Sub-fund may be offered at a fixed initial subscription price as set forth in the Sub-fund Supplements.

8.5  Shares  shall  be  issued  to  Eligible  Investors  (as  defined  in  the  Issuing  Document)  only  upon  acceptance  of  the

subscription and payment of the issue price. The issue price must be received before the issue of Shares. The payment will
be made under the conditions and within the time limits as determined by the General Partner.

8.6 The Fund may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind, in compliance with the conditions

set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from an independent auditor, which
qualifies as a réviseur d’entreprises agréé.

8.7 The General Partner may delegate to any duly authorized manager, officer or to any other duly authorized agent the

power to accept subscriptions, to receive payment of the price of any Shares to be issued and to deliver them.

Art. 9. Conversion of shares. The conversion is not allowed unless otherwise specified in the relevant Sub-fund Sup-

plements, and subject to the sole discretion of the General Partner.

Art. 10. Redemption of shares. The Fund may repurchase Shares at the request of the Shareholders in the conditions set

forth in the Issuing Document and the relevant Sub-fund Supplement. The General Partner may request the redemption of
all or part of the Shares under the terms and procedures as set forth in the Issuing Document as well as any Sub-fund
Supplements.

Art. 11. Restrictions on ownership of shares.
11.1 The Fund may restrict or prevent the ownership of Shares in the Fund by any person, firm or corporate body, namely

any person in breach of any law or requirement of any country or governmental authority and any person which is not
qualified to hold such Shares (a Prohibited Person) by virtue of such law or requirement or if in the opinion of the Fund
such holding may be detrimental to the Fund or if the holding of Shares by such person results in a breach of law or
regulations whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Fund may become subject to laws (including without
limitation tax laws) other than those of the Grand Duchy of Luxembourg.

11.2 “Prohibited Person” also includes any person which does not qualify as a well-informed investor within the meaning

of the 2007 Law.

11.3 Transfer of Shares in the Fund may be subject to transfer conditions as set forth in the relevant Sub-fund Supple-

ments.

Art. 12 Calculation of the net asset value.
12.1 The reference currency of the Fund is the USD. Each Sub-fund may have a different reference currency. The net

asset value of each Sub-fund’s Shares (the NAV) is expressed in the reference currency of the respective Sub-fund and
within each Sub-fund the NAV of each Class, if applicable, is expressed in the reference currency of the respective Class,
as further described in the relevant Sub-fund Supplements. The NAV is calculated by the Administrative Agent under the
responsibility of the Manager.

12.2 The NAV (being the assets less the liabilities) is calculated on a Class by Class basis (if applicable) on such frequency

as set forth in the relevant Sub-fund Supplements.

12.3 For the purpose of determining the NAV of the Fund, the net assets attributable to each Class within each Sub-fund

shall, if not denominated in USD, be converted into USD and the NAV of the Fund shall be the aggregate of the net assets
of all the Sub-funds.

67001

L

U X E M B O U R G

12.4 The Fund reserves the right to suspend the determination of the NAV of a Sub-fund under circumstances set forth

in the Issuing Document.

12.5 The Manager has adopted a policy of valuing its investments at fair value. The Manager, in its discretion and in

good faith, may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such valuation better reflects the fair
value of any asset of the Fund.

12.6 If since the time of determination of the NAV there has been a material change in the quotations in the markets on

which a substantial portion of the investments of the Fund are dealt in or quoted, the Fund may, in order to safeguard the
interests of the Shareholders and the Fund, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

12.7 In the absence of bad faith, negligence or manifest error, every decision in calculating the NAV taken by the

Manager or by the Administrative Agent, shall be final and binding on the Fund and present, past or future Shareholders.

12.8 The assets of the Fund shall include:
(i) all cash in hand, receivable or on deposit, including any interest accrued thereon;
(ii) all bills and notes payable on demand and any account due (including the proceeds of securities sold but not deli-

vered);

(iii) all securities, shares, bonds, time notes, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants and other se-

curities, money market instruments and similar assets owned or contracted for by the Fund;

(iv) all interest accrued on any interest-bearing assets, except to the extent that the same is included or reflected in the

principal amount of such assets;

(v) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Fund to the extent information thereon

is reasonably available to the Fund;

(vi) the preliminary expenses of the Fund, including the cost of issuing and distributing Shares of the Fund, insofar as

the same have not been written off and insofar the Fund shall be reimbursed for the same;

(vii) the liquidating value of all forward contracts and all call or put options the Fund has an open position in; and
(viii) all other assets of any kind and nature, including expenses paid in advance.
12.9 The value of such assets shall be determined at fair value with due regard to the following principles:
(i) investment in underlying undertakings for collective investment are taken at their last official net asset value known

in Luxembourg at the time of calculating the net asset value of the relevant Sub-fund. If such price is not representative of
the fair value of such assets, then the price shall be determined, in order to safeguard the interests of the Shareholders, by
the General Partner on a fair value basis. Investments subject to bid and offer prices are valued at their mid-price, if not
otherwise determined by the General Partner;

(ii) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless
in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making
such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;

(iii) securities listed and traded primarily on one or more recognized securities exchanges shall be valued at their last

known prices on the valuation day;

(iv) unlisted securities for which over-the-counter market quotations are readily available (included listed securities for

which the primary market is believed to be the over-the-counter-market) shall be valued at a price equal to the last reported
price as supplied by recognized quotation services or broker-dealers;

(v) all other non-publicly traded securities, other securities or instruments or investments for which reliable market

quotations are not available, and securities, instruments or investments which the Fund determines in its discretion that the
foregoing valuation methods do not fairly represent the fair value of such securities, instruments or investments, will be
valued by the Fund either at their cost basis to the Sub-fund or in good faith using methods it considers appropriate and
always in order to safeguard the interests of the Shareholders.

12.10 Assets expressed in a currency other than the reference currency of the Sub-fund concerned shall be converted

on the basis of the rate of exchange ruling on the relevant valuation day. If such rate of exchange is not available, the rate
of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the General Partner.

12.11 The liabilities of the Fund shall include:
(i) all loans, bills and accounts payable;
(ii) all accrued interest on loans;
(iii)  all  accrued  or  payable  expenses  (including  administrative  expenses,  advisory  and  management  fees,  including

incentive fees, depositary fees, and corporate agents’ fees);

(iv) all known liabilities, present or future, including all matured contractual obligations for payment of money, including

the amount of any unpaid distributions declared by the Fund;

(v) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the calculation day, as determined from

time to time by the General Partner, and other reserves (if any) authorised and approved by the General Partner, as well as
such amount (if any) as the General Partner may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent
liabilities of the Fund; and

67002

L

U X E M B O U R G

(vi) all other liabilities of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted accounting prin-

ciples.

In determining the amount of such liabilities the General Partner shall take into account all expenses payable by the

Fund which shall include formation expenses, fees, expenses, disbursements and reasonable out-of-pocket expenses payable
to its accountants, the Depositary and its correspondents, if any, as well as any other agent employed by the Fund, the
remuneration of the managers and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage and reasonable travelling
costs in connection with board of managers of the General Partner meetings and investment committee meetings, fees and
expenses for legal and auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of
the Fund with any governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country,
licensing fees for the use of the various indexes, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing, trans-
lating, printing, advertising and distributing the Issuing Document, further explanatory sales documents, periodical reports
or registration statements, the costs of publishing the NAV and any information relating to the estimated value of the Fund,
the cost of printing certificates, if any, and the costs of any reports to Shareholders, the cost of convening and holding
Shareholders’, board of managers of the General Partner and committee meetings, all taxes, duties, governmental and
similar charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, transaction fees, the cost
of publishing the issue and redemption prices, interests, bank charges and brokerage, postage, insurance, telephone and
telex. The General Partner may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an
estimated amount ratable for yearly or other periods.

12.12 The assets and liabilities of different Sub-funds or different Classes shall be allocated as follows:
(i) the proceeds to be received from the issue of Shares of a Sub-fund shall be applied in the accounts of the Fund to the

relevant Sub-fund;

(ii) where an asset is derived from another asset, such derived asset shall be applied in the books of the Fund to the same

Sub-fund as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value
shall be applied to the relevant Sub-fund;

(iii) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-fund or to any action taken in

connection with an asset of a particular Sub-fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-fund;

(iv) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on Shares of any Sub-fund,

the assets of such Sub-fund shall be reduced by the amount of such dividends; and

(v) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular Sub-

fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-funds pro rata to the NAV of the relevant Sub-fund or in such
other manner as determined by the General Partner acting in good faith.

12.13 For the purposes of the NAV computation:
(i) Shares of the Fund to be redeemed hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after

the time specified by the General Partner on the relevant valuation time and from such time and until paid by the Fund the
price therefore shall be deemed to be a liability of the Fund;

(ii) Shares to be issued by the Fund shall be treated as being in issue as from the time specified by the General Partner

on the valuation time, and from such time and until received by the Fund the price therefore shall be deemed to be a debt
due to the Fund;

(iii) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the currency in which the NAV

for the relevant Sub-fund is calculated shall be valued after taking into account the rate of exchange prevailing on the
principal regulated market of each such asset on the dealing day preceding the valuation time;

(iv) Where on any valuation time the Fund has contracted to:
a. purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Fund

and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Fund;

b. sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Fund and

the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Fund;

provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such valuation

time, then its value shall be estimated by the General Partner.

Art. 13. Frequency and temporary suspension of the calculation of the net asset value per share and of the issue, Re-

demption and conversion of shares.

13.1 The net asset value of Shares and the price for the issue, redemption and conversion of the Shares of all Sub-funds

shall be calculated from time to time by the Fund or any agent appointed thereto by the Fund, at the frequency as determined
in the Issuing Document with respect to each Sub-fund but at least once per year.

13.2 The General Partner may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued; the General Partner

may, in particular, decide that Shares shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity
as provided for in Article 8 and/or elsewhere in these Articles and/or in the Issuing Document.

13.3 The Fund may suspend the determination of the net asset value per Share and the issue, redemption and conversion

of Shares of any Sub-fund:

67003

L

U X E M B O U R G

(i) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of

the investments of the Fund attributable to such Sub-fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than
for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction or sus-
pension affects the valuation on the investments of the Fund attributable to a Sub-fund quoted thereon; or

(ii) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the General Partner as

a result of which disposals or valuation of assets owned by the Fund attributable to such Sub-fund would be impracticable
or detrimental to the Fund; or

(iii) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any

of the investments of such Sub-fund or the current price or values on any stock exchange or other market in respect of the
assets attributable to such Sub-fund; or

(iv) when for any other reason the prices of any investments owned by the Fund attributable to any Sub-fund cannot

promptly or accurately be ascertained; or

(v) during any period when the General Partner is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of the Shares of such Sub-fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition,
of investments or payments due on redemption of Shares cannot, in the opinion of the General Partner, be effected at normal
rates of exchange; or

(vi) if a resolution calling for the liquidation of the Fund has been adopted; or
(vii) if an underlying asset in which the Fund has invested in excess of 10% (ten percent) of the NAV of the Fund

suspends the calculation of the NAV of the relevant shares.

Any such suspension shall be notified as soon as possible to all Shareholders concerned. Where possible, all reasonable

steps will be taken to bring a period of suspension to an end as soon as possible.

III. Administration and supervision

Art. 14. Management.
14.1 The Fund shall be managed by Goodhart Partners S.à r.l., acting as General Partner, who shall be the unlimited

liable shareholder (associé-gérant-commandité) and who shall be personally, jointly and severally liable with the Fund for
all liabilities which cannot be met out of the assets of the Fund. The Shareholders shall refrain from acting in a manner or
capacity other than by exercising their rights as Shareholders in general meetings and shall be liable to the extent of their
investments made to the Fund as per Article 8 hereof.

14.2 The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the

Fund’s interest which are not expressly reserved by laws or by these Articles to the general meeting of Shareholders, each
time in compliance with the investment objectives and strategy of the Fund.

14.3 The General Partner may not be removed from its capacity as manager of the Fund, except as otherwise expressly

provided for by the law and by these Articles, in any other event except for fraud, gross negligence or wilful misconduct.

14.4 Upon the removal of the General Partner, a new manager of the Fund shall be appointed by the Shareholders in a

general meeting with the majority requirements set out in Article 33 below, which shall substitute the General Partner as
manager of the Fund by the accomplishment of any relevant and appropriate formalities, and which shall assume the General
Partner’s obligations as manager of the Fund.

14.5 The General Partner may, from time to time, appoint officers or agents of the Fund as required for the operation

and management of the Fund, provided however that the Limited Shareholders may not act on behalf of the Fund without
risking their limited liability status. The appointed officers or agents shall be entrusted with the powers and duties conferred
to them by the General Partner.

14.6 Pursuant to the AIFMD and the 2013 Law, the General Partner may in particular appoint (i) service providers as

permitted by applicable rules and regulations, (ii) a Luxembourg or foreign alternative investment fund manager authorised
pursuant to the AIFMD and the 2013 Law (the Manager). The General Partner may enter into agreements with such persons
or companies for the provision of their services, the delegation of powers to them, and the determination of their remune-
ration to be borne by the Fund. Where the law of a non-EU member country requires that certain financial instruments are
held in custody by a local entity and there are no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in Article
21,  paragraph  11  (d)  (ii),  of  the  AIFMD  respectively  Article  19,  paragraph  (11)  (d)  (ii)  of  the  2013  Law,  the  Fund’s
depositary may discharge itself of liability provided that the conditions laid down in article 21, paragraph 14, of the AIFMD
respectively Article 19, paragraph (14) of the 2013 Law are met. Information regarding any discharge by the depositary of
its liability, as well as any material change to this information, will be disclosed or made available to prospective investors
and Shareholders in accordance with Article 8.3 of these Articles and to the extent required by applicable laws and regu-
lations. The General Partner may enter into agreements with such persons or companies for the provision of their services,
the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Fund. Where the law of
a non-EU member country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity and there are no
local entities that satisfy the delegation requirements laid down in article 21, paragraph 11 (d) (ii), of the AIFMD, the Fund's
depositary can discharge itself of liability provided that the conditions laid down in article 21, paragraph 14, of the AIFMD
are met.

67004

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Corporate signature.
15.1 Vis-à-vis third parties, the Fund is validly bound by the sole signature of the General Partner acting through one

or more authorised signatories or by the individual or joint signatures of any other persons to whom authority shall have
been delegated by the General Partner as the General Partner shall determine in its discretion.

Art. 16. Delegation of powers.
16.1 The General Partner may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as

well as any other officers that the Fund deems necessary for the operation and management of the Fund or any Sub-fund.
Such appointments may be cancelled at any time by the General Partner. The officers need not be Shareholders of the Fund.
Unless otherwise stipulated by these Articles, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the
General Partner. The General Partner may furthermore appoint other agents, who need not to be members of the board of
managers of the General Partner and who will have the powers determined by the General Partner.

16.2 The General Partner may create from time to time one or several committees composed of members of the board

of managers of the General Partner and/or external persons and to which it may delegate powers and roles as appropriate.

Art. 17. Investment policies and restrictions.
17.1 The General Partner, based upon the principle of risk diversification and in accordance with the Issuing Document,

has the power to determine the investment policies and strategies of each Sub-fund of the Fund and the course of conduct
of the management and business affairs of the Fund, within the restrictions as shall be set forth by the General Partner in
compliance with applicable laws and regulations.

17.2 The Fund may employ for each Sub-fund techniques and instruments relating to transferable securities, currencies

or any other financial assets or instruments in the context of its investment policy or for the purpose of hedging or efficient
portfolio management.

Art. 18. Conflict of interests.
18.1 No contract or other transaction between the Fund and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the fact that any one or more of the manager or officers of the General Partner is interested in, or is a manager, associate,
officer or employee of such other company or firm. Any manager or officer of the General Partner who serves as a manager,
officer or employee of any company or firm, with which the Fund shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm be prevented from considering and voting or acting upon
any matters with respect to such contract or other business.

18.2 In the event that any manager or officer of the General Partner may have in any transaction of the Fund an interest

different to the interests of the Fund, such manager or officer shall make known to the General Partner such conflict of
interest and shall not consider or vote on any such transaction and such transaction, and such manager’s or officer’s interest
therein shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.

18.3 The term «conflict of interests», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest

in any matter, position or transaction involving the sponsor, the investment manager, the depositary, the distributors as well
as any other person, company or entity as may from time to time be determined by the General Partner on its discretion.

Art. 19. Indemnification.
19.1 The Fund may indemnify any General Partner or committee member and his heirs, executors and administrators

against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a manager or officer or committee member of the Fund or, at its request, of
any other company of which the Fund is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement as to which the Fund is advised by counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty.

19.2 The General Partner may decide that expenses effectively incurred by any General Partner or committee member

in accordance with this Article may be advanced to the indemnified officer, provided that this officer will repay the advanced
amounts if it is ultimately determined that he has not met the standard of care for which indemnification is available.

19.3 The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which any officer may be entitled.

Art. 20. Auditor.
20.1 The accounting data related in the annual report of the Fund shall be examined by an auditor (réviseur d’entreprises

agréé) appointed by the General Partner and remunerated by the Fund.

20.2 The auditor shall fulfil the duties prescribed by the 2007 Law.

IV. General meetings

Art. 21. Powers.
21.1 The general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Fund.

67005

L

U X E M B O U R G

21.2 Its resolutions shall be binding upon all the Shareholders of the Fund. It shall have the broadest powers to order,

carry out or ratify acts relating to the operations of the Fund.

Art. 22. Annual general meetings of shareholders.
22.1 The annual general meeting of Shareholders shall be held on the last Monday of the month of June of each year at

4.00 p.m. (Luxembourg time) and for the first time on 2010. If this date is not a business day, the annual general meeting
shall be held on the next following business day.

22.2 The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the General Partner,

exceptional circumstances beyond the scope of the Fund’s or of its Shareholder’s control will so require.

Art. 23. Other general meetings of shareholders. The General Partner may convene other general meetings of Share-

holders. Shareholders representing one tenth of the share capital may also request the General Partner to call a general
meeting of Shareholders. Such other general meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be
specified in the respective notices of the meeting.

Art. 24. Procedure.
24.1 The general meetings of Shareholders shall be convened by the General Partner pursuant to a notice setting forth

the agenda and sent to the Shareholders by registered letter at least eight calendar days prior to the meeting. If all Share-
holders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general
meeting may take place without notice of the meeting.

24.2 Notices to Shareholders may be mailed by registered mail only.
24.3 The General Partner may determine all other conditions, which must be fulfilled by the Shareholders in order to

attend a general meeting of Shareholders.

24.4 The chairman of the board of the General Partner shall preside at all general meetings of Shareholders, but, in his

absence, the general meeting of Shareholders may appoint a manager or any other person as chairman pro tempore, by vote
of a majority of Shares present or represented at any such meeting. The chairman of such meeting of Shareholders shall
designate a secretary who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the general meeting of Shareholders
as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the chairman.

Art. 25. Vote.
25.1 The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by Luxembourg law) and business incidental to such matters.

25.2 Each Share in whatever Sub-fund is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles.

Only full Shares are entitled to vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by giving a written proxy to
another person, who needs not to be a Shareholder and who may be a manager of the Fund.

25.3 Unless otherwise provided by Luxembourg law or herein, resolutions of the general meeting of Shareholders are

passed by a simple majority vote of the Shareholders present or represented.

25.4 Any resolution of the general meeting of Shareholders affecting the rights of the holders of Shares of any Sub-fund

vis-à-vis the rights of the holders of Shares of any other Sub-fund(s), shall be subject in respect of each Sub-fund to the
quorums and majority requirements described in article 33 hereof.

Art. 26. General meetings of sub-fund(s).
26.1 The Shareholders of any Sub-fund may hold, at any time, general meetings of Shareholders to decide on any matter,

which relates exclusively to such Sub-fund.

26.2 The provisions of articles 25, paragraphs 1, 2 and 3 as well as article 24, paragraphs 1 and 2 shall apply to such

Sub-fund specific general meetings of Shareholders. Unless otherwise provided for by Luxembourg law or herein, reso-
lutions of the general meeting of Shareholders of a Sub-fund are passed by a simple majority vote of the Shareholders
present or represented.

Art. 27. Term, liquidation and merger of sub-funds.
27.1 The Sub-funds may be created for any undetermined period or for a fixed period as provided for in the Issuing

Document. In case a Sub-fund is created for a fixed period, it will terminate automatically on its maturity date provided
for in the Issuing Document.

27.2 The General Partner of the Fund may decide to liquidate one Sub-fund if the net assets of such Sub-fund have

decreased to, or have not reached, an amount determined by the General Partner to be the minimum level for such Sub-
fund to be operated in an economically efficient manner or if a change in circumstances relating to the Sub-fund concerned
would justify such liquidation. Any Shareholders will be notified by the Fund of any decision to liquidate the relevant Sub-
fund prior to the effective date of the liquidation and the notice will indicate the reasons for, and the procedures of, the
liquidation operations.

27.3 Unless otherwise provided for in the relevant Sub-fund Supplement, the Shareholders of the Sub-fund concerned

may request the redemption, free of charge, of their Shares upon or prior to the liquidation by application of the applicable
liquidation NAV as determined by the General Partner. Assets which cannot be distributed to their beneficiaries upon the

67006

L

U X E M B O U R G

close of liquidation of the Sub-fund concerned will be deposited with the Depositary for a period of nine months starting
at the decision to liquidate. Such a nine months period could be extended with the CSSF prior approval in special cir-
cumstances. After such time, the assets will be deposited with the Caisse des Consignations on behalf of their beneficiaries.

27.4 The General Partner may decide to terminate one Sub-fund and contribute its assets and liabilities into another Sub-

fund or into another collective investment scheme or an assimilated entity. The General Partner may resolve to amalgamate
two or more Sub-funds. The General Partner may also resolve to amalgamate two or more Share Classes. Affected Sha-
reholders will be notified any such decision and the relevant information in relation to the new Sub-fund or Class. Notice
will be provided at least one month before the date on which the amalgamation becomes effective in order to enable
Shareholders to request that their Shares be redeemed before the amalgamation is completed.

Art. 28. Consolidation/splitting. The General Partner may decide to consolidate or split the Shares of a Sub-fund within

a given Share Class. The Shareholders will be notified by the General Partner and will benefit from a one month period to
redeem their Shares free of charge.

V. Accounting year - Distributions

Art. 29. Accounting year.
29.1 The accounting year of the Fund shall commence each year on the 1 (first) of April and shall terminate on the 31

(thirty-first) of March of the same year.

29.2 The first accounting year of the Fund will commence on the date of incorporation of the Fund and terminate on the

31 (thirty-first) March 2010.

Art. 30. Distributions.
30.1 Distributions shall be paid in accordance with any order of payments set forth in the Issuing Document and more

in particular as set forth in respect of each Sub-fund in the Sub-fund Supplements. The general meeting of Shareholders in
respect of each Sub-fund, within the limits provided for by Luxembourg law, shall determine how the profits, if any, of the
Fund shall be treated, and from time to time may declare dividends, provided, however, that the capital of the Fund does
not fall below the prescribed minimum Share capital.

30.2 The General Partner may in its discretion decide to pay interim dividends at any point in time unless otherwise

provided for in the Issuing Document and, more in particular, as set forth in the Sub-fund Supplements.

30.3 Distributions shall be paid in USD or in the base currency of a Sub-fund or Share Class and at such time and place

that the General Partner shall determine from time to time.

30.4 No interest shall be paid on a dividend declared by the Fund and kept by it at the disposal of its beneficiary.
30.5 A dividend declared but not paid on a Share cannot be claimed by the holder of such Share after a period of five

years from the notice given thereof, unless the General Partner has waived or extended such period in respect of all Shares,
and shall otherwise revert after expiry of the period to the relevant Sub-fund of the Fund. The General Partner shall have
power from time to time to take all steps necessary and to authorize such action on behalf of the Fund to perfect such
reversion.

Art. 31. Depositary.
31.1 To the extent required by law, the Fund shall enter into a written depositary agreement with a credit institution,

investment firm, professional depositary of assets other than financial instruments or any other eligible entity that may
qualify as depositary from time to time, as these entities are defined by the Luxembourg law of 5 April, 1993 on the financial
sector, as amended from time to time, and which shall satisfy the requirements of the 2007 Law and the AIFM Law (herein
referred to as the Depositary).

31.2 The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2007 Law, the AIFM Law as well

as by all other applicable Luxembourg Laws and regulations.

31.3 If the Depositary wishes to retire, the General Partner shall use its best endeavours to find a successor Depositary

within two months of such retirement. The General Partner may terminate the appointment of the Depositary but shall not
remove the Depositary unless and until a successor depositary shall have been appointed in to act in its place.

Art. 32. Dissolution.
32.1 The Fund may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders subject to the quorum

and majority requirements referred to in article 33 hereof.

32.2 Whenever the share capital falls below the two thirds of the minimum capital indicated in article 5 hereof, the

question of the dissolution of the Fund shall be referred to the general meeting of Shareholders by the General Partner. The
general meeting of Shareholders, for which no quorum shall be required, shall decide by a simple majority of the votes of
the Shares present and represented at the meeting.

32.3 The question of the dissolution of the Fund shall further be referred to the general meeting of Shareholders whenever

the share capital falls below one fourth of the minimum Share capital set by article 5 hereof; in such an event, the general
meeting of Shareholders shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by the votes
of the Shareholders holding one fourth of the Shares represented at the meeting.

67007

L

U X E M B O U R G

32.4 The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from the discovery that the net assets

of the Fund have fallen below two thirds or one fourth of the legal minimum, as the case may be.

32.5 In the event of a dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be

physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall deter-
mine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to law.

32.6 The net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-fund shall be distributed by the liquidators to the holders

of Shares of each Sub-fund in proportion to their holding in the respective Sub-fund (s).

32.7 Any liquidation proceeds that cannot be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the liquidation

will be deposited with the Depositary for a period of nine months thereafter; after such period, the assets will be deposited
with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

Art. 33. Amendments to the articles of association. These Articles may be amended by a general meeting of Shareholders

subject to the quorum requirements provided for by the 1915 Law.

Art. 34. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons

or Shareholders also include corporations, partnerships, associations and any other organized group of persons whether
incorporated or not.

Art. 35. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915

Law and the 2007 Law (the Laws) as such Laws have been or may be amended from time to time.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to approve the modifications to the issuing document of the SIF, in the form provided to them.

<i>Declaration

Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the members of the Bureau.
Signé: C. LEROY, J.-B. SIMBA, S. GIOVANARDI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 février 2015. Relation: 1LAC/2015/4946. Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015054876/561.
(150062808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Grand Shanghai s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 11, rue d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 151.152.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Grand Shanghai S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015053657/12.
(150061181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Pépinière Weisen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3980 Wickrange, 19, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 41.992.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 09/04/2015.

Signature.

Référence de publication: 2015053896/10.
(150061562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

67008


Document Outline

Buildco Warsaw S.A.

Caballo Fello S.à r.l.

Café Beim Marco S.à r.l.

Carignan Holding S.A.

Carlo Invest S.A. SPF

Catalyst Holdings S.à r.l.

Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l.

Cessna S.A.

Cesto S.A.

Cesto S.A.

CGI Luxembourg SA

Chimica Sospirolo S.à r.l.

CHSM S.à r.l.

Class Real Estate Investments S.à r.l.

Clowns4u

Coditel S.à.r.l.

Cogetech

Communauté Agricole Soprana

Compagnie Internationale de Participations Automobiles S.A.

ContourGlobal Development S.à r.l.

ContourGlobal Luxembourg S.à r.l.

Cournoise Investments S.A.

Covidien Group S.à r.l.

Creathor Venture Management Luxembourg

Credit Opportunity One S.à r.l.

Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF

Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF

Crystal GP S.à.r.l.

Cube Infrastructure Fund

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung A S.à r.l.

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung A S.à r.l.

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung B S.à r.l.

Dortmund, Westenhellweg 30-36 Beteiligung B S.à r.l.

Dragon Holdings S.à r.l.

East&amp;West Finances S.A.

Eclaircie s.à.r.l.

EdgeWorth Capital (Luxembourg) S.à r.l.

EDU Luxco S.à r.l.

Entreprise Jacques Streff Services S.A.

Goodhart Partners Longitude Fund Sicav-SIF

Grand Shanghai s.à r.l.

Pépinière Weisen S.A.

Shaftesbury GP 2 S.à r.l.