logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1304

20 mai 2015

SOMMAIRE

Abbott Overseas Luxembourg S.à r.l.  . . . .

62576

Abbott Poland Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

62577

Abbott Products Luxembourg S.à r.l.  . . . .

62577

Abbott South Africa Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62577

Adriatic Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62578

Advanced Global Holding Limited S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62578

Aicy International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62578

AIR.CA S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62578

Ambo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62579

BHI (GBA) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62579

BRE/Mannheim I Hotel S. à r.l.  . . . . . . . . . .

62579

BRE/Nine Hotel Holding S. à r.l.  . . . . . . . . .

62580

Caireen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62580

Carmosina S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62581

CFG Patrimoine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62554

CitCor Franconia Süd S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

62582

Cristal Investment s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

62582

CROWN PREMIUM Private Equity V Mas-

ter Europe S.C.S., SICAF-FIS  . . . . . . . . . .

62582

Data Center S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62546

Diekirch Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

62584

Digital Consulting Company S.A.  . . . . . . . .

62582

Dornie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62584

DSG S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62584

Dutyfly Solutions Luxembourg S.à r.l. . . . .

62586

East Coast S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62585

Edmond de Rothschild Europportunities

Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62585

Embafin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62585

Euro Prudence F.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62569

Findel Business Center West Side S.A. . . .

62571

Horest, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62572

Immobilière Daniel Beck S.à r.l.  . . . . . . . . .

62573

Ipan Investment SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62574

Lux Chapiteaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62592

Marie Lingerie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62574

MCH Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62575

Mondial Industrie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62592

NPF Soparfi D S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62575

NYK Hummingbird S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

62575

Oeko-Bureau, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62576

Recordati S.A. Chemical and Pharmaceu-

tical Company  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62569

Sol o plafond S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62576

Superfund Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62590

Top Manager  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62569

62545

L

U X E M B O U R G

Data Center S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 193.221.

In the year two thousand and fifteen, the sixth day of May.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand- Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Data Center S.C.A., a Luxembourg corporate

partnership limited by shares (société en commandite par actions) having its registered office at 121, avenue de la Faïen-
cerie L- 1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 193221 (the Company). The Company was incorporated on 15 December 2014 pursuant to a deed of
demerger of Data Center S.C.A. (renamed Data Center II S.C.A.), a Luxembourg corporate partnership limited by shares
(société en commandite par actions) having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170139,
recorded by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N° 152 of 20 January 2015. The articles of association of the Company (the Articles) have last been
amended on 24 March 2015, pursuant to a deed recorded by the undersigned notary, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting opens and the Meeting elects Mrs. Anaïs DEYGLUN, notary clerk, with professional address in L-8510

Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, as chairman of the Meeting (the Chairman).

The Chairman appoints Mrs. Sara LECOMTE, notary clerk, with professional address in L-8510 Redange-sur-Attert,

66, Grand-Rue, as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, with professional address in L-8510 Redange-sur-Attert, 66,

Grand-Rue as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The shareholders represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list

established by the members of the Bureau which will remain attached to the present deed. The attendance list is signed
by the attorney in fact of all the shareholders, the members of the Bureau and the notary.

The proxies of the shareholders of the Company, after having been signed ne varietur by the proxyholders acting on

behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with
such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the undersigned notary to record the

following:

I. that the agenda of the Meeting (the Agenda) is worded as follows:
(1) increase of the share capital of the Company by a nominal amount of EUR 220,760.57 (two hundred twenty thousand

seven hundred sixty Euros and fifty-seven cents) in order to bring the share capital of the Company from its current
amount of EUR 882,851.22 (eight hundred eighty-two thousand eight hundred fifty-one Euros and twenty-two cents) to
EUR 1,103,611.79 (one million one hundred three thousand six hundred eleven Euros and seventy-nine cents) by way of
creation and issuance of 22,076,057 (twenty-two million seventy-six thousand fifty-seven) Class A3 Shares in the Company
having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each in the share capital of the Company;

(2) individual waiver by the existing shareholders of their preemptive rights in connection with the increase of the

share capital as referred to in item (1) above in favour of Data Genpar Master Vehicle S.C.S.;

(3) intervention, subscription to and payment in full of the new shares specified under item (1) above by Data Genpar

Master Vehicle S.C.S. by means of a contribution in cash in an amount of EUR 15,183,384.27 (fifteen million one hundred
eighty-three thousand three hundred eighty-four Euros and twenty-seven cents);

(4) distribution of the Equalisation Distribution (as defined in the Articles) as follows:
(i) Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 141,427.04 (one hundred forty-one thousand

four hundred twenty-seven Euros and four cents) to bring the share capital from its current amount of EUR 1,103,611.79
(one  million  one  hundred  three  thousand  six  hundred  eleven  Euros  and  seventy-nine  cents)  to  an  amount  of  EUR
962,184.75 (nine hundred sixty-two thousand one hundred eighty-four Euros and seventy-five cents) by way of the can-
cellation of:

- 13,764,125 (thirteen million seven hundred sixty-four thousand one hundred twenty-five) Class A1 Old Investment

Shares; and

- 378,579 (three hundred seventy-eight thousand five hundred seventy-nine) Class A1 New Investment Shares;
held by ColData 4 (Lux) S.à r.l.; and
(ii) distribution of EUR 12,551,438.98 (twelve million five hundred fifty-one thousand four hundred thirty-eight Euros

and ninety-eight Cents) out of the share premium account to ColData 4 (Lux) S.à r.l.;

62546

L

U X E M B O U R G

(5) Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 35,404.51 (thirty-five thousand four hundred

and four Euros and fifty-one cents) to bring the share capital from its current amount of EUR 962,184.75 (nine hundred
sixty-two thousand one hundred eighty-four Euros and seventy-five cents) to an amount of EUR 926,780.24 (nine hundred
twenty-six thousand seven hundred eighty Euros and twenty-four cents) by way of the cancellation of 3,540,451 (three
million five hundred forty thousand four hundred fifty-one) Class A3 Shares held by Data Genpar Master Vehicle S.C.S.

(6) amendment to article 5.1 of the Articles in order to reflect the changes set out in the above agenda items;
(7) amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to the sole manager of the Company to proceed, on behalf of the Company, to the registration of the changes
required by the matters here above in the share register of the Company; and

(8) miscellaneous.
II. It appears from the attendance list that all of the 88,185,122 (eighty-eight million one hundred eighty-five thousand

one hundred twenty-two) Class A1 Shares, 99,900 (ninety-nine thousand nine hundred) Class B Shares and 100 (one
hundred) Class C Shares of the Company, having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, are duly represented at
the Meeting; the Meeting waiving the convening notices, the shareholders represented consider themselves as duly con-
vened and declare having perfect knowledge of the Agenda which has been communicated to them in advance.

III. After having acknowledged that Data Genpar S.à r.l. (the General Partner), being the holder of the Class C Shares

of the Company, represented by Mrs. Virginie PIERRU, by virtue of a power of attorney given under private seal, consents
to the passing of all the below resolutions, the Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon
the items on the Agenda.

After deliberation, the Meeting has taken, by a unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 220,760.57 (two hundred

twenty thousand seven hundred sixty Euros and fifty-seven cents) in order to bring the share capital of the Company
from its current amount of EUR 882,851.22 (eight hundred eighty-two thousand eight hundred fifty-one Euros and twenty-
two cents) represented by 88,185,122 (eighty-eight million one hundred eighty-five thousand one hundred twenty-two)
Class A1 Shares, 99,900 (ninety-nine thousand nine hundred) Class B Shares and 100 (one hundred) Class C Shares,
having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, to an amount of EUR 1,103,611.79 (one million one hundred three
thousand six hundred eleven Euros and seventy-nine cents) by way of the creation and issuance of 22,076,057 (twenty-
two million seventy-six thousand fifty-seven) Class A3 Shares in the Company, having a nominal value of EUR 0.01 (one
Cent) each.

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles accordingly, the content of which shall be included in the

sixth resolution below.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to accept and record the following interventions relating to the waiver of the pre-emptive rights

of the shareholders of the Company to the extent required for the purpose of the issuance of the Class A3 Shares, as
set out under the first resolution, to Data Genpar Master Vehicle S.C.S.

<i>Interventions

All the shareholders of the Company, each being represented by Mrs. Virginie PIERRU, prenamed, by virtue of powers

of attorney given under private seal, initialled and attached to this deed, as described above, declare to individually waive
their preemptive rights to the extent required for the purpose of the issuance of the Class A3 Shares, as set out under
the first resolution, to Data Genpar Master Vehicle S.C.S.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following intervention, subscription to and full payment of the share

capital increase referred to under the above first resolution as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Data Genpar Master Vehicle S.C.S., a limited partnership (société en commandite simple) incorporated under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 176585
(Master Vehicle),

hereby represented by Mrs. Virginie PIERRU, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal,

initialled ne varietur by the attorney in fact of all the shareholders, the members of the Bureau and the notary which will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

intervenes at the present Meeting and hereby declares to:
(i) subscribe to all the 22,076,057 (twenty-two million seventy-six thousand fifty-seven) Class A3 Shares, having a

nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, for an aggregate subscription price of EUR 15,183,384.27 (fifteen million one

62547

L

U X E M B O U R G

hundred eighty-three thousand three hundred eighty-four Euros and twenty-seven cents), each share having the same
subscription price; and

(ii) pay the 22,076,057 (twenty-two million seventy-six thousand fifty-seven) Class A3 Shares by means of a contribution

in cash in an aggregate amount of EUR 15,183,384.27 (fifteen million one hundred eighty-three thousand three hundred
eighty-four Euros and twenty-seven cents) (the Contribution); and

The Contribution described above in an aggregate amount of EUR 15,183,384.27 (fifteen million one hundred eighty-

three thousand three hundred eighty-four Euros and twenty-seven cents) shall be allocated as follows:

- EUR 220,760.57 (two hundred twenty thousand seven hundred sixty Euros and fifty-seven cents) to the share capital

account of the Company, and

- EUR 14,962,623.70 (fourteen million nine hundred sixty-two thousand six hundred twenty-three Euros and seventy

cents) to the share premium of the Company.

The sum of EUR 15,183,384.27 (fifteen million one hundred eighty-three thousand three hundred eighty-four Euros

and twenty-seven cents) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary.

The Meeting acknowledges that Master Vehicle has become the holder of the issued 22,076,057 (twenty-two million

seventy-six thousand fifty-seven) Class A3 Shares.

As a consequence of the above, Master Vehicle, entitled to vote and represented by Mrs. Virginie PIERRU, prenamed,

by virtue of a power of attorney given under private seal, joins the Meeting for purposes of the following resolutions and
signs the attendance list.

<i>Fourth resolution

The Meeting acknowledges the terms of article 5.7 of the Articles pursuant to which “The holders of Class A1 Shares

shall be entitled to receive a one-off special cash distribution (a) by way of a capital reduction for an amount of EUR
141,427.04 (one hundred forty-one thousand four hundred twenty-seven Euros and four cents) by the cancellation of
13,764,125 (thirteen million seven hundred sixty-four thousand one hundred twenty-five) Class A1 Old Investment Shares
and 378,579 (three hundred seventy-eight thousand five hundred seventy-nine) Class A1 New Investment Shares and (b)
out of the share premium of the Company for an amount of EUR 12,551,438.98 (twelve million five hundred fifty-one
thousand four hundred thirty-eight Euros and ninety-eight cents) (the Equalisation Distribution) subject to and after the
first issuance of Class A3 Shares to be subscribed by the Master Vehicle for a corresponding amount. The Equalisation
Distribution shall be decided by the General Meeting on a date which shall be no earlier than the date of the first issuance
of Class A3 Shares to the Master Vehicle referred to above and no later than 4 (four) days after such date.”

The Meeting resolves to approve the Equalisation Distribution as follows.
The Meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 141,427.04 (one hundred

forty-one thousand four hundred twenty-seven Euros and four cents) in order to bring the share capital from its current
amount of EUR 1,103,611.79 (one million one hundred three thousand six hundred eleven Euros and seventy-nine cents),
represented by 110,261,179 (one hundred ten million two hundred sixty-one thousand one hundred seventy-nine) Class
A Shares, divided into 88,185,122 (eighty-eight million one hundred eighty-five thousand one hundred twenty-two) Class
A1 Shares and 22,076,057 (twenty-two million seventy-six thousand fifty-seven) Class A3 Shares, 99,900 (ninety-nine
thousand nine hundred) Class B Shares and 100 (one hundred) Class C Shares, with a nominal value of EUR 0.01 (one
Cent) each, to an amount of EUR 962,184.75 (nine hundred sixty-two thousand one hundred eighty-four Euros and
seventy-five cents) by way of the cancellation of 14,142,704 (fourteen million one hundred forty-two thousand seven
hundred and four) Class A1 Shares as follows:

- 13,764,125 (thirteen million seven hundred sixty-four thousand one hundred twenty-five) Class A1 Old Investment

Shares; and

- 378,579 (three hundred seventy-eight thousand five hundred seventy-nine) Class A1 New Investment Shares,
held by ColData 4 (Lux) S.à r.l.
The Meeting acknowledges that as a result of this share capital decrease by way of the cancellation of 14,142,704

(fourteen million one hundred forty-two thousand seven hundred and four) Class A1 Shares held by ColData 4 (Lux) S.à
r.l., an aggregate amount of EUR 141,427.04 (one hundred forty-one thousand four hundred twenty-seven Euros and four
cents) shall be due to ColData 4 (Lux) S.à r.l.

The Meeting acknowledges that this share capital decrease by way of the cancellation of 14,142,704 (fourteen million

one hundred forty-two thousand seven hundred and four) Class A1 Shares will allow creditors of the Company to apply
for the posting of collateral to the Luxembourg district court within 30 days from the publication of the notarial deed
recording the minutes of the Meeting in the Luxembourg official gazette in accordance with article 69 of the law dated
10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles accordingly, the content of which shall be included in the

sixth resolution below.

The Meeting further acknowledges that, according to the information made available to it by the general partner of

the Company and based on (i) the interim accounts of the Company as at 31 March 2015 and (ii) a certificate of the sole

62548

L

U X E M B O U R G

manager of the Company dated 6 May 2015 (the Management Certificate), (a) an amount of at least EUR 12,551,438.98
(twelve million five hundred fifty-one thousand four hundred thirty-eight Euros and ninety-eight Cents) is booked in the
share premium account of the Company and is available for distribution by the Company, and (b) the Company does not
have losses that would prevent that distribution from being made.

The interim accounts of the Company as at 31 March 2015 and the Management Certificate, after having been signed

ne varietur by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The  Meeting  resolves  to  approve  the  distribution  of  share  premium  from  the  Company  in  the  amount  of  EUR

12,551,438.98 (twelve million five hundred fifty-one thousand four hundred thirty-eight Euros and ninety-eight Cents)
out of the share premium account of the Company, to the sole holder of Class A1 Shares, i.e. ColData 4 (Lux) S.à r.l.

<i>Fifth resolution

The  Meeting  resolves  to  decrease  the  share  capital  of  the  Company  by  an  amount  of  EUR  35,404.51  (thirty-five

thousand four hundred and four Euros and fifty-one cents) in order to bring the share capital from its current amount of
EUR 962,184.75 (nine hundred sixty-two thousand one hundred eighty-four Euros and seventy-five cents), represented
by 96,118,475 (seven ninety-six million one hundred eighteen thousand four hundred seventy-five) Class A Shares, divided
into 74,042,418 (seventy-four million forty-two thousand four hundred eighteen) Class A1 Shares and 22,076,057 (twenty-
two million seventy-six thousand fifty-seven) Class A3 Shares, 99,900 (ninety-nine thousand nine hundred) Class B Shares
and 100 (one hundred) Class C Shares, with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, to an amount of EUR 926,780.24
(nine hundred twenty-six thousand seven hundred eighty Euros and twenty-four cents) by way of the cancellation of
3,540,451 (three million five hundred forty-thousand four hundred fifty-one) Class A3 Shares held by Master Vehicle.

The Meeting acknowledges that as a result of this share capital decrease by way of the cancellation of 3,540,451 (three

million five hundred forty-thousand four hundred fifty-one) Class A3 Shares held by Master Vehicle, an aggregate amount
of EUR 35,404.51 (thirty-five thousand four hundred and four Euros and fifty-one cents) shall be due to Master Vehicle.

The Meeting acknowledges that this share capital decrease by way of the cancellation of 3,540,451 (three million five

hundred forty-thousand four hundred fifty-one) Class A3 Shares will allow creditors of the Company to apply for the
posting of collateral to the Luxembourg district court within 30 days from the publication of the notarial deed recording
the minutes of the Meeting in the Luxembourg official gazette in accordance with article 69 of the law dated 10 August
1915 on commercial companies, as amended.

All the shareholders, represented as stated above, expressly agree to this capital reduction to the benefit of Master

Vehicle and waive any rights they may have in this respect.

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles accordingly, the content of which shall be included in the

sixth resolution below.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the increase and decreases of the share capital of the Company set out in the first, fourth and

fifth resolutions here above, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles accordingly, which shall henceforth
read as follows:

“ 5.1. Outstanding share capital. The share capital is set at EUR 926,780.24 (nine hundred twenty-six thousand seven

hundred eighty Euros and twenty-four cents), represented by:

(a) 92,578,024 (ninety-two million five hundred seventy-eight thousand twenty-four) limited shares of class A (the

Class A Shares), being further sub-divided into two sub-classes consisting of:

(i) 74,042,418 (seventy-four million forty-two thousand four hundred eighteen) class A1 shares (the Class A1 Shares),

which are further sub-divided into72,060,415 (seventy-two million sixty thousand four hundred fifteen) Class A1 Old
Investment Shares and 1,982,003 (one million nine hundred eighty-two thousand and three) Class A1 New Investment
Shares; and

(ii) 18,535,606 (eighteen million five hundred thirty-five thousand six hundred six) class A3 shares (the Class A3 Shares);
(b) 99,900 (ninety-nine thousand nine hundred) limited shares of class B (the Class B Shares); and
(c) 100 (one hundred) unlimited shares of class C (the Class C Shares),
having a nominal value of EUR 0.01 (one cent) each.
The Class A Shares and the Class B Shares are collectively referred to as the limited shares and the Class C Shares

are referred to as the unlimited shares, and the terms limited shareholder and unlimited shareholder shall be construed
accordingly. The Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares are collectively referred to as the shares and
the term shareholder shall be construed accordingly.

The Class B Shares shall be held by the Promoter in accordance with the Shareholders Agreement.
Notwithstanding the provisions of this Article 5, any issuance of new Instruments by the Company will have to comply

with the relevant provisions of the Shareholders Agreement.”

62549

L

U X E M B O U R G

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorizes the any manager of the General Partner, as well as any manager of Colony Luxembourg S.à r.l.
to, in the name and on behalf of the Company, proceed to the registration of the issuance of the new shares in the share
register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

<i>Statement

The undersigned notary declares that the conditions provided by 26-3 and 26-5 of the law dated 10 August 1915 on

commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

There being no further business on the Agenda of the Meeting, the Chairman declares the Meeting closed.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately six thousand five hundred Euros (EUR 6,500.-).

Whereof the present notarial deed is drawn in Redange-sur-Attert, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, the appearing parties signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de mai.
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur- Attert, Grand-Duché du Luxembourg,

S’est tenue

une assemblée générale extra un ordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de Data Center S.C.A., une société en

commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro B 193221 (la Société). La Société a été constituée en date du 15 décembre 2014 suivant un acte de scission
de Data Center S.C.A. (renommée en Data Center II S.C.A.), une société en commandite par actions de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 170139, enregistré
par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations N° 152 en date du 20 janvier 2015. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été
modifiés pour la dernière fois le 24 mars 2015 en vertu d’un acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée s’ouvre et l’Assemblée nomme Mme Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, demeurant professionnellement

à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, comme président de l’Assemblée (le Président).

Le Président désigne comme secrétaire de l’Assemblée Mme Sara LECOMTE, clerc de notaire, demeurant profes-

sionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand- Rue (le Secrétaire).

L’Assemblée nomme comme scrutateur de l’Assemblée Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant profes-

sionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand- Rue (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble le Bureau.
Les actionnaires représentés à l’Assemblée ainsi que le nombre d’actions qu'ils détiennent sont indiqués dans une liste

de présence établie par les membres du Bureau qui restera annexée au présent acte. La liste de présence est signée par
le représentant de tous les actionnaires, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

Les procurations des actionnaires représentés à l’Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les mandataires

au nom des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte afin d’être enregistrées
avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

Le Bureau ainsi constitué, le Président constate et prie le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée (l’Ordre du Jour) est le suivant:
(1) Augmentation du capital social de la Société d’un montant nominal de 220.760,57 EUR (deux cent vingt mille sept

cent soixante euros et cinquante-sept cents) afin de porter le capital social de son montant actuel de 882.851,22 EUR
(huit cent quatre-vingt-deux mille huit cent cinquante-et-un euros et vingt-deux cents) à un montant de 1.103.611,79 EUR
(un million cent trois mille six cent onze euros et soixante-dix-neuf cents) au moyen de la création et de l’émission de
22.076.057 (vingt-deux millions soixante-seize mille cinquante-sept) Actions de Classe A3 de la Société ayant une valeur
nominale de 0,01 EUR (un cent d’euro) chacune dans le capital social de la Société;

62550

L

U X E M B O U R G

(2) Renonciation individuelle aux droits de préemption des actionnaires actuels concernant l’augmentation de capital

social mentionnée au point (1) ci-dessus en faveur de Data Genpar Master Vehicle S.C.S.;

(3) Intervention, souscription et paiement en intégralité des nouvelles actions mentionnées au point (1) ci-dessus par

Data Genpar Master Vehicle S.C.S. au moyen d’un apport en numéraire d’un montant de 15.183.384,27 EUR (quinze
millions cent quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-sept cents);

(4) Distribution de la Distribution d’Egalisation (telle que définie dans les Statuts), comme suit:
(i) Réduction du capital social de la Société d’un montant de 141.427,04 EUR (cent quarante-et-un mille quatre cent

vingt-sept euros et quatre cents) afin de porter le capital social de son montant actuel de 1.103.611,79 EUR (un million
cent trois mille six cent onze euros et soixante-dix-neuf cents) à un montant de 962.184,75 EUR (neuf cent soixante-
deux mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quinze cents) au moyen de l’annulation de:

- 13.764.125 (treize millions sept cent soixante-quatre mille cent vingt-cinq) Actions de Classe A1 Ancien Investisse-

ment; et

- 378.579 (trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent soixante-dix-neuf) Actions de Classe A1 Nouvel Investissement
détenues par ColData 4 (Lux) S.à r.l.; et
(ii) distribution d’un montant de 12.551.438,98 EUR (douze millions cinq cent cinquante-et-un mille quatre cent trente-

huit euros et quatre-vingt-dix-huit cents) pris sur le compte de prime d’émission en faveur de ColData 4 (Lux) S.à r.l.;

(5) Réduction du capital social de la Société d’un montant de 35.404,51 EUR (trente-cinq mille quatre cent quatre

euros et cinquante-et-un cents) afin de le porter de son montant actuel de 962.184,75 EUR (neuf cent soixante-deux
mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quinze cents) à un montant de 926.780,24 EUR (neuf cent vingt-six mille
sept cent quatre-vingt euros et vingt-quatre cents) au moyen de l’annulation de 3,540,451 (trois millions cinq cent quarante
mille quatre cent cinquante-et-un) Actions de Classe A3 détenues par Data Genpar Master Vehicle S.C.S.

(6) Modification de l’article 5.1 des Statuts afin d’y refléter les modifications mentionnées aux points ci-dessus de

l’Ordre du Jour;

(7) Modification du registre des actions de la Société afin d’y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et

autorisation accordés au gérant unique de la Société afin de procéder, pour le compte de la Société, à l’inscription des
modifications ci-dessus dans le registre des actions de la Société; et

(8) Divers.
II. Il apparaît sur la liste de présence que la totalité des 88.185.122 (quatre-vingt-huit millions cent quatre-vingt-cinq

mille cent vingt-deux) Actions de Classe A1, 99.900 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents) Actions de Classe B, et 100
(cent) Actions de Classe C de la Société, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d’euro), est dûment
représentée à l’Assemblée; l’Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires représentés se consi-
dérant  comme  dûment  convoqués  et  déclarant  avoir  une  parfaite  connaissance  de  l’Ordre  du  Jour,  qui  leur  a  été
communiqué auparavant.

III. Après avoir pris connaissance que Data Genpar S.à r.l. (le Gérant Commandité), détenteur des Actions de Classe

C de la Société, représenté par Mme Virginie PIERRU, prénommée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé,
consent à l’approbation de toutes les résolutions ci-dessous, l’Assemblée est par conséquent régulièrement constituée
et apte à délibérer sur les point de l’Ordre du Jour.

Après délibération, l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant nominal de 220.760,57 EUR (deux cent

vingt mille sept cent soixante euros et cinquante-sept cents) afin de porter le capital social de son montant actuel de
882.851,22 EUR (huit cent quatre-vingt-deux mille huit cent cinquante-et-un euros et vingt-deux cents) représenté par
88.185.122 (quatre-vingt-huit millions cent quatre-vingt-cinq mille cent vingt-deux) Actions de Classe A1, 99.900 (quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf cents) Actions de Classe B et 100 (cent) Actions de Classe C, ayant chacune une valeur nominale
de 0,01 EUR (un cent d’euro), à un montant de 1.103.611,79 EUR (un million cent trois mille six cent onze euros et
soixante-dix-neuf cents) au moyen de la création et de l’émission de 22.076.057 (vingt-deux millions soixante-seize mille
cinquante-sept) Actions de Classe A3 de la Société, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d’euro).

L’Assemblée décide de modifier l’article 5.1 des Statuts en conséquence, afin de lui conférer la teneur qui sera reprise

à la sixième résolution ci-dessous.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les interventions suivantes et la renonciation à leurs droits de pré-

emption par les actionnaires de la Société en vue de l’émission des Actions de Classe A3, tel qu'indiqué dans la première
résolution ci-dessus, en faveur de Data Genpar Master Vehicle S.C.S.

<i>Interventions

Tous les actionnaires de la Société, représentés individuellement par Mme Virginie PIERRU, prénommée, en vertu de

procurations  accordées  sous  seing  privé,  paraphées  et  annexées  au  présent  acte,  tel  que  décrit  ci-dessus,  déclarent

62551

L

U X E M B O U R G

renoncer individuellement à leurs droits de préemption en vue de l’émission des Actions de Classe A3, tel que stipulé
dans la première résolution ci-dessus, en faveur de Data Genpar Master Vehicle S.C.S.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer l’intervention, la souscription et la libération suivantes de l’augmenta-

tion de capital social mentionnée dans la première résolution ci-dessus, selon les modalités suivantes:

<i>Intervention - Souscription - Libération

Data Genpar Master Vehicle S.C.S., une société en commandite simple de droit luxembourgeois, avec siège social au

121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176585 (Master Vehicle),

ci-après représentée par Mme Virginie PIERRU, prénommée, en vertu d’une procuration accordée sous seing privé,

paraphée ne varietur par le mandataire des parties comparantes, le membres du Bureau et le notaire, laquelle procuration
restera annexée au présent acte afin d’être déposée ensemble auprès des autorités de l’enregistrement,

intervient à la présente Assemblée et déclare:
(i) souscrire à l’intégralité des 22.076.057 (vingt-deux millions soixante-seize mille cinquante-sept) Actions de Classe

A3, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d’euro), pour un prix de souscription total de 15.183.384,27
EUR (quinze millions cent quatre-vingt- trois mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-sept cents), ayant chacune
le même prix de souscription; et

(ii) libérer l’ensemble des 22.076.057 (vingt-deux millions soixante-seize mille cinquante-sept) Actions de Classe A3

au moyen d’un apport en numéraires d’un montant total de 15.183.384,27 EUR (quinze millions cent quatre-vingt-trois
mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-sept cents) (l’Apport).

L’Apport décrit ci-dessus, d’un montant total de 15.183.384,27 EUR (quinze millions cent quatre-vingt-trois mille trois

cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-sept cents) sera ventilé comme suit:

- 220.760,57 EUR (deux cent vingt mille sept cent soixante euros et cinquante-sept cents) seront affectés au compte

de capital social de la Société, et

- 14.962.623,70 EUR (quatorze millions neuf cent soixante-deux mille six cent vingt-trois euros et soixante-dix cents)

seront affectés à la prime d’émission de la Société.

Le montant de 15.183.384,27 EUR (quinze millions cent quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quatre euros

et vingt-sept cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire.

L’Assemblée reconnaît que Master Vehicle est devenu titulaire des 22.076.057 (vingt-deux millions soixante-seize mille

cinquante-sept) Actions de Classe A3 émises.

En conséquence de ce qui précède, Master Vehicle, ayant pouvoir de voter et étant représenté par Mme Virginie

PIERRU, prénommée, en vertu d’une procuration accordée sous seing privé, participe dès lors à l’Assemblée afin de
délibérer des résolutions suivantes, et signe la liste de présence.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée note les termes de l’article 5.7 des Statuts en vertu desquels:
«Les détenteurs d’Actions de Classe A1 auront droit à recevoir une distribution en espèce en une seule fois (a) par

voie d’une réduction de capital d’un montant de 141.427,04 EUR par l’annulation de 13.764.125 Actions de Classe A1
Ancien Investissement et 378.579 Actions de Classe A1 Nouvel Investissement et (b) depuis le compte de prime d’émis-
sion de la Société pour un montant de 12.551.438,98 EUR (la Distribution d’Egalisation) soumise à et après la première
émission d’Actions de Classe A3 devant être souscrites par le Master Vehicle pour un montant équivalent. La Distribution
d’Egalisation sera décidée par l’Assemblée Générale à une date qui ne pourra être antérieure à la date de la première
émission d’Actions de Classe A3 à Master Vehicle référencé ci-dessus et pas plus tard que 4 (quatre) jours après cette
même date.»

L’Assemblée décide d’approuver la Distribution d’Egalisation (telle que définie dans les Statuts), comme suit.
L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de 141.427,04 EUR (cent quarante-et-un

mille quatre cent vingt-sept euros et quatre cents) afin de porter le capital social de son montant actuel de 1.103.611,79
EUR (un million cent trois mille six cent onze euros et soixante-dix-neuf cents) représenté par 110.261.179 (cent dix
millions deux cent soixante-et-un mille cent soixante-dix-neuf) Actions de Classe A, divisées en 88.185.122 (quatre-vingt-
huit millions cent quatre-vingt-cinq mille cent vingt-deux) Actions de Classe A1 Actions de Classe A1 et 22.076.057 (vingt-
deux millions soixante-seize mille cinquante-sept) Actions de Classe A3, 99.900 (quatre-vingt-dix- neuf mille neuf cents)
Actions de Classe B et 100 (cent) Actions de Classe C, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d’euro) chacune,
à un montant de 962.184,75 EUR (neuf cent soixante-deux mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quinze cents)
au moyen de l’annulation de 14.142.704 (quatorze millions cent quarante-deux mille sept cent quatre) Actions de Classe
A1, selon la répartition suivante:

- 13.764.125 (treize millions sept cent soixante-quatre mille cent vingt-cinq) Actions de Classe A1 Ancien Investisse-

ment; et

62552

L

U X E M B O U R G

- 378.579 (trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent soixante-dix- neuf) Actions de Classe A1 Nouvel Investissement,
détenues par ColData (Lux) S.à r.l.
L’Assemblée reconnaît qu'en conséquence de la réduction de capital social au moyen de l’annulation de 14.142.704

(quatorze millions cent quarante-deux mille sept cent quatre) Actions de Classe A1 détenues par ColData 4 (Lux) S.à
r.l., un montant total de 141.427,04 EUR (cent quarante-et-un mille quatre cent vingt-sept euros et quatre cents) sera dû
à ColData 4 (Lux) S.à r.l.

L’Assemblée reconnaît que ladite réduction de capital social au moyen de l’annulation de 14.142.704 (quatorze millions

cent quarante-deux mille sept cent quatre) Actions de Classe A1 permettra aux créanciers de la Société de déposer des
demandes de garanties auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans un délai de 30 jours suivant la publication
de l’acte notarié contenant les minutes de l’Assemblée dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, con-
formément à l’article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5.1 des Statuts en conséquence, afin de lui conférer la teneur reprise dans la

sixième résolution ci-dessous.

L’Assemblée reconnaît en outre que, conformément aux informations que le gérant unique de la Société a mises à sa

disposition, et sur la base (i) des comptes intérimaires de la Société au 31 mars 2015 et (ii) d’un certificat émis par le
gérant unique de la Société en date du 6 mai 2015 (le Certificat de Gérance), (a) un montant minimum de 12.551.438,98
EUR (douze millions cinq cent cinquante-et-un mille quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-dix-huit cents) est
comptabilisé dans le compte de prime d’émission de la Société et est disponible pour être distribué par la Société, et (b)
la Société ne présente aucune perte susceptible d’empêcher la Distribution d’Egalisation (telle que définie dans les Statuts).

Les comptes intérimaires de la Société au 31 mars 2015 et le Certificat de Gérance, après avoir été signés ne varietur

par les mandataires agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexés au
présent acte pour être enregistrés avec ce dernier par les autorités compétentes.

L’Assemblée décide d’approuver la distribution de la prime d’émission de la Société d’un montant de 12.551.438,98

EUR (douze millions cinq cent cinquante-et-un mille quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-dix-huit cents) prise
sur le compte de prime d’émission de la Société en faveur du seul détenteur de Parts Sociales de Classe A1, c'est-à-dire
ColData 4 (Lux) S.à r.l.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de 35.404,51 EUR (trente-cinq mille quatre

cent  quatre  euros  et  cinquante-et-un  cents)  afin  de  le  porter  de  son  montant  actuel  de  962.184,75  EUR  (neuf  cent
soixante-deux mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quinze cents), représenté par 96.118.475 (quatre-vingt-
six millions cent dix-huit mille quatre cent soixante-quinze) Actions de Classe A, divisées en 74.042.418 (soixante-quatorze
millions quarante-deux mille quatre cent dix-huit) Actions de Classe A1, et 22.076.057 (vingt-deux millions soixante-seize
mille cinquante-sept) Actions de Classe A3, 99.900 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents) Actions de Classe B et 100
(cent) Actions de Classe C, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d’euro) chacune, à un montant de 926.780,24
EUR (neuf cent vingt-six mille sept cent quatre-vingt euros et vingt-quatre cents) au moyen de l’annulation de 3,540,451
(trois millions cinq cent quarante mille quatre cent cinquante-et- un) Actions de Classe A3 détenues par Master Vehicle.

L’Assemblée reconnaît qu'en conséquence de la présente réduction de capital social au moyen de l’annulation de

3,540,451 (trois millions cinq cent quarante mille quatre cent cinquante-et-un) Actions de Classe A3 détenues par Master
Vehicle, un montant total de 35.404,51 EUR (trente-cinq mille quatre cent quatre euros et cinquante-et- un cents) sera
dû à Master Vehicle.

L’Assemblée reconnaît que ladite réduction de capital social au moyen de l’annulation de 3,540,451 (trois millions cinq

cent quarante mille quatre cent cinquante-et- un) Actions de Classe A3 permettra aux créanciers de la Société de déposer
des demandes de garanties auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans un délai de 30 jours suivant la
publication de l’acte notarié contenant les minutes de l’Assemblée dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, conformément à l’article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Tous les actionnaires, représentés comme indiqué ci-dessus, acceptent expressément la présente réduction de capital

social au bénéfice de Master Vehicle, et renoncent à tous droits qu'ils pourraient avoir.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5.1 des Statuts en conséquence, afin de lui conférer la teneur reprise dans la

sixième résolution ci-dessous.

<i>Sixième résolution

En conséquence de l’augmentation et des réductions successives du capital social de la Société décidées dans les

première, quatrième et cinquième résolutions ci-dessus, l’Assemblée décide de modifier l’article 5.1 des Statuts, qui aura
désormais la teneur suivante:

« 5.1. Montant du capital social. Le capital social est fixé à un montant de 926.780,24 EUR (neuf cent vingt-six mille

sept cent quatre-vingt euros et vingt-quatre cents), représenté par:

(a) 92.578.024 (quatre-vingt-douze millions cinq cent soixante-dix-huit mille vingt-quatre) actions commanditaires de

Classe A (les Actions de Classe A), subdivisées en sous-Classes de:

62553

L

U X E M B O U R G

(i) 74.042.418 (soixante-quatorze millions quarante-deux mille quatre cent dix-huit) actions de Classe A1 (les Actions

de Classe A1), elles-mêmes subdivisées en 72.060.415 (soixante-douze millions soixante mille quatre cent quinze) Actions
de Classe A1 Ancien Investissement et 1.982.003 (un million neuf cent quatre-vingt-deux mille et trois) Actions de Classe
A1 Nouvel Investissement; et

(ii) 18.535.606 (dix-huit millions cinq cent trente-cinq mille six cent six) actions de Classe A3 (les Actions de Classe

A3);

(b) 99.900 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents) actions commanditaires de Classe B (les Actions de Classe B); et
(c) 100 (cent) actions commanditées de Classe C (les Actions de Classe C),
ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d’euro) chacune.
Les Actions de Classe A et les Actions de Classe B sont collectivement dénommées actions commanditaires et les

Actions de Classe C sont dénommées actions commanditées, et les termes actionnaire commanditaire et actionnaire
commandité sont à interpréter en conséquence. Les Actions de Classe A, les Actions de Classe B et les Actions de Classe
C sont collectivement dénommées actions et le terme actionnaire est à interpréter en conséquence.

Les Actions de Classe B sont détenues par le Promoteur conformément au Pacte d’Actionnaires.
Nonobstant les dispositions du présent Article 5, toute émission de nouveaux Instruments par la Société devra être

faite conformément aux dispositions y relatives du Pacte d’Actionnaires.»

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société de façon à y refléter les changements repris ci-

dessus et accorde pouvoir et autorité à tout gérant du Gérant Commandité, ainsi qu'à tout gérant de Colony Luxembourg
S.à r.l. afin de procéder, pour le compte de la Société, à l’inscription de l’émission des nouvelles actions dans le registre
des actions de la Société, et afin de pourvoir à toute formalité y relative.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par les articles 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été satisfaites et en constate expressément l’accomplissement.

En l'absence d'autres points figurant à l'Ordre du Jour de l’Assemblée, le Président déclare l’Assemblée close.

<i>Frais

Les dépenses, frais, émoluments et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte notarié sont estimés approximativement à six mille cinq cents euros (6.500,- EUR).

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Redange-sur-Attert.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent

acte notarié a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en
cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux parties comparantes, les parties comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent

acte.

Signé: A.DEYGLUN, S.LECOMTE, V.PIERRU, D.KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 11 mai 2015. Relation: DAC/2015/7757. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): J. THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 12 mai 2015.

Référence de publication: 2015070761/490.
(150081198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2015.

CFG Patrimoine, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 196.707.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of the month of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Iris Finance, a company incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at 41 rue François

er

 , 75008 Paris, France,

62554

L

U X E M B O U R G

represented by Alexandre Hübscher, avocat, residing professionally in Luxembourg pursuant to a proxy dated 30 April

2015.

The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to

this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a company which it intends to incorporate in Luxembourg.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a company which it intends to incorporate in Luxembourg

Title I. Denomination, Duration, Object, Registered office

Art. 1. Name. There exists among the subscriber and all those who may become holders of shares of the Company

hereafter issued, a company in the form of a société anonyme (public limited company) qualifying as a société d'investis-
sement  à  capital  variable  -  fonds  d’investissement  spécialisé  (investment  company  with  variable  capital  -  specialised
investment fund) under the name of CFG Patrimoine (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved by a resolution

of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the "Articles").

Art. 3. Object. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in any kind of permitted assets

with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its port-
folio.

The Company is subject to the provisions of the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as

amended from time to time (the "Law") and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, in the Grand

Duchy of Luxembourg.

Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

resolution of the board of directors of the Company (the "Board").

The Board is authorised to transfer the registered office of the Company within the municipality of Luxembourg and,

to the extent that it is allowed by the law, to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg.

The registered office may also be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means

of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for any amend-
ment to the Articles.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economical, social or military events have occurred

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company.

Title II. Share capital - Shares - Certificates - Net asset value

Art. 5. Share Capital. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time

be equal to the net assets of the Company as defined in Articles 12 and 13 hereof.

The initial subscribed capital is thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) divided into thirty-one (31) fully paid up shares

which may be entirely redeemed at their initial value by the launch date of the Company. The minimum capital of the
Company shall be the minimum capital required by Luxembourg law and must be reached within twelve (12) months
after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under the Law.

The shares to be issued in the Company may, as the Board shall determine, be of one or more different classes (each

such class, a "Class"), the features, terms and conditions of which shall be established by the Board. For the purposes of
these Articles, any reference hereinafter to a "Class" shall also mean a reference to a "Sub-Class", unless the context
otherwise requires.

The proceeds from the issue of shares of any Class within the Company shall be invested pursuant to the investment

objectives and policies of the Company as set forth in the sales documents of the Company i.e. in securities of any kind
or other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such
specific types of equity or debt securities or assets or with such other specific features, as the Board shall from time to
time determine in respect of the Company.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class shall, if not

expressed in EUR, be converted into EUR and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes.

The general meeting of shareholders of the Company or Class, deciding with simple majority, or the Board, may

consolidate ("reverse split") or split the shares of the Company or Class.

62555

L

U X E M B O U R G

The Company shall in any event issue Class I shares. Class I shares shall be issued to the initial shareholder of the

Company (as defined in the sales documents of the Company) or to any person designated by such initial shareholder as
its successor.

Any change to paragraph 7 of this Article 5 are subject to the consent of all Class I shareholders.

Art. 6. Issue of shares.  The  Board  is  authorised  without  limitation  to  issue  further  partly  or  fully  paid  shares,  as

determined  by  the  Board,  at  any  time,  in  accordance  with  the  procedures  and  subject  to  the  terms  and  conditions
determined by the Board and disclosed in the sales documents, without reserving to the existing shareholders preferential
or pre-emptive rights to subscription of the shares to be issued.

Investors will either subscribe for a determined number of shares or for a determined amount, as determined by the

Board and disclosed in the sales documents or subscription form of the Company. Any reference to a subscription to
shares shall be construed accordingly.

Investors shall have either to commit to subscribe to shares or may directly subscribe to shares, as determined by the

Board and disclosed in the sales documents.

In case the Board decides that investors have to commit to subscribe shares, investors will be required to execute a

subscription agreement and indicate therein their total committed capital (the "Commitment" or "Commitments"), subject
to any minimum Commitment as may be decided by the Board. The procedures relating to Commitments and drawdown
of the Commitments will be disclosed in the sales documents and the subscription agreement.

If at any time an investor or shareholder fails to honour its Commitment through the full payment of the subscription

price within the timeframe decided by the Board (a "Defaulting Investor") and referred to in the sales document, the
Board has the authority, in addition to any legal remedies, to take vis-à-vis such Defaulting Investor one or several of the
measures as disclosed in the sales documents.

Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents, the issue price shall be based on the Net

Asset Value for the relevant Class, as determined in accordance with the provisions of Articles 13 hereof, plus all applicable
subscription fees and charges, as the sales documents may provide.

The Board may also make any adjustment to the issue price as it may consider appropriate to ensure fairness between

the shareholders. For the avoidance of doubt, the issue price may among others also be based at any time on the initial
subscription price for the Company or Class, plus any applicable subscription fees and charges as the sales documents
may provide.

Shares of the Company are restricted to institutional investors, professional investors or any other well-informed

investors (investisseurs avertis) within the meaning of the Law ("Eligible Investors").

The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised

person, the duty of accepting subscriptions and/or delivering and receiving payment for such new shares, remaining always
within the limits imposed by the Law.

The Board is further authorised to determine the conditions of any such issue and to make any such issue subject to

payment at the time of issue of the shares.

The issue of shares shall be suspended if the calculation of the Net Asset Value is suspended pursuant to Article 12

hereof.

The Board may decide to issue shares against contribution in kind in accordance with Luxembourg law. To the extent

required by the applicable laws and regulations, the contributed assets shall be valued in a report issued by the approved
statutory auditor of the Company. Any costs incurred in connection with a contribution in kind shall be borne by the
relevant shareholder, unless the Board considers that the subscription in kind is in the interests of the Company in which
case such costs may be borne in all or in part by the Company.

The Board reserves the right to accept or refuse any application in whole or in part in its entire discretion and without

having to give the reasons thereof.

The Board may also, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares until such time

as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Eligible Investor.

In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Eligible Investor, and who

holds shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board, the other shareholders and
the Company’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to any such holding in circums-
tances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or
untrue representations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or had failed to notify the Company of its
loss of such status.

Art. 7. Form of shares. The Company will in principle issue shares in registered form only. If and to the extent permitted,

and under the conditions provided for, by law, the Board may at its discretion decide to issue, in addition to shares in
registered form, shares in dematerialised form. Under the same conditions, holders of registered shares may also request
the conversion of their shares into dematerialised shares.

The costs resulting from the conversion of registered shares at the request of their holders will be borne by the latter

unless the Board decides at its discretion that all or part of these costs must be borne by the Company.

62556

L

U X E M B O U R G

All issued registered shares of the Company other than dematerialised shares (if issued) shall be inscribed in the register

of shareholders (the "Register"), which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefor by
the Company. The Register shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile
as notified to the Company and the number and Class(es) of shares held by him.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements

from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register. In the event of joint holders of shares, only
one address will be inserted and any notices will be sent to that address only.

In the event that a shareholder does not provide an address, or such notices and announcements are returned as

undeliverable to an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register and the
shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or any other address as may be so
entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by the shareholder.
The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register by means of a written notification to the
Company at its registered office, or at any other address as may be set by the Company from time to time.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the Register as full owner of the

shares. The Company shall be entitled to consider any right, interest or claim of any other person in or upon such shares
to be non-existing, provided that the foregoing shall deprive no person of any right which he might properly have to
request a change in the registration of his shares.

Holders of dematerialised shares must provide, or must ensure that registrar agents shall provide, the Company with

information for identification purposes of the holders of such shares in accordance with applicable laws. If on a specific
request of the Company, the holder of dematerialised shares does not furnish the requested information, or furnishes
incomplete or erroneous information within a time period provided for by law or determined by the Board at its dis-
cretion, the Board may decide to suspend voting rights attached to all or part of the dematerialised shares held by the
relevant person until satisfactory information is received.

The Company will recognise only one holder per share. In the event of joint ownership the Company may suspend

the exercise of any right deriving from the relevant share(s) until one person has been designated to represent the joint
owners vis-à-vis the Company.

In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or

other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint
holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.

Fractions of registered shares up to the number of decimal places to be decided by the Board will be issued if so

decided by the Board. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net
assets and any distributions attributable to the relevant Class on a pro rata basis.

Fractions of dematerialised shares, if any, may also be issued at the discretion of the Board.
The Company shall decide whether share certificates shall be delivered to the shareholders and under which conditions

or whether the shareholders shall receive a written confirmation of their shareholding, in accordance with the sales
documents.

Any share certificates shall be signed by two (2) directors or by a director and an official duly authorised by the Board

for such purpose. Signatures of the directors may be either manual, or printed, or by facsimile. The signature of the
authorised official shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in any such form as the Board
may from time to time determine.

Transfer of registered shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register to be made by the Company

upon delivery of the certificate or certificates, if any, representing such shares, to the Company along with appropriate
document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee and any such other documentation as the
Company may require.

The transfer of dematerialised shares (if issued) shall be made in accordance with applicable laws.
The Company will refuse to give effect to any transfer of shares and refuse any transfer of shares to be entered in the

Register in circumstances where such a transfer would result in shares being held by any person not qualifying as an Eligible
Investor.

Art. 8. Destruction of share certificates. If share certificates are issued and if any shareholder can prove to the satis-

faction of the Company that his share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate
share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company
but without restriction thereto, as the Company may determine. At the issue of the new share certificate, on which it
shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall
become void.

The Company may elect to charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and all

reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issue and registration thereof, or in connection
with the annulment of the original share certificate.

62557

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Certificates. In addition to share capital, the Company may, from time to time, issue parts bénéficiaires under

the meaning of Article 37 of the 1915 Law (as defined in Article 34 below), which will be referred to as "certificates" in
these Articles. Certificates shall be issued at a price and in accordance with the terms and conditions, including economic
rights, determined in accordance with the sales documents.

The Board may decide to issue Certificates against contribution in kind.
The Certificates to be issued may, as the Board shall determine, be of one or more different classes or series, the

features, terms and conditions of which shall be established by the Board in accordance with the sales documents.

Certificates within a class shall rank pari passu in all respects one vis-à-vis the other.
Certificates of a specified class may also, as the Board shall determine, be of different sub-Classes, the features, terms

and conditions of which shall be established by the Board and further described in the sales documents.

Certificates may be redeemable, in kind or in cash, at any time by the Company under the terms and at a price defined

in the sales documents.

Certificates shall be reserved to certain types of investors in accordance with the sales documents and will in any case

be restricted to persons qualifying as Eligible Investors.

The Certificates of a specific Class may or may not benefit from voting rights at meetings of investors of the Company

as disclosed in the sales documents.

The Board may decide to determine a net asset value per certificate in which case the provisions of Articles 12 and

13 thereof shall apply mutatis mutantis.

Art. 10. Restrictions on the ownership of shares. The Board shall have power to impose such restrictions as it may

think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person not
qualifying as an Eligible Investor, (b) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental
authority or (c) any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company incurring
any liability or taxation or suffering any pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred
or suffered. More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any
person, firm or corporate body.

For such purposes the Company may:
a) decline to issue any share or to register any transfer of any share where it appears to it that such a registry would

or might result in the share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the
Company;

b) at any time require any person whose name is entered in the Register to furnish it with any information, supported

by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of that
shareholder's share rests or will rest in a person who is precluded from holding shares in the Company;

c) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of

shareholders of the Company; and

d) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares or a certain proportion

of the shares in the Company or whom the Company reasonably believes to be precluded from holding shares in the
Company, either alone or in conjunction with any other person is beneficial owner of shares, (i) direct such shareholder
to (a) transfer his shares to a person qualified to own such shares, or (b) request the Company to redeem his shares, or
(ii) compulsorily redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "Redemption Notice") upon the shareholder holding such

shares or appearing in the Register as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as
aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect of such shares is
payable. Any such Redemption Notice may be served upon the shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to him at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder
shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates (if issued) representing
the  shares  specified  in  the  Redemption  Notice.  Immediately  after  the  close  of  business  on  the  date  specified  in  the
Redemption Notice, the shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held or owned by him
shall be cancelled;

2) The price at which the shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the "Redemption

Price") shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of shares in the Company of the relevant Class,
determined in accordance with Article 13 hereof, less any service charge (if any). Where it appears that, due to the
situation  of  the  shareholder,  payment  of  the  redemption  price  by  the  Company,  any  of  its  agents  and/or  any  other
intermediary may result in either the Company, any of its agents and/or any other intermediary to be liable to a foreign
authority for the payment of taxes or other administrative charges, the Company may further withhold or retain, or allow
any of its agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the Redemption Price an amount sufficient to
cover such potential liability until such time that the shareholder provides the Company, any of its agents and/or any
other intermediary with sufficient comfort that their liability shall not be engaged, it being understood (i) that in some
cases the amount so withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign authority, in which case the amount
may no longer be claimed by the shareholder, and (ii) that potential liability to be covered may extend to any damage

62558

L

U X E M B O U R G

that the Company, any of its agents and/or any other intermediary may suffer as a result of their obligation to abide by
confidentiality rules;

3) Payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency

of denomination for the relevant Class and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere
(as specified in the Redemption Notice) for payment to that person but only, if a share certificate shall have been issued,
upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in the Redemption Notice. Upon
deposit of the price as aforesaid no person interested in the shares specified in the Redemption Notice shall have any
further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except
the right of the shareholder appearing as the thereof owner to receive the price so deposited (without interest) from
the bank as aforesaid.

4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any

case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was other than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such a
case the said powers were exercised by the Company in good faith.

The provisions of this Article shall apply, mutatis mutandis, to Certificates.

Art. 11. Redemption and Conversion of Shares. As is more specifically prescribed herein below the Company has the

power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by law.

Unless otherwise provided for a specific Class in the sales documents, any shareholder may request the redemption

of all or part of his/her/its shares by the Company under the terms, conditions and limits set forth by the Board in the
sales documents and within the limits provided by law and these Articles. Any redemption request must be filed by the
shareholder in written form, subject to the conditions set out in the sales documents of the Company, at the registered
office of the Company or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of
shares, together with the delivery of the certificate(s) for such shares in proper form (if issued).

Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents, the redemption price shall be based on

the Net Asset Value for the relevant Class as determined in accordance with the provisions of Articles 12 and 13 hereof
less all applicable redemption fees and charges as the sales documents may provide. This price may be rounded up or
down, as the Board may determine, and such rounding will accrue to the benefit of the Company, as the case may be.
The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the Board provided that the share certi-
ficates, if issued, and any requested documents have been received by the Company, subject to Article 12 hereof.

The Board may determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of any specific Class

or Classes. The specific period for payment of the redemption proceeds of any Class of the Company and any applicable
notice period as well as the circumstances of its application will be published in the sales documents relating to the sale
of such shares.

The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised

person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.

The Board may (subject to the principle of equal treatment of shareholders and, if required by the applicable laws and

regulations, the consent of the shareholder(s) concerned) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by
allocating to the redeeming shareholders investments from the portfolio in value equal to the applicable redemption price
attributable to the shares to be redeemed as described in the sales documents. To the extent required by the applicable
laws and regulations, any such redemption will be subject to a special audit report by the approved statutory auditor of
the Company.

The specific costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, if any, will have to

be borne by the shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company
unless the Board considers that the redemption in kind is in the interests of the Company or made to protect the interests
of the Company.

Any request for redemption is revocable under the conditions determined by the Board and disclosed in the sales

documents, if any, and in the event of suspension of redemption pursuant to Article 12 hereof or a deferral of the
redemption request as provided for below. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first Valuation
Day after the end of the suspension.

Unless otherwise provided for in the sales documents, any shareholder may request conversion of whole or part of

his shares of one Class into shares of another Class at the respective Net Asset Values of the shares of the relevant
Classes under the terms, conditions and limits set forth by the Board in the sales documents. The Board may notably
impose restrictions between Classes of shares as disclosed in the sales documents as to, inter alia, frequency of conversion,
and may make conversions subject to payment of a charge as specified in the sales documents. The conditions relating
to the exercise of such right by the Board will (if any) be detailed in the sales documents of the Company.

The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the shares to be converted has

been fully settled by the shareholder.

If with respect to any given Valuation Day, redemption requests and conversion requests exceed a certain level de-

termined by the Board and set forth in the sales documents, the Board may decide that part or all of such requests for

62559

L

U X E M B O U R G

redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the Board considers to be in the best
interests of the Company.

The Board may refuse redemptions for an amount less than the minimum redemption amount as determined by the

Board and disclosed in the sales documents, if any, or any other amount the Board should determine at its sole discretion.

If a redemption or conversion were to reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of the Company

or Class below the minimum holding amount (if any) as the Board shall determine from time to time and publish in the
sales documents of the Company, then that shareholder may be deemed to have requested the redemption or conversion,
as the case may be, of all his shares of the Company or Class. The Board may, in its absolute discretion, compulsory
redeem or convert any holding with a value of less than the minimum holding amount under the conditions disclosed in
the sales documents of the Company.

In exceptional circumstances relating to a lack of liquidity of certain investments made by the Company, if any, and the

related difficulties in determining the Net Asset Value of the Shares of the Company, the treatment of redemption requests
may be deferred and/or the issue, redemptions and conversions of Shares suspended by the Board.

In the same circumstances, the Board may consider the creation of sidepockets via any means and to the largest extent

authorised pursuant to applicable Luxembourg laws and regulations.

In addition to the foregoing, the Board may decide to temporarily suspend the redemption of shares if exceptional

circumstances as set forth in Article 12, so warrant.

The Board or any duly appointed agent may further decide to compulsorily redeem shares (i) the subscription of which

would not be made in accordance with the sales documents of the Company or (ii) whose wired subscriptions amounts
would be insufficient to cover the relevant subscription price (including, for the avoidance of doubt, any applicable sub-
scription charge).

Such redemption will be carried out under the most favourable conditions for the Company, including among other

the possibility for the Company to keep the difference between the redemption price and the subscription price when
the latter is lower than the former or claim to the relevant investor that difference when the latter is higher than the
former.

The Board may further redeem shares of the Company in order to make a distribution. Such redemption shall be made

under the conditions and at the price set forth in the sales documents of the Company.

Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.

Art. 12. Frequency of the calculation of the NAV. The Net Asset Value of shares shall, for the purpose of the re-

demption, conversion or issue of shares, be determined by the Company or any agent appointed thereto, under the
responsibility of the Board, from time to time, but in no event less than once per year, as the Board may determine (every
day or time for determination of net asset value being referred to herein as a "Valuation Day").

The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value of the Company and consequently

the issue, redemption and conversion of shares of the Company, it being understood that where the context so requires
"Company" may also be read as "Class":

(a) during any period when any one of the stock exchanges or other principal markets on which a substantial portion

of the assets of the Company, from time to time, is quoted or dealt in is closed (otherwise than for ordinary holidays)
or during which dealings therein are restricted or suspended provided that such restriction or suspension affects the
valuation of the investments of the Company quoted thereon; or

(b) during any period when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside

the control, responsibility and power of the Board, or the existence of any state of affairs which constitutes an emergency
in the opinion of the Board, disposal or valuation of the assets held by the Company is not reasonably practicable without
this being seriously detrimental to the interests of Shareholders, or if in the opinion of the Board, the issue and, if applicable,
redemption prices cannot fairly be calculated; or

(c) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price

or value of any of the investments of the Company or the current prices or values on any stock exchanges or other
markets in respect of the assets of the Company; or

(d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of Shares of the Company or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of
investments or payments due on redemption of Shares of the Company cannot, in the opinion of the Board, be effected
at normal exchange rates; or

(e) from the time of publication of a notice convening an extraordinary general meeting of shareholders for the purpose

of winding up the Company, or merging the Company, or informing the shareholders of the decision of the Board to
terminate or merge the Company; or

(f) when for any other reason, the prices of any investments owned by the Company cannot be promptly or accurately

ascertained.

62560

L

U X E M B O U R G

Notice of the suspension shall be given by the Company to all the shareholders affected, i.e. having made an application

for subscription, redemption or conversion of shares for which the determination of the Net Asset Value has been
suspended.

Any application for subscription, redemption or conversion of shares is irrevocable except in case of suspension of

the calculation of the Net Asset Value of the Company, in which case, shareholders may give written notice that they
wish to withdraw their application. If no such notice is received by the Company, such application will be dealt with on
the first Valuation Day following the end of the period of suspension.

Art. 13. Valuation regulations. A Net Asset Value may be calculated for all or some Classes/Sub-Classes of shares at

the frequency provided for in the sales documents of the Company. To the extent such a calculation is made, the principles
described in this Article 13 shall apply.

The Net Asset Value of shares of each Class (the "Net Asset Value") shall be expressed in the reference currency of

the relevant Class (and/or in any other currencies as the Board shall from time to time determine) as a per share figure
and shall be determined as at any Valuation Day by dividing the value of the total assets of the Company properly allocated
to that Class less the liabilities of the Company properly allocated to that Class by the total number of Shares of that
Class outstanding as at any Valuation Day, in accordance with the rules set forth below.

The Net Asset Value per share may be rounded up or down as the Board shall determine.
The Net Asset Value per share will be calculated and available not later than the date set forth in the sales documents.
A. If, since the time of determination of the Net Asset Value as at the relevant Valuation Day, there has been a substantial

change in the valuation of the investments attributable to the Company, the Company may, in order to safeguard the
interests of the shareholders and of the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation until any
subscription, redemption or conversion has been processed on the basis of the Net Asset Value so determined.

The assets of the Company shall be deemed to include (without limitation):
(1) All cash at hand and on deposit, including interest accrued thereon.
(2) All bills and demand notes payable and accounts receivable (including the proceeds of securities sold but not

delivered).

(3) All bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights,

warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company.

(4) All stock dividends, cash dividends and cash distributions declared receivable by the Company to the extent that

information thereon is reasonably available to the Company.

(5) All interest accrued on any interest-bearing asset owned by the Company except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of that asset.

(6) The preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,

insofar as they have not been amortised.

(7) The liquidating value of all futures and forward contracts and all call and put options in which the Company has an

open position.

(8) All other assets of any kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
(1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,

cash dividends declared and interest accrued, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless,
however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after
making such discount as the Board may consider appropriate to reflect the true value thereof.

(2) The value of securities (including shares or units of closed-ended investment funds) which are quoted, traded or

dealt in on any stock exchange shall be based on the latest available price or, if appropriate, on the average price on the
stock exchange which is normally the principal market of such securities, and each security traded on any other regulated
market shall be valued in a manner as similar as possible to that provided for quoted securities.

(3) For non-quoted securities or securities not traded or dealt in on any stock exchange or other regulated market

as well as quoted or non-quoted securities on such other market for which no valuation price is available, or securities
for which the quoted prices are, in the opinion of the Board, not representative of the fair market value, the value thereof
shall be determined prudently and in good faith by the Board on the basis of foreseeable sale prices.

(4) Liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an

amortised cost basis.

(5) Futures and options are valued by reference to the previous day's closing price on the relevant market; the market

prices used are the futures exchanges settlement prices.

(6) Investments in open-ended investment funds will be taken at their latest official net assets values or at their latest

unofficial net asset values (i.e. which are not generally used for the purposes of subscription and redemption of shares of
the underlying investment funds) as provided by the relevant administrators or investment managers if more recent than
their official net asset values.

62561

L

U X E M B O U R G

If events have occurred which may have resulted in a material change of the net asset value of such shares or units in

other investment funds since the day on which the latest official net asset value was calculated, the value of such shares
or units may be adjusted in order to reflect, in the reasonable opinion of the Board, such change of value.

(7) Swaps are valued at fair value based on the last available closing price of the underlying security.
(8) All other securities and assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures

established by the Board.

The Board, or any appointed agent, at its discretion, may permit some other method of valuation to be used, if it

considers that such a valuation better reflects the fair value and is in accordance with good accounting practice.

For  the  purpose  of  determining  the  value  of  the  Company's  assets,  the  administrative  agent  may  rely  upon  such

automatic pricing services as it shall determine or, if so instructed by the AIFM and/or the Board, it may use information
received from various professional pricing sources (including fund administrators and brokers, if any). In such circums-
tances, the administrative agent shall not, in the absence of manifest error on the part of the administrative agent, be
responsible for any loss suffered by the Company or any shareholder by reason of any error in the calculation of the Net
Asset Value of the Company or any Class and the Net Asset Value per share resulting from any inaccuracy in the infor-
mation provided by such professional pricing sources.

In circumstances where one or more pricing sources fail(s) to provide valuations for an important part of the assets

to the administrative agent preventing the latter to determine the subscription and redemption prices, the administrative
agent shall inform the Board who may decide to suspend the Net Asset Value calculation.

For the avoidance of doubt, the provisions of this Article 13 are rules for determining Net Asset Value per share and

are not intended to affect the treatment for accounting or legal purposes of the assets and liabilities of the Company or
any securities issued by the Company.

B. The liabilities of the Company shall be deemed to include (without limitation):
(1) All loans, bills and accounts payable.
(2) All accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans).
(3) All accrued or payable fees and expenses (including administrative expenses, management fees, including incentive

fees, depositary fees, central administration agent's fees and registrar and transfer agent's fees).

(4) All known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments in cash or in

kind, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company.

(5) An appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from

time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board, as well as an amount
(if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company.

(6) All other liabilities of the Company, of whatever kind and nature reflected in accordance with generally accepted

accounting principles. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses
payable by the Company, including, without any limitation, the incorporation expenses and costs for subsequent amend-
ments to the constitutional documents, all translation costs, fees and expenses payable to the investment manager(s)/
advisor(s),  including  performance  fees,  if  any,  the  depositary  and  its  correspondent  agents,  the  administrative  agent,
domiciliary and corporate agent, the registrar and transfer agent, listing agent, any paying agent, any distributor or other
agents and employees of the Company, as well as any permanent representatives of the Company in countries where it
is subject to registration, the costs and expenses for legal, accounting and auditing services, any fees and expenses involved
in registering and maintaining the registration of the Company with any government agencies or stock exchanges in the
Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing,
printing, advertising and distributing prospectuses, explanatory memoranda, periodical reports or registration statements,
the cost of printing share certificates, if any, and the costs of any reports to the shareholders, expenses incurred in
determining the Company’s Net Asset Value, the cost of convening and holding shareholders’ and directors’ meetings,
reasonable travelling expenses of directors, directors’ fees, all taxes and duties charged by governmental or similar au-
thorities and stock exchanges, the costs of publishing the issue and repurchase prices as well as any other operating costs,
including the costs of buying and selling assets, finder fees, financial, banking and brokerage expenses and all other admi-
nistrative costs as well as interest, bank charges, currency conversion costs, postage, telephone and telex, insurance costs,
including insurance costs for the directors, employees and agents of the Company, costs and expenses related to legal,
notarial and /or administrative proceedings and indemnifications resulting from such proceedings, involving, directly or
indirectly, the Company, directors, employees and agents of the Company as well as legal, as far as is permitted by law,
notarial  and/or  administrative  proceedings  and  indemnifications  resulting  from  such  proceedings,  related,  directly  or
indirectly to former or existing shareholders.

In assessing the amount of such liabilities, the Company shall take into account pro rata temporis any expenses or

other costs, administrative and other, that occur regularly or periodically.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted

accounting principles.

62562

L

U X E M B O U R G

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken

by the Board or by any agent which the Board may appoint for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be
final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

C. For the purpose of valuation under this article:
(a) each of the Company’s shares subject to a redemption request shall be considered as a share issued and outstanding

until the close of business on the Valuation Day on which it is redeemed and its price shall be considered a liability of the
Company from the close of business on that Valuation Day until the price has been paid;

(b) each share to be issued by the Company in accordance with subscription forms received shall be considered as

issued from the close of business on the Valuation Day of its issue;

(c) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the reference

currency in which the Net Asset Value per share of the relevant Class is calculated shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant
Class; and

(d) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for the Company on

such Valuation Day to the extent practicable.

Art. 14. Co-management. The Board may authorise investment and management of all or any part of the portfolio of

assets of the Company on a co-managed or cloned basis with assets belonging to other Luxembourg collective investment
schemes, all subject to compliance with applicable regulations.

Title III. Administration and supervision

Art. 15. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three

(3) members; members of the Board need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period determined by the meeting in

compliance with the law.

Class I shareholders are entitled to propose a list of names of candidates to the general meeting of shareholders out

of which a majority of the directors appointed by the general meeting of shareholders to the Board must be chosen (the
"Class I Directors"). There shall be in any case a majority of Class I Directors at the Board at all times. Shareholders may
not express their votes for a number of candidates exceeding the number of director positions to be filled. The only
economic right attached to Class I shares is the right to receive reimbursement of the initial contribution of the Class I
shareholder (as further detailed under section "Subscription and Payment" below) either upon request of the redemption
of its shares or at the liquidation of the Company.

Any person who wants to propose a candidate for the position of directors of the Company to the general meeting

of shareholders, must present such candidate to the Company in writing at least three (3) weeks prior to the date of
such general meeting.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general

meeting, provided however that if a Class I Director is removed and that the number of remaining Class I Directors
would no longer constitute the majority of the Board, the remaining directors must call for an extraordinary general
meeting without delay in order for a new Class I Director to be appointed in his/her/its place and the new Class I Director
appointed by the general meeting of shareholders must be chosen from the candidates on the list presented by the Class
I shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director appointed by a general meeting of shareholders, because of death,

retirement or otherwise, the remaining directors so appointed may elect, by majority vote, a Director to fill the vacancy
until the next general meeting of shareholders. For the avoidance of doubt, a vacancy in the office of a Class I Director
must be filled with a new Class I Director.

Any change to paragraphs 3 to 6 of this Article 15 is subject to the consent of all Class I shareholders.

Art. 16. Meeting of the Board. The Board will choose a chairman from among its members, and may choose one or

more vice-chairmen from among its members. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon
call by the Chairman or by any two (2) directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the shareholders or

the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the hour set for the meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram,
telex, telefax or any other electronic means capable of evidencing such a waiver of each director. Separate notice shall
not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution
of the Board.

62563

L

U X E M B O U R G

Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex, telefax message

or any electronic means capable of evidencing such an appointment, another director as his proxy. Any director may
attend a meeting of the Board using teleconference or videoconference means. Directors may also cast their vote in
writing or by cable, telegram, telex, telefax message or any other electronic means capable of evidencing that vote.

The directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their

individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.

The Board can deliberate or act validly only if at least two (2) directors are present or represented by another Director

as  proxy  at  a  meeting  of  the  Board.  Decision  shall  be  taken  by  a  majority  of  the  votes  of  the  directors  present  or
represented at that meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be
equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms in the form of one

or several documents in writing signed by all the directors or by telex, cable, telegram, telefax message or by telephone
provided that in any such latter event that vote is confirmed in writing.

The Board may, from time to time, appoint officers of the Company, including a general manager, a secretary, and any

assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operations and manage-
ment of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be directors
or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the
powers and duties given to them by the Board.

The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to

carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any com-
mittee, consisting of any such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit,
provided that the majority of the members of the committee are directors and that no meeting of the committee shall
be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present
are directors of the Company. The Company may act as an alternative investment fund manager ("AIFM") in the meaning
of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the "AIFM Law") or appoint another entity as desi-
gnated AIFM of the Company.

Art. 17. Minutes. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman, as the case may be, pro

tempore who presided at the meeting or by any two (2) directors.

Copies or extracts of any such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 18. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful

for accomplishing the Company's corporate objectives, including all acts of administration and disposition in the Com-
pany's interest. All powers not expressly reserved by law or these Articles to the general meeting of shareholders will
be exercised by the Board.

The Board shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment

policy and the course of conduct of management and business affairs of the Company.

The Board shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the

Company.

Art. 19. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of any such other company or firm. Any director or officer of the
Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract
or otherwise engage in business, shall not, by reason of his connection and/or relationship with that other company or
firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to any such contract or other
business.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted

for approval to the Board conflicting with that of the Company, that director or officer shall make known to the Board
such conflict and shall not consider or vote on any such transaction, and any such transaction shall be reported to the
next meeting of shareholders.

The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board or by the single director relates to current

operations entered into under normal conditions.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in

any matter, position or transaction involving any entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or any other
company or entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion, provided that this personal
interest is not considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations.

Art. 20. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to

62564

L

U X E M B O U R G

which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be
indemnified. Any such person shall be indemnified in all circumstances except in relation to matters as to which he shall
be finally adjudged in any action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a
settlement, any indemnity shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which
the Company is advised by its counsel that the person to be indemnified did not commit any such breach of duty. The
foregoing right of indemnity shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 21. Signatory power. The Company will be bound by the joint signature of any two (2) directors or by the joint

or single signature(s) of any other person(s) to whom such authority has been delegated by the Board.

Art. 22. Approved Statutory Auditor. The Company shall appoint a réviseur d'entreprises agréé (approved statutory

auditor) who shall carry out the duties prescribed by of the Law. The approved statutory auditor shall be elected by the
general meeting of the shareholders for a period determined by such meeting and until its successor is elected.

Title IV. General meetings - Accounting year - Distribution

Art. 23. General meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the
Company regardless of the Class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company.

The Board may decide to issue categories of Certificates whose holders benefit from a voting right at general meetings

of the shareholders of the Company. In case the Company has issued Certificates with a voting right, references to "shares"
or "shareholders" in provisions of these Articles or in applicable law referring to general meetings of shareholders, notably
in terms of quorum and majority requirements, shall be read as references to "shares and Certificates with a voting right"
or "shareholders and holders of Certificates with a voting right". Notwithstanding the foregoing, if the quorum or majority
requirements provided by law in relation to a general meeting of shareholders are of public order, such quorum and
majority requirements shall apply at the level of the shares issued and, in addition, the same majority requirements (at
the exclusion of quorum requirements) shall apply, mutatis mutantis, at the level of the Certificates.

Art. 24. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Lu-

xembourg law, at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the
notice of meeting, on the first Wednesday of the month of June at 11 p.m. (Luxembourg time). If this day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next bank business day. The annual general
meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of

shareholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, which date, time
and place are to be decided by the Board.

Other meetings of shareholders or of holders of shares of any specific Class may be held at any such place and time

as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 25. Quorum and voting. The quorum and notice periods required by law shall govern the conduct of the meetings

of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders

may provide that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined according to the
shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the
right of a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attached to his shares
will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date. In case of dematerialised
shares (if issued) the right of a holder of such shares to attend a general meeting of shareholders and to exercise the
voting rights attached to such shares will be determined by reference to the shares held by this holder as at the time and
date provided for by Luxembourg laws and regulations.

Each share of whatever Class and regardless of the Net Asset Value per share within that Class, is entitled to one

vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by
appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex, telefax message or any other electronic
means capable of evidencing such proxy.

Any such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders’ meeting. A

company may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of votes cast. The Board may determine all other conditions that must be
fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to

the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and
which contain at least the place, date and time of the general meeting, the agenda of the general meeting, the proposal

62565

L

U X E M B O U R G

submitted to the decision of the general meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to
vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms, which show neither a vote in favour nor against the resolution, or an abstention, shall be void. The

Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the general meeting of shareholders
they relate to.

Art. 26. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January and shall terminate

on the thirty-first day of December of the same year.

Art. 27. Distributions. Distributions shall be made in accordance with the provisions set forth in the sales documents

of the Company under the form of redemption of shares, dividends or otherwise, as determined by the Board. The general
meeting of shareholders, upon recommendation of the Board, shall determine how the remainder of the annual net profits
shall be disposed of and may declare dividends from time to time. Interim dividends may be distributed upon decision of
the Board.

No distribution of dividends shall be made if, as a result thereof, the capital of the Company became less than the

minimum prescribed by law.

A dividend declared but not paid on a share during five (5) years cannot thereafter be claimed by the holder of that

share, shall be forfeited by the holder of that share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Title V. Dissolution, Liquidation

Art. 28. Dissolution. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or more

liquidators appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.
The net proceeds may be distributed in kind to the holders of shares.

Art. 29. Liquidation. If the net assets of any Class fall below or do not reach an amount determined by the Board at

its discretion to be the minimum level for such Class to be operated in an economically efficient manner or if a change
in the economic, monetary or political situation relating to the Class concerned justifies it or in order to proceed to an
economic rationalisation, the Board has the discretionary power to liquidate that Class by compulsory redemption of
shares of the Class at the Net Asset Value per share (but taking into account actual realisation prices of investments and
realisation expenses) determined as at the Valuation Day at which such a decision shall become effective. The decision
of the liquidation will be published by the Company prior to the effective date of the liquidation and the publication will
indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the Board decides otherwise in the
interests of, or in order to ensure equal treatment of, the shareholders, the shareholders of the Class concerned may
continue to request redemption or conversion of their shares free of redemption or conversion charges (but taking into
account actual realisation prices of investments and realisation expenses).

Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, a general meeting of Shareholders

of any Class may, upon proposal from the Board and with its approval, redeem all the Shares of that Class and refund to
the Shareholders the Net Asset Value of their Shares (taking into account actual realisation prices of investments and
realisation expenses) determined as at the Valuation Day at which such a decision shall take effect. There shall be no
quorum requirements for such a general meeting of Shareholders at which resolutions shall be adopted by simple majority
of the votes cast.

Assets which could not be distributed to the relevant shareholders upon the close of the liquidation of a Class will be

deposited with the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the relevant shareholders. Amounts not claimed
will be forfeited in accordance with Luxembourg law.

Title VI. Final provisions

Art. 30. Depositary. The Company shall enter into a depositary agreement with an entity, which shall satisfy the

requirements of the Luxembourg laws (the "Depositary").

The Depositary shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by applicable

laws and regulations, as amended from time to time.

The Company hereby expressly allows the Board to decide whether to grant a discharge of liability to the Depositary

under the condition that this discharge is not prohibited by any applicable laws and regulations and shall be in place in
accordance with the conditions set out in applicable laws and regulations.

Information regarding any discharge of the Depositary’s liability, as well as any material change to this information, may

be disclosed or made available to Investors in, via and/or at any of the Information Means listed in Article 32 of these
Articles; it being understood that availability or disclosure of any information regarding discharge of the Depositary’s
liability may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.

To the maximum extent authorised by applicable laws and regulations, the Company hereby expressly authorises the

Board to decide to agree upon the transfer of any assets of the Company to, and reuse by, of any third party, including
the Company's Depositary appointed from time to time.

62566

L

U X E M B O U R G

Art. 31. Preferential treatment of Investors. Any prospective or existing shareholder (an "Investor" or collectively the

"Investors")  may  be  accorded  a  preferential  treatment,  or  a  right  to  obtain  a  preferential  treatment  (a  "Preferential
Treatment") subject to, and in compliance with the conditions set forth in applicable laws and regulations.

A Preferential Treatment may consist (i) in the diminution or removal of any applicable fees, (ii) in the partial or total

reimbursement or rebate of certain fees, charges and/or expenses, (iii) in preferential terms applicable to any subscription,
redemption, conversion or transfer of shares (such as shorter or no prior notice, lower or no minimum amount requi-
rements, lower or no gating, reduced or no side-pocketing, tag-along or drag-along rights; the foregoing being illustrative
and not exhaustive), (iv) in the possibility of avoiding investment in, or exposure to, certain assets, liabilities or counter-
parties, (v) in the access to, or increased transparency of information related to certain aspects of the Company's portfolio
or of the Company's or its AIFM's management or activities (whether past, present and/or future) in general, (vi) in
preferential terms in relation to any distribution (whether of dividends, carried interests, liquidation proceeds or of any
other amount that may be distributed by the Company to Investors), (vii) in certain preferential terms and rights (including
veto) in relation to the appointment or removal of members of the Company's or its AIFM's governing bodies and/or
internal committees, (viii) in the participation to the Company's or its AIFM's management or activities in general (including
participation to their governing bodies and/or internal committees), (ix) in a right to veto, to postpone or to otherwise
condition certain decisions or resolutions, (x) in increased or additional voting rights, (xi) in a "most favoured nation" (or
similar) right, or (xii) in any other advantage or privilege that is not inconsistent with these Articles and/or with applicable
laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of the Company and/or its
AIFM.

A Preferential Treatment may be accorded on the basis (i) of the size, nature, timing or any feature of the investment

in, or of any commitment taken vis-à-vis the Company, (ii) of the type, category, nature, specificity or any feature of the
Investor or Investors, (iii) of the involvement in, or participation to the Company's or its AIFM's management or activities
(whether past, present and/or future) in general, or (iv) of any other criteria, element or feature that is not inconsistent
with these Articles or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the
discretion of the Company and/or its AIFM.

A Preferential Treatment may (x) take the form (i) of a contractual arrangement, (ii) of a side letter or (iii) of the

creation of a specific category or Class of shares, or (y) take any other form or arrangement that is not inconsistent with
these Articles or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the
discretion of, the Company and/or its AIFM.

A Preferential Treatment is not necessarily assorted with the so-called "most favoured nation" clause in favour of all

Investors, meaning that, unless otherwise provided to the contrary or required by applicable laws or regulations, the
existence or introduction of a Preferential Treatment or the fact that one or more Investors have been accorded a
Preferential Treatment does not create a right in favour of any other prospective or existing Investor to claim for its
benefit such a Preferential Treatment, even if, in relation to this Investor, all criteria and features on which is based the
relevant Preferential Treatment are met, and even if the situation and features of this Investor are similar to any of the
Investors to whom this Preferential Treatment has been accorded.

Whenever an Investor obtains a Preferential Treatment, a description of that Preferential Treatment, the type of

Investors who obtain such Preferential Treatment and, where relevant, their legal or economic links with the Company
or its AIFM, as well as any material change to this information, may be disclosed or made available to Investors in, via
and/or at any of the Information Means listed in Article 32 of these Articles; it being understood that availability or
disclosure of any information regarding Preferential Treatment may be restricted to the largest extent authorised by
applicable laws and regulations.

Art. 32. Investor's Information. Any information or document that the Company or its AIFM must or wishes to disclose

or be made available to some or all of the Investors shall be validly disclosed or made available to any of the concerned
Investors in, via and/or at any of the following information means (each an "Information Means"): (i) the Company's sales
documents, offering or marketing documentation, (ii) subscription, redemption, conversion or transfer form, (iii) contract
note, statement or confirmation in any other form, (iv) letter, telecopy, email or any type of notice or message, (v)
publication in the (electronic or printed) press, (vi) the Company's periodic report, (vii) the Company's, AIFM's or any
third party's registered office, (viii) a third-party, (ix) internet/a website (as the case may be subject to password or other
limitations) and (x) any other means or medium to be freely determined from time to time by the Company or its AIFM
to the extent that such means or medium comply and remain consistent with these Articles and applicable laws and
regulations.

The Company or its AIFM may freely determine from time to time the specific Information Means to be used to

disclose or make available a specific information or document, provided, however, that at least one current Information
Means used to disclose or make available any specific information or document to be disclosed or made available shall at
least be indicated in either the Company's sales documents or at the Company's or AIFM's registered office.

Certain Information Means (each hereinafter an "Electronic Information Means") used to disclose or make available

certain information or document requires an access to internet and/or to an electronic messaging system. By the sole
fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor acknowledges the possible use of Electronic

62567

L

U X E M B O U R G

Information Means and confirms having access to internet and to an electronic messaging system allowing this Investor
to access the information or document disclosed or made available via an Electronic Information Means.

By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor (i) acknowledges and consents

that the information to be disclosed in accordance with applicable laws and regulations may be provided by means of a
website without being addressed personally thereto and (ii) that the address of the relevant website and the place of the
website where the information may be accessed is indicated in either the Company's sales documents or at the Company's
or AIFM's registered office.

Art. 33. Amendment of the Articles. These Articles may be amended from time to time by a general meeting of

shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg. By derogation to
the foregoing, any change to a provision affecting the rights of Class I shareholders will be subject to the consent of all
Class I shareholders. For the avoidance of doubt, the consent of Class I shareholders will be required to amend Article
5, paragraph 7 and Article 15, paragraphs 3 to 6 hereof.

Art. 34. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of

10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto (the "1915 Law") and the Law.

<i>Transitional dispositions

1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2015.
2) The first annual general meeting shall be held in 2016.

<i>Subscription and Payment

The subscriber has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amount as mentioned hereafter:

Shareholder

Subscribed

capital

number

of shares

Iris Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000

31

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000

31

Proof of this payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).

<i>Statements

The notary drawing up this deed declares that the conditions set forth in Article 26, 26-3 and 26-5 of the law of 1915

Law, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Extraordinary general meeting

The appearing person has forthwith taken immediately the following resolutions:

<i>First resolution

The registered office of the Company is set at 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

<i>Second resolution

The following persons are appointed directors for a period ending at the first annual general meeting which will be

held in 2016:

- Michael Sellam, professionally residing at 41, rue François 1 

er

 , 75008 Paris, France;

- Jérôme Cazals, professionally residing at 5 rue de l'Université, 1205 Geneva, Switzerland; and
- Bertrand Gibeau, professionally residing at 51 rue Sainte Anne, 75002 Paris, France.

<i>Third resolution

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative having its registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been appointed as approved statutory auditor (“réviseur d’entreprises
agréé”) of the Company for a period ending at the first annual general meeting.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, this deed is worded in English.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, this

original deed.

Signé: A. HÜBSCHER et H. HELLINCKX.

62568

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 8 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/14443. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 mai 2015.

Référence de publication: 2015072242/814.
(150082441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Top Manager, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Top Manager coordonné au 1 

er

 Mai 2015 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Mr. Noboru MATSUSHIMA
<i>Conducting Officer &amp; Director

Référence de publication: 2015072511/11.
(150082780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Euro Prudence F.T., Fonds Commun de Placement.

La société de gestion EURO PROVIDENCE a décidé le 31 décembre 2014 de liquider le compartiment TCA du Fonds

EURO PRUDENCE F.T.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

<i>Pour EURO PROVIDENCE SARL
Monsieur Jean-Paul CHERRIER
<i>Gérant

Référence de publication: 2015072920/11.

Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company, Société Anonyme.

Capital social: EUR 82.500.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 59.154.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of April,
Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,

notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholder of Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company, a

société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office at 6, rue Eugène
Ruppert L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 59154, with an issued share capital amounting to EUR 82,500,000.-

THERE APPEARED:

Recordati Spa, an Italian Company governed by the laws of Italy, having its registered office at via Civitali 1, Milan (Italy)

registered with the Trade and Companies Register of Milan under number 00748210150 (the “Sole Shareholder”)

here represented by Mr. Maurizio Di Bernardo Maggiore, private employee, residing professionally at Via Civitali, 20148

Milan, Italy, by virtue of a proxy established on 24 April 2015.

The proxy signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain appended herewith to

be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following:
1. The appearing party is the sole shareholder of the Company. As a result, ALL and WHOLE of the 82,500,000 shares

currently issued in the share capital of the Company are represented at this extraordinary general meeting of the sha-
reholders of the Company (the “Meeting”). The Sole Shareholder declares having been informed in advance of the agenda

62569

L

U X E M B O U R G

of the Meeting and waived all convening requirements and formalities. The Meeting is therefore regularly constituted and
can validly deliberate and take the appropriate resolutions;

2. Approval of the merger (the “Merger” and the “Merger Approval”) between the Company, acting as the absorbing

company (the “Absorbing Company”) and another company fully held and controlled by the Company, namely SGAM AI
Kantara Co. II. S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg having
its registered office at 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 143567, with an issued share capital amounting to
EUR 12,500.-, fully paid-up and subscribed and divided into 12,500 shares with each a par value of EUR 1.- (the “Absorbed
Company”, and together with the Absorbing Company, the “Merging Companies”);

After the foregoing was approved by the Meeting, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

After having duly noted that the common merger plan between the Merging Companies (the “Common Merger Plan”)

had been acted pursuant to a notarial deed dated 12 March 2015, as further published in the Mémorial, Section C, n°
813, dated 25 March 2015, pages 38988, and that all conditions and formalities previously required for the purpose of
this Merger Approval have been fulfilled, the Meeting resolves to approve the Merger, in full accordance with Article 272
of the Luxembourg law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Companies’ Law”).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that all the documents required by article 267 from (a) to (c) (included)

of the Law have been deposited at the registered office of the Company for its inspection at least one (1) month before
the date of the present meeting.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the Merger Approval are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

<i>Declaration

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and

legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the Merger Proposal.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois d’avril,
Pardevant Me Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hel-

linckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des associés de Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company, une

société anonyme ayant son siège statutaire à 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59154, ayant un capital social de EUR 82.500.000,-
intégralement souscrit et libéré (la “Société Absorbante”).

A COMPARU:

Recordati Spa, une société constituée sous l’empire du droit italien, ayant son siège statutaire à via Civitali 1, Milan

(Italie), immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Milan sous le numéro 007482100150. (“l’Ac-
tionnaire Unique”).

Telle que représentée par Mr. Maurizio Di Bernardo Maggiore, employé privé, résidant professionnellement à Via

Civitali, 20148 Milano, Italie, en vertu d’une procuration à lui donnée le 24 avril 2015.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La partie comparante, telle que représentée, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte qui suit:
1. La partie comparante est le seul associé de la Société. Par suite, l’intégralité des 82.500.000 actions présentement

émises dans le capital social de la Société sont représentées à cette assemblée générale extraordinaire de la Société

62570

L

U X E M B O U R G

(l’”Assemblée”). L’Actionnaire Unique déclare avoir été informé par avance de l’agenda de l’Assemblée et a renoncé à
toutes formalités de convocation. L’Assemblée est par conséquent valablement constituée et peut valablement délibérer
et prendre des résolutions.

2. Approbation de la fusion par absorption (la “Fusion” et l’“Approbation de la Fusion”) entre la Société, agissant en

qualité de société absorbante (la “Société Absorbante”) et une autre société intégralement détenue par l’Actionnaire
Unique, à savoir SGAM AI Kantara Co. II. S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège statutaire à 6, rue
Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 143567, ayant un capital social de EUR 12.500,-, intégralement souscrit et libéré et divisé en 12.500
parts sociales, chacune d’une valeur nominale de EUR 1,- (la “Société Absorbée”, et ensemble avec la Société Absorbante,
les “Sociétés Fusionnantes”);

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première unique

Après avoir noté que le projet commun de fusion entre les Sociétés Fusionnantes (le “Projet Commun de Fusion”) a

été acté en vertu d’un acte notarié en date du 12 mars 2015, tel que publié au Mémorial, Section C, n° 893, en date du
25 mars 2015, pages 38988 et suivantes, et que toutes les conditions et formalités préalables à l’Approbation de la Fusion
ont été respectées, l'Assemblée décide d’approuver la Fusion, conformément à l’Article 272 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (“LSC”).

<i>Deuxième résolution

L’Actionnaire Unique décide de prendre acte que tous les documents requis par l'article 267 (a) à (c) (inclus) de la Loi,

ont été déposés au siège social de la Société pour inspection au moins un (1) mois avant la date de la présente assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné certifie conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi l'existence et la légalité de

tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: M. DI BERNARDO MAGGIORE et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/13952. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 mai 2015.

Référence de publication: 2015070355/118.
(150080128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Findel Business Center West Side S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 140.974.

L'an deux mille quinze, le vingt-trois mars.
Pardevant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINDEL BUSINESS CENTER WEST SIDE

S.A., ayant son siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 23 juillet 2008, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C no 2164 en date du 5 septembre 2008.
L'assemblée est ouverte à 17.45 heures sous la présidence de Monsieur Marc GIORGETTI, Diplômé en gestion d'Entre-
prises, demeurant à L-7423 Dondelange, 2, route de Luxembourg,

62571

L

U X E M B O U R G

qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul GIORGETTI, Ingénieur en Génie Civil, demeurant à L-1870 Luxembourg,

102, Kohlenberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul FEIDER, employé privé, demeurant à L-2627 Luxembourg, 9,

rue Jean-Pierre Thoma.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I.- l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1.- Elargissement de l'objet social avec changement subséquent de l'article 4 des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires ou leurs mandataires, par le notaire
soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s)
signée(s) «ne varietur» par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée, et qu'il a

donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée générale prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide d'élargir l'objet social et en conséquence l'article 4.- des statuts aura dorénavant la teneur

suivante:

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la construction, la gestion, la location et/ou la vente d'immeubles ou parts

d'immeubles, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder des hypothèques ou garanties, emprunter avec ou sans garantie

ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect

avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation, ainsi que la prise de participations dans toutes autres
sociétés ayant un objet analogue ou complémentaire.

Plus rien ne restant à l'ordre du jour, Monsieur le Président a levé la séance.

<i>Frais

Les frais et charges en rapport avec les présentes resteront à charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états ou

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Giorgetti, Giorgetti, Feider, Schuman.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 mars 2015. Relation: EAC / 2015 / 7099. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Differdange, le 31 mars 2015.

Référence de publication: 2015049822/53.
(150057125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

Horest, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8355 Garnich, 26, rue Nic Arend.

R.C.S. Luxembourg B 26.475.

DISSOLUTION

L'an deux mil quinze, le dix-huit mars,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Madame Anne Marie CONSTANT, retraitée, née à Jamoigne, Belgique, le 24 août 1946, demeurant à L-8355 Garnich,

26, rue Nic Arend,

Agissant en sa qualité de mandataire de:

62572

L

U X E M B O U R G

Monsieur Christian TOCK, salarié, né à Luxembourg le 23 février 1971, demeurant à B-6700 Sterpenich, 65, rue de

Kleinbettingen, et

Monsieur Laurent TOCK, salarié, né à Luxembourg le 21 décembre 1978, demeurant à L-8355 Garnich, 26, rue Nic

Arend,

en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles après avoir été signées ne varietur par le notaire et la comparante,

resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.

Après avoir exposé que ses mandants détiennent toutes les parts sociales de la société HOREST s.à r.l., avec siège à

L-8355  Garnich,  26,  rue  Nic  Arend,  constituée aux  termes  d’un acte reçu  par Maître Aloyse  BIEL, alors  notaire de
résidence à Differdange, en date du 31 août 1987, publié au Mémorial C numéro 353 du 05 décembre 1987, et dont les
statuts ont été modifiés aux termes d’une assemblée générale extraordinaire actée par le prédit notaire Aloyse BIEL,
alors de résidence à Esch/Alzette, en date du 10 novembre 2011, publiée au Mémorial C numéro 256 du 31 janvier 2012.

Laquelle comparante, es-qualité qu'elle agit, a déclaré:
Que ses mandants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée HOREST s.à r.l., avec siège à Garnich,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 26475,

Que la société HOREST s.à r.l., a cessé toute activité commerciale.
Que les comptes sociaux sont parfaitement connus des associés et sont approuvés par eux.
Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l’actif a été distribué.
Que les associés n’ont plus de revendication envers la société.
Ceci approuvé, la comparante a prié le notaire d’acter les résolutions unanimes suivantes:
1. La société HOREST s.à r.l. est dissoute et liquidée avec effet immédiat.
2. Pour autant que de besoin, Madame CONSTANT préqualifiée, est à considérer comme liquidateur, qui est également

personnellement et solidairement responsable des frais des présentes.

3. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans au domicile du liquidateur.
4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé au liquidateur, les associés susdits en suppor-

teraient les frais ou en ferait le bénéfice.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la comparante, connue du notaire par nom,

prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. M. CONSTANT, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9098. Reçu soixante-quinze euros. 75,-

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 30 mars 2015.

Référence de publication: 2015049873/48.
(150057231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

Immobilière Daniel Beck S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 30, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 49.611.

L'an deux mille quinze, le seize mars.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Daniel BECK, gérant de société, né à Luxembourg le 3 août 1970, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher,

64, route du Vin,

détenteur de cent (100) parts sociales.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "IMMOBILIERE Daniel

BECK S.à r.l." (numéro d’identité 1994 24 10 894), avec siège social à L-1318 Luxembourg, 2, rue des Celtes, inscrite au
R.C.S.L.  sous  le  numéro  B  49.611,  constituée  suivant  acte  reçu  par  le  notaire  Tom  METZLER,  alors  de  résidence  à
Luxembourg-Bonnevoie, en date du 15 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 131 du 23 mars 1995 et dont les
statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le prédit notaire Tom METZLER
en date du 6 juin 2011, publié au Mémorial C, numéro 1791 du 5 août 2011,

a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

62573

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social à L-8041 Strassen, 30, rue des Romains et en conséquence de

modifier le 1 

er

 alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 2. alinéa 1 

er

 .  Le siège de la société est établi à Strassen.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique constate que l’adresse de l’associé unique, respectivement du gérant unique Monsieur Daniel BECK,

préqualifié, est désormais fixée à L-5405 Bech-Kleinmacher, 64, route du Vin.

Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le

bénéficiaire réel de la société faisant l’objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que la société ne se
livre pas et ne s’est pas livrée pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à six cents euros (€ 600.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: BECK, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9013. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 1 

er

 avril 2015.

Référence de publication: 2015049888/43.
(150057294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

Ipan Investment SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.597.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 25 mars 2015

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 25 mars 2015 que le siège social de la société est

transféré du 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg au 46 A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et ce avec effet
au 1 

er

 mars 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2015.

Référence de publication: 2015049902/13.
(150057704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

Marie Lingerie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 140.390.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Fidiciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2015049996/13.
(150057439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

62574

L

U X E M B O U R G

MCH Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 175.066.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2015.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015049999/13.
(150057492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

NPF Soparfi D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 120.086.

Les comptes consolidés de CBRE Nordic Property Fund au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015050032/13.
(150057132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

NYK Hummingbird S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 195.765.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 17 mars 2015 que la personne suivante a démissionné

avec effet au 17 mars 2015 de sa fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Richard Beyer, né le 14 octobre 1969 à York, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle à City Point,

1 Ropemaker Street, EC2Y 9NY Londres, Royaume-Uni.

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 17 mars 2015, et pour

une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société:

- Monsieur Remy Cornet, né le 8 juin 1984 à Marche-en-Famenne, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 7,

rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Monsieur Hiroaki Nishiyama, né le 15 juin 1966 à Tokyo, Japon, résidant au 31, Margin Drive, Wimbledon, SW19

5HA Londres, Royaume-Uni,

- Monsieur Remy Cornet, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 1 

er

 avril 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

62575

L

U X E M B O U R G

Signature

Référence de publication: 2015050033/29.

(150057241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

Oeko-Bureau, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3714 Rumelange, 3, place des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 24.988.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2015050051/13.

(150057079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

Sol o plafond S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 113, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 148.938.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2015

Il résulte de l'AGE tenue ce 31 mars 2015 ce qui suit:

Transfert du siège social de n°123, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, vers n° 113 Route d'Arlon à L-8009 Strassen.

Augmentation du plafond pour la signature individuelle de Mr Alexandre ANTOINE à un montant de 10.000,00€

Augmentation du plafond pour la signature individuelle de Mr Laurent OUTREQUIN à un montant de 10.000,00€

Sol O Plafond Sàrl

Référence de publication: 2015050136/13.

(150057119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

Abbott Overseas Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 585.688.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 144.636.

EXTRAIT

La Société a pris connaissance que:

1. L'adresse de sa gérante, Madame Tara R. Kaesebier, se trouve désormais au 100 Abbott Park Road, Abbott Park,

Illinois 60064, Etats-Unis d'Amérique; et

2. L'adresse de ses gérants, Monsieur Richard Brekelmans et Monsieur Johan Dejans, se trouve désormais au 6, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015050235/17.

(150058678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

62576

L

U X E M B O U R G

Abbott Poland Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.420.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 190.809.

EXTRAIT

La Société a pris connaissance que l’adresse de sa gérante, Madame Tara R. Kaesebier, se trouve désormais au 100

Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, Etats-Unis d’Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015050236/14.
(150058366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

Abbott Products Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 42.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.989.

EXTRAIT

La Société a pris connaissance que:
1. L'adresse de sa gérante, Madame Tara R. Kaesebier, se trouve désormais au 100 Abbott Park Road, Abbott Park,

Illinois 60064, Etats-Unis d'Amérique; et

2. L'adresse de ses gérants, Monsieur Richard Brekelmans et Monsieur Johan Dejans, se trouve désormais au 6, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015050237/17.
(150058633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

Abbott South Africa Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 7.001.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 158.173.

EXTRAIT

La Société a pris connaissance que:
1. L’adresse de sa gérante, Madame Tara R. Kaesebier, se trouve désormais au 100 Abbott Park Road, Abbott Park,

Illinois 60064, Etats-Unis d’Amérique; et

2. L’adresse de ses gérants, Monsieur Richards Brekelmans et Monsieur Johan Dejans, se trouve désormais au 6, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2015.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015050238/17.
(150058364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

62577

L

U X E M B O U R G

Adriatic Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 189.672.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales en date du 31 mars 2015 que l'associé unique de la Société, Mid Europa IV

Management Limited a transféré toutes ses parts sociales à un nouvel associé:

Adriatic (Guernsey) Limited, une Limited Company constituée selon la législation de Guernesey, avec siège social à 2

nd

 Floor Tudor House Le Bordage, GY1 1BT St Peter Port, Guernsey et immatriculée au registre de commerce de

Guernesey sous le numéro 60072.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015050239/17.
(150058052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

Advanced Global Holding Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 184.968.

Il est porté à la connaissance des tiers que Deloitte Tax &amp; Consulting, en sa qualité d'agent domiciliataire, a dénoncé

avec effet immédiat, le siège social de la société Advanced Global Holding Limited S.à r.l., 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg numéro RCS B 184.968.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2015.

Pour extrait conforme
Deloitte Tax &amp; Consulting
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2015050240/14.
(150057986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

Aicy International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 68.660.

Les comptes annuels du 01/01/2014 au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015050257/10.
(150058057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

AIR.CA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 85.818.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AIR.CA S.A.

Référence de publication: 2015050259/10.
(150058504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

62578

L

U X E M B O U R G

Ambo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 42.057.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 1 

er

 avril 2015, il a été décidé:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle du 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg vers le

2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AMBO S.A.
Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2015050273/14.
(150058575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

BHI (GBA) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.689.

Il résulte d’une lettre de démission datée du 19 décembre 2015 que Monsieur Luc HANSEN a démissionné de son

mandat d’administrateur de catégorie B de la société BHI (GBA) S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 139 689, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 2 avril 2015.

CF Corporate Services
Société Anonyme
2, avenue Charles de Gaulle
L - 1653 Luxembourg

Référence de publication: 2015050303/15.
(150058319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

BRE/Mannheim I Hotel S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 114.681.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 31 mars 2015

En date du 31 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de BRE/Management 3 S.A. de son mandat de gérant unique de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Christian HUPFER, né le 21 avril 1982 à Lahr, Allemagne, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: Kurfürstendamm 207-208, D-10719 Berlin, Allemagne, en tant que nouveau gérant unique de la Société
avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- de transférer le siège social de la Société du 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au:
* 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg avec effet au 31 mars 2015;
* l'associé unique de la Société, BRE/Nine Hotel Holding S.à r.l. a également transféré son siège social au 6, Boulevard

Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2015.

BRE/Mannheim I Hotel S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015050313/22.
(150058589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

62579

L

U X E M B O U R G

BRE/Nine Hotel Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 114.688.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 31 mars 2015

En date du 31 mars 2015, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de transférer le siège social de la Société du 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au: 6, Boulevard Pierre

Dupong, L-1430 Luxembourg avec effet immédiat;

- d'accepter les démissions de Messieurs Jean-François BOSSY, Francesco BISCARINI, Michael FRONTE et Madame

Solveig Diana HOFFMANN de leur mandat respectif de gérant de la Société avec effet immédiat;

- de nommer Monsieur Christian HUPFER, né le 21 avril 1982 à Lahr, Allemagne, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: 207-208, Kurfùrstendamm, 10719 Berlin, Allemagne, en tant que nouveau gérant unique de la Société
avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

<i>Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts avec effet au 31 mars 2015, que:
- l'associé de la Société, BRE/German Hotel Holding I S.à r.l., a cédé la totalité des 450 parts sociales de classe A qu'il

détenait dans la Société à LONIPEST LIMITED, une limited liability company constituée et régie selon les lois de Chypre,
ayant son siège social à l'adresse suivante: 2, Faros Avenue Shop, Spyros Thalassines Alkyoniedes, 7560 Pervolia, Chypre
et immatriculée auprès du Registre de Commerce de Nicosia, sous le numéro HE 341448;

- l'associé de la Société, ART HOTEL HOLDING S.à r.l., a cédé 24 des 50 parts sociales de classe B qu'il détenait dans

la Société à LONIPEST LIMITED, une limited liability company constituée et régie selon les lois de Chypre, ayant son
siège social à l'adresse suivante: 2, Faros Avenue Shop, Spyros Thalassines Alkyoniedes, 7560 Pervolia, Chypre et imma-
triculée auprès du Registre de Commerce de Nicosia, sous le numéro HE 341448;

- l'associé de la Société, ART HOTEL HOLDING S.à r.l., a cédé les 26 des 50 parts sociales de classe B restantes qu'il

détenait dans la Société à GLODEMCO LTD, une limited liability company constituée et régie selon les lois de Chypre,
ayant son siège social à l'adresse suivante: 173, Arch Makarious, 2311 Lakatemia, Nicosia, Chypre et immatriculée auprès
du Registre de Commerce de Nicosia, sous le numéro HE 269023.

En conséquence, les 500 parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

LONIPEST LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 parts sociales de classe A

24 parts sociales de classe B

GLODEMCO LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 parts sociales de classe B

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2015.

BRE/Nine Hotel Holding S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015050314/39.
(150058264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

Caireen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 119.660.

L'an deux mille quinze, le 02 avril,
En vertu du contrat de cession de parts signé en date du 9 mars 2015, les parts de la société ont été transférées comme

suit:

Monsieur Nicholas James MARTIN, gérant unique de la société Caireen S.à r.l. ayant son siège social à L-9227 Diekirch,

50 Esplanade, inscrite après du registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B. 119.660, né le 03 janvier 1974
à Guernesey (UK), demeurant professionnellement à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade.

a transféré 100 parts de 125 Euro chacune détenues dans la société Caireen S.à r.l. ayant son siège social à L-9227

Diekirch, 50 Esplanade, à Monsieur James Henry O'SULLIVAN né le 1 

er

 novembre 1974 à Horsham (UK), demeurant

au 98000, Monte Carlo, 10 Avenue de Grande Bretagne (Monaco),

Le gérant unique décide en date du 31 mars 2015 la nomination aux fonctions de gérant unique avec effet immédiat

de:

62580

L

U X E M B O U R G

Monsieur Roy Phillip HARDING, gérant, né le 16 octobre 1951 à Cape Town (ZA) demeurant à 1, rue Henri Dunant,

L-4085 Esch-sur-Alzette (L);

Le gérant unique décide en date du 31 mars 2015 la révocation immédiate aux fonctions de gérant avec effet immédiat

de:

Monsieur Nicholas James MARTIN, né le 03 janvier 1974 à Guernesey (UK), demeurant professionnellement à L-9227

Diekirch, 50 Esplanade.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 02 avril 2015.

<i>Pour la société
COFICOM Trust S.à r.l.
B.P. 126
50, Esplanade
L-9227 DIEKIRCH
Signature

Référence de publication: 2015050321/32.
(150058348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

Carmosina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 179.231.

EXTRAIT

Il résulte contrat de vente signé en date du 21 novembre 2014 avec effet au 1 

er

 juillet 2014, que les parts sociales de

la société de USD 1,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'actionnaire

Nombre de parts sociales

Hamilton Alexander Budge Lowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53c Cornwall Gardens, SW7 4BG London,
United Kingdom

2.300 Parts Sociales de Classe A
4.530 Parts Sociales de Classe B

Sir Frank Budge Lowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mall Cottage, Chiswick Mall, London W4 2PN
United Kingdom

1.920 Parts Sociales de Classe A
1.552 Parts Sociales de Classe B

Jose Fernando Villa Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rua Dr. Thomaz Carvalhal, 555, apto 172
CEP 04006-001 São Paulo, SP, Brazil

200 Parts Sociales de Classe A

John Desmond Wakely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Doneraile St.
London, SW66EN United Kingdom

200 Parts Sociales de Classe B

Brian Clarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 Peel Street, Peel Cottage,
W8 7PF London, United Kingdom

1.000 Parts Sociales de Classe B

Daniel Sean Arnhold Moura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 Rua Andre Fernandes, Apt 61
04536-0020 Sao Paulo, SP, Brazil

80 Parts Sociales de Classe A

INGA Administração e Participações LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cambara, State of Parana,
BR 369 Rodovia CEP 86.390-000, Brazil

2.620 Parts Sociales de Classe A
5.598 Parts Sociales de Classe B

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 2 avril 2015.

Référence de publication: 2015050323/36.
(150058626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

62581

L

U X E M B O U R G

CitCor Franconia Süd S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 3.125.868,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.147.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 27 mars 2015

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Bernhard Rieksmeier en tant que gérant de la Société avec effet au 31 mars 2015;
- de nommer Thomas Gerd Gemeinholzer, née le 3 février 1967, Baden-Baden, Allemagne, ayant son adresse profes-

sionnelle au Jahnstraße 64, 63150 Heusenstamm, Allemagne, en tant que gérant de la Société avec effet au 1 

er

 avril 2015

et ce pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2015.

Référence de publication: 2015050338/15.
(150058484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

Cristal Investment s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5316 Contern, 40, rue des Près.

R.C.S. Luxembourg B 47.861.

Les comptes annuels au 31 octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2015050373/12.
(150058127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

CROWN PREMIUM Private Equity V Master Europe S.C.S., SICAF-FIS, Société en Commandite simple

sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, Place d'Argent.

R.C.S. Luxembourg B 163.405.

Les statuts coordonnés de la Société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CROWN PREMIUM Private Equity V MASTER EUROPE S.C.S., SICAF-FIS
Signatures

Référence de publication: 2015050374/12.
(150057862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

DCC S.A., Digital Consulting Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 51, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 81.398.

L’an deux mille quinze, le onze mars.
Pardevant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux.

S'est réunie

l’assemblée  générale  des  actionnaires  de  la  société  anonyme..  Digital  Consulting  Company  S.A.  en  abrégé  DCC

S.A.” (2001 2207 183) avec siège social à L - 1930 Luxembourg, 16A, Avenue de la Liberté; RCS B81398;

constituée originairement sous la dénomination sociale de DOT COM CONSULTING S.A., suivant acte reçu par

Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 28 mars 2001, publié au Mémorial C numéro
944 du 31 octobre 2001,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en

date du 29 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 948 du 15 septembre 2003, contenant notamment le changement
de la dénomination sociale en DEGRO CHARTERED CONSULTING S.A. en abrégé DCC S.A. et dont la dénomination

62582

L

U X E M B O U R G

social a été changée en DIGITAL CONSULTING COMPANY S.A., en abrégé DCC S.A., suivant acte reçu par Maître
Jean Seckler, prénommé, en date du 29 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 309 du 17 mars 2004,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros

(100,- EUR) chacune.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Edgard GROSJEAN, gérant de sociétés, demeu-

rant à B-4950 Waimes, 1, rue des Ecoles,

qui désigne comme secrétaire Madame Lydia JUNGBLUT, retraitée, demeurant à L-4499 Limpach, 19, rue de Reckange;
et comme scrutateur Madame Isabelle KAYSER, secrétaire de direction, demeurant à L-1465 Luxembourg, 7, rue

Michel Engels.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarant se
référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

L’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:
1) - transfert du siège social et modification subséquente du 1 

er

 alinéa de l'article 2 des statuts;

2) - révocation du commissaire aux comptes;
3) - nomination d’un nouveau commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.
4) - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exact par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend, à

l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social statutaire de la société de L-1930 Luxembourg, 16A,

Avenue de la Liberté à L-9980 Wilwerdange, 51, Hauptstrooss et de donner la teneur suivante au premier alinéa de
l’article2:

« Art. 2. alinéa 1. Le siège de la société est établi dans la commune de Troisvierges.»
Le reste de l’article 2 reste inchangé.
L’adresse de la société est à L-9980 Wilwerdange, 51, Hauptstrooss.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de révoquer avec effet au 31 décembre 2014, la société VERICOM SA, avec siège

social  à  L-1855  Luxembourg,  46A,  Avenue  J-F  Kennedy,  de  sa  fonction  de  commissaire  aux  comptes  et  lui  accorde
décharge.

<i>Troisième et dernière résolution

L’assemblée appelle à l’unanimité aux fonctions de commissaire aux comptes, avec effet au 01 janvier 2015, la société

Confidencia-Dagest, Services Oase sàrl, ayant son siège social à L-9980 Wilwerdange, 53, Hauptstrooss, pour une durée
de 6 ans.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 11.00 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Clervaux.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  tous  connus  du  notaire  instrumentaire  par  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Grosjean, Jungblut, Kayser, Martine Weinandy.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, en date du 19 mars 2015. Relation: DAC/2015/4662. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Clervaux, le 02 avril 2015.

Référence de publication: 2015050384/68.
(150058314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

62583

L

U X E M B O U R G

Dornie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 183.890.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 03 mars 2015

Il a été décidé de transférer le siège social de la Société du 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au

28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet au 1 

er

 avril 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Le 1 

er

 avril 2015.

Référence de publication: 2015050388/13.
(150058243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

Diekirch Investment S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 72.699.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 1 

<i>er

<i> avril 2014

Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue au siège de la société en date du 1 

er

 avril 2014,

que:

1. Le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Mignani Christophe, né le 25/02/1966 à Woippy et

demeurant professionnellement au 47 Grand Rue L-1661 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2020,
est voté.

2. Le renouvellement du mandat d'administrateur de la société MARCAMI SA, société de droit Luxembourgeois, ayant

son siège social au 47 Grand Rue L-1661 Luxembourg et immatriculée au RCSL sous le numéro B 143 377, jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en 2020, est voté.

3. Le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Luidinant Jean Philippe, né le 21/02/1961 à Uccle (Bel-

gique) et demeurant professionnellement au 31 Bd Prince Henri L-1724 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra en 2020 est voté.

4. Le renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes de la société ABROAD CONSULTING SA, société de

droit Luxembourgeois ayant son siège social au 47 Grand Rue L-1661 Luxembourg, immatriculée au RCSL sous le numéro
B 92 617, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2020 est voté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015050391/24.
(150058704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

DSG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 114.708.

<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 12 mars 2015, avec effet au 31 mars 2015

1. M. Nicolas GASZTONYI démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2.  M.  Gérard  BIRCHEN,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Esch-sur-Alzette  (Luxembourg),  le  13  Décembre  1961,

demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert 6 (Luxembourg), a été nommé comme gérant
de classe B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DSG S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015050396/16.
(150058540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

62584

L

U X E M B O U R G

Edmond de Rothschild Europportunities Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 117.203.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 1 

er

 avril 2015 que la personne suivante a démissionné

de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 5 février 2015:

- Monsieur Norbert Becker, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse

professionnelle au 41, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Depuis lors, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Nicolas Cuisset, né le 25 avril 1973 à Aulnoye-Aymeries, France, ayant son adresse professionnelle au 1B,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Jérémie Mélin, né le 11 février 1976 à Fiers, France, ayant son adresse professionnelle au 47, rue du Faubourg

Saint Honoré, 75008 Paris, France,

- Monsieur Antoine Le Bourgeois, né le 24 mai 1969 à Fontenay aux Roses, France, ayant son adresse professionnelle

au 47, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France,

- Monsieur Samuel Pinto, né le 16 avril 1957 à Casablanca, Maroc, ayant son adresse professionnelle au 13, Rehov

Aaron David Gordon, 63407 Tel Aviv, Israël.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 avril 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2015050400/30.
(150058634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

East Coast S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 81, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 48.541.

Les comptes annuels du 01/01/2014 au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015050407/10.
(150058056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

Embafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 46.238.

EXTRAIT

La Société prend acte du changement d'adresse de Monsieur Roberto Cavadini, administrateur de la Société. Elle est

désormais la suivante:

Via Ferruccio Pelli, 12
6901 Lugano
Suisse
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

62585

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 2 avril 2015.

Référence de publication: 2015050413/16.
(150058410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

Dutyfly Solutions Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2987 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg B 196.727.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-neuf avril.
Pardevant Me Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hel-

linckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

La société DUTYFLY SOLUTIONS SAS, avec siège social à 6, rue du Meunier - BP 17014, F-95726 Roissy-CDG Cedex

(RCS Pontoise 443 014 527),

Ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé,
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer

pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:

La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agie, a requis le notaire instrumentant de dresser

l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les lois

du Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi de 1915»), par l'Article 1832 du Code Civil ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite

notamment, de cession de parts sociales ou d'émission de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La société a pour objet l’exploitation et le développement d’une activité de vente de produits sous

douane à bord des compagnies aériennes au départ principalement de l’aéroport de Luxembourg tels que le tabac, l’alcool,
la gastronomie et la petite restauration à consommer à bord, la coordination et la gestion des opérations de logistique
associées à cette activité ainsi que la vente en boutique de parfums, cosmétiques, électroniques, bijoux, accessoires de
mode et montres, et généralement toutes les opérations commerciales, financières, industrielles, civiles mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire
ou connexe.

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination de "Dutyfly Solutions Luxembourg S.à r.l.".

Art. 4. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Lu-

xembourg).

Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'as-

semblée des associés.

Le gérant ou, le cas échéant, le Conseil de gérance, comme défini à l'Article 12, peut pareillement établir des succursales

et des filiales aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le gérant ou, le cas échéant, le Conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre  l'activité  normale  de  la  Société  à  son  siège  social,  ou  la
communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le gérant ou, le cas échéant, par le Conseil

de gérance de la Société.

62586

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-), divisé en quinze mille

(15.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant une résolution

de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres parts sociales.

Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi de 1915 et les

Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de

la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts - Rachats de parts sociales propres. Si la Société est composée d'un associé unique, ledit

associé unique peut librement céder ses parts.

Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les

parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social, par application des prescriptions des articles 189 et 190
de la Loi de 1915.

La Société peut racheter ses parts sociales.

Art. 11. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évé-

nement similaire de l'associé unique ou l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 12. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise par l'associé unique ou, le cas échéant, par une décision prise

à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun
terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée.

Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout

moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de Gérance (le «Conseil de gérance»).
Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens

de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les
autres et de communiquer les unes avec les autres. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut
à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne.

Les gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant

au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter, étant entendu qu'au moins deux gérants soient présents
en personne ou par conférence téléphonique.

Une convocation écrite à toute réunion du Conseil de gérance devra être donnée aux gérants au moins vingt-quatre

(24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de
l'urgence devront être mentionnées dans la convocation.

La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné par écrit, par télégramme, télex, e-mail ou

télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, ainsi que par une renonciation expresse donnée par tous
les gérants présents ou représentés à la réunion du Conseil de gérance, cette renonciation étant mentionnée dans le
procès-verbal de la réunion.

Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu dé-

terminés dans une résolution adoptée préalablement par le Conseil de gérance.

L'associé unique ou le cas échéant l'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des Gérants de classes

différentes. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée con-
cernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Le Conseil de gérance ne peut agir ou délibérer validement que si une majorité des gérants en fonction sont présents

ou représentés.

62587

L

U X E M B O U R G

Les décisions du Conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la

Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'associé unique ou l'assemblée générale des associés
aurait nommé différentes classes de gérants, toute résolution du Conseil de gérance ne pourra être valablement prise
que si elle est approuvée par la majorité des Gérants, y inclus au moins un gérant de chaque classe.

Les listes de présence et les procès-verbaux des réunions du Conseil de gérance devront être signés par les gérants

présents ou représentés à cette réunion.

Le Conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents simi-

laires  par  voie  de  circulaires  exprimant  son  approbation  par  écrit,  par  mail  ou  télécopie  ou  tout  autre  moyen  de
communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment signés l'existence de
la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra
être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

Art. 13. Evénements affectant les gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout autre événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas
la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son
mandat.

Art. 15. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle en cas de gérant unique, et

en cas d'un Conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu cependant que si l'associé unique
ou l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, la Société ne sera valablement engagée que
par la signature conjointe d'un gérant de chaque classe (y inclus par voie de représentation).

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

de signature ont été délégués soit par le gérant; ou soit par deux gérants en cas d'un Conseil de gérance ou, en cas de
classes de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de chaque classe (y inclus par voie de représentation).

Art. 16. Assemblée générale des associés. Tant que la Société ne comporte qu'un (1) associé unique, celui-ci exerce

les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de
la Loi de 1915 ne sont pas applicables.

Lorsque  la  Société  est  composée  de  plusieurs  associés,  les  décisions  collectives  sont  prises  lors  d'une  assemblée

générale des associés.

Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle

se tiendra dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social au siège social de la Société ou en tout autre lieu à spécifier
dans la convocation de cette l'assemblée.

Art. 17. Décisions des associés. Les décisions collectives ne sont valablement prises pour autant que les associés

possédant plus que la moitié du capital les adoptent. Cependant, les décisions ayant pour objet une modification des
Statuts ne peuvent être adoptées qu'à la majorité (en nombre) des associés possédant au moins les trois quarts des parts
sociales de la Société, sauf dispositions contraires de la Loi de 1915. Le changement de la nationalité de la Société requiert
l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés lors d'une assemblée des associés, et s'ils déclarent connaître l'ordre

du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, seront établies par écrit et tenues par la

gérance au siège social de la Société.

Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

Art. 18. Année sociale. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre.

Art. 19. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes annuels de la Société sont établis

par le gérant ou, le cas échéant, par le Conseil de gérance. Le gérant ou, le cas échéant, le Conseil de gérance dresse un
inventaire général comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société. Chaque associé ou son mandataire
muni d'une procuration écrite peut prendre connaissance desdits inventaires et bilans au siège social de la Société.

Art. 20. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des

frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil peut décider de payer à l'associé unique ou, le cas échéant, aux

associés des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir

62588

L

U X E M B O U R G

que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas
excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi de 1915
ou des Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés
seront remboursées par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.

Art. 21. Dissolution, Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l'insolvabilité ou de la faillite d'un des associés.

La liquidation de la Société sera décidée par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée des associés en con-

formité avec les dispositions légales applicables.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

selon le cas par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Disposition générale. Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents Statuts seraient régies

conformément à la Loi de 1915.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en

numéraire les montants ci après énoncés:

Associé

Capital

souscrit

(EUR)

Nombre

de parts

Libération

(EUR)

DUTYFLY SOLUTIONS SAS, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,-

15.000

15.000,-

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées de sorte que la somme de quinze

mille euros (EUR 15.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l'Article 183 de la Loi de 1915, ont été respectées.

<i>Évaluations des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à mille quatre cents Euros (EUR 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de fixer à un le nombre de Gérant.
Est nommé en qualité de Gérant, Monsieur Philippe LE GOFF, né à Guérande (F), le 8 novembre 1967, demeurant

professionnellement à Aéroport de Luxembourg - Inflight Catering - L-2987 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi à Aéroport de Luxembourg -Inflight Catering - L-2987 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide que la première période comptable de la Société commencera au jour du présent acte et

s'achèvera le 31 décembre 2015.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu par le notaire par son nom, prénom, état et

demeure, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. GALIOTTO et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/13959. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 mai 2015.

Référence de publication: 2015072293/210.
(150082821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

62589

L

U X E M B O U R G

Superfund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 54.921.

The board of directors of the Company (the “Board of Directors”) has decided to make the following changes with

the effect as of 1 July 2015 (the “Effective Date”).

Background
The Company currently has four (4) sub-funds in the “Green” strategy: Superfund Green A, Superfund Green B,

Superfund Green C and Superfund Green One.

The “Superfund Green A, B and C” sub-funds utilize the Superfund Green managed futures investment strategy, but

differ in terms of volatility and risk levels as well as the incentive fee level. The sub-fund Superfund Green One shall be
renamed to “Superfund Green” (the new “Superfund Green” strategy).The managed futures investment strategy already
utilized in Superfund Green One - being a result of continuing development of the Superfund Green strategy features the
most advanced Superfund trading systems. In particular, the newly developed “Performance Stabiliser” aims to keep
volatility in a defined bandwidth, automatically adapting the market exposure and the positions depending on the current
market environment, potentially increasing the return/risk-ratio. This makes different Superfund Green sub-strategies -
respectively risk classes - (Superfund Green A, B and C) obsolete.

Further, due to a decrease in the total net assets of the “Green A, B and C” sub-funds over the last years, the Board

of Directors, following a recommendation from the Company´s investment manager, considers it to be in the best interest
of the shareholders of the Company to decrease the number of available sub-funds through mergers in order to optimise
the cost structure. Therefore it was decided to merge the sub-funds Superfund Green A, B and C into the sub-fund
“Superfund Green”. By reducing the overall fund structure from four “Green” sub-funds to one “Green” sub-fund and
sixteen share classes to four share classes in the new “Superfund Green”, the merger will help to reduce overall costs,
create scope for investment efficiencies as well as for economies of scale.

Moreover, due to the implementation of the European AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive), also

the requirements for the distribution to retail clients were amended. This limits the possibilities to distribute certain
current “Green” sub-funds and/or share classes to retail clients in certain European countries. The new “Superfund
Green” sub-fund fulfils all necessary requirements to be distributed to retail clients in the most important sales market.
This significantly contributes to securing the economic longevity of the Company.

Volatility as well as the risk level of the new “Superfund Green” is similar to that of Superfund Green B and higher

than that of Superfund Green A and less, than that of Superfund Green C. Shareholders should note that due to the
different volatility and risk levels of the new “Superfund Green” compared to Superfund Green A and Superfund Green
C, the potential of making losses, but also of making profits, will be higher compared to Superfund Green A and lower
compared to Superfund Green C.

The incentive fee in the new “Superfund Green” is 20% (based on the high watermark method), thus the same as in

Superfund Green A, but less than in Superfund Green B (currently 25%) and less than in Superfund Green C (currently
30%). The other fees are the same in all “Green” sub-funds.

The minimum subsequent investments for investors in the new “Superfund Green” are EUR 5,000 for the EUR share

class and USD 5,000 for the USD, Gold and Silver share classes.

1) Merger of Sub-Funds
As of the Effective Date, the following mergers by way of absorption will take place:

• For the Sub-Fund Superfund Green A:

- the share classes USD R will be merged into the new “Superfund Green” class USD;
- the share classes EUR R and EUR I will be merged into the new “Superfund Green” class EUR;
- the share class USD Gold will be merged into the new “Superfund Green” Class Gold

• For the Sub-Fund Superfund Green B:

- the share classes USD R, USD I and GCT USD will be merged into the new “Superfund Green” class USD;
- the share classes EUR R and GCT EUR will be merged into the new “Superfund Green” class EUR
- the share class USD Gold will be merged into the new “Superfund Green” Class Gold

• For the Sub-Fund Superfund Green C:

- the share classes USD R will be merged into the new “Superfund Green” class USD;
- the share classes EUR R will be merged into the new “Superfund Green” class EUR.

62590

L

U X E M B O U R G

As a consequence, as of the Effective Date all assets and liabilities of the sub-funds Superfund Green A, Superfund

Green B and Superfund Green C (the “Absorbed Sub-Funds”) will be transferred into the sub-fund “Superfund Green” (the
“Absorbing Sub-Fund”) and the Absorbed Sub-Funds will cease to exist.

The merger will be a merger in cash, being understood that the portfolios of the Absorbed Sub-Funds will be sold and

all the positions will be closed. Hence, for a limited period of time (until the effectiveness of the merger), the Absorbed
Sub-Funds will only consist of cash.

Overview table:

Current

After merger

ISIN

Sub-Fund

Share Class

ISIN

Sub-Fund

Share Class

LU0199179838

Superfund
Green A

USD R

==>

LU1084751459

Superfund
Green

USD

LU0302258057

Superfund
Green A

USD Gold

==>

LU1084751533

Superfund
Green

Gold

LU0199179911

Superfund
Green A

EUR R

==>

LU1084752002

Superfund
Green

EUR

LU0302256788

Superfund
Green A

EUR I

==>

LU1084752002

Superfund
Green

EUR

LU0199180257

Superfund
Green B

USD R

==>

LU1084751459

Superfund
Green

USD

LU0302258214

Superfund
Green B

USD I

==>

LU1084751459

Superfund
Green

USD

LU0302258487

Superfund
Green B

USD Gold

==>

LU1084751533

Superfund
Green

Gold

LU0199180414

Superfund
Green B

EUR R

==>

LU1084752002

Superfund
Green

EUR

LU0067494376

Superfund
Green B

GCT USD

==>

LU1084751459

Superfund
Green

USD

LU0138077283

Superfund
Green B

GCT EUR

==>

LU1084752002

Superfund
Green

EUR

LU0199181222

Superfund
Green C

USD R

==>

LU1084751459

Superfund
Green

USD

LU0199181651

Superfund
Green C

EUR R

==>

LU1084752002

Superfund
Green

EUR

<i>Impact of the Merger on the shareholders
As of the Effective Date, all shares of the Absorbed Sub-Funds in issue will be cancelled and the shareholders will

receive new shares of the respective share class in the new “Superfund Green”. The total value of the received shares in
the new “Superfund Green” will correspond to the total value of shares of the respective shareholder in the Absorbed
Sub-Fund(s).

Shareholders should particularly be aware that the incentive fee in the new “Superfund Green” will be charged based

on the high watermark calculation of the new “Superfund Green”. The NAV of the new “Superfund Green” currently is
closer to its high watermark compared to the absorbed sub-funds Superfund Green A, B and C. Therefore the new
“Superfund Green” will likely pay incentive fees earlier than Superfund Green A, B and C would have.

The Alternative Investment Fund Manager, Investment Manager, Depository and the Domiciliary, Administrative and

Transfer Agent will remain unchanged.

<i>Calculation method of the share class conversion rates
The conversion rates between shares of the Absorbed Sub-Funds and shares of the Absorbing Sub-Fund will be cal-

culated on a ratio to be defined as of the Effective Date.

<i>Costs
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred with respect to the Merger will be

borne by the Company's investment manager.

<i>Additional Information
The merger of Sub-Funds respectively share classes should not be a taxable event at the fund level from a Luxembourg

tax point of view. Further, also on the shareholder level, the merger should not have a tax impact. However, shareholders
are advised to consult their professional advisors concerning the possible taxation or other consequences of the merger
under the laws of their country of incorporation, establishment, citizenship, residency, ordinary residence or domicile.

62591

L

U X E M B O U R G

Shareholders of the Company's Sub-Funds who do not agree with the changes set out above may request the re-

demption of all or a part of their shares at the applicable net asset value of the relevant shares without any redemption
charges (except for any transaction costs incurred by the Absorbed Sub-Funds in effecting redemptions) until 30 June
2015.

Luxembourg, 20 May 2015.

<i>The Board of Directors .

Référence de publication: 2015073570/755/127.

Mondial Industrie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle ZARE Ilot Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 56.203.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 4 mars 2015

1) RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrice ROSATI, né le 22 février 1960 à Mont Saint Martin (F), demeurant

à 16, Rue de Schifflange, L-4392 Pontpierre est renouvelé pour un terme de six années; il prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire à tenir en 2021.

-  Le  mandat  d'administrateur  de  Madame  Isabelle  ROSE,  née  le  8  mai  1964  à  Thionville  (F),  demeurant  à  8,  Um

Klaeppchen, L-5720 Aspelt est renouvelé pour un terme de six années; il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire à tenir en 2021.

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Jacques BERGER, né le 23 avril 1966 à Koenigsmacker (F), demeurant à 8,

Um Klaeppchen, L-5720 Aspelt est renouvelé pour un terme de six années; il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire à tenir en 2021.

2) RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR DELEGUE
- Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Patrice ROSATI, né le 22 février 1960 à Mont Saint Martin (F),

demeurant à 16, Rue de Schifflange, L-4392 Pontpierre est renouvelé pour un terme de six années; il prendra fin à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2021.

3) RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
- Le mandat de commissaire de Madame COIGNARD Marie Aline, née le 24 avril 1961 à Briey (F), 16, Rue de Schifflange,

L-4392 Pontpierre est renouvelé pour un terme de six années; il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à
tenir en 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehlerange, le 4 mars 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Patrice ROSATI
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2015050012/32.

(150057174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

Lux Chapiteaux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 159.456.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Troisvierges, le 29 mars 2015.

La Gérance
Eric Wansart
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2015049975/13.

(150057550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

62592


Document Outline

Abbott Overseas Luxembourg S.à r.l.

Abbott Poland Luxembourg S.à r.l.

Abbott Products Luxembourg S.à r.l.

Abbott South Africa Luxembourg S.à r.l.

Adriatic Luxco S.à r.l.

Advanced Global Holding Limited S.à r.l.

Aicy International S.A.

AIR.CA S.A.

Ambo S.A.

BHI (GBA) S.A.

BRE/Mannheim I Hotel S. à r.l.

BRE/Nine Hotel Holding S. à r.l.

Caireen S.à r.l.

Carmosina S.à r.l.

CFG Patrimoine

CitCor Franconia Süd S.à r.l.

Cristal Investment s.à r.l.

CROWN PREMIUM Private Equity V Master Europe S.C.S., SICAF-FIS

Data Center S.C.A.

Diekirch Investment S.A.

Digital Consulting Company S.A.

Dornie S.à r.l.

DSG S.à r.l.

Dutyfly Solutions Luxembourg S.à r.l.

East Coast S.à r.l.

Edmond de Rothschild Europportunities Management S.à r.l.

Embafin S.A.

Euro Prudence F.T.

Findel Business Center West Side S.A.

Horest, S.à r.l.

Immobilière Daniel Beck S.à r.l.

Ipan Investment SCA

Lux Chapiteaux

Marie Lingerie S.à r.l.

MCH Holding S.A.

Mondial Industrie S.A.

NPF Soparfi D S.à r.l.

NYK Hummingbird S.à r.l.

Oeko-Bureau, S.à r.l.

Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company

Sol o plafond S.à r.l.

Superfund Sicav

Top Manager