This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1282
18 mai 2015
SOMMAIRE
Adventive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61532
ATHRIS WIND (Luxembourg) S.A. . . . . .
61532
Bock Capital Investors S.à r.l. . . . . . . . . . . .
61536
Captainjet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61536
Ceria S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61536
C.F.F. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61526
IsatyLux, S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61530
Lamudi Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61490
Lands Improvement Holdings Poole S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61514
Logic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61514
Logic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61515
Lutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61515
Maghery Trade S.à.r.l. - SPF . . . . . . . . . . . .
61522
Malt Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61521
Marine International Operations S.A. . . . .
61522
Maris S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61515
Marmor und Granit International A.G. . . .
61522
Marsaco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61516
Matteo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61522
Maxiflow Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
61523
McGraw Hill Financial European Holdings
(Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61517
McGraw Hill Financial Global Holdings (Lu-
xembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61517
McGraw Hill Financial (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61516
Meistor Beteiligungen S.A. . . . . . . . . . . . . . .
61524
«Mercury Investment Company S.à r.l.»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61517
Meridiam Infrastructure Germany S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61517
Meridiam Infrastructure Germany S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61518
Meridian Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
61519
Mesotos SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61524
Milano Properties and Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61520
Mirko S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61520
Mont Cervin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61520
Morgan Stanley Curtiss Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61521
Morgan Stanley Morane Investments S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61521
Morgan Stanley Spad Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61521
Na2O S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61525
New Dragon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61524
Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l. . . . . .
61525
Operamba S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61525
Oval Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61525
Paragem Assets S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
61526
Paris Nord S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61526
Paris Nord S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61526
P.E.S.Y. GBP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61525
61489
L
U X E M B O U R G
Lamudi Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.486.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of February.
Before us, Maître C sita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 177.038,
having its registered office at 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “AIH”),
being the holder of six thousand two hundred fifty (6,250) common shares, six thousand two hundred fifty (6,250)
series A1 shares and four thousand two (4,002) series B shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Berlin, Germany, on 9 February 2015, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 9 February 2015,
2. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,
registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 139778 B, having
its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of three thousand one hundred twenty-five (3,125) common shares and three thousand one hundred
twenty-five (3,125) series A2 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Berlin, Germany, on 9 February 2015,
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 176.544,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a
share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000),
being the holder of one thousand five hundred sixty-two (1,562) common shares and one thousand five hundred sixty-
three (1,563) series A3 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
London, on 12 February 2015,
4. TEC Global Invest VII GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,
registered with Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg under number HRB 26063, having its registered office at
Wissollstrasse 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany (hereinafter “TEC”),
being the holder of one thousand five hundred sixty-three (1,563) common shares, one thousand five hundred sixty-
two (1,562) series A4 shares and one thousand five hundred (1,500) series B shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Mülheim an der Ruhr, Germany, on 9 February 2015, and
5. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 191.426 (hereinafter “Holtzbrinck”),
becoming the holder of one thousand two hundred fifty (1,250) series B shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 10 February 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties under 1., 2., 3. and 4. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Lamudi Global S.à r.l.
(hereinafter the “Company”), formerly Digital Services XXV S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered
office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 188486, incorporated pursuant to a deed of notary Carlo Wersandt on 18 June
2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2492 on 16 September 2014. The articles of
association have been amended pursuant to a deed of notary Cosita Delvaux dated 29 January 2015, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement. The general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Holtzbrinck
participates and votes for the purpose of agenda point 3 et seqq. only:
61490
L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
1. Acceptance of HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 191.426, as new shareholder of the Company.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250)
from its current amount of thirty thousand five hundred two euro (EUR 30,502) up to thirty-one thousand seven hundred
fifty-two euro (EUR 31,752) through the issuance of one thousand two hundred fifty (1,250) series B shares, with a nominal
value of one euro (EUR 1) each.
3. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth
read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-one thousand seven hundred fifty-two euro (EUR 31,752.00), repre-
sented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A1 Shares”),
5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A3 Shares”),
5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”), and
5.1.6 six thousand seven hundred fifty-two (6,752) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series B Shares”).
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings
S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”) and (v) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtz-
brinck”; AIH, LIH, Aismare, TEC and Holtzbrinck jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to
subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment
offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections
15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved by the
Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more
matching shareholders -required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase
under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii)
Aismare, (iv) TEC and (v) Holtzbrinck shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it
has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and/or
(v) Holtzbrinck intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This
Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”
4. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Lamudi Global
S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
61491
L
U X E M B O U R G
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-one thousand seven hundred fifty-two euro (EUR 31,752.00), repre-
sented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A1 Shares”),
5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A3 Shares”),
5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”), and
5.1.6 six thousand seven hundred fifty-two (6,752) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series B Shares”).
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings
S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”) and (v) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtz-
brinck”; AIH, LIH, Aismare, TEC and Holtzbrinck jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to
subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment
offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections
15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved by the
Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more
matching shareholders -required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase
under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii)
Aismare, (iv) TEC and (v) Holtzbrinck shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it
has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and/or
61492
L
U X E M B O U R G
(v) Holtzbrinck intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This
Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing Shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The Shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the Shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of Shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by an Investor to a company affiliated
to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (each an “Affiliate”);
7.4.2 in case of the transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares of one Investor to a company or entity
(x) which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by
one or more direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Con-
trol” or “Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by way of
(a) managing the company or entity as managing shareholder, (b) holding the majority of Shares or (c) holding the majority
of voting rights by means of a contractual voting pool, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders
of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by a Shareholder to the Company and/or
any of the Investors pursuant to a call-option under a vesting scheme;
7.5 To the extent a sale, transfer, assignment or any other disposal of Shares requires no additional consent of the
shareholders' meeting pursuant to Article 7.4.1 through Article 7.4.3 above, neither duties to offer for sale, nor any rights
of first refusal, nor rights of pre-emption, nor tag-along rights, nor drag-along rights apply in favour of other Shareholders.
7.6 Any sale, transfer, assignment or other disposal of Shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification thereof to, or upon the acceptance thereof by the Company in accordance with Article
1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the Shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an
economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii)
of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of Shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50 % of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the
events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) -
subject to Articles 8.2 and 8.3 below - will be distributed in accordance with Article 8.4 to the Shareholders pro rata to
their participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series B Shares shall receive per Share an amount of EUR 2,000 being
subject to the Liquidity Event.
61493
L
U X E M B O U R G
8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series
A4 Shares shall receive per Share of the respective Share class an amount stipulated next to the relevant share class being
subject to the Liquidity Event in the following table:
Share Class
Amount
per Share
in Euro
Series A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Series A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,695.18
Series A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,599.49
Series A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,600.51
8.4 After the payments on the First Level and on the Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall
be allocated on a third level (“Third Level”) to all selling Shareholders pro rata to their participation in the Liquidity Event.
Any amounts received by any Investor on the First Level and/or Second Level shall reduce the amount to be allocated to
such Investor on this Third Level provided that no Investor shall be obliged to repay any amount received on the First
Level and/or Second Level. Irrespective of whether or not the sale of Shares is made in one Liquidity Event or after the
Liquidity Event in one transaction or more transactions, no shareholder shall receive for the sale of all of its Shares (and
shall repay any exceeding amount to the other shareholders) an amount exceeding the higher of (i) its Share in the total
Exit Proceeds or proceeds pro rata to the Shares sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such
shareholder on the First Level and/or Second Level and/or Third Level from a subsequent sale. All rights related to the
liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.
8.5 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies for the benefit of the respective Investor so
long as the respective Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to such Investor according to
the First Level.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own Shares. The voting rights of any of its Shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings
is rejected for lack of assets;
9.2.2 the Share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such Share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the Shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles of association together with
the declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the
Law and the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the Shares in such case and undertakes to register
the transfer in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed Shares. The effective
date is the date before the redemption resolution.
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the Shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
61494
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the Shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the share to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of
association, for the Shares to be assigned is owed by the person acquiring the Shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds Shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
61495
L
U X E M B O U R G
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous
consent.
Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
Art. 17. Shareholders' Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the
consent of the Advisory Board:
17.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company;
17.1.2 amendment of these articles of association including the resolution with respect to the merger, separation and
transformation of the Company;
17.1.3 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such
profits to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;
17.1.4 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG));
17.1.5 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of existing
shares or issuance of new shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other con-
tractual party is granted a participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the
Company's profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agree-
ments concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties
within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also requires the consent of
the Investors.
17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company's own Shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and
transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.
17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of Shares the special rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders' who hold
all the issued Shares of that class.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
61496
L
U X E M B O U R G
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
22.8 The managers shall require the consent of the advisory board (the “Advisory Board”) for the legal transactions
and measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined
and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:
22.8.1 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
22.8.2 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of five hundred thousand Euros
(EUR 500,000.00) in aggregate;
22.8.3 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,
however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
22.8.4 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two
hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework, excluding,
however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
22.8.5 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
22.8.6 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.7 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
22.8.8 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than five hundred thousand Euros (EUR 500,000.00) in the individual case;
61497
L
U X E M B O U R G
22.8.9 passing on of industrial property rights or know-how by the Company to a third party outside the ordinary
course of business;
22.8.10 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals as set
forth in any shareholders' agreement between the shareholders;
22.8.11 amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections
291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)); and
22.8.12 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)
other than the establishment of any simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the
Company in a shareholders' agreement, if any.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers) such minutes shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company has set up an Advisory Board. It consists of five (5) voting members. The shareholders may by way
of unanimous Shareholders' Consent increase or decrease the number of voting members of the Advisory Board.
25.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous
shareholders' consent.
25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-
pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
25.3.1 One (1) voting member of the Advisory Board, having six (6) votes, shall be nominated by the shareholder AIH
in its sole discretion;
25.3.2 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder
LIH in its sole discretion;
25.3.3 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder
Aismare in its sole discretion; and
25.3.4 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder
TEC in its sole discretion.
25.3.5 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, having one (1) vote, shall be nominated by
the shareholder Holtzbrinck in its sole discretion.
25.4 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. The chairman shall be the member nominated
by the largest shareholder in terms of percentage participation that is entitled to nominate a member to the Advisory
Board. The rules of procedure of the Advisory Board may provide for further provisions in particular on the self-orga-
nization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast. In case
of a vote tie, the chairman shall have a casting vote if at the point in time of the respective decision the Shareholder having
61498
L
U X E M B O U R G
nominated the chairman holds more than 50 % of all shares in the Company. For the avoidance of doubt the deputy
chairman shall not have a casting vote.
25.5 The objective and responsibility of the Advisory Board shall be the granting of consents to specific transactions
of the management of the Company which pursuant to (i) any shareholders' agreement relating to the Company, (ii) these
articles of association, (iii) the rules of procedure for the managers, (iv) the rules of procedure for the Advisory Board
or (v) respective shareholders' resolutions require the consent of the Advisory Board. Further powers and responsibilities
may be conferred on the Advisory Board by shareholders' resolution. In addition to those consent requirements, the
Advisory Board has a consultative function and will not interfere in the management of the Company.
25.6 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
E. Audit and supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they
hold in the Company.
Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
61499
L
U X E M B O U R G
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.
31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
5. Subsequently, decision to grant power to any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr
Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders'
register of the Company.
6. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the undersigned notary to enact, the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to accept HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en com-
mandite simple incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 191.426, as new shareholder of the Company.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to increase the share capital of the Company by an amount of one
thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250) from its current amount of thirty thousand five hundred two euro (EUR
30,502) up to thirty-one thousand seven hundred fifty-two euro (EUR 31,752) through the issuance of one thousand two
hundred fifty (1,250) Series B Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The new one thousand two hundred fifty (1,250) Series B Shares have been duly subscribed by Holtzbrinck, afore-
mentioned, for the subscription price of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250).
<i>Paymenti>
The new one thousand two hundred fifty (1,250) Series B Shares subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, have
been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250).
The proof of the existence of the above contribution in cash has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250) is entirely allocated to the share
capital of the Company.
<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article five (5)
of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-one thousand seven hundred fifty-two euro (EUR 31,752.00), repre-
sented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A1 Shares”),
5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A3 Shares”),
5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”), and
5.1.6 six thousand seven hundred fifty-two (6,752) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series B Shares”).
61500
L
U X E M B O U R G
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings
S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”) and (v) HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtz-
brinck”; AIH, LIH, Aismare, TEC and Holtzbrinck jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to
subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment
offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections
15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved by the
Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more
matching shareholders -required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase
under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii)
Aismare, (iv) TEC and (v) Holtzbrinck shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it
has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and/or
(v) Holtzbrinck intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This
Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”
<i>Fourth Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the
articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Fifth Resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby grants power to any manager of the Company, regardless of his category,
as well as Mr Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the
shareholders' register of the Company.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at EUR 1,800.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizehnten Februar,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 177.038, mit Sitz in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg („AIH“),
Inhaberin von sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Stammanteilen, sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Antei-
len der Serie A1 und viertausendzwei (4.002) Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht aus-
gestellt in Berlin, Deutschland, am 9 Februar 2015, und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 9 Februar 2015,
2. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 139778
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaberin von dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Stammanteilen und dreitausendeinhundertfünfundzwanzig
(3.125) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom9
Februar 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland,
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
61501
L
U X E M B O U R G
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000),
Inhaberin von eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Stammanteilen und eintausendfünfhundertdreiundsechzig
(1.563) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
12 Februar 2015, ausgestellt in London,
4. TEC Global Invest VII GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRB 26063, mit Sitz in Wissoll-
straße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland („TEC“),
Inhaberin von eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Stammanteilen, eintausendfünfhundertzweiundsechzig
(1.562) Anteilen der Serie A4 und eintausendfünfhundert (1.500) Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
9 Februar 2015, ausgestellt in Mülheim an der Ruhr, Deutschland, und
5. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend
unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés)
unter der Nummer B 191.426 („Holtzbrinck“),
zukünftige Inhaberin von eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
10 Februar 2015, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur pa-
raphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien unter 1., 2., 3. und 4. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Lamudi Global S.à
r.l. (die „Gesellschaft”), vormals Digital Services XXV S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Lu-
xemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188486, gegründet am 18. Juni 2014 gemäß einer
Urkunde des Notars Carlo Wersandt, welche am 16. September 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 2492 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde am 29. Januar 2015 gemäß einer Urkunde
der Notarin Cosita Delvaux geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffent-
licht wurde.
Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
Tagesordnung verhandeln, wobei Holtzbrinck ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimm-
berechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Aufnahme von HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, einer Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Groß-
herzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés) unter der Nummer B 191.426, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von dreißigtausendfünfhundert-
zwei Euro (EUR 30.502) um einen Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) auf einen Betrag von
einunddreißigtausendsiebenhundertzweiundfünfzig Euro (EUR 31.752) durch die Ausgabe von eintausendzweihundert-
fünfzig (1.250) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
3. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausendsiebenhundertzweiundfünfzig Euro (EUR
31.752,00), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“),
61502
L
U X E M B O U R G
5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und
5.1.6 sechstausendsiebenhundertzweiundfünfzig (6.752) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B“).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“) und (v) HV Holtzbrinck Ventures
Fund VI SCS („Holtzbrinck“; AIH, LIH, Aismare, TEC und Holtzbrinck gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein
„Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch
ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit
einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittin-
vestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) -unabhängig davon, ob diese vom
Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Betei-
ligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen,
wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) Holtzbrinck
hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition
eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und/oder (v)
Holtzbrinck ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser
Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“
4. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Lamudi Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Artikel
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
61503
L
U X E M B O U R G
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausendsiebenhundertzweiundfünfzig Euro (EUR
31.752,00), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“),
5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und
5.1.6 sechstausendsiebenhundertzweiundfünfzig (6.752) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B“).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“) und (v) HV Holtzbrinck Ventures
Fund VI SCS („Holtzbrinck“; AIH, LIH, Aismare, TEC und Holtzbrinck gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein
„Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch
ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit
einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittin-
vestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) -unabhängig davon, ob diese vom
Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Betei-
ligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen,
wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) Holtzbrinck
hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition
eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und/oder (v)
Holtzbrinck ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser
Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-
venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
61504
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Über-
tragung von Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Investor an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) (jeweils eine „Verbundene Gesellschaft“);
7.4.2 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines
Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welche/s direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen
oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“)
Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte
„Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft oder
des Unternehmens bezeichnen, durch (a) die Leitung der Gesellschaft oder des Unternehmens als geschäftsführender
Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine
vertragliche Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher/m der betreffende Investor oder ein oder mehrere Gesellschafter
dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang
mit einer Vesting-Regelung.
7.5 Sofern ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen keiner weiteren
Zustimmung als der der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 7.4.1 bis 7.4.3 bedarf, gelten weder Verpflichtungen
zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesell-
schafter.
7.6 Ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft darüber in Kenntnis
gesetzt wurde oder diesem/dieser zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zugestimmt hat (wobei die Anteile des verstorbenen Ge-
sellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich,
wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen
Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer
Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Transaktionen oder in zeit-
licher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der Übertragung von
Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder
mehr als 50% des Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw.
Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter
(i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiter-
löse“) - vorbehaltlich der Artikel 8.2 und 8.3 - im Einklang mit Artikel 8.4 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer
Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B pro Anteil einen Betrag von
EUR 2.000, vorausgesetzt, dass das Liquiditätsereignis eingetroffen ist.
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2,
Anteilen der Serie A3 und Anteilen der Serie A4 pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse einen in der folgenden Tabelle
neben der entsprechenden vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteilsklasse vereinbarten Betrag:
Anteilsklasse
Betrag
pro Anteil
61505
L
U X E M B O U R G
in Euro
Serie A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,00
Serie A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.695,18
Serie A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.599,49
Serie A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600,51
8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen
Exiterlöse auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene”) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entspre-
chend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Investor auf der Ersten Ebene und/oder
Zweiten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Investor zu erhaltenden Betrag auf dieser Dritten Ebene,
mit der Maßgabe, dass kein Investor zur Rückzahlung eines auf der Ersten Ebene und/oder Zweiten Ebene erhaltenen
Betrags verpflichtet ist. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach
in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen
Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein
Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen
und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten Ebene und/
oder Zweiten Ebene und/oder Dritten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin
festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.
8.5 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene gilt zugunsten des jeweiligen Investors solange, wie
dieser den Gesamtbetrag, welcher diesem Investor gemäß der Ersten Ebene zuzuteilen ist, noch nicht erhalten hat.
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
61506
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche
in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
61507
L
U X E M B O U R G
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-
treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.
Art. 17. Gesellschafterbeschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und
zudem die Zustimmung des Beirats:
17.1.1 Veräußerung des Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens, ein-
schließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
17.1.2 Änderung dieser Satzung, einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und
Umwandlung der Gesellschaft;
17.1.3 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-
cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln;
17.1.4 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
17.1.5 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (zur Klarstellung, nicht durch die Veräußerung bestehender oder
die Ausgabe neuer Anteile) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die
andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag
der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, ein-
schließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abge-
schlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der
Gesellschaft und Werbepartnern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-
stimmung der Investoren:
17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.
17.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
ihre Amtszeit festlegt.
19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
61508
L
U X E M B O U R G
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (der „Beirat“) für die untenstehenden Rechtsgeschäfte
und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert
und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:
22.8.1 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
22.8.2 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von fünfhun-
derttausend Euro (EUR 500.000,00) überschreiten;
61509
L
U X E M B O U R G
22.8.3 Gewährung von Darlehen, die, im Einzelfall, einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00)
überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Toch-
tergesellschaften der Gesellschaft;
22.8.4 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,
einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, aller-
dings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der
Gesellschaft;
22.8.5 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-
aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.6 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
22.8.7 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
22.8.8 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streit-
wert von über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,00) im Einzelfall;
22.8.9 Weitergabe von gewerblichen Schutzrechten oder Know-how von der Gesellschaft an Dritte außerhalb des
gewöhnlichen Geschäftsgangs;
22.8.10 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen,
wie in Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern dargelegt;
22.8.11 Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes
(AktG)); und 22.8.12 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der
Gewährung jeglicher Anteilsoder Aktienoptionen) mit Ausnahme der Einführung einer vereinfachten Mitarbeiterbeteili-
gung, die zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart
wurde.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-
lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.
61510
L
U X E M B O U R G
Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat gebildet. Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-
sellschafter können die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats mit einstimmiger Zustimmung erhöhen oder
herabsetzen.
25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur mit einstimmiger Zustimmung festlegen und/
oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.3.1 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit sechs (6) Stimmen wird von dem Gesellschafter AIH nach
eigenem Ermessen ernannt;
25.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem Gesellschafter LIH nach
eigenem Ermessen ernannt;
25.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem Gesellschafter Aismare nach
eigenem Ermessen ernannt; und 25.3.4 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem
Gesellschafter TEC nach eigenem Ermessen ernannt.
25.3.5 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem Gesellschafter Holtzbrinck
nach eigenem Ermessen ernannt.
25.4 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Beirats ist das
Mitglied, welches von dem Gesellschafter ernannt wurde, welcher von der prozentualen Beteiligung her der größte der-
jenigen ist, welche zur Ernennung eines Beiratsmitglieds ermächtigt sind. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende die entscheidende Stimme, sofern
zu dem Zeitpunkt der jeweiligen Entscheidung derjenige Gesellschafter, der den Vorsitzenden ernannt hat, mehr als 50%
aller Anteile an der Gesellschaft hält. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass der stellvertretende Vorsitzende
nicht die entscheidende Stimme hat.
25.5 Ziel und Zuständigkeit des Beirats ist die Erteilung von Zustimmungen zu spezifischen Transaktionen der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft, welche gemäß (i) einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft, (ii) dieser
Satzung, (iii) der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, (iv) der Geschäftsordnung für den Beirat oder (v) entsprech-
ender Gesellschafterbeschlüsse die Zustimmung des Beirats erfordern. Weitere Befugnisse und Zuständigkeiten können
dem Beirat durch einen Gesellschafterbeschluss übertragen werden. Neben diesen Zustimmungserfordernissen hat der
Beirat eine beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
25.6 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinnund Ver-
lustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
61511
L
U X E M B O U R G
28.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene
Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den
Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen
den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
5. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie
Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit unein-
geschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
6. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en com-
mandite simple) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou
Hemmer, L-1748 Findel, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
(Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 191.426, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft auf-
zunehmen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
dreißigtausendfünfhundertzwei Euro (EUR 30.502) um einen Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250)
auf einen Betrag von einunddreißigtausendsiebenhundertzweiundfünfzig Euro (EUR 31.752) durch die Ausgabe von ein-
tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die neuen eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Serie B wurden ordnungsgemäß von Holtzbrinck, vor-
benannt, zum Bezugspreis von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) gezeichnet.
61512
L
U X E M B O U R G
<i>Zahlungi>
Die von Holtzbrinck, vorbenannt, gezeichneten eintausendzweihundertfünfzig (1.250) neuen Anteile der Serie B wur-
den vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250).
Der Nachweis über die Existenz der oben bezeichneten Bareinlage wurde der unterzeichnenden Notarin erbracht.
Die Einlage in Höhe von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel fünf (5) der Satzung der Ge-
sellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausendsiebenhundertzweiundfünfzig Euro (EUR
31.752,00), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“),
5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und
5.1.6 sechstausendsiebenhundertzweiundfünfzig (6.752) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B“).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“) und (v) HV Holtzbrinck Ventures
Fund VI SCS („Holtzbrinck“; AIH, LIH, Aismare, TEC und Holtzbrinck gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein
„Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch
ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit
einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittin-
vestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) -unabhängig davon, ob diese vom
Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Betei-
ligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen,
wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) Holtzbrinck
hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition
eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und/oder (v)
Holtzbrinck ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser
Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, einstimmig die gänzliche Neu-
fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt
lautet.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Herrn Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden
Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 1.800,- geschätzt.
61513
L
U X E M B O U R G
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unter-
zeichnet worden.
Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 février 2015. Relation: 1LAC/2015/5068. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 31. März 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015049301/1354.
(150056864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Lands Improvement Holdings Poole S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.515.
<i>1. Extrait des résolutions du conseil de gérance du 11 mars 2015:i>
- Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société est transféré du 28, Boulevard Royal, L- 2449 Luxem-
bourg au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 23 mars 2015.
2. Il est à noter que:
- le siège social de l'Associé Unique a été transféré au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 23
mars 2015.
- l'adresse professionnelle de Madame Joanne Fitzgerald a été transférée au 35a, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Lu-
xembourg avec effet au 23 mars 2015.
- l'adresse professionnelle de Madame Delloula Aouinti a été transférée au 35a, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxem-
bourg avec effet au 23 mars 2015.
- l'adresse professionnelle de Monsieur Joel Davidson a été transférée au 35a, avenue J.F. Kennedy, L -1855 Luxembourg
avec effet au 23 mars 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 23 mars 2015.
<i>Pour la Société
i>Joel Davidson
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015049303/25.
(150056490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Logic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 84.553.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
LOGlC S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2015049325/13.
(150056214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61514
L
U X E M B O U R G
Logic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 84.553.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 mars 2015i>
L'Assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes actuel et de pourvoir à son remplacement en appelant
à la fonction de commissaire aux comptes la société VP Services, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social
au 89A rue Pafebruch, L-8308 Capellen.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice
2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
LOGIC S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2015049326/18.
(150056215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Lutos, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 49, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 114.658.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015049327/11.
(150056285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Maris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 188.684.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 mars 2015i>
En date du 24 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de prendre note du décès de Monsieur Hiroyuki Rex SATO, gérant A de la Société, en date du 7 mars 2015;
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Anne Catherine GRAVE de son mandat de gérant B de la Société
avec effet au 31 mars 2015;
- de nommer Madame Antonella GRAZIANO, née le 20 janvier 1966 à Orvieto, Italie, résidant à l'adresse profes-
sionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 31 mars
2015 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Madame Sonia BALDAN, née le 27 janvier 1960 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant
à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant B de la Société
avec effet au 31 mars 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur John FOSINA, gérant A
- Monsieur Christian REYNT JENS, gérant A
- Monsieur Christophe AURAND, gérant A
- Madame Catherine KOCH, gérant B
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant B
- Madame Sonia BALDAN, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
61515
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Maris S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015049330/30.
(150056510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Marsaco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 169.809.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 24 mars 2015i>
En date du 24 mars 2015, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de prendre note du décès de Monsieur Hiroyuki Rex SATO, gérant A de la Société, en date du 7 mars 2015;
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Anne Catherine GRAVE de son mandat de gérant B de la Société
avec effet au 31 mars 2015;
- de nommer Madame Antonella GRAZIANO, née le 20 janvier 1966 à Orvieto, Italie, résidant à l'adresse profes-
sionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 31 mars
2015 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Madame Sonia BALDAN, née le 27 janvier 1960 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant
à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant B de la Société
avec effet au 31 mars 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur John J. FOSINA, gérant A
- Monsieur Christian REYNTJENS, gérant A
- Monsieur Christophe AURAND, gérant A
- Madame Catherine KOCH, gérant B
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant B
- Madame Sonia BALDAN, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Marsaco S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015049331/30.
(150056495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
McGraw Hill Financial (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 90.667,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.254.
Veuillez prendre note du changement suivant:
Paul James SANSOM, gérant A de la société, ayant désormais pour adresse professionnelle 20 Canada Square, Canary
Wharf, London, E14 5LH, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Martha Caballero
<i>Gérante Bi>
Référence de publication: 2015049334/14.
(150056557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61516
L
U X E M B O U R G
McGraw Hill Financial European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.385.506,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 150.542.
Veuillez prendre note du changement suivant:
Paul James SANSOM, gérant A de la société, ayant désormais pour adresse professionnelle 20 Canada Square, Canary
Wharf, London, E14 5LH, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Martha Caballero
<i>Gérante Bi>
Référence de publication: 2015049335/14.
(150056556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
McGraw Hill Financial Global Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 662.630.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 150.329.
Veuillez prendre note du changement suivant:
Paul James SANSOM, gérant A de la société, ayant désormais pour adresse professionnelle 20 Canada Square, Canary
Wharf, London, E14 5LH, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Martha Caballero
<i>Gérante Bi>
Référence de publication: 2015049336/14.
(150056555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Meridiam Infrastructure Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 192.512.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2015.
Référence de publication: 2015049338/10.
(150056237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
«Mercury Investment Company S.à r.l.», Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 189.110.
Il résulte que la Société a pris acte en date du 31 mars 2015:
- de la démission de Monsieur Martinus Cornelis Johannes Weijermans, en tant que gérant de classe B du conseil de
gérance, de la Société avec effet au 31 mars 2015;
- de la démission de Monsieur Robert van t Hoeft, en tant que gérant de classe B du conseil de gérance, de la Société
avec effet au 31 mars 2015;
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Steven Mark Powell, Gérant de Classe A;
- M. Charles Rupert Camden Parker, Gérant de Classe A;
- M. Ian Gordon Watson Gérant de Classe A;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
61517
L
U X E M B O U R G
Exequtive Partners S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015049337/20.
(150056850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Meridiam Infrastructure Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 192.512.
In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of March,
before the undersigned, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Meridiam Infrastructure Europe II (SCA) SICAR, a corporate partnership limited by shares (société en commandite
par actions) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg which is further subject to the law dated June 15,
2004 relating to the investment company in risk capital, as amended (the “SICAR law”), having its registered office at 5,
Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with Register of Commerce and Companies, under number B 149.213
(the Sole Shareholder), represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, whose professional address is L-1750 Lu-
xembourg, 74, avenue Victor Hugo, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 11 March
2015, being the sole shareholder of Meridiam Infrastructure Germany S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), having its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 192.512 (the Company).
The Company was incorporated on 28 November 2014 pursuant to a deed drawn up by the notary enacting this deed,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 10 of 2 January 2015. The articles of association
of the Company (the Articles) have not been amended since its incorporation.
After signature “ne varietur” by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary,
this power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder resolves as follows:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 3 of the Articles, which shall henceforth read as
follows:
“ 3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or en-
terprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire,
by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial
instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin. The Company may also generally carry out any transaction with respect
to real estate or movable property.”
<i>Estimate of costi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this
deed is drawn up in English and French, and that in the case of discrepancies, the English version shall prevail.
Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder’s authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mil quinze, le onzième jour du mois de mars,
par devant Maître Martine SCHAEFFER, soussignée, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg,
A comparu:
Meridiam Infrastructure Europe II (SCA) SICAR, une société en commandite par actions immatriculée à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 149.213 (l’Associé Unique), représentée par Madame Isabel DIAS,
61518
L
U X E M B O U R G
employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 11 mars 2015, étant l’associé unique de Meridiam Infrastructure
Germany S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 192.512 (la Société).
La Société a été constituée le 28 novembre 2014 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 10 du 2 janvier 2015. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été
modifiés depuis sa constitution.
Après signature ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire soussigné, la procuration restera
annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique prend la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article 3 des Statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
« 3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société peut éga-
lement, de façon générale, effectuer toute transaction relative à la propriété immobilière ou mobilière.»
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare à la demande de l’Associé Unique, que le
présent acte est rédigé en Anglais et en Français et qu'en cas de divergences, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture à haute voix faite par le notaire, celui-ci signe le présent acte avec le mandataire de l’Associé Unique.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 20 mars 2015. 2LAC/2015/6161. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2015.
Référence de publication: 2015049339/87.
(150056238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Meridian Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 19.448.673,15.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 154.555.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 12 mars 2015i>
En date du 12 mars 2015, l'associé unique:
- Approuve le rapport du commissaire à la liquidation au 12 mars 2015;
- Prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister;
- Décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans à partir du 12
mars 2015 au 1-3 boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049340/17.
(150057007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61519
L
U X E M B O U R G
Milano Properties and Investments S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 112.728.
EXTRAIT
Le siège social de la société anonyme Milano Properties and Investments S.A. 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxem-
bourg a été dénoncé avec effet immédiat de sorte que celle-ci se trouve jusqu'à nouvel avis sans domicile ni résidence
connus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2015.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2015049342/14.
(150056225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Mirko S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 190.224.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 26 mars 2015i>
En date du 26 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de prendre note du décès de Monsieur Hiroyuki Rex SATO, gérant A de la Société, en date du 7 mars 2015;
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Anne Catherine GRAVE de son mandat de gérant B de la Société
avec effet au 31 mars 2015;
- de nommer Madame Antonella GRAZIANO, née le 20 janvier 1966 à Orvieto, Italie, résidant à l'adresse profes-
sionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 31 mars
2015 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Madame Sonia BALDAN, née le 27 janvier 1960 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant
à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant B de la Société
avec effet au 31 mars 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur John J. FOSINA, gérant A
- Monsieur Christian REYNTJENS, gérant A
- Monsieur Christophe AURAND, gérant A
- Madame Catherine KOCH, gérant B
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant B
- Madame Sonia BALDAN, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Mirko S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015049343/30.
(150056477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Mont Cervin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 153.417.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
61520
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 31 mars 2015.
C.W.Karsten
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2015049344/12.
(150056631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Morgan Stanley Curtiss Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 147.928.
Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015049345/10.
(150056497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Morgan Stanley Morane Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 147.927.
Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015049346/10.
(150056498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Morgan Stanley Spad Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 147.926.
Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015049347/10.
(150056499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Malt Capital SA, Société Anonyme.
Siège social: L-5355 Oetrange, 8B, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 175.247.
L'actionnaire unique a pris la résolution suivante:
Monsieur Thomas SIDOT, demeurant 1D rue d'Itzig L-5852 HESPERANGE, est nommé en qualité de commissaire
aux comptes de la société à compter du 31 mars 2015, en remplacement de l'AUXILIAIRE DES P.M.E., RCSL B30.718,
sise 58 rue Glesener L-1630 LUXEMBOURG.
Son mandat prendra effet sur les comptes de l'exercice 2014 et se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra
en l'année 2018.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour MALT CAPITAL SA
i>Signature
Référence de publication: 2015049350/16.
(150056916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61521
L
U X E M B O U R G
Maghery Trade S.à.r.l. - SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 400.000,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, Avenue Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 193.178.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance tenue le 30 mars 2015i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-
bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.
Luxembourg, le 30 mars 2015.
Signature
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015049348/13.
(150057018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Marine International Operations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 76.762.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que le commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE SEVE S.A., inscrite sous le numéro RCS B 82421 et ayant
son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, a changé de dénomination en date du 14 juin 2013 et
porte désormais la dénomination FIDUSEVE S.A.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour MARINE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.i>
Référence de publication: 2015049351/15.
(150056514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Marmor und Granit International A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 64.960.
Die Konten am 31 Dezember 2013 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MARMOR UND GRANIT INTERNATIONAL A.G.
Référence de publication: 2015049352/10.
(150056782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Matteo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 87.110.
L'an deux mille quinze.
Le seize mars.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MATTEO S.A., établie et ayant son siège
social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 87.110,
constituée suivant un acte reçu le 23 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1061 du 11 juillet 2002,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maitre Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 27 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 1898 du 10 octobre 2006
61522
L
U X E M B O U R G
La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre HOFFMANN, expert comptable, avec
adresse professionnelle à Bofferdange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec
adresse professionnelle à Esch/Alzette.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse pro-
fessionnelle à Esch/Alzette.
Le Président expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les SEIZE MILLE
CINQ CENTS (16.500) ACTIONS d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, représentant l'intégralité
du capital social de CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 165.000,-), sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti
à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société;
2) Nomination des liquidateurs, Messieurs Jean-Louis JAMOTTON et Guy JAMOTTON
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateurs à deux (2).
Sont nommés liquidateurs:
- Monsieur Jean-Louis JAMOTTON, demeurant à B-7370 Dour, 17, rue Emile Estiévenart, et
- Monsieur Guy JAMOTTON, demeurant à B-7370 Dour, 12, rue Delval.
L'assemblée confère aux liquidateurs les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et
suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu'ils doivent recourir à une autorisation particulière de
l'assemblée générale.
Les liquidateurs sont dispensés de dresser inventaire et ils peuvent s'en référer aux écritures de la société.
Ils peuvent, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses
pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.
Ils sont spécialement autorisés à vendre de gré à gré tout l'actif immobilier de la société, d'encaisser le prix de vente
et de renoncer au privilège du vendeur et à l'action résolutoire.
Ils engagent la société moyennant leur signature individuelle.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Hoffmann, Conde, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 mars 2015. Relation: EAC/2015/6881. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015049356/59.
(150056743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Maxiflow Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 59.635.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2015i>
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2014:
1. La démission de Madame Catherine PIRLOT de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué avec date
d'effet au 1
er
septembre 2012. Elle ne sera pas remplacée.
2. La révocation de Monsieur Gilbert AMERYCKX de son poste d'administrateur. Il ne sera pas remplacé.
61523
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 27 mars 2015.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015049357/15.
(150056224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Meistor Beteiligungen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 89.914.
<i>Extrait de l'assemblée générale du 27 mars 2015i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la société, tenue à Luxembourg le 27 mars 2015, que les
résolutions suivantes ont été adoptées:
- L'assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Sylvain Elias de son mandat d'administrateur.
- L'assemblée décide de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Madame Léa Duval, née à Nancy
(France) le 20 juin 1990, résidant professionnellement au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg et ce, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle à tenir en 2021.
- L'assemblée décide de renouveler les mandats de Madame Véronique De Meester et de Monsieur Patrice Declerieux
à la fonction d'administrateur, et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2021.
- L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Patrice Declerieux à la fonction de commissaire aux
comptes, et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2015.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015049358/23.
(150056259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Mesotos SC, Société Civile.
Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg E 5.243.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des Résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2015i>
L'assemblée générale décide la dissolution de la société civile et prononce sa clôture de liquidation volontaire.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015049359/11.
(150056138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
New Dragon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 139.636.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-
bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Signature
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015049372/13.
(150057023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61524
L
U X E M B O U R G
Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 172.337.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 404 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049374/9.
(150056925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Na2O S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 160.888.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015049386/13.
(150057009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Operamba S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 183.093.
Par décision de l'administrateur unique du 24 mars 2015, Monsieur Alfred GUETTI, domicilié professionnellement au
8A, rue de Messancy, L-4962 CLEMENCY, a été coopté administrateur unique en remplacement de Monsieur Martin
RUTLEDGE, démissionnaire au 31 mars 2015.
Le mandat de l'administrateur unique s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2021.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour: OPERAMBA S.A. SPF
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015049409/16.
(150056443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Oval Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 177.538,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.833.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2015.
Référence de publication: 2015049412/10.
(150056354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
P.E.S.Y. GBP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 177.679.
Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
61525
L
U X E M B O U R G
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015049414/13.
(150056728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Paragem Assets S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 179.253.
<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 30 mars 2015i>
- Madame Kristine Vanaga-Mihailova, née à Riga, Lettonie, le 8 août 1979, demeurant professionnellement à 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a été nommée comme gérant A, avec effet au 30 mars 2015, pour une durée
indéterminée.
- Monsieur Nicolas Gasztonyi, né à Etterbeek (Belgium), le 11 août 1965, demeurant professionnellement à 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a démissionné de son mandat gérant A, avec effet au 30 mars 2015.
Luxembourg, le 31.03.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Paragem Assets S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015049418/17.
(150056680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Paris Nord S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 192.152.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049419/10.
(150056387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
C.F.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 64.719.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-
bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Signature
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015049037/13.
(150057025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Paris Nord S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 192.152.
In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of December,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
61526
L
U X E M B O U R G
Huakee Asset Management Pte Ltd, a private limited liability company incorporated and existing under the laws of the
Republic of Singapore, having its registered office at 9 Battery Road #15-01, Straits Trading Building, Singapore 049910
(“Sole Shareholder”),
represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue
Victor Hugo, pursuant to a proxy dated 23 December 2014, which proxy, initialled “ne varietur” by the appearing party
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The appearing party, acting in its capacity as Sole Shareholder of Paris Nord S.à r.l. has requested the undersigned
notary to document the following:
The appearing party is the Sole Shareholder of Paris Nord S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité
limiteé) incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 37A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855
Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, incorporated by a deed of the notary Martine Schaeffer, notary residing
in Luxembourg, on 7 November 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 12 December
2014 under number 3857 and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under
number B192152 (the 'Company'). The articles of incorporation have not been amended since.
The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions to
be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To increase the Company's subscribed capital by an amount of one Euro (EUR 1) and to issue one (1) new share,
with a nominal value of one Euro (EUR 1), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares
and entitlement to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on the proposed share
capital increase.
2. To accept the subscription of one (1) share with a nominal value of one Euro (EUR 1) by the Sole Shareholder and
to accept payment in full of this share by a contribution in kind (the ‘Contribution')
3. To authorise the attorney to state the abovementioned capital increase before a Luxembourg notary, inter alia to
amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company,
4. To authorise the attorney to record the capital increase in the share register of the Company and to accomplish
any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the Mémorial C, with power
to sign any documents, delegate under his own responsibility the present power of attorney to another representative,
consent to the above on behalf of the principal and, in general, do whatever seems appropriate or useful.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company's subscribed capital by an amount of one Euro (EUR 1) so as
to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into twelve thousand five
hundred (12,500) shares, each share with a nominal value of one Euro (EUR 1) to twelve thousand five hundred and one
Euro (EUR 12,501) divided into twelve thousand five hundred and one (12,501) shares, each share, with a nominal value
of one Euro (EUR 1) and to issue one (1) new share so as to raise the number of shares from twelve thousand five hundred
(12,500) shares to twelve thousand five hundred and one (12,501) shares, each share with a nominal value of one Euro
(EUR 1), having the same rights and privileges as those attached to the existing share and entitlement to dividends as from
the day of the decision of the Sole Shareholder resolving on the proposed capital increase.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon appeared Mister Gianpiero SADDI, prenamed, in his capacity as duly authorized attorney in fact of Huakee
Asset Management Pte Ltd. by virtue of the proxy referred to here above.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder for one (1) new share
so as to raise the number of shares from twelve thousand five hundred (12,500) shares to twelve thousand five hundred
and one (12,501) shares, each share with a nominal value of one Euro (EUR 1) and to accept payment in full of each of
these shares by the conversion into capital of a claim from the sole shareholder against Paris Nord S.à r.l. in the amount
of twenty-two million nine hundred and twenty thousand Euro (EUR 22.920.000,00) (the ‘Contribution in Kind').
The Sole Shareholder acknowledged the value of the Contribution in Kind as described in the report of the board of
managers of the Company dated 29 December 2014, which shall be annexed hereto to be registered with the deed. The
Sole Shareholder approved the valuation of the Contribution in Kind.
The Sole Shareholder acting through its duly authorized attorney in fact declared that there exists no impediment to
the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without any restriction or limitation and that valid
instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid
transfer of the Contribution in Kind to the Company.
Proof of the existence and the ownership of the Sole Shareholder of the Contribution in Kind have been given to the
undersigned notary.
61527
L
U X E M B O U R G
The Sole Shareholder resolved to allocate an amount equal to the nominal value of the new share to the share capital
accounts and an amount of twenty-two million nine hundred and nineteen thousand nine hundred and ninety-nine Euro
(EUR 22.919.999,00) to the share premium account of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company.
The first paragraph of article 5 of the articles of association shall now read as follows:
Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred and one Euro (EUR 12,501)
divided into twelve thousand five hundred and one (12,501) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to authorize any manager of the Company to record the capital increase in the share
register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies
Register and the Mémorial C with power to sign any documents, delegate under its own responsibility the present power
of attorney to another representative, consent to the above on behalf of the principal and, in general, do whatever seems
appropriate or useful.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document, are estimated at approximately six thousand eight hundred Euro (EUR 6,800.-).
The undersigned notary who understands English, states herewith that on request of the above appearing person the
present deed is worded in English followed by a German version, on request of the same person and in case of any
differences between the English and the German text, the English text will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Texts:
Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreissigsten Tag des Monats Dezember,
Vor der unterzeichnenden Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg,Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Huakee Asset Management Pte Ltd., eine gemäß der Gesetze von Singapur gegründete und bestehende Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit Sitz in 9 Battery Road #15-01, Straits Trading Building, Singapore 049910, („Alleiniger
Gesellschafter“);
vertreten durch Herrn Gianpiero SADDI, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-1750 Luxemburg, 74, avenue
Victor Hugo, durch unter Privatschrift gezeichnete Vollmacht vom 23 Dezember 2014, welche „ne varietur“ gezeichnet
gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit ihr einregistriert zu werden.
Der Erschienene, der im Namen des alleinigen Gesellschafters der Paris Nord S.à r.l. handelt, bittet die Notarin fol-
gendes festzuhalten:
Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter der Paris Nord S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), gegründet nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 37A, Avenue J.F. Ken-
nedy, L - 1855 Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 12,500.- am 7. November 2014 von Frau
Notarin Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxembourg,,veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions am 12.Dezember 2014 unter der Nummer 3857, und eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschafts-
register unter der Nummer B192152 (die ‚Gesellschaft‘). Die Satzung wurde noch nicht abgeändert.
Der Erschienene, vertreten wie oben erwähnt, gibt an, über die folgenden Beschlüsse der Agenda informiert zu sein:
<i>Agendai>
1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um ein Euro (EUR 1) durch Ausgabe von einem (1) neuen Anteil mit
einem Nennwert von einem Euro (EUR 1). Die Anteile haben dieselben Rechte und Privilegien wie die vorherigen Anteile
und sind ab dem Tag des Gesellschafterbeschlusses, der über die Kapitalerhöhung bestimmt, zur Dividende berechtigt.
2. Genehmigung der Zeichnung von einem (1) Anteil mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) durch den Alleinigen
Gesellschafter und die Genehmigung der Zahlung des Anteils durch Sacheinlage (die ‚Sacheinlage‘).
3. Beauftragung des Stellvertreters diese Kapitalerhöhung vor der Notarin zu beantragen und somit den ersten Para-
graph des Artikel 5 der Statuten der Gesellschaft zu ändern und
4. Beauftragung des Stellvertreters den Beschluss über die Kapitalerhöhung im Anteilsregister der Gesellschaft zu
dokumentieren, sowie alle notwendigen Formalitäten im Zusammenhang mit dem luxemburgischen Firmen- und Han-
delsregister und dem Mémorial C zu veranlassen. Die Vollmacht erstreckt sich auf die Unterzeichnung aller notwendigen
61528
L
U X E M B O U R G
Dokumente. Die Vollmacht kann eigenverantwortlich und im Sinne des oben genannten an Dritte weitergegeben werden,
im Allgemeinen ist die Bevollmächtigte zu jeder Handlung, die angemessen und hilfreich ist, bevollmächtigt.
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt das Stammkapital der Gesellschaft um ein Euro (EUR 1) von derzeitigen zwölf-
tausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile, mit einem Nennwert von
je einem Euro (EUR 1) auf zwölftausendfünfhundertundein Euro (EUR 12.501) unterteilt in zwölftausendfünfhundertund-
ein (12.501) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu erhöhen. Es wird ein (1) neuer Anteil ausgegeben,
was die derzeitige Anzahl der Anteile von zwölftausendfünfhundert (12.500) auf zwölftausendfünfhundertundein (12.501)
Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) erhöht. Die Anteile haben dieselben Rechte und Privilegien wie
die vorherigen Anteile und sind zur Dividende berechtigt ab dem Tag des Gesellschafterbeschlusses der über die Kapi-
talerhöhung bestimmt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Hier erschien Herrn Gianpiero SADDI, vorbenannt, in seiner Funktion als Bevollmächtigte der Huakee Asset Ma-
nagement Pte Ltd. bevollmächtigt wie oben beschrieben.
Der Erschienene gibt an im Namen und im Auftrag des Alleinigen Gesellschafter für einen (1) neuen Anteil zu zeichnen,
um die Anzahl der Anteile von zwölftausendfünfhundert (12.500) auf zwölftausendfünfhundertundeinen (12.501) Anteil
mit einem Nennwert von einen Euro (EUR 1) zu erhöhen. Die Zahlung der Anteile erfolgt durch Umwandlung eines
Anspruches des alleinigen Gesellschafters gegen die Paris Nord S.à r.l. auf Zahlung in Höhe von zweiundzwanzigmillio-
nenneunhundertzwanzigtausend Euro (EUR 22.920.000,00) in Gesellschaftskapital. (die ‚Sachkapitalerhöhung‘).
Der alleinige Gesellschafter nimmt den Wert der Sacheinlage, wie im Geschäftsführerreport vom 29. Dezember 2014
beschrieben, zur Kenntnis (der Report soll als Anhang zusammen mit der Urkunde einregistriert werden). Der Alleinige
Gesellschafter genehmigt die Bewertung der Sacheinlage.
Der Alleinige Gesellschafter erklärt, dass es keine Einschränkung hinsichtlich der freien Übertragbarkeit des Sachka-
pitals an die Gesellschaft besteht. Klare Anweisung zur Anmeldung, Registrierung und anderen notwendigen Formalitäten,
um die Sachkapitalerhöhung durchzuführen, wurden erteilt.
Dem Notar wurde bestätigt, dass das Sachkapital besteht und im Besitz des Alleinigen Gesellschafters ist.
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, einen Betrag in Höhe des Nennwerts des neuen Anteils dem Gesellschafts-
kapital und den Betrag von zweiundzwanzigmillionenneunhundertneunzehntausendneunhundertneunundneunzig Euro
(EUR 22.919.999,00) dem Share Premium Account zuzuführen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt den ersten Paragraph des 5. Artikels der Satzung der Gesellschaft zu ändern.
Der erste Paragraph des 5. Artikels der Satzung soll wie folgt lauten:
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundertundeinen Euro (EUR 12.501) geteilt in
zwölftausendfünfhundertundeinen (12.501) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1).
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen jeden Geschäftsführer der Gesellschaft zu bevollmächtigen die Kapital-
erhöhung im Anteilsregister der Gesellschaft zu dokumentieren, sowie alle notwendigen Formalitäten im Zusammenhang
mit dem luxemburgischen Firmen- und Handelsregister und dem Mémorial C zu veranlassen. Die Vollmacht erstreckt
sich auf die Unterzeichnung aller notwendigen Dokumente. Die Vollmacht kann eigenverantwortlich und im Sinne des
oben genannten an Dritte weitergegeben werden, im Allgemeinen ist die Bevollmächtigte zu jeder Handlung, die ange-
messen und hilfreich ist, bevollmächtigt.
<i>Kosteni>
Sämtlich Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren, welche der Gesellschaft erwachsen, werden auf sechstau-
sendachthundert Euro (EUR 6.800.-) geschätzt.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber die vorliegende notarielle Urkunde in Luxembourg ausgestellt wurde, an dem zu Beginn des Dokumentes
aufgeführten Tag.
Nachdem das Dokument der erschienen Person vorgelegt wurde, hat die Bevollmächtigte das vorliegende Protokoll
zusammen mit der Notarin unterzeichnet.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
61529
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 8 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/599. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049420/177.
(150056388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
IsatyLux, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 35, rue de l'hippodrome.
R.C.S. Luxembourg B 195.744.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le douze mars.
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
1. Monsieur Thierry Mahé, employé, né le 27 mai 1966 à Saint-Helier (Royaume-Uni), demeurant au 35, rue de l'hip-
podrome, L-1730 Luxembourg;
2. Madame Isabelle Dubois, employée de banque, née le 4 juin 1963 à Turin (Italie), demeurant au 35, rue de l'hippo-
drome, L-1730 Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent con-
stituer pour leur propre compte et entre tous ceux qui en viendront associés par la suite et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaire actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y
relatives ainsi que par les présents statuts.
La société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite
notamment, de cession de parts sociales ou d'émission de parts sociales nouvelles.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un snack, le commerce de sandwichs et de boissons chaudes ou froides,
ainsi que les services de restauration à emporter ou à consommer sur place.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature
à en faciliter l'extension ou le développement.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,
des transactions commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de «IsatyLux, S.à r.l.»
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La
société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital émis de la Société est fixé à la somme de 50.000 Euros (cinquante mille euros), divisé en 50.000
(cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 Euro (un euro) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinquante mille Euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
61530
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif
social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
Titre II. Administration - Assemblée Générale
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés
par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.
A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ayant reçu l'autorisation d'établissement ont vis-
à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir sous leur signature individuelle au nom de la société dans toutes les
circonstances.
En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront
responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se
faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception
du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille quinze.
Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes
sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts ainsi arrêtés, les comparants ont souscrit toutes les 50.000 (cinquante mille) parts sociales comme suit:
1.- Monsieur Thierry Mahé, préqualifié, vingt-cinq mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
2.- Madame Isabelle Dubois, préqualifiée, vingt-cinq mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
Total: cinquante mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de
50.000 Euros (cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été
donnée au notaire instrumentant.
61531
L
U X E M B O U R G
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18
septembre 1933) se trouvent remplies.
<i>Evaluation des Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
<i>Résolutions des associési>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de fixer à un (1) le nombre de gérants.
Est nommé en qualité de gérant unique, Monsieur Thierry Mahé, employé, né le 27 mai 1966 à Saint-Helier (Royaume-
Uni), demeurant au 35, rue de l'hippodrome, L-1730 Luxembourg.
Le mandat de gérant unique est établi pour une durée indéterminée.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la Société est établi au 35, rue de l'hippodrome, L-1730 Luxembourg.
Dont acte, fait passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ils ont signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: T. MAHE, I. DUBOIS, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7915. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015049244/122.
(150056467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
ATHRIS WIND (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 167.792.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015048983/9.
(150056348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Adventive, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 195.739.
STATUTS
L'an deux mille quinze,
le vingt-trois mars.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
ont comparu:
1) Monsieur Thierry Ducros de Saint Germain, dirigeant de sociétés, né à Saint Quentin (France), le 15 février 1951,
demeurant au 4, rue Charles IV, L-1309 Luxembourg,
ici représenté par:
Monsieur Philippe Loux, avocat, avec résidence professionnelle au 19- 25, rue des Capucins L-2012 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 19 mars 2015, et
61532
L
U X E M B O U R G
2) Madame Fiona Ducros de Saint Germain, épouse de Thierry Ducros, née à Leeds (Royaume-Uni), le 04 mai 1955,
demeurant au 4, rue Charles IV, L-1309 Luxembourg,
ici représentée par:
Monsieur Philippe Loux, prénommé,
en vertu d'une procuration sous privé lui donnée à Luxembourg, le 19 mars 2015,
Lesquelles procurations, signées «ne varietur» par le mandataire des personnes comparantes et le notaire instrumen-
taire, resteront annexées au présent acte aux fins de formalisation.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée que les personnes prénommées déclarent constituer entre elles:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux
qui pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par
l'article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Objet. Elle a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
Elle peut acquérir, gérer, mettre en valeur et aliéner des brevets, droits de brevets, marques, marques déposées,
licences et autres droits de la propriété intellectuelle.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera
utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «Adventive», société à responsabilité limitée.
Art. 4. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée
générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés.
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12'500.- EUR) divisé en cent
vingt-cinq (125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, celles-ci étant entièrement
libérées.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision de
l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachées aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
61533
L
U X E M B O U R G
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d'un associé unique, ledit associé unique peut librement céder
ses parts.
Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément
donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou
acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événe-
ment similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Les gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un
gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'adminis-
tration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à
condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société
en justice soit en demandant soit en défendant.
Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou
temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).
Art. 15. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 16. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.
Art. 17. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique
ou en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe ou la signature
individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seulement dans les
limites de ce pouvoir.
Art. 18. Assemblée générale des associés. Lorsque la société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les
pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi
du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par
vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 19. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, seront établies
par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés,
ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.
Art. 20. Année sociale. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre
de la même année.
61534
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la
société et un bilan résumant cet inventaire.
Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication
desdits inventaire et bilan.
Art. 22. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des
frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.
Art. 23. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 24. Disposition générale. Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents statuts seraient régies
conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les personnes comparantes ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre de parts sociales et
ont libéré en numéraire les montants ci-après énoncés:
Associés
Capital
souscrit
(EUR)
Nombre
de parts
sociales
Libération
(EUR)
M. Thierry Ducros de Saint Germain, prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9'400.-
94
9'400.-
Mme Fiona Ducros de Saint Germain, prénommée; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3'100.-
31
3'100.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'500.-
125
12'500.-
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.
<i>Evaluations des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de fixer à deux (2) le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que
Gérants de la Société pour une période indéterminée, avec les pouvoirs prévus à l'article QUATORZE (14) des statuts
de la Société:
1) Monsieur Thierry Ducros de Saint Germain, dirigeant de sociétés, né à Saint Quentin (France), le 15 février 1951,
demeurant au 4, rue Charles IV, L-1309 Luxembourg; et
2) Madame Fiona Ducros de Saint Germain, épouse de Thierry Ducros, née à Leeds (Royaume-Uni), le 04 mai 1955,
demeurant au 4, rue Charles IV, L-1309 Luxembourg.
En conformité avec l'article DIX-SEPT (17) des statuts de la Société, cette dernière sera valablement engagée vis-à-vis
des tiers par la signature conjointe des deux (2) gérants.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est fixé au 68, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes connu du notaire
instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le même mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. LOUX, J.J. WAGNER.
61535
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 mars 2015. Relation: EAC/2015/6872. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015048941/175.
(150056435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Captainjet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 195.247.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 17 mars 2015i>
L'Assemblée prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer Mme Anne-Céline ROUX, née le 17 juin 1983 à Bron (France), demeurant
professionnellement au 10A, rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie B.
Le nouvel administrateur est nommé pour une période de 6 (six) ans et son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de l'exercice 2020.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer Mme Nathalie VAZQUEZ, née le 11 mai 1983 à Metz (France), demeurant
professionnellement au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie B.
Le nouvel administrateur est nommé pour une période de 6 (six) ans et son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de l'exercice 2020.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de délégué la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société
en ce qui concerne cette gestion à Mme Anne-Céline ROUX, pour la période couvrant son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de requalifier la fonction de Mr. Philippe TOUSSAINT, anciennement administrateur
unique, administrateur de catégorie A jusqu'à la fin de son mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire
de l'exercice 2020.
Référence de publication: 2015049041/26.
(150056362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Ceria S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 176.483.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 30 mars 2015.
Référence de publication: 2015049074/10.
(150056269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Bock Capital Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 128.538.
Les statuts coordonnés au 13/02/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30/03/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015048995/12.
(150056824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
61536
Adventive
ATHRIS WIND (Luxembourg) S.A.
Bock Capital Investors S.à r.l.
Captainjet S.A.
Ceria S.A.
C.F.F. S.A.
IsatyLux, S.à.r.l.
Lamudi Global S.à r.l.
Lands Improvement Holdings Poole S.à r.l.
Logic S.A.
Logic S.A.
Lutos
Maghery Trade S.à.r.l. - SPF
Malt Capital SA
Marine International Operations S.A.
Maris S.à r.l.
Marmor und Granit International A.G.
Marsaco S.à r.l.
Matteo S.A.
Maxiflow Consulting S.A.
McGraw Hill Financial European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
McGraw Hill Financial Global Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
McGraw Hill Financial (Luxembourg) S.à r.l.
Meistor Beteiligungen S.A.
«Mercury Investment Company S.à r.l.»
Meridiam Infrastructure Germany S.à r.l.
Meridiam Infrastructure Germany S.à r.l.
Meridian Holding S.à r.l.
Mesotos SC
Milano Properties and Investments S.A.
Mirko S.à r.l.
Mont Cervin S.à r.l.
Morgan Stanley Curtiss Investments S.à r.l.
Morgan Stanley Morane Investments S.à r.l.
Morgan Stanley Spad Investments S.à r.l.
Na2O S.A.
New Dragon S.A.
Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l.
Operamba S.A. SPF
Oval Holdings S.à r.l.
Paragem Assets S.à r.l.
Paris Nord S.à r.l.
Paris Nord S.à r.l.
P.E.S.Y. GBP S.à r.l.