This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1281
18 mai 2015
SOMMAIRE
Artbo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61468
Babcock & Brown European Investments
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61469
Baliste Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . .
61470
BERTOPHE Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61470
Beverage Packaging Factoring (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61469
Bini Electricité Maintenance S.à r.l. . . . . . .
61469
Bonito Luxembourg Holdings S. à r.l. . . . .
61470
BR Craven JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61471
Consultants des Beaux Arts S.A. . . . . . . . .
61471
Helpling Group Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .
61442
IK Investment Partners VII B S.à r.l. . . . . .
61472
Immocalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61471
Index Ventures IV Investors (Alpha) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61472
Interarrow S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61472
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61473
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61473
In Vino Veritas Consulting S.àr.l. . . . . . . . .
61472
JAB Holding Company s.à.r.l. . . . . . . . . . . .
61473
Jimlux Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61473
Jovest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61474
Jovest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61474
Jugendstil SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61474
JV Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61475
Kaolin S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61483
Karmon S.à r.l. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61482
Keasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61483
Kerdi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61483
KG Far East (Luxembourg) Sàrl . . . . . . . . .
61484
KG Participações S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
61484
Kipp-Trans S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61482
Klee S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61484
KMM Investments Holding, S.à r.l. . . . . . . .
61484
Kohlenberg & Ruppert Premium Proper-
ties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61482
Konkret S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61485
Konkret S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61485
KPI Investment Property 59 S.à r.l. . . . . . .
61486
KPI Residential Property 14 S.à r.l. . . . . . .
61486
KPI Retail Property 39 S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
61487
KPI Retail Property 40 S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
61487
KPMG Pension Scheme, Sepcav . . . . . . . . .
61487
Marona Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61488
QIAGEN EURO Finance (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61487
61441
L
U X E M B O U R G
Helpling Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 184.677.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of February,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet AG (formerly Rocket Internet GmbH), a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the
laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at
the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of ten thousand (10,000) common shares of the Company and one thousand five hundred eighty-
seven (1,587) series B1 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-
chränkt)) existing under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial
register at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under number HRB 126893 B,
having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of two thousand five hundred (2,500) common shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
3. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands with its registered
office in Schiphol, the Netherlands, registered with the commercial register of the Dutch Trade Register, under no.
60628022, having its business address at Schiphol Boulevard 127, 1118 BG Schiphol, the Netherlands,
being the holder of four hundred seventeen (417) series A1 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 176.544, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, and having a share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000),
being the holder of one thousand two hundred fifty (1,250) series A1 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 26
th
2015;
5. JP Ventures UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt))
existing under the laws of Germany with its statutory seat in Wehingen, Germany, registered with the commercial register
(Handelsregister) at the local court of Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart), Germany, under no. HRB 733673, having its
business address at Gosheimer Straße 48, 78564 Wehingen, Germany,
being the holder of forty-two (42) series A1 shares of the Company and ten (10) series B1 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 25
th
2015;
6. Kaltroco Limited, a company incorporated in Jersey with registered number 60595, having its business address at
Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3AS,
being the holder of two thousand five hundred (2,500) series A2 shares of the Company and three hundred eighteen
(318) series B1 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
7. Phenomen Ventures LP, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, registration number OG -
66003, having its registered office at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands,
being the holder of two thousand eighty-four (2,084) series A3 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
8. Mangrove IV Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce
61442
L
U X E M B O U R G
et des Sociétés) under number B 189.521, having its registered office at 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg,
being the holder of three thousand three hundred thirty-four (3,334) series A4 shares of the Company and five hundred
thirty (530) series B1 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
9. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda with its statutory
seat in Hamilton, Bermuda, having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11,
being the holder of four hundred seventeen (417) series A5 shares of the Company and ninety-five (95) series B1
shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
10. David W. Zalaznick, born on 16 April 1954, resident at 9 West 57
th
Street - 33
rd
Floor, New York, NY 10019,
United States of America,
being the holder of four hundred seventeen (417) series A5 shares of the Company and becoming the holder of ninety-
five (95) newly created series B2 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
11. Luktev GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of Germany with
its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of
Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 119212 B, having its business address at Moh-
renstrasse 60, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of four hundred seventeen (417) series A5 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
12. Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws of
Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local
court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRA 45915 B, having its business address
at Jägerstraße 65, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of three hundred eighty-one (381) series A5 shares of the Company and eighty-seven (87) series B1
shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
13. Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws of Germany
with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court
of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRA 45911 B, having its business address at
Jägerstraße 65, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of thirty-six (36) series A5 shares of the Company and seven (7) series B1 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
14. L'Arche B.V., a private company with limited liability (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
under the laws of the Netherlands, registered with the Dutch trade register of the Chambers of Commerce, under no.
59430982, having its business address at Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam, the Netherlands,
being the holder of one thousand five hundred eighty-seven (1,587) series B1 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
15. Mercura Capital GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of
Germany with its statutory seat in Starnberg, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Munich (Amtsgericht München) under no. HRB 200948, having its business address at Schießstättstraße 22,
82319 Starnberg, Germany,
being the holder of seven hundred ninety-four (794) series B1 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 25
th
2015;
16. SHCO 57 S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg with its statutory seat in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
61443
L
U X E M B O U R G
Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B183.425, having its registered
office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Grand Duchy of Luxembourg,
being the holder of four hundred seventy-six (476) series B1 shares of the Company, here represented by Julien De
Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on February 25
th
2015;
17.Team Europe Venture Ltd., a limited liability company under the laws of England and Wales with its statutory seat
at 69 Great Hampton Street, Birmingham, B18 6EW, United Kingdom, registered with the Companies House Cardiff
under no. 05831082, with a branch office (Zweigniederlassung) at Mohrenstraße 60, 10117 Berlin, Germany, registered
with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Ger-
many, under no. HRB 115038 B, participating and voting only for purposes of agenda points 4 et seqq,
becoming the holder of one thousand five hundred eighty-seven (1,587) newly created series B2 shares of the Company,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given on February 24
th
2015;
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. and 16. (the “Existing Shareholders”) are all the
shareholders of Helpling Group Holding S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de
Commerce et des Sociétés) under number B 184.677 and incorporated pursuant to a deed of the notary Henri Hellinckx,
residing in Luxembourg, on 7 February 2014, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1074 dated 28 April 2014. The articles of association were last amended pursuant to a deed of Maître Cosita Delvaux
on 30 January 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement, and the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the party 17.
(the “New Investor”) participates and votes for the purpose of agenda points 4 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Decision to create one (1) new series of shares in the share capital of the Company, namely the series B2 shares,
so that the Company will hence have eight (8) series of shares, being the common shares (hereinafter the “Common
Shares”), the series A1 shares (hereinafter the “Series A1 Shares”), the series A2 shares (hereinafter the “Series A2
Shares”), the series A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”), the series A4 shares (hereinafter the “Series A4
Shares”), the series A5 shares (hereinafter the “Series A5 Shares”), the series B1 shares (hereinafter the “Series B1
Shares”) and the series B2 shares (hereinafter the “Series B2 Shares”).
2. Acceptance of Team Europe Ventures Ltd., aforementioned, as new shareholder of the Company.
3. Increase of the Company's share capital by an amount of one thousand six hundred eighty-two euros (EUR 1,682)
so as to raise it from its current amount of twenty-nine thousand two hundred eighty-six euros (EUR 29,286) up to thirty
thousand nine hundred sixty-eight euros (EUR 30,968) by issuing one thousand six hundred eighty-two (1,682) Series B2
Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
4. Restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the capital increase as per the third
resolution as well as to reflect several amendments to the articles of association following the entry into the capital of
the Company by the New Investor.
5. Miscellaneous.
The general meeting of shareholders acknowledges that, for the purposes of the above agenda, all Existing Shareholders
have unanimously waived the investors' consent requirement for the amendment of the articles of association of the
Company set forth by article 16 of the articles of association of the Company and any preferential subscription right they
may have according to article 5.3 of the articles of association of the Company.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create one (1) new series of shares in the share capital of the Company,
namely the Series B2 Shares, so that the Company will hence have eight (8) series of shares, being the Common Shares,
the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 Shares, the Series A4 Shares, the Series A5 Shares, the Series
B1 Shares and the Series B2 Shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to accept Team Europe Ventures Ltd., aforementioned, as new share-
holder of the Company.
61444
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one
thousand six hundred eighty-two euros (EUR 1,682) so as to raise it from its current amount of twenty-nine thousand
two hundred eighty-six euros (EUR 29,286) up to thirty thousand nine hundred sixty-eight euros (EUR 30,968) by issuing
one thousand six hundred eighty-two (1,682) Series B2 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The one thousand six hundred eighty-two (1,682) Series B2 Shares have been duly subscribed as follows:
- ninety-five (95) Series B2 Shares have been duly subscribed by Mr. David W. Zala-znick, aforementioned, represented
by Mr Julien De Mayer, as stated here above;
- one thousand five hundred eighty-seven (1,587) Series B2 Shares have been duly subscribed by Team Europe Ventures
Ltd., aforementioned, represented by Mr Julien De Mayer, as stated here above.
<i>Paymenti>
The one thousand six hundred eighty-two (1,682) Series B2 Shares have been entirely paid up as follows:
- the ninety-five (95) Series B2 Shares subscribed by Mr. David W. Zalaznick, aforementioned, have been entirely paid
up through a contribution in cash in an amount of ninety-five euros (EUR 95);
- the one thousand five hundred eighty-seven (1,587) Series B2 Shares subscribed by Team Europe Ventures Ltd.,
aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand five hundred
eighty-seven euros (EUR 1,587).
The proof of the existence and of the value of the above contributions has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of one thousand six hundred eighty-two euros (EUR 1,682) is entirely allocated to
the share capital.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to proceed to a complete restatement of the articles of association of
the Company in order to reflect the capital increase as per the third resolution as well as to reflect several amendments
to the articles of association following the entry into the capital of the Company by the New Investors.
The articles of association of the Company shall henceforth read as follows:
“
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Helpling Group
Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
61445
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty thousand nine hundred sixty-eight euros (EUR 30,968.00), represented
by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), each with a nominal
value of one euro (EUR 1.00),
5.1.2 one thousand seven hundred nine (1,709) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), each with a nominal
value of one euro (EUR 1.00),
5.1.3 two thousand five hundred (2,500) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”), each with a nominal value
of one euro (EUR 1.00),
5.1.4 two thousand eighty-four (2,084) series A3 shares (hereinafter “Series A3 Shares”), each with a nominal value
of one euro (EUR 1.00),
5.1.5 three thousand three hundred thirty-four (3,334) series A4 shares (hereinafter “Series A4 Shares”), each with a
nominal value of one euro (EUR 1.00),
5.1.6 one thousand six hundred sixty-eight (1,668) series A5 shares (hereinafter “Series A5 Shares”), each with a
nominal value of one euro (EUR 1.00), and jointly with the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 shares
and the Series A4 Shares the “Series A Shares”,
5.1.7 five thousand four hundred ninety-one (5,491) series B1 shares (hereinafter “Series B1 Shares”), each with a
nominal value of one euro (EUR 1.00), and
5.1.8 one thousand six hundred eighty-two (1,682) series B2 shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.00)
(hereinafter “Series B2 Shares”, the Series B1 Shares and the Series B2 Shares hereinafter also referred to as the “Series
B Shares”; the Series A Shares and the Series B Shares hereinafter jointly referred to as the “Preferred Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association, any shareholders' agreement or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of the shareholders Rocket Internet AG (“Rocket”), Netris B.V. (“Eiffel”), Aismare Lux Holdings S.à r.l.
(“Aismare”), JP Ventures UG (haftungsbeschränkt) (“JP”), Kaltroco Limited (“Kaltroco”), Phenomen Ventures LP (“Phe-
nomen”), Mangrove IV Investments S.à r.l. (“Mangrove”), TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”), David W.
Zalaznick (“DZ”), Luktev GmbH (“Luktev”), Team Europe Ventures Ltd. (“Team Europe Ventures”, jointly with Luktev
“Team Europe”), Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG (“Point Nine Capital”), Point Nine Co-Invest II GmbH &
Co. KG (“Point Nine Co-Invest”, jointly with Point Nine Capital “Point Nine”), L’Arche B.V. (“L’Arche”), SHCO 57 S.à
r.l. (“SHCO”) and Mercura Capital GmbH (“Mercura”; Mercura jointly with Rocket, Eiffel, Aismare, Kaltroco, Phenomen,
Mangrove, TJT, DZ, Team Europe, Point Nine, L’Arche and SHCO the “Investors” and each also an “Investor”) shall be
entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an
investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning
of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)) (a “Third Party Investor”) which has been approved with
an Advisory Board Majority (as defined in Article 25.5 below) (such investment being a “Third Party Investment”) –
irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders – required to maintain up
to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which
the Third Party Investment is based on. The respective Investor or other entitled shareholder pursuant to this Article
5.3 shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks whether it intends to exercise its right pursuant
to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors or
other shareholders (or a company affiliated to an Investor or other shareholder within the meaning of sections 15 et
seqq. German Stock Corporation Act (AktG)) subscribe for further shares.
61446
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders, subject to the provisions of any shareholders' agreement
between the shareholders of the Company, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-
along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders of the Company.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by a majority vote of seventy five per cent (75%) of the votes of all shareholders of the Company (such majority being a
“Super Majority”) and subject to the provisions of any shareholders’ agreement between the shareholders of the Com-
pany, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights contained
in any shareholders’ agreement between the shareholders of the Company. To the extent that such approval has been
granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a Transfer (as defined in Article 8.1 below) or any other disposal of shares by any Investor to a
company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a Transfer or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is directly or indirectly
Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct or indirect
shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Controlled” or “Con-
trolling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing
shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a contractual voting
pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies of a person,
whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one or more
shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a Transfer or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under the simplified employee
participation agreed upon between the shareholders of the Company in a shareholders' agreement, if any or (ii) to the
Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme implemented pursuant to such simplified
employee participation;
7.4.4 in case of any Transfer or any other disposal of shares within the framework of transformation procedures
pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company, if the
shareholders of the Company hold more than fifty per cent (50%) in any surviving legal entity after such transformation
procedure.
7.5 In the cases provided for in Articles 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights
of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any Transfer or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third parties through
the notification of the Transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the Transfer, assignment
or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any Transfer of at least fifty per cent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of
the Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to
one another, or (ii) Transfer of at least 50% of the Company's Assets or business of the Company, in a single or more
related transactions or (iii) Transfer of a material part of the Company's Intellectual Property Rights in a single or more
related transactions or (iv) of the liquidation or de facto liquidation of the Company (in particular following an asset deal)
61447
L
U X E M B O U R G
or (v) of any sale or Transfer of shares in the Company either to third parties or other shareholders that would result
in either more than fifty per cent (50%) of the registered share capital or more than fifty per cent (50%) of the voting
rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each
of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”)
- subject to Article 8.2 below - will be distributed in accordance with Article 8.3 to the shareholders pro rata to (i) in
case of an asset Trans-fer, their shareholding in the registered share capital of the Company or (ii) in case of a share
Transfer, the number of shares sold in the Liquidity Event (as applicable).
“Transfer” means, with respect to any asset (including without limitation, shares and Intellectual Property Rights), any
transfer, assignment, sale, pledge, hypothecation, Encumbrance or other disposition of that asset or of any rights or
obligations associated with that asset, whether voluntary or involuntary, including an option to do any of the forgoing.
“Encumbrance”/“Encumbered” means any encumbrance whatsoever, including a mortgage, charge, debenture, pledge,
hypothecation, lien, security interest, title retention, option, right to acquire or purchase, restriction upon sale or transfer,
right of first refusal, right of pre-emption, third party right or interest, claims, trust arrangement, agreement to confer
security, other encumbrance or security interest of any kind or other type of preferential arrangement or any equity or
other restriction or limitation of any nature whatsoever (including, without limitation, a title transfer or retention ar-
rangement, any preliminary agreement or other arrangement to create any of the above) having similar effect.
8.2 On a first preferred level (“First Preferred Level”), each holder of Series B Shares shall receive an amount equal
to its respective total investment made to acquire its respective Series B Shares held by it (consisting of the nominal
amount of the Series B Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account
115) paid by the respective holder to the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on
the First Preferred Level, the Exit Proceeds shall be allocated to each holder of Series B Shares pro rata to the amounts
that would have been allocated to that holder on the First Preferred Level if the Exit Proceeds had been sufficient.
8.3 On a second preferred level (“Second Preferred Level”), each holder of Series A Shares shall receive an amount
equal to its respective investment made to acquire its respective Series A Shares held by it (i.e. the respective series A
nominal amount and the respective series A additional payment). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to
be made on the Second Preferred Level, the Exit Proceeds shall be allocated to each holder of Series A Shares pro rata
to the amounts that would have been allocated to that holder on the Second Preferred Level if the Exit Proceeds had
been sufficient.
8.4 After the payments on the First Preferred Level and the Second Preferred Level have been made, the remaining
Exit Proceeds shall be allocated on a common level (“Common Level”) to all selling shareholders pro rata to the respective
shares disposed of in connection with the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on a Preferred Level
shall reduce the amount to be allocated to such shareholder on the Common Level; provided that no shareholder shall
be obliged to repay any amount received on the First Preferred Level and/or the Second Preferred Level. Any Exit
Proceeds remaining unallocated after allocation under this Article 8.4 shall also be allocated in accordance with this Article
8.4 by applying Article 8.4 repeatedly until all Exit Proceeds have been allocated to the shareholders. Irrespective of
whether or not the sale of shares is made in one or more transactions, no shareholder shall receive for the sale of all of
its shares (and repay any exceeding amount to the other shareholder) an amount exceeding the higher of (i) its share in
the total Exit Proceeds pro rata to the Shares sold or (ii) the amount of its investment in the Company (payment of
purchase price for shelf company, payment of share capital, including premium, if any, and payments into account 115 of
the standard chart of accountants “apport en capitaux propres non rémunérés par des titres” under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg (additional amounts)) in respect of the shares sold. If shares in the Company are sold in more than
one transaction, no shareholder shall receive less proceeds than it would have received if the shares in the Company
were sold in one transaction.
8.5 The preferred allocation on the First Preferred Level and the Second Preferred Level applies for the benefit of the
respective shareholder so long as the respective shareholder (including any sales prior to a Liquidity Event) has not yet
received the full amount that is to be allocated to such shareholder according to the First Preferred Level and/or the
Second Preferred Level.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings
is rejected for lack of assets;
9.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
61448
L
U X E M B O U R G
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective
date is the date before the redemption resolution.
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable compensation for redemption, such compensation is
to be determined by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement
is reached, the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a
shareholder or of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion
shall be borne by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall
be set off with the compensation for redemption and the compensation for redemption shall be reduced accordingly.
The shareholder shall bear the remaining costs in case the compensation for redemption does not cover the costs
allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence, the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
61449
L
U X E M B O U R G
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.
Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company' s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If there is no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in
compliance with Article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital
represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of
the votes cast.
Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous
consent.
Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority, provided that it includes the consent
of all of the Investors. Any amendment of these articles of association that materially or adversely affects the rights of
the holders of Preferred Shares require the consent of all of the holders of those Preferred Shares.
Art. 17 Shareholders' Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and require the
consent of the Advisory Board:
17.1.1 conclusion, amendment and termination of intra-group affiliation agreements (Unternehmensverträge within
the meaning of sections 291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG));
17.1.2 conclusion or amendment of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal
of shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a
participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does
not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a
prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of
business, e.g. agreements between the Company and advertising partners.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the consent of
all of the Investors:
17.2.1 material changes to the business object of the Company or any material modification of the fields of business
of the Company or the termination of existing and commencement of new fields of business;
17.2.2 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.3 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and
transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association;
17.2.4 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company;
17.2.5 merger, separation and transformation of the Company.
61450
L
U X E M B O U R G
17.3. Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares, the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.
D. Board of managers
Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company' s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by
the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event, however, the general meeting of shareholders has appointed different
61451
L
U X E M B O U R G
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
22.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board for the legal transactions and measures specified
below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance
been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:
22.8.1 approval of the annual plan including the budget plan for each following year;
22.8.2 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros
(EUR 200,000.00) in the individual case;
22.8.3 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
22.8.4 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.5 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
22.8.6 institution and termination of legal disputes, including arbitration proceedings, involving a judicial amount in
controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;
22.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals;
22.8.8 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party outside the
ordinary course of business;
22.8.9 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such
profits to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;
22.8.10 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)
other than the establishment of any simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the
Company in a shareholders' agreement, if any.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Co m-pany will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company has set up an advisory board (the “Advisory Board”). It consists of nine (9) voting members, each
having the number of votes as set forth in this Article 25. The shareholders may by way of unanimous shareholders'
61452
L
U X E M B O U R G
consent increase or decrease (i) the number of voting members of the Advisory Board and/or (ii) the number of the
respective votes.
25.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of unanimous
shareholders' consent.
25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member' s
respective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
25.3.1 two (2) voting members of the Advisory Board, one having three (3) votes and the other having two (2) votes,
shall be nominated by the Investor Rocket (“Rocket Members”) in its sole discretion;
25.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Aismare
(“Aismare Member”) in its sole discretion;
25.3.3 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Phenomen
(“Phenomen Member”) in its sole discretion;
25.3.4 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Mangrove
(“Mangrove Member”) in its sole discretion;
25.3.5 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor L’Arche
(“L’Arche Member”) in its sole discretion;
25.3.6 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor SHCO
(“SHCO Member”) in its sole discretion;
25.3.7 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Mercura
(“Mercura Member”) in its sole discretion; and
25.3.8 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the Investor Team
Europe (“Team Europe Member”) in its sole discretion.
25.4 Each Investor other than those entitled to appoint a voting member of the Advisory Board pursuant to Article
25.3 shall be entitled to appoint a non-voting member to the Advisory Board as an observer.
25.5 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman yet none of them shall have a casting vote and/
or any additional right and/or authority differing from the other members of the Advisory Board. One of the Rocket
Members shall be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board may provide for
further provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. Subject to any consents or approvals
otherwise required under these Articles and/or any shareholders' agreement with respect to the Company, if any, the
Advisory Board shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast (the “Advisory Board Majority”). In addition,
for certain measures required under a shareholders’ agreement with respect to the Company, the Advisory Board shall
adopt resolutions with the simple majority of votes cast, provided that it includes the affirmative vote of three (3) out of
the Aismare Member and/or the Phenomen Member and/or the Mangrove Member and/or the L’Arche Member and/or
the SHCO Member and/or the Mercura Member and/or the Team Europe Member and/or any further member of the
Advisory Board nominated after the date hereof (the “Qualified Advisory Board Majority”). The Advisory Board shall
hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.
25.6 In addition to any consents or approvals otherwise required under these Articles and/or any shareholders' agree-
ment with respect to the Company, if any, the Advisory Board has a consultative function and will not interfere in the
management of the Company.
25.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
E. Audit and supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
ac-counting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
61453
L
U X E M B O U R G
Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be r educed in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company' s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they
hold in the Company.
Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable - in accordance with the provisions of Article 8 - and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders' agreement with respect to the Company which may be entered into from time to time between the
shareholders and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter con-
tained in these articles conflicts with the provisions of any shareholders' agreement with respect to the Company, such
shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.
31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.“
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 2,200.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebenundzwanzigsten Februar,
vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg:
SIND ERSCHIENEN:
61454
L
U X E M B O U R G
1. Rocket Internet AG (vormals Rocket Internet GmbH), eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht
mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg,
Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaber von zehntausend (10.000) Stammanteilen der Gesellschaft und eintausendfünfhundertsiebenundachtzig (1.587)
Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter
deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaber von zweitausendfünfhundert (2.500) Stammanteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
3. Netris B.V., eine Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, mit Sitz in Schiphol,
Niederlande, eingetragen im Handelsregister des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz
in Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, Niederlande,
Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société a responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000),
Inhaber von eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie A1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
26. Februar 2015;
5. JP Ventures UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter deutsch-
em Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Wehingen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Stuttgart, Deutschland, unter der Nummer HRB 733673, mit Geschäftssitz in Gosheimer Straße 48, 78564 Wehingen,
Deutschland,
Inhaber von zweiundvierzig (42) Anteilen der Serie A1 der Gesellschaft und zehn (10) Anteilen der Serie B1 der
Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
25. Februar 2015;
6. Kaltroco Limited, eine Gesellschaft gegründet in Jersey, eingetragen unter der Nummer 60595, mit Geschäftssitz in
Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3AS,
Inhaber von zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A2 der Gesellschaft und dreihundertachtzehn (318)
Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
7. Phenomen Ventures LP, eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht der Kaimaninseln, Eintragungsnummer OG -
66003, mit Sitz in 89, Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Kaimaninseln,
Inhaber von zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteilen der Serie A3 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
8. Mangrove IV Investments S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société a responsabilité limitée),
gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 189.521, mit Sitz in 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg,
Inhaber von dreitausenddreihundertvierunddreißig (3.334) Anteilen der Serie A4 der Gesellschaft und fünfhundertd-
reißig (530) Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
9. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft nach dem Recht der Bermuda-Inseln mit satzungs-
mäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda-Inseln, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda-
Inseln HM11,
Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A5 der Gesellschaft und fünfundneunzig (95) Anteilen der
Serie B1 der Gesellschaft,
61455
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
10. David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954, ansässig in 9 West 57
th
Street, 33
rd
Floor, New York, NY 10019,
Vereinigte Staaten von Amerika, Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A5 der Gesellschaft und
zukünftiger
Inhaber von fünfundneunzig (95) Anteilen der neu geschaffenen Serie B2 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
11. Luktev GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in
Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 119212 B, mit Geschäftssitz in Mohrenstrasse 60, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A5 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
12. Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmä-
ßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRA 45915 B, mit Geschäftssitz in Jägerstraße 65, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaber von dreihunderteinundachtzig (381) Anteilen der Serie A5 der Gesellschaft und siebenundachtzig (87) Anteilen
der Serie B1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
13. Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem
Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der
Nummer HRA 45911 B, mit Geschäftssitz in Jägerstraße 65, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaber von sechsunddreißig (36) Anteilen der Serie A5 der Gesellschaft und sieben (7) Anteilen der Serie B1 der
Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
14. L'Arche B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
nach dem Recht der Niederlande, eingetragen im niederländischen Handelsregister der Handelskammern, unter der
Nummer 59430982, mit Geschäftssitz in Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam, Niederlande,
Inhaber von eintausendfünfhundertsiebenundachtzig (1.587) Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
15. Mercura Capital GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem
Sitz in Starnberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Num-
mer HRB 200948, mit Geschäftssitz in Schießstättstraße 22, 82319 Starnberg, Deutschland,
Inhaber von siebenhundertvierundneunzig (794) Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
25. Februar 2015;
16. SHCO 57 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société a responsabilité limitée), gegründet und
bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register unter der Nummer B 183.425, mit Sitz in 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg,
Inhaber von vierhundertsechsundsiebzig (476) Anteilen der Serie B1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
25. Februar 2015;
17. Team Europe Ventures Ltd., eine Gesellschaft nach dem Recht von England und Wales mit satzungsmäßigem Sitz
in 69 Great Hampton Street, Birmingham, B18 6EW, Vereinigtes Königreich, eingetragen im Gesellschaftsregister von
Cardiff unter der Nummer 05831082, mit einer Zweigniederlassung in Mohrenstraße 60, 10117 Berlin, Germany, einge-
tragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 115038 B, aus-
schließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,
zukünftiger Inhaber von eintausendfünfhundertsiebenundachtzig (1.587) Anteilen der neu geschaffenen Serie B2 der
Gesellschaft,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
24. Februar 2015;
61456
L
U X E M B O U R G
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. und 16. (die „Bestehenden Gesellschafter”) sind alle
Gesellschafter der Helpling Group Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (so-
ciété à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.677, gegründet am 7. Februar 2014
gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars, welche am 28. April 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 1074 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt geändert am 30. Januar
2015 gemäß einer Urkunde von Maître Cosita Delvaux, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations veröffentlicht wurde.
Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet, und die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die fol-
gende Tagesordnung verhandeln, wobei die Partei 17. (der „Neue Investor”) ausschließlich für die Punkte 4 ff. der
Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) neuen Serie von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, und
zwar der Anteile der Serie B2, sodass die Gesellschaft nunmehr acht (8) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen
(die „Stammanteile”), Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1”), Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie
A2”), Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3”), Anteilen der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4”), Anteilen der
Serie A5 (die „Anteile der Serie A5”), Anteilen der Serie B1 (die „Anteile der Serie B1”) und Anteilen der Serie B2 (die
„Anteile der Serie B2”).
2. Aufnahme von Team Europe Ventures Ltd., vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von neunundzwanzigtausend-
zweihundertsechsundachtzig Euro (EUR 29.286) um einen Betrag von eintausendsechshundertzweiundachtzig Euro (EUR
1.682) auf einen Betrag von dreißigtausendneunhundertachtundsechzig Euro (EUR 30.968) durch die Ausgabe von ein-
tausendsechshundertzweiundachtzig (1.682) Anteilen der Serie B2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
4. Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um die Kapitalerhöhung gemäß dem dritten Beschluss, sowie weitere
Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage durch den Neuen Investor wiederzugeben.
5. Verschiedenes.
Die Gesellschafterversammlung erkennt an, dass alle Bestehenden Gesellschafter zum Zwecke der vorstehenden Ta-
gesordnung auf die Verpflichtung der Zustimmung der Investoren zur Veränderung der Satzung der Gesellschaft gemäß
Artikel 16 der Satzung und auf Vorzugsrechte, welche ihnen gemäß Artikel 5.3 der Satzung zustehen könnten, einstimmig
verzichtet haben.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) neue Serie von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft
zu schaffen, und zwar die Anteile der Serie B2, sodass die Gesellschaft nunmehr acht (8) Anteilsklassen hat, bestehend
aus Stammanteilen, Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2, Anteilen der Serie A3, Anteilen der Serie A4, Anteilen
der Serie A5, Anteilen der Serie B1 und Anteilen der Serie B2.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Team Europe Ventures Ltd., vorbenannt, als neuen Gesellschafter der
Gesellschaft anzunehmen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
neunundzwanzigtausendzweihundertsechsundachtzig Euro (EUR 29.286) um einen Betrag von eintausendsechshundert-
zweiundachtzig Euro (EUR 1.682) auf einen Betrag von dreißigtausendneunhundertachtundsechzig Euro (EUR 30.968)
durch die Ausgabe von eintausendsechshundertzweiundachtzig (1.682) Anteilen der Serie B2 mit einem Nominalwert von
je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die eintausendsechshundertzweiundachtzig (1.682) Anteile der Serie B2 wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:
- fünfundneunzig (95) Anteile der Serie B2 wurden ordnungsgemäß von Herrn David W. Zalaznick, vorbenannt, hier
vertreten durch Julien De Mayer, gezeichnet;
61457
L
U X E M B O U R G
- eintausendfünfhundertsiebenundachtzig (1.587) Anteile der Serie B2 wurden ordnungsgemäß von Team Europe Ven-
tures Ltd., vorbenannt, hier vertreten durch Julien De Mayer, gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die eintausendsechshundertzweiundachtzig (1.682) Anteile der Serie B2 wurden vollständig wie folgt eingezahlt:
- die von Herrn David W. Zalaznick, vorbenannt, gezeichneten fünfundneunzig (95) Anteile der Serie B2 wurden
vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von fünfundneunzig Euro (EUR 95) eingezahlt;
- die von Team Europe Ventures Ltd., vorbenannt, gezeichneten eintausendfünfhundertsiebenundachtzig (1.587) An-
teile der Serie B2 wurden vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendfünfhundertsiebenundachtzig Euro
(EUR 1.587) eingezahlt.
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlagen wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Die Einlage in Höhe von eintausendsechshundertzweiundachtzig Euro (EUR 1.682) wird vollständig dem Gesellschafts-
kapital zugeführt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt eine vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um die Kapital-
erhöhung gemäß dem dritten Beschluss, sowie weitere Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage durch die Neuen
Investoren wiederzugeben.
Die Satzung der Gesellschaft lautet nunmehr wie folgt:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Helpling Group Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915”) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
61458
L
U X E M B O U R G
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreißigtausendneunhundertachtundsechzig Euro (EUR 30.968),
bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”) mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1),
5.1.2 eintausendsiebenhundertneun (1.709) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1”) mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1),
5.1.3 zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2”) mit einem Nominalwert von
je einem Euro (EUR 1),
5.1.4 zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3”) mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1),
5.1.5 dreitausenddreihundertvierunddreißig (3.334) Anteilen der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4”) mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1),
5.1.6 eintausendsechshundertachtundsechzig (1.668) Anteilen der Serie A5 (die „Anteile der Serie A5”) mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), gemeinsam mit den Anteilen der Serie A1, den Anteilen der Serie A2, den
Anteilen der Serie A3 und den Anteilen der Serie A4 die „Anteile der Serie A”,
5.1.7 fünftausendvierhunderteinundneunzig (5.491) Anteilen der Serie B1 (die „Anteile der Serie B1”) mit einem No-
minalwert von je einem Euro (EUR 1),
5.1.8 eintausendsechshundertzweiundachtzig (1.682) Anteilen der Serie B2, mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1) (die „Anteile der Serie B2”; die Anteile der Serie B1 gemeinsam mit den Anteilen der Serie B1 im Folgenden auch
die „Anteile der Serie B”; die Anteile der Serie A gemeinsam mit den Anteilen der Serie B im Folgenden die „Vorzugs-
anteile”).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung, in einer
Gesellschaftervereinbarung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jeder der Gesellschafter Rocket Internet AG („Rocket”), Netris B.V. („Eiffel”), Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Ais-
mare”), JP Ventures UG (haftungsbeschränkt) („JP”), Kaltroco Limited („Kaltroco”), Phenomen Ventures LP („Pheno-
men”), Mangrove IV Investments S.à r.l. („Mangrove”), TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. („TJT”), David W.
Zalaznick („DZ”), Luktev GmbH („Luktev”), Team Europe Ventures Ltd. („Team Europe Ventures”, gemeinschaftlich mit
Luktev „Team Europe”), Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG („Point Nine Capital”), Point Nine Co-Invest II
GmbH & Co. KG („Point Nine Co-Invest”, gemeinschaftlich mit Point Nine Capital „Point Nine”), L'Arche B.V. („L'Ar-
che”), SHCO 57 S.à r.l. („SHCO”) und Mercura Capital GmbH („Mercura”; Mercura gemeinschaftlich mit Rocket, Eiffel,
Aismare, Kaltroco, Phenomen, Mangrove, TJT, DZ, Team Europe, Point Nine, L'Arche und SHCO die „Investoren” und
jeweils ein „Investor”) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt,
wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um
eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein
„Drittinvestor”) handelt), der mit einer Mehrheit des Beirats (wie in Artikel 25.5 definiert) zugestimmt wurde (wobei
eine solche Investition als „Investition eines Dritten” bezeichnet wird) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor
oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an
der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer
Investition eines Dritten. Der jeweilige Investor oder der bezugsberechtigte Gesellschafter gemäß diesem Artikel 5.3 hat
die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein
Recht gemäß dem vorstehenden Satz dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer
der Investoren oder anderen Gesellschafter (oder eine mit einem Investor oder einem anderen Gesellschafter im Sinne
der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) verbundene Gesellschaft) weitere Anteile zeichnet, entsprechend
anwendbar.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-
venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
61459
L
U X E M B O U R G
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar, vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaf-
tervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vor-
kaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft übertragen werden.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung einer Mehrheit von fünf-
undsiebzig Prozent (75%) der Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft (wobei eine solche Mehrheit als „Qualifizierte
Mehrheit” bezeichnet wird) und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Ge-
sellschaftern der Gesellschaft, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder
Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft
übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Übertragung von
Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung (wie in Artikel 8.1 definiert) oder jeglichen anderen Veräußerung durch einen Investor an
eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung durch einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche
direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreff-
enden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft”) Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der
gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle” oder „Kontrolliert Wird” oder „Kontrolliert”
die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnet, durch (a) die Leitung der Gesellschaft als geschäfts-
führender Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte
durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Ge-
schäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder
anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses
Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung (i) an einen Dritten, welcher Anteile unter einer,
sofern von den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung beschlossen, vereinfachten Mitar-
beiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im
Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung, die gemäß einer solchen vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung eingeführt
wurde;
7.4.4 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung im Rahmen von Umwandlungsvorgängen gemäß des
Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmelzung der Gesellschaft, so-
fern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer
überlebenden juristischen Person halten.
7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung oder jegliche andere Veräußerung wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel
1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung in
Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn einer solchen Übertragung mit einer Qualifizierten Mehrheit zugestimmt wird (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben
des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) einer Übertragung von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren ver-
bundenen Transaktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) einer Übertragung von mindestens 50% des
Vermögens oder der Geschäfte der Gesellschaft in einer oder mehreren verbundenen Transaktionen oder (iii) einer
61460
L
U X E M B O U R G
Übertragung eines wesentlichen Teils der Rechte des geistigen Eigentums der Gesellschaft in einer oder mehreren ver-
bundenen Transaktionen oder (iv) der Liquidation oder der de facto-Liquidation der Gesellschaft (insbesondere nach
einem Asset Deal) oder (v) eines Verkaufs oder einer Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte
oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des eingetragenen
Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien
wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii)
und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis” bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse”) -
vorbehaltlich des Artikels 8.2 - im Einklang mit Artikel 8.3 auf einer pro rata-Basis (i) entsprechend ihrer Beteiligung am
eingetragenen Gesellschaftskapital der Gesellschaft im Falle einer Vermögensübertragung, oder (ii) entsprechend der
Anzahl der im Liquiditätsereignis verkauften Anteile (soweit anwendbar) im Falle einer Anteilsübertragung an die Gesell-
schafter verteilt.
„Übertragung” meint, im Hinblick auf Vermögenswerte (einschließlich, ohne Beschränkung, Anteile und Rechte des
geistigen Eigentums), eine Übertragung, eine Abtretung, einen Verkauf, eine Verpfändung (pledge), eine Beleihung (hy-
pothecation), eine Belastung oder andere Veräußerung dieses Vermögenswertes oder damit verbundener Rechte und
Pflichten, ob absichtlich oder unabsichtlich, einschließlich einer Option hinsichtlich jeder der vorgenannten Handlungen.
„Belastung”/„Belastet” meint Belastungen jedweder Art, einschließlich Hypotheken, Belastungen (charge), Obligatio-
nen, Verpfändungen, Beleihungen, Pfandrechte, Sicherungsrechte, Eigentumsvorbehalte, Optionsrechte, Erwerbs- oder
Bezugsrechte, Verkaufs- oder Übertragungsbeschränkungen, Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Rechte oder Interessen eines
Dritten, Forderungen, Trust-Arrangements, Verträge bezüglich der Übertragung von Wertpapieren, anderer Belastungen
oder anderer Sicherungsrechte jeder Art oder anderer Vorzugsvereinbarungen oder Eigenkapital oder anderer Ein-
schränkungen oder Beschränkungen jedweder Art (einschließlich, ohne Beschränkung, Übertragungsabkommen von
Titeln oder Vorbehaltsvereinbarungen, Vorverträge oder andere Vereinbarungen bezüglich einer der vorgenannten
Handlungen) mit ähnlicher Wirkung;
8.2 Auf einer ersten Vorzugsebene („Erste Vorzugsebene”) erhält jeder Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag,
welcher dem Betrag seiner jeweiligen Gesamtinvestition entspricht, die er getätigt hat, um seine jeweiligen von ihm
gehaltenen Anteile der Serie B zu erwerben (bestehend aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen
Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen
Kontenplans), die von dem jeweiligen Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht ausreichend Exiterlöse für
die Zahlungen auf der Ersten Vorzugsebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an jeden Inhaber der Anteile der Serie
B auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an diesen Inhaber auf der Ersten Vorzugsebene verteilt worden
wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.
8.3 Auf einer zweiten Vorzugsebene („Zweite Vorzugsebene”) erhält jeder Inhaber von Anteilen der Serie A einen
Betrag, welcher dem Betrag seiner jeweiligen Investition entspricht, die er zum Erwerb seiner jeweiligen von ihm gehalt-
enen Anteile der Serie A getätigt hat (d.h. den jeweiligen Nominalbetrag der Anteile der Serie A und die jeweilige
zusätzliche Einzahlung). Sind nicht ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der Zweiten Vorzugsebene vorhanden,
so werden die Exiterlöse an jeden Inhaber der Anteile der Serie A auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die
an diesen Inhaber auf der Zweiten Vorzugsebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen
wären.
8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Vorzugsebene und der Zweiten Vorzugsebene geleistet wurden, werden
die übrigen Exiterlöse auf einer gemeinsamen Ebene („Gemeinsame Ebene”) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer
pro rata-Basis entsprechend den jeweiligen Anteilen, die im Zusammenhang mit dem Liquiditätsereignis veräußert wurden,
verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf einer Vorzugsebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Ge-
sellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Gemeinsamen Ebene; mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzah-
lung eines auf der Ersten Vorzugsebene und/oder der Zweiten Vorzugsebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist.
Exiterlöse, welche nach der Verteilung gemäß dieses Artikels 8.4 nicht zugeteilt wurden, werden auch im Einklang mit
diesem Artikel 8.4 durch die wiederholte Anwendung des Artikels 8.4 verteilt, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter
verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder
nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an
die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse auf einer
pro rata-Basis zu den verkauften Anteilen, oder (ii) als der Betrag seiner Investition in die Gesellschaft (Zahlung des
Kaufpreises für eine eventuelle Vorratsgesellschaft, Einzahlung des Gesellschaftskapitals, einschließlich ggf. des Agios, und
Einzahlungen auf Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans „apport en capitaux propres non ré-
munérés par des titres” nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (zusätzliche Beträge)) in Bezug auf die
verkauften Anteile. Werden Anteile der Gesellschaft in mehr als einer Transaktion verkauft, so hat kein Gesellschafter
weniger Erlöse zu erhalten, als er erhalten hätte, wenn die Anteile der Gesellschaft in einer Transaktion verkauft worden
wären.
8.5 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten Vorzugsebene und der Zweiten Vorzugsebene gilt zugunsten des ent-
sprechenden Investors solange, wie dieser (einschließlich von Verkäufen vor einem Liquiditätsereignis) den vollständigen
Betrag, der an diesen Gesellschafter gemäß der Ersten Vorzugsebene und/oder der Zweiten Vorzugsebene zu verteilen
ist, noch nicht erhalten hat.
61461
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist diese Aus-
gleichszahlung von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemein-
schaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser
auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondisse-
ment) bestimmt. Die Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der
Gesellschaft und dem betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende
Teil mit der Ausgleichszahlung für den Rückkauf verrechnet und die Ausgleichszahlung für den Rückkauf dementsprechend
herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen Kosten zu tragen, sofern die Ausgleichszahlung für den Rückkauf
die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
61462
L
U X E M B O U R G
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung” in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche
in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesell-
schaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im
Einklang mit Artikel 13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesell-
schafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der
die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen, die die Zustimmung aller Investoren
vorausgesetzt. Änderungen dieser Satzung, durch welche die Rechte der Inhaber der Vorzugsanteile erheblich oder
nachteilig beeinflusst werden, bedürfen der Zustimmung aller Inhaber dieser Vorzugsanteile.
Art. 17. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und
zudem die Zustimmung des Beirats:
17.1.1 Abschluss, Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Akti-
engesetzes (AktG));
17.1.2 Abschluss oder Änderung von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Ver-
äußerung von Anteilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere
61463
L
U X E M B O U R G
Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der
Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich
Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wur-
den, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und
Werbepartnern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-
stimmung aller Investoren:
17.2.1 wesentliche Änderungen des Geschäftszwecks der Gesellschaft oder jegliche wesentliche Modifikation der Ge-
schäftsfelder der Gesellschaft oder die Aufgabe bestehender und die Aufnahme neuer Geschäftsfelder;
17.2.2 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.3 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung;
17.2.4 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-
gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
17.2.5 Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
17.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer
Art. 18. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer” nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer” als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer” auszulegen.
18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
ihre Amtszeit festlegt.
19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschluss festgehalten und
die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
61464
L
U X E M B O U R G
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, oder per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer
kann seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des
betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Be-
schlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maß-
nahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im
Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:
22.8.1 Genehmigung des Jahresplans, einschließlich des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr;
22.8.2 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Betrag von zweihundert-
tausend Euro (EUR 200.000,00) übersteigen;
22.8.3 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-
aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.4 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungverpflichtungen jeglicher Art;
22.8.5 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
22.8.6 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-
wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;
22.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen;
22.8.8 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder dokumentiertem Wissen durch die Gesellschaft an einen
Dritten, die außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs liegt;
22.8.9 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-
cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln;
22.8.10 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung
jeglicher Aktienoptionen) mit Ausnahme der Schaffung einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den Ge-
sellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-
lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
61465
L
U X E M B O U R G
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durcheinenGesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des Alleinigen Ge-
schäftsführers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Ge-
schäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines
(1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.
Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat gebildet (der „Beirat”). Dieser besteht aus neun (9) stimmberechtigten Mitglie-
dern, jeweils mit der in diesem Artikel 25 angegebenen Anzahl an Stimmen. Die Gesellschafter können durch einstimmige
Zustimmung der Gesellschafter (i) die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats erhöhen oder herabsetzen
und/oder (ii) die jeweilige Anzahl der Stimmen erhöhen oder herabsetzen.
25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-
schafter festlegen und/oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.3.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats, von denen eines über drei (3) Stimmen und eines über zwei
(2) Stimmen verfügt, werden von dem Investor Rocket nach eigenem Ermessen ernannt (die „Rocket-Mitglieder”);
25.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor Aismare
nach eigenem Ermessen ernannt (das „Aismare-Mitglied”);
25.3.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor Phe-
nomen nach eigenem Ermessen ernannt (das „Phenomen-Mitglied”);
25.3.4 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor Mang-
rove nach eigenem Ermessen ernannt (das „Mangrove-Mitglied”);
25.3.5 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor L'Arche
nach eigenem Ermessen ernannt (das „L'Arche-Mitglied”);
25.3.6 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor SHCO
nach eigenem Ermessen ernannt (das „SHCO-Mitglied”);
25.3.7 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor Mercura
nach eigenem Ermessen ernannt (das „Mercura-Mitglied”);
25.3.8 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats, das über eine (1) Stimme verfügt, wird von dem Investor Team
Europe nach eigenem Ermessen ernannt (das „Team Europe-Mitglied”);
61466
L
U X E M B O U R G
25.4 Jeder Investor, der nicht zur Ernennung eines stimmberechtigten Mitglieds des Beirats gemäß Artikel 25.3 be-
rechtigt ist, darf ein nicht-stimmberechtigtes Mitglied des Beirats als Beobachter ernennen.
25.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, wobei keiner von beiden eine
entscheidende Stimme und/oder zusätzliche Rechte und/oder Befugnisse hat, die sich von denen der anderen Mitglieder
des Beirats unterscheiden. Eines der Rocket-Mitglieder ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats
hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten. Vorbehaltlich an-
derer Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarungen
bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, fasst der Beirat Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men (die „Mehrheit des Beirats”). Darüber hinaus fasst der Beirat für bestimmte Maßnahmen, die sich aus einer
Gesellschaftervereinbarung ergeben, Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern die Ja-Stimmen
von zumindest drei (3) der folgenden Mitglieder abgegeben worden sind: Aismare-Mitglied und/oder Phenomen-Mitglied
und/oder Mangrove-Mitglied und/oder L'Arche-Mitglied und/oder SHCO-Mitglied und/oder Mercura-Mitglied und/oder
Team Europe-Mitglied und/oder jedem anderen Mitglied des Beirats, das nach dem Datum dieser Satzung ernannt wird
(die „Qualifizierte Mehrheit des Beirats”). Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.
25.6 Vorbehaltlich anderer Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesell-
schaftervereinbarungen bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, hat der Beirat eine beratende Funktion und wird
nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen GesellschaftererbrachteEinlageninRücklagenkönnen mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls
der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls - im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 -
verteilt und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebe-
61467
L
U X E M B O U R G
nenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch
vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser
Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft
eingehen und durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Sat-
zung mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft in Widerspruch stehen, so ist
die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.” Da somit die Tagesordnung
erschöpft ist, ist die Versammlung aufgehoben.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 2.200,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.
Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/6471. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 31. März 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015049207/1506.
(150056953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Artbo SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 115, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 150.529.
<i>Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société du 9 mars 2015i>
L'actionnaire unique de la Société, a décidé de
- révoquer avec effet immédiat, Madame Blandine Lhomme de ses fonctions d'administrateur et de délégué à la gestion
journalière de la Société.
- Nommer administrateur de la Société Madame Corinne Bréart, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange,
115 rue de Luxembourg.
- nommer délégué à la gestion journalière de la Société Madame Sylvie Barthol, demeurant professionnellement à
L-8077 Bertrange, 115 rue de Luxembourg
61468
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015048981/17.
(150056218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Babcock & Brown European Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 109.507.
Les statuts coordonnés au 12 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015048987/11.
(150056494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Beverage Packaging Factoring (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 166.005.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prise par l'actionnaire unique en date du 23 Mars 2015 que:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1014 Luxembourg et immatriculé au RCS
Luxembourg sous le numéro B 65477 a été renommé réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en l'année 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 31 Mars 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015048988/16.
(150056504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Bini Electricité Maintenance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Luxembourg, 130, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 106.108.
L'an deux mille quinze, le vingt-trois mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1. Monsieur Laurent BINI, directeur de société, né à Longwy, (France), le 27 juillet 1961, et son épouse
2. Madame Lydie BRUZZECHESSE, employée privée, née à Longwy, (France), le 15 août 1966,
demeurant ensemble à L-1948 Luxembourg, 78, rue Louis XIV,
3. La société anonyme «BIFRACO S.A.», établie et ayant son siège social à L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro B 145076,
sont ici représentés par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu de deux procurations lui délivrées.
4. Madame Joanne DYER, employée privée, née à Epsom, Comté de Surrey, (Royaume-Uni), le 21 juillet 1965, de-
meurant à L-4993 Sanem, 23, Cité Schmiedenacht,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de
5. Monsieur Daniel MARCHAND, employé privé, né à Mont-Saint-Martin, (France), le 10 juillet 1963, demeurant à
L-4993 Sanem, 23, Cité Schmiedenacht, ici représenté en vertu procuration délivrée au mandataire.
Les procurations après avoir été signées «ne varietur» par les mandataires des comparants et le notaire instrumentant
resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
61469
L
U X E M B O U R G
- Que la société à responsabilité limitée «Bini Electricité Maintenance S.à r.l.», (la «Société»), établie et ayant son siège
social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 106.108, a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHT-
GEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 573 du 14 juin 2005.
- Que les comparants sub 1-5 sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et que les comparants se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social vers L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon et de modifier en
conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 3. (1
er
alinéa). Le siège social est établi dans la Commune de Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de 900,- EUR et les associés,
s'y engagent personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Joanne DYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 mars 2015. Relation GAC/2015/2551. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015048989/48.
(150056428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Bonito Luxembourg Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 116.898.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Bonito Luxembourg Holdings S. à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.1.
Référence de publication: 2015048996/11.
(150056832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Baliste Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 103.606.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2015049003/11.
(150056709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
BERTOPHE Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 41.269.
Le bilan de la société au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
61470
L
U X E M B O U R G
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015049008/12.
(150056614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
BR Craven JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: DKK 114.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.445.
<i>1. Extrait des résolutions du conseil de gérance du 11 mars 2015:i>
Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société est transféré du 28, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg
au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 23 mars 2015.
2. Il est à noter que:
- le siège social de l'Associé BR SH Craven S.à r.l. a été transféré au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
avec effet au 23 mars 2015.
- l'adresse professionnelle de Madame Joanne Fitzgerald a été transférée au 35a, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Lu-
xembourg avec effet au 23 mars 2015.
- l'adresse professionnelle de Madame Delloula Aouinti a été transférée au 35a, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxem-
bourg avec effet au 23 mars 2015.
- l'adresse professionnelle de Monsieur Joel Davidson a été transférée au 35a, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxem-
bourg avec effet au 23 mars 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 23 mars 2015.
<i>Pour la Société
i>Joel Davidson
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015049019/25.
(150056246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Consultants des Beaux Arts S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 147.509.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-
bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Signature
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015049056/13.
(150056753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Immocalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 155.200.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-
bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.
61471
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Signature
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015049257/13.
(150056749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
In Vino Veritas Consulting S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 57.558.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015049258/10.
(150056578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
IK Investment Partners VII B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 166.964.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049252/9.
(150056587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Interarrow S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 139.871.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
INTERARROW S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2015049263/11.
(150057000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Index Ventures IV Investors (Alpha) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 132.686.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de la Société en date du 26 février 2015 de transférer toutes les parts détenues comme suit;
Index Ventures IV Parallel Entrepreneur Fund (Jersey) L.P., transfère toutes les 9, 850,432 parts sociales à la société
Index Ventures IV (Jersey), L.P., avec effet immédiat.
Index Ventures IV (Jersey), L.P., devient l'associé unique de la société avec 113, 627,000 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049238/14.
(150056518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61472
L
U X E M B O U R G
Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 44.318.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2015049242/12.
(150056844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 44.318.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 Mars 2015i>
Le mandat de la personne chargée du contrôle des comptes venant également à échéance, l'Assemblée décide de
réélire pour une durée d'un an venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2015, la société KPMG
Luxembourg, 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (avec mandat de Réviseur d'entreprises agréé).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2015049243/15.
(150056859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
JAB Holding Company s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 164.586.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 30 mars 2015.
Référence de publication: 2015049271/10.
(150056278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Jimlux Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 118.061.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 19 mars 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société:
la société anonyme JIMLUX SOPARFI S.A (RCS B118061) avec siège social à L-3450 Dudelange, 28, rue du commerce,
de fait inconnue à cette adresse.
Les frais ont été mis à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Stéphanie STAROWICZ
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015049275/16.
(150056339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61473
L
U X E M B O U R G
Jovest Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
R.C.S. Luxembourg B 38.919.
avec siège social à Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg, inscrite section B 38.919
Le domicile de la Société est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
FIDUPAR
Référence de publication: 2015049277/11.
(150056539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Jovest Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 38.919.
Au Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg est requis de procéder à l'inscription de
la modification suivante pour la Société anonyme
JOVEST HOLDING S.A.
Société Anonyme
1, rue Joseph hackin
L-1746 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 38.919
Monsieur Joseph WINANDY et la société JALYNE S.A. représentée par Monsieur Jacques BONNIER ont démissionné
de leur mandat d'Administrateur de la société en date du 19 mars 2015 avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
Référence de publication: 2015049278/18.
(150056817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Jugendstil SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 59.016.
<i>Extrait de l'assemblée générale du 27 mars 2015i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la société, tenue à Luxembourg le 27 mars 2015, que les
résolutions suivantes ont été adoptées:
- L'assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Sylvain Elias de son mandat d'administrateur.
- L'assemblée décide de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Madame Léa Duval, née à Nancy
(France) le 20 juin 1990, résidant professionnellement au 3, rue des Bains, L-2018 Luxembourg et ce, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle à tenir en 2021.
- L'assemblée décide de renouveler les mandats de Madame Véronique De Meester et de Madame Emilie Bensmihen
à la fonction d'administrateur, et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2021.
- L'assemblée accepte la démission, avec effet immédiat de la société Milkyway Inc. Group de son mandat de commis-
saire aux comptes.
- L'assemblée décider de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société Fidus
Gestion S.A. (B.55.098) 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2015.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015049279/25.
(150056652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61474
L
U X E M B O U R G
JV Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 195.728.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the seventeenth day of March.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, to whom the present deed will remain.
THERE APPEARED:
Mr Alan Lawrence Lee, private employee, born on September 4
th
, 1957 in London, United Kingdom, residing at Apt.
19, Connaught House, Mount Street 1-3, London,
here represented by Thibaut Dejaegere, private employee, residing professionally in Schuttrange,
by virtue of a proxy given on March 11, 2015.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10
th
August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Arti-
cles”).
Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies
or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the
proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies of the group. The Company
may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its
assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of
any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of
the financial sector without having obtained the required authorisation.
The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against
credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name “JV Holdings S.à r.l.”
Art. 5. The registered office is established in Schuttrange.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EURO)
represented by TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED(12,500) shares with a par value of ONE EURO (1.-EUR) each,
all subscribed and fully paid-up.
The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
61475
L
U X E M B O U R G
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
The Company may redeem its own shares. However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the
shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are
available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an
unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary
general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 9. Appointment and removal of managers
The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the
term of their office. The managers need not be shareholders.
The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 10. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the Board.
Powers of the board of managers
All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
10.1 Procedure
10.1.1 The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in
principle, is in Luxembourg.
10.1.2 Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
10.1.3 No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full
knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a
meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
10.1.4 A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of
the Board.
10.1.5 The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board shall be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of
the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by
all the managers present or represented.
10.1.6 Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other
means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
10.1.7 Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
10.2 Representation
10.2.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of two managers.
10.2.2 The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 11. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or
the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been
delegated.
Art. 12. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.
61476
L
U X E M B O U R G
Art. 13. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions
13.1 Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
13.2 Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General
Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting
or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Reso-
lutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters (3/4) of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
13.3 Sole shareholder
(i) Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by
the Law to the General Meeting.
(ii) Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions
is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
(iii) The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
Art. 14. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31
st
of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31
st
of December
2015.
Art. 15. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
61477
L
U X E M B O U R G
Art. 17. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 18. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party,
represented as stated here above, declares to subscribe for the TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) shares
and to have them fully paid up in cash of an amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR).
Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately ONE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (1,200.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered for an unlimited period by the following managers:
- Michelle Carvill, private employee, residing professionally at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange;
- Alexander N.J. van Zeeland, private employee, residing professionally at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange;
- Guardian Financial Company S.à r.l., with registered office at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange and registered
with the Register of Commerce and Companies under the number B159446
2) The address of the corporation is fixed at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange.
<i>Déclarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil
status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente
minute.
A COMPARU:
Monsieur Alan Lawrence Lee, employé privé, né le 4 septembre 1957 à Londres, Angleterre, demeurant profession-
nellement à Apt. 19, Connaught House, Mount Street 1-3, London
Ici représenté par
M Thibaut Dejaegere, employé privé, demeurant professionnellement à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange,
en vertu d'une procuration datée du 11 mars 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité
limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après “La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après “La Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”).
Art. 2. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée.
Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle
peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intel-
lectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
61478
L
U X E M B O U R G
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés du groupe. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l’autorisation requise.
La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements
et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres
risques.
La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: “JV Holdings S.à r.l.”
Art. 5. Le siège social est établi à Schuttrange.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand- Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR), représenté par DOUZE MILLE
CINQ CENTS (12,500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un euro (1.-Eur) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.
Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
La Société peut racheter ses propres parts sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale
des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont dispo-
nibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par
un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire
et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 8. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 9. Nomination et révocation des gérants
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés
Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 10. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil.
10.1 Pouvoirs du conseil de gérance
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
10.2 Procédure
61479
L
U X E M B O U R G
10.2.1 Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe,
est au Luxembourg.
10.2.2 Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.
10.2.3 Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
10.2.4 Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
10.2.5 Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
10.2.6 Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre
moyen de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre
et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement
convoquée et tenue.
10.2.7 Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables
et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
10.3 Représentation
10.3.1 La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.
10.3.2 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués.
Art. 11. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou
aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 12. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
Art. 13. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés
13.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’ Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
13.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
61480
L
U X E M B O U R G
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
13.3 Associé unique
(i) Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la
Loi à l’Assemblée Générale.
(ii) Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
(iii) Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année
qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
Art. 15. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 16. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 17. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 18. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ici représentée comme indiqué
ci-dessus, a déclaré souscrire aux DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en
espèces un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR).
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200.-EUR).
<i>Décision de l'associé uniquei>
1) La Société est administrée, pour une durée indéterminée, par les gérants suivants:
- Michelle Carvill, employée privée, demeurant professionnellement à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange;
- Alexander N.J. van Zeeland, demeurant professionnellement à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange;
- Guardian Financial Company S.à r.l., ayant son siège social à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange et immatriculé
sous le numéro B159446 avec le Registre de Commerce et des Sociétés.
2) L'adresse de la Société est fixée à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange.
61481
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms état et demeure,
a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. DEJAEGERE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8462. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2015.
Référence de publication: 2015049280/394.
(150055637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Karmon S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.284.
<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 30 mars 2015i>
- Madame Kristine Vanaga-Mihailova, née à Riga, Lettonie, le 8 août 1979, demeurant professionnellement à 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a été nommée comme gérant A, avec effet au 30 mars 2015, pour une durée
indéterminée.
- Monsieur Nicolas Gasztonyi, né à Etterbeek (Belgium), le 11 août 1965, demeurant professionnellement à 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a démissionné de son mandat gérant A, avec effet au 30 mars 2015.
Luxembourg, le 31.03.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Karmon S.à r.l. SPF
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015049281/17.
(150056640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Kipp-Trans S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle "Um Monkeler".
R.C.S. Luxembourg B 116.415.
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015049283/10.
(150056724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Kohlenberg & Ruppert Premium Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.314.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
61482
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 mars 2015.
Jean-Jacques Josset
<i>Administrateur Bi>
Référence de publication: 2015049284/13.
(150056825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Kaolin S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 179.060.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2015i>
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme KAOLIN S.A., SPF, ayant son
siège social à Luxembourg, a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période
de cinq (5) ans au siège de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2015.
<i>Pour KAOLIN S.A., SPF
i>FIDESCO S.A.
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2015049285/18.
(150056441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Keasy, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 136.812.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 18 juillet 2013i>
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la société en date du 18 juillet 2013:
- L'acceptation de la démission de Monsieur François-Xhavier Depireux en tant que gérant de la société avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 18 juillet 2013.
<i>Pour la Société
i>Benjamin de Seille
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015049286/17.
(150056869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Kerdi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 110.001.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015049287/13.
(150057010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61483
L
U X E M B O U R G
KG Far East (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 320.077.350,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 149.409.
EXTRAIT
La Société prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Mauro Ostwald, gérant de la Société, comme suit:
Laan van Roos en Doorn 29B
2514BC Den Haag
Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049288/15.
(150056673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
KG Participações S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 183.710.
EXTRAIT
La Société prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Mauro Ostwald, gérant de la Société, comme suit:
Laan van Roos en Doorn 29B
2514BC Den Haag
Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049289/15.
(150056672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Klee S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 36, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 150.547.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 30 mars 2015.
Référence de publication: 2015049291/10.
(150056281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
KMM Investments Holding, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 98.961.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 19 mars 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société:
la société à responsabilité limitée KMM INVESTMENTS HOLDING SARL (RCS B98961) avec siège social à L-3450
Dudelange, 28, rue du commerce, de fait inconnue à cette adresse.
Les frais ont été mis à charge du Trésor.
61484
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Stéphanie STAROWICZ
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015049292/16.
(150056338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Konkret S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7513 Mersch, 8, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 77.004.
Les statuts coordonnés de la prédite société au 19 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beringen, le 31 mars 2015.
Maître Marc LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015049293/13.
(150056865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Konkret S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7513 Mersch, 8, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 77.004.
L'an deux mille quinze, le dix-neuf mars.
Par-devant nous, Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
A COMPARU:
- Monsieur Pierre KRAUS, indépendant, né à Luxembourg, le 2 mai 1956, demeurant professionnellement à L-7513
Mersch, 8 route d'Arlon,
- Madame Nicole ARENDT, gérante de sociétés, née à Luxembourg, le 6 décembre 1959, demeurant professionnel-
lement à L-7513 Mersch, 8 route d'Arlon,
Qu'ils déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée «KONKRET, S. à r. l.», établie et ayant
son siège social à L-7513 Mersch, 8, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors
de résidence à Hesperange, en date du 20 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations,
numéro 894 du 16 décembre 2000, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 77.004 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 700 du 7 mai 2002,
I. Qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils s'entendent par ailleurs dûment convoqués
et ont à l'unanimité pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent de modifier l'article 5 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. La société́ a pour objet la tenue d'une agence immobilière ainsi que la promotion immobilière avec vente de
tous matériaux pour le bâtiment.
La société a également pour objet la location de véhicules automoteurs sans chauffeur et l'exploitation d'une entreprise
de transports nationaux et internationaux de biens et de personnes.
En général, elle a pour objet toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, mobilières ou immobilières,
qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la
réalisation ou l'extension.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. L'assemblée générale fixera le pouvoir de
signature.»
61485
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée prend acte de la nouvelle adresse professionnelle de Monsieur Pierre KRAUS et de Madame Nicole
KRAUS-ARENDT au L-7513 Mersch, 8 route d'Arlon et décide de nommer ou de renouveler pour une période indé-
terminée les mandats des gérants suivants:
- Pour le volet immobilier et location de voitures sans chauffeur:
1. Monsieur Pierre KRAUS, prénommé, comme gérant technique.
2. Madame Nicole KRAUS-ARENDT, prénommée, comme gérante administrative.
3. Monsieur Gilles KRAUS, employé, né à Luxembourg, le 23 avril 1988, demeurant professionnellement à L-7513
Mersch, 8 route d'Arlon, comme gérant administratif.
Le gérant technique a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société pour ce qui concerne le volet immobilier
et location de voiture sans chauffeur par sa seule signature. Chaque gérant administratif a tous pouvoirs de signature
individuelle pour toutes les affaires n'excédant pas 1.240,- EUR. Au-delà de ce montant, la signature du gérant technique
est requise.
- Pour le volet transport:
1. Monsieur Pierre KRAUS, prénommé, comme gérant administratif.
2. Monsieur Gilles KRAUS, prénommé, comme gérant technique.
La société sera engagée pour ce qui concerne le volet transport par les signatures conjointes du gérant administratif
et du gérant technique.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Beringen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire, la présente minute.
Signé: P. KRAUS, N. ARENDT, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 20 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/6181. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR COPIE CONFORME.
Beringen, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049294/63.
(150056866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
KPI Investment Property 59 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 124.404.
Les statuts coordonnés au 12 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015049295/11.
(150056693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
KPI Residential Property 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 114.517.
Les statuts coordonnés au 12 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015049296/11.
(150056636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61486
L
U X E M B O U R G
KPI Retail Property 39 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 125.281.
Les statuts coordonnés au 12 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015049297/11.
(150056595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
KPI Retail Property 40 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 125.282.
Les statuts coordonnés au 12 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015049298/11.
(150056525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
KPMG Pension Scheme, Sepcav, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.358.
<i>Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 3 mars 2015i>
Le siège social de KPMG Pension Scheme, SEPCAV est transféré du 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 39, Avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 mars 2015.
<i>Pour KPMG Pension Scheme, SEPCAV
i>Carlo Jentgen
Référence de publication: 2015049299/13.
(150056553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
QIAGEN EURO Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 35.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.537.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, qui s'est tenue le 19 mars 2015, que
les actionnaires de la Société ont décidé de procéder à la clôture de la liquidation.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à partir de la date de
la clôture de la liquidation au 49, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015049454/18.
(150056716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
61487
L
U X E M B O U R G
Marona Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 123.496.
L'an deux mille quinze, le vingt mars.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la déno-
mination de "MARONA INVEST S.A.", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 123.496, ayant son siège social
au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, constituée par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster,
en date du 14 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 374 du 14 mars 2007.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, juriste, domicilié professionnellement au 18,
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, domiciliée profession-
nellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, domicilié professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)
actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.à r.l.,
inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 117.503, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à
l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. En conséquence, il est mis fin au mandat
des administrateurs.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, M. Krecké, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 24 mars 2015. 2LAC/2015/6425. Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.
Référence de publication: 2015049354/51.
(150056403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
61488
Artbo SA
Babcock & Brown European Investments S.à.r.l.
Baliste Investissement S.A.
BERTOPHE Spf S.A.
Beverage Packaging Factoring (Luxembourg) S.à r.l.
Bini Electricité Maintenance S.à r.l.
Bonito Luxembourg Holdings S. à r.l.
BR Craven JV S.à r.l.
Consultants des Beaux Arts S.A.
Helpling Group Holding S.à r.l.
IK Investment Partners VII B S.à r.l.
Immocalux S.A.
Index Ventures IV Investors (Alpha) S.à r.l.
Interarrow S.àr.l.
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
In Vino Veritas Consulting S.àr.l.
JAB Holding Company s.à.r.l.
Jimlux Soparfi S.A.
Jovest Holding S.A.
Jovest Holding S.A.
Jugendstil SPF S.A.
JV Holdings S.à.r.l.
Kaolin S.A. S.P.F.
Karmon S.à r.l. SPF
Keasy
Kerdi S.A.
KG Far East (Luxembourg) Sàrl
KG Participações S.à r.l.
Kipp-Trans S. à r.l.
Klee S.A.
KMM Investments Holding, S.à r.l.
Kohlenberg & Ruppert Premium Properties S.A.
Konkret S.à r.l.
Konkret S.à r.l.
KPI Investment Property 59 S.à r.l.
KPI Residential Property 14 S.à r.l.
KPI Retail Property 39 S.àr.l.
KPI Retail Property 40 S.àr.l.
KPMG Pension Scheme, Sepcav
Marona Invest S.A.
QIAGEN EURO Finance (Luxembourg) S.A.