logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1279

18 mai 2015

SOMMAIRE

Cooper Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

61392

Digital Services Holding XXI s.à r.l.  . . . . . .

61346

F9 B Chateau S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61370

F9 B Chateau S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61372

Falcon Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61368

Fincherry S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61368

Flagssen Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61368

Flex Multimedia Entertainment - EMEA

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61369

FMC Technologies Global Rental Tools

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61369

FRATELLI International, Société anonyme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61369

FRC Consult S.A.,SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61369

Freedom Luxembourg Investor S.à r.l.  . . .

61392

FVVP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61370

G-E-O S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61392

G.N. Research S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61372

G.W.T. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61372

MEUBLES Carlo SCHEER et Cie s.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61373

Meubles Marc Scheer S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

61374

Meubles Marc Scheer S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

61374

Mike S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61375

Minerals & Resources Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61375

Miran S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61375

Miso S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61376

MMA INT S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61376

Moon International Luxembourg S.A. . . . .

61377

NB Queen S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61379

Nolan S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61377

Nordea Alternative Investment  . . . . . . . . .

61379

Nordea Dedicated Investment Fund Sicav-

Fis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61380

Nordea Institutional Investment Fund, SI-

CAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61377

Nordea Institutional Investment Fund, SI-

CAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61378

Nordea Multi Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61378

Nordea Multi Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61378

Nordic Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

61379

Northland Power Euro Wind S.à r.l.  . . . . .

61379

Nova Marine Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

61380

Novellus Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61380

NPF Soparfi A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61382

NYK Hummingbird S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

61383

Optimiz Advices S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61389

Optique New Look  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61392

ShopWings Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

61346

61345

L

U X E M B O U R G

ShopWings Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Digital Services Holding XXI s.à r.l.).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.604.

In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of February,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) under the laws of Germany with its statutory seat in

Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amts-
gericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany (hereinafter “Rocket”),

being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Berlin, Germany, on 9 

th

 February 2015;

2.  Bambino  53.  V  V  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability  company  (Unternehmergesellschaft  (haftungsbes-

chränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister)
at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 126893 B, having its re-
gistered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “Bambino 53. V V”),

being the holder of one (1) common share,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Berlin, Germany, on 9 February 2015;

3. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands, registered with

the commercial register of the Dutch Trade Register, under no. 60628022, having its business address at Schiphol Bou-
levard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands (hereinafter “Eiffel”),

being the holder of six hundred ninety-five (695) series A1 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Schiphol, the Netherlands, on 9 

th

 February 2015;

4. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda, having its

business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11 (hereinafter “TJT”),

being the holder of three hundred forty-eight (348) series A2 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Bermuda, on 12 

th

 February 2015;

5. David W. Zalaznick, born on 16 April 1954, resident at 9 West 57 

th

 Street - 33 

rd

 Floor, New York, NY 10019,

United States of America (hereinafter “DZ”),

being the holder of three hundred forty-eight (348) series A2 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in New York, United States of America, on 9 February 2015;

6. TEC Global Invest XI GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of

Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local
court of Duisburg (Amtsgericht Duisburg), Germany, under no. HRB 23773, having its business address at Wissollstraße
5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany (hereinafter “TEC”),

being the holder of six thousand nine hundred forty-five (6,945) series A3 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Mülheim an der Ruhr, Germany, on 9 February 2015; and

7. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 191.426 (hereinafter “Holtzbrinck”),

becoming the holder of one thousand seven hundred thirty-six (1,736) series A4 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 10 February 2015.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

61346

L

U X E M B O U R G

The parties under 1., 2., 3., 4., 5. and 6. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Digital Services Holding

XXI S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 188.604 and incorporated
pursuant to a deed of the notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, on 1 July 2014, published in the Mémorial C,
Recueil  des  Sociétés  et  Associations  number  2447  dated  11  September  2014.  The  articles  of  association  have  been
amended pursuant to a deed of notary Cosita Delvaux, residing in Luxembourg, dated 21 January 2015, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement. The general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Holtzbrinck
participates and votes for the purpose of agenda point 5 et seqq. only:

<i>Agenda

1. Amendment of the name of the Company from “Digital Services Holding XXI S.à r.l.” to “ShopWings Global S.à

r.l.” and subsequent amendment of article one (1) of the articles of association of the Company which shall now read as
follows:

“ Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name ShopWings

Global S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”

2. Decision to create one (1) additional class of shares, so that the Company will hence have five (5) classes of shares,

divided into common shares (hereinafter “Common Shares”), series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), series
A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”), series A3 shares (hereinafter “Series A3 Shares”) and series A4 shares (he-
reinafter “Series A4 Shares”; the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 Shares and the Series A4 Shares
together the “Series A Shares”).

3. Acceptance of HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer, L- 1748 Findel,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 191.426, as new shareholder of the Company.

4. Increase of the Company’s share capital by an amount of one thousand seven hundred thirty-six euro (EUR 1,736.00)

so as to raise it from its current amount of twenty thousand eight hundred thirty-six euro (EUR 20,836.00) up to twenty-
two thousand five hundred seventy-two euro (EUR 22,572.00) by issuing one thousand seven hundred thirty-six (1,736)
Series A4 Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

5. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth

read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1  The  Company’s  share  capital  is  set  at  twenty-two  thousand  five  hundred  seventy-two  euro  (EUR  22,572.00),

represented by

5.1.1  twelve  thousand  five  hundred  (12,500)  common  shares,  with  a  nominal  value  of  one  euro  (EUR  1.00)  each

(hereinafter “Common Shares”),

5.1.2 six hundred ninety-five (695) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A1 Shares”),

5.1.3 six hundred ninety-six (696) series A2 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A2 Shares”),

5.1.4 six thousand nine hundred forty-five (6,945) series A3 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A3 Shares”), and

5.1.5 one thousand seven hundred thirty-six (1,736) series A4 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A4 Shares”; the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 Shares and the Series A4
Shares hereinafter also the “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

6. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name Shop-

Wings Global S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

61347

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.
5.1  The  Company’s  share  capital  is  set  at  twenty-two  thousand  five  hundred  seventy-two  euro  (EUR  22,572.00),

represented by

5.1.1  twelve  thousand  five  hundred  (12,500)  common  shares,  with  a  nominal  value  of  one  euro  (EUR  1.00)  each

(hereinafter “Common Shares”),

5.1.2 six hundred ninety-five (695) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A1 Shares”),

5.1.3 six hundred ninety-six (696) series A2 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A2 Shares”),

5.1.4 six thousand nine hundred forty-five (6,945) series A3 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A3 Shares”), and

5.1.5 one thousand seven hundred thirty-six (1,736) series A4 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A4 Shares”; the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 Shares and the Series A4
Shares hereinafter also the “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

61348

L

U X E M B O U R G

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of shares - transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions
of any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-
emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To
the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet AG

("Rocket"), the shareholder Netris B.V. (“Eiffel”), the shareholder TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”),
the shareholder David W. Zalaznick (“DZ”), the shareholder TEC Global Invest XI GmbH (“TEC”) and the shareholder
HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtzbrinck”; jointly with Rocket, Eiffel, TJT, DZ and TEC the "Investors" and
each also an "Investor") to a company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock
Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by
means of a contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the ma-
nagement and policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the
respective Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a calloption under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation

procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than fifty per cent (50 %) in any surviving legal entity after such
transformation procedure.

7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights

of first refusal, rights of preemption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company

61349

L

U X E M B O U R G

hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.

8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).

Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date

is the date before the redemption resolution.

9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

11.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

11.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

61350

L

U X E M B O U R G

Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

12.2  The  shareholders’  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.

Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If there is no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in
compliance with Article 12.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital
represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of
the votes cast.

Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.

Art. 16. Shareholders’ resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders’ resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-

holders (ii) who also constitute a Super Majority:

16.1.1 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners;

16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
16.2.4 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and

transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.

16.3. Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

61351

L

U X E M B O U R G

17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced  manager  by  the  remaining  managers  until the  next meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

61352

L

U X E M B O U R G

21.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board (as defined below) for the legal transactions and

measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and
have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:

21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

21.8.2 future transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

21.8.6 transfer of industrial property rights or documented knowhow by the Company to a third party, excluding,

however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;

21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et
seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct
or indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The
consent requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of
business of the Company and is at arm’s length;

21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders’ agree-
ment, if any.

21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board (as defined below). The Advisory Board (as defined
below) may give its consent also in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

21.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board (“Advisory Board”). It shall consist of four (4) voting members. The

shareholders may by way of unanimous shareholders’ consent increase or decrease the number of voting members of
the Advisory Board.

24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous

shareholders’ consent.

24.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

61353

L

U X E M B O U R G

24.3.1 Two (2) voting members of the Advisory Board, each having two (2) votes, shall be nominated by Rocket in its

sole discretion;

24.3.2 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by TEC in its sole

discretion; and

24.3.3 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by Holtzbrinck in its

sole discretion.

24.4 Each member of the Advisory Board may be represented by another member of the Advisory Board or any other

representative of the respective party. In this case a written proxy must be presented at the respective Advisory Board
meeting. For this purpose, Rocket, TEC and Holtzbrinck are entitled to appoint one substitute member for each Advisory
Board member.

24.5 The Advisory Board may have non-voting members of the Advisory Board as observers.
24.6 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall

be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board, if any, may provide for further
provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with
the simple majority of votes cast. The Advisory Board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar
quarter.

24.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
24.8 In addition to any consents or approvals otherwise required under these articles of association and/or any sha-

reholders’ agreement with respect to the Company, if any, the Advisory Board has a consultative function and will not
interfere in the management of the Company.

E. Audit and supervision

Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

27.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

61354

L

U X E M B O U R G

28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

7. Subsequently, decision to grant power to any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr

Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders’
register of the Company.

8. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned

notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to modify the name of the Company from “Digital Services Holding XXI

S.à r.l.” to “ShopWings Global S.à r.l.” and to subsequently amend article one (1) of the articles of association of the
Company which shall now read as follows:

“ Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name ShopWings

Global S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to create one (1) additional class of shares, so that the Company will

hence have five (5) classes of shares, divided into common shares (hereinafter “Common Shares”), series A1 shares
(hereinafter “Series A1 Shares”), series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”), series A3 shares (hereinafter “Series
A3 Shares”) and series A4 shares (hereinafter “Series A4 Shares”; the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series
A3 Shares and the Series A4 Shares together the “Series A Shares”).

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to accept HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en com-

mandite simple incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 191.426, as new shareholder of the Company.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s share capital by an amount of one thousand

seven hundred thirty-six euro (EUR 1,736.00) so as to raise it from its current amount of twenty thousand eight hundred
thirty-six euro (EUR 20,836.00) up to twenty-two thousand five hundred seventy-two euro (EUR 22,572.00) by issuing
one thousand seven hundred thirty-six (1,736) Series A4 Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

<i>Subscription

The one thousand seven hundred thirty-six (1,736) Series A4 Shares have been duly subscribed by Holtzbrinck, afo-

rementioned, for the price of one thousand seven hundred thirty-six euro (EUR 1,736.00).

<i>Payment

The one thousand seven hundred thirty-six (1,736) Series A4 Shares subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, have

been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand seven hundred thirty-six euro (EUR
1,736.00).

61355

L

U X E M B O U R G

The proof of the existence of the above contribution in cash has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of one thousand seven hundred thirty-six euro (EUR 1,736.00) is entirely allocated to

the share capital of the Company.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article five (5) of the articles of association of the Company

so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1  The  Company’s  share  capital  is  set  at  twenty-two  thousand  five  hundred  seventy-two  euro  (EUR  22,572.00),

represented by

5.1.1  twelve  thousand  five  hundred  (12,500)  common  shares,  with  a  nominal  value  of  one  euro  (EUR  1.00)  each

(hereinafter “Common Shares”),

5.1.2 six hundred ninety-five (695) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A1 Shares”),

5.1.3 six hundred ninety-six (696) series A2 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A2 Shares”),

5.1.4 six thousand nine hundred forty-five (6,945) series A3 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A3 Shares”), and

5.1.5 one thousand seven hundred thirty-six (1,736) series A4 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A4 Shares”; the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 Shares and the Series A4
Shares hereinafter also the “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

<i>Sixth Resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of

association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Seventh Resolution

The general meeting of shareholders hereby grants power to any manager of the Company, regardless of his category,

as well as Mr Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the
shareholders’ register of the Company.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 1,800.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizehnten Februar,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit
Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),

Inhaberin von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 9. Februar 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

61356

L

U X E M B O U R G

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und be-

stehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),

Inhaberin eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 9 Februar 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

3. Netris B.V., eine Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, eingetragen im Handels-

register des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz in Schiphol Boulevard 127, 1118BG
Schiphol, Niederlande („Eiffel“),

Inhaberin von sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Herrn Julien de Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 9. Februar 2015, ausgestellt in Schiphol, Niederlande;

4. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft (limited liability company) nach dem Recht der

Bermuda-Inseln, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11 („TJT“),

Inhaberin von dreihundertachtundvierzig (348) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 12. Februar 2015, ausgestellt in Bermuda;

5. Herr David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954, wohnhaft in 9 West 57 

th

 Street - 33 

rd

 Floor, New York,

NY 10019, Vereinigte Staaten von Amerika („DZ“),

Inhaber von dreihundertachtundvierzig (348) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 9. Februar 2015, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika;

6. TEC Global Invest XI GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmä-

ßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der
Nummer HRB 23773, mit Geschäftssitz in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland („TEC“),

Inhaberin von sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 9 Februar 2015, ausgestellt in Mülheim an der Ruhr, Deutschland; und

7. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend

unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés)
unter der Nummer B 191.426 („Holtzbrinck“),

zukünftige Inhaberin von eintausendsiebenhundertsechsunddreißig (1.736) Anteilen der Serie A4,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 10 Februar 2015, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur pa-

raphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien unter 1., 2., 3., 4., 5. und 6. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Digital Services

Holding XXI S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188.604, gegründet am 1.
Juli 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 11. September 2014
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2447, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft
wurde am 21. Januar 2015 gemäß einer Urkunde der Notarin Cosita Delvaux geändert, welche noch nicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht wurde.

Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
Tagesordnung verhandeln, wobei Holtzbrinck ausschließlich für die Punkte 5 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimm-
berechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Änderung des Namens der Gesellschaft von „Digital Services Holding XXI S.à r.l.“ in „ShopWings Global S.à r.l.“

und dementsprechende Änderung des Artikels eins (1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

ShopWings Global S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“

2. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse, sodass die Gesellschaft nunmehr fünf (5) An-

teilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“), Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), Anteile

61357

L

U X E M B O U R G

der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“), Anteile der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“) und Anteile der Serie A4 (die
„Anteile der Serie A4“; die Anteile der Serie A1, die Anteile der Serie A2, die Anteile der Serie A3 und die Anteile der
Serie A4 gemeinsam die „Anteile der Serie A“).

3. Aufnahme von HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, einer Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Groß-
herzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés) unter der Nummer B 191.426, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.

4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwanzigtausendachthun-

dertsechsunddreißig Euro (EUR 20.836,00) um einen Betrag von eintausendsiebenhundertsechsunddreißig Euro (EUR
1.736,00) auf einen Betrag von zweiundzwanzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig Euro (EUR 22.572,00) durch die Aus-
gabe von eintausendsiebenhundertsechsunddreißig (1.736) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1,00).

5. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zweiundzwanzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig Euro (EUR

22.572,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 sechshundertsechsundneunzig (696) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“), und

5.1.5 eintausendsiebenhundertsechsunddreißig (1.736) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“; die Anteile der Serie A1, die Anteile der Serie A2, die Anteile der Serie A3
und die Anteile der Serie A4 im Folgenden gemeinschaftlich die „Anteile der Serie A“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

ShopWings Global S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf
sonstige Art.

61358

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zweiundzwanzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig Euro (EUR

22.572,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 sechshundertsechsundneunzig (696) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“), und

5.1.5 eintausendsiebenhundertsechsunddreißig (1.736) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“; die Anteile der Serie A1, die Anteile der Serie A2, die Anteile der Serie A3
und die Anteile der Serie A4 im Folgenden gemeinschaftlich die „Anteile der Serie A“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-

gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

61359

L

U X E M B O U R G

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung
von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter

Rocket Internet AG („Rocket“), den Gesellschafter Netris B.V. („Eiffel“), den Gesellschafter TJT (B) (Bermuda) Investment
Company Ltd. („TJT“), den Gesellschafter David W. Zalaznick („DZ“), den Gesellschafter TEC Global Invest XI GmbH
(„TEC“) und den Gesellschafter HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS („Holtzbrinck“; gemeinschaftlich mit Rocket, Eiffel,
TJT, DZ und TEC die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit einem solchen Investor verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile
oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige
Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das
Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor
oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3  bei  einer  Übertragung,  einer  Abtretung  oder  einer  anderen  Veräußerung  von  Anteilen  (i)  an  einen  Dritten,

welcher Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-

wandlungsvorgängen  gemäß  des  Umwandlungsrechts  Luxemburgs,  insbesondere  (jedoch  nicht  beschränkt  auf)  eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikeln 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten

gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen

werden, wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben
des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer

61360

L

U X E M B O U R G

im Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.

10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Ausgleichs-

zahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft
als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in

der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

12.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die

61361

L

U X E M B O U R G

Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesell-

schaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Ein-
klang mit Artikel 12.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesell-
schafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der
die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.

Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 15 Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen Mehr-

heit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.

Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit

der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:

16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;

16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.

16.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.

17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

61362

L

U X E M B O U R G

17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt wer-
den, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

19.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

20.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates
der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

61363

L

U X E M B O U R G

21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (wie unten definiert) für die unten genannten Rechts-

geschäfte und Maßnahmen im Einklang mit Artikel 24.5. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsge-
schäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des
Beirats genehmigt wurden:

21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-

wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft

an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.

Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß
§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt
15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehr-
heitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß diesem Artikel 21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteilsoder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.

21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des  Beirats  (wie  unten  definiert)  erfordern.  Der  Beirat  (wie  unten  definiert)  kann  seine  Zustimmung  für  bestimmte
Gruppen und Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls  vorhanden,  oder  von  zwei  (2)  beliebigen  Geschäftsführern  unterzeichnet.  Sofern  die  Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;

61364

L

U X E M B O U R G

sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat („Beirat“). Dieser besteht aus vier (4) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-

sellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Beirats erhöhen oder herabsetzen.

24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-

schafter festlegen und/oder verändern.

24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

24.3.1 Zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats mit je zwei (2) Stimmen werden von Rocket nach eigenem

Ermessen ernannt;

24.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von TEC nach eigenem Ermessen

ernannt; und 24.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von Holtzbrinck nach eigenem
Ermessen ernannt.

24.4 Jedes Mitglied des Beirats kann von einem anderen Mitglied des Beirats oder einem anderen Vertreter der je-

weiligen Partei vertreten werden. In diesem Fall muss bei der jeweiligen Sitzung des Beirats eine schriftliche Vollmacht
vorgelegt werden. Zu diesem Zweck sind Rocket, TEC und Holtzbrinck berechtigt, ein Ersatzmitglied für jedes Beirats-
mitglied zu ernennen.

24.5 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimm-

berechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann gegebenenfalls weitere
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalen-
derquartal.

24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
24.8 Vorbehaltlich anderer Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesell-

schaftervereinbarungen bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, hat der Beirat eine beratende Funktion und wird
nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

61365

L

U X E M B O U R G

27.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesell-
schaft verwendet werden soll.

27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Andwendbares recht

Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

7. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie

Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit unein-
geschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

8. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Namen der Gesellschaft von „Digital Services Holding XXI S.à r.l.“ in

„ShopWings  Global  S.à  r.l.“  und  dementsprechend  Artikel  eins  (1)  der  Satzung  der  Gesellschaft  zu  ändern,  welcher
nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

ShopWings Global S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Anteilsklasse zu schaffen, sodass die Gesellschaft nunmehr

fünf (5) Anteilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“), Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie
A1“), Anteile der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“), Anteile der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“) und Anteile
der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“; die Anteile der Serie A1, die Anteile der Serie A2, die Anteile der Serie A3 und
die Anteile der Serie A4 gemeinsam die „Anteile der Serie A“).

61366

L

U X E M B O U R G

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en com-

mandite simple) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, Rue Lou
Hemmer, L-1748 Findel, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
(Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 191.426, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft auf-
zunehmen.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

zwanzigtausendachthundertsechsunddreißig Euro (EUR 20.836,00) um einen Betrag von eintausendsiebenhundertsech-
sunddreißig  Euro  (EUR  1.736,00)  auf  einen  Betrag  von  zweiundzwanzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig  Euro  (EUR
22.572,00) durch die Ausgabe von eintausendsiebenhundertsechsunddreißig (1.736) Anteilen der Serie A4 mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die eintausendsiebenhundertsechsunddreißig (1.736) Anteile der Serie A4 wurden ordnungsgemäß von Holtzbrinck,

vorbenannt, zu einem Preis von eintausendsiebenhundertsechsunddreißig Euro (EUR 1.736,00) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Holtzbrinck, vorbenannt, gezeichneten eintausendsiebenhundertsechsunddreißig (1.736) Anteile der Serie A4

wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendsiebenhundertsechsunddreißig Euro (EUR
1.736,00).

Der Nachweis über die Existenz der oben bezeichneten Bareinlage wurde der unterzeichnenden Notarin erbracht.
Die Einlage in Höhe von eintausendsiebenhundertsechsunddreißig Euro (EUR 1.736,00) wird vollständig dem Gesell-

schaftskapital zugeführt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr

wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zweiundzwanzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig Euro (EUR

22.572,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 sechshundertsechsundneunzig (696) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“), und

5.1.5 eintausendsiebenhundertsechsunddreißig (1.736) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“; die Anteile der Serie A1, die Anteile der Serie A2, die Anteile der Serie A3
und die Anteile der Serie A4 im Folgenden gemeinschaftlich die „Anteile der Serie A“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der

Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt hiermit, jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kate-

gorie, sowie Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift
und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

61367

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 1.800,- geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unter-
zeichnet worden.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 février 2015. Relation: 1LAC/2015/5066. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 31. März 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015049093/1242.
(150056544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Falcon Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 121.017.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015

Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-

bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Signature
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2015049150/13.
(150056756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Fincherry S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 147.874.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015

Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-

bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Signature
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2015049154/13.
(150056759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Flagssen Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.594.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

61368

L

U X E M B O U R G

<i>Pour Flagssen Invest S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015049156/14.
(150056232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Flex Multimedia Entertainment - EMEA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 175.604.

<i>Extrait sincère et conforme de la décision du Gérant unique du 20 mars 2015 à 10 heures

Il résulte de la décision du Gérant unique que le siège social de la société est désormais situé au
39 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
au lieu du 68, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 mars 2015.

Référence de publication: 2015049157/12.
(150056933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

FMC Technologies Global Rental Tools S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 195.123.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société à Luxembourg en date du 16 mars 2015

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité de nouveaux gérants de Classe B la Société,

avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- M. Aidan Foley, né le 8 décembre 1976 à Port Láirge / Waterford, Irlande, demeurant professionnellement au 8-10,

Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, et

- M. Sébastien François, né le 4 décembre 1980 à Libramont-Chevigny, Belgique, demeurant professionnellement au

8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049159/16.
(150056190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

FRATELLI International, Société anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 184.390.

Les comptes annuels clôturés au 19 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015049162/11.
(150056914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

FRC Consult S.A.,SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 193.538.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015

Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-

bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.

61369

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Signature
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2015049163/13.
(150057020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

FVVP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5978 Itzig, 13, rue Abbé Nicolas Weyrich.

R.C.S. Luxembourg B 132.465.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015049167/10.
(150056763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

F9 B Chateau S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 185.214.

In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth of March.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

F9 International Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, with registered office at 33, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 175.014,
represented by Mr Diego Rico and Mr Vincenzo Arnò,

here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, professionally residing in L-1750 Luxembourg, 74, avenue

Victor Hugo, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on 11 

th

 March 2015,

(the Shareholder),
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholder has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of F9 B Chateau

S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B.185.214, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, dated 6 March 2014,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C N°1260 dated 16 May 2014. The articles of incor-
poration have not been amended since.

The Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Decision to amend the corporate purpose of the Company; and
2. Subsequent amendment of the articles of association of the Company.
This having been declared, the Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder decides to amend the corporate purpose of the Company.

<i>Second resolution

The Shareholder decides to amend article 2 of the articles of association of the Company which will henceforth read

as follows:

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

61370

L

U X E M B O U R G

The Company may borrow in any form and privately issue bonds or notes.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment and development of its purpose.

In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or
indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above,
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove

mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le treize mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

F9 International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 175.014, représentée par M. Diego Rico et M. Vincenzo Arnò,

ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée, le 11 mars 2015,

(l'Associé)
ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de F9 B

Chateau S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B.185.214, selon acte de Maître Martine Schaeffer du 6 mars 2014, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1260 du 16 mai 2014. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés
depuis.

L'Associé déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de modifier l'objet social de la Société; et
2. Modification subséquente des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé décide de modifier l'objet social de la Société.

<i>Seconde résolution

L'Associé décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou 4 toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations.
La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement et le développement de son objet.

En plus, la Société peut acquérir et céder des propriétés immobilières, pour son propre compte, à la fois au Grand-

Duché  de  Luxembourg  et  à  l'étranger  et  elle  peut  effectuer  toutes  les  opérations  en  relation  avec  des  propriétés

61371

L

U X E M B O U R G

immobilières, y inclus la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères
qui ont comme objet principal l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de propriétés
immobilières."

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 mars 2015. 2LAC/2015/5756. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur

 (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Référence de publication: 2015049168/110.
(150056562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

F9 B Chateau S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 185.214.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Référence de publication: 2015049169/10.
(150056912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

G.N. Research S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 114.822.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 28

janvier 2015 que la société KPMG Luxembourg, société coopérative de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège
social 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 149.133, a été nommée en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour effectuer les
travaux de revue des comptes relatifs à l'exercice social se terminant le 31 décembre 2014.

A Luxembourg, le 31 mars 2015.

<i>Pour les actionnaires
Le mandataire

Référence de publication: 2015049171/15.
(150056509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

G.W.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 146.403.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015

Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-

bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Signature
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2015049172/13.
(150057022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

61372

L

U X E M B O U R G

MEUBLES Carlo SCHEER et Cie s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 14, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 102.439.

L'an deux mille quinze, le vingt-quatre février.
Pardevant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Carlo SCHEER, commerçant, né à Wiltz le 2 février 1959, demeurant à L-9540 Wiltz, 22, avenue de la

Gare.

2.- Madame Mariette LOUES, salariée, épouse de Monsieur Carlo Scheer, née à Wiltz le 23 mars 1966, demeurant à

L-9540 Wiltz, 22, avenue de la Gare.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que suivant convention de cession de parts datée du 24 février 2015, Monsieur Marc SCHEER, commerçant, né à

Wiltz le 14 décembre 1956, demeurant à L-9651 Eschweiler/Wiltz, 23, Kraiz, propriétaire de DIX (10) parts sociales
d'une valeur nominale de DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS (€ 248,00) chacune de la société à responsabilité
limités «MEUBLES CARLO SCHEER ET CIE, S.à r.l.», avec siège social à L-9540 Wiltz, 14, avenue de la Gare, et imma-
triculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B102.439, constituée suivant acte de Maître Paul
BETTINGEN, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 22 2 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, le 24 février 1994, numéro 74 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte de Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, en date du 11 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, le 13 mai 2011, numéro 999, a cédé et transporté avec toutes les garanties de fait
et de droit, avec effet à la date de la prédite convention, DIX (10) parts sociales à Monsieur Carlo SCHEER, prénommé.

Que ladite cession de parts est par ailleurs approuvée unanimement par les associés ici réunis, représentant plus de

la majorité des parts.

Un exemplaire de la dite cession de parts, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire, restera

annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

- Que les comparants se sont ensuite réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix,

les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

En conséquence de ce qui a été déclaré ci-avant, l'assemblée décide de constater que la répartition des parts est

dorénavant la suivante:

a) Monsieur Carlo SCHEER, prénommé, cent quatre-vingt-une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
b) Madame Mariette Loues, prénommée, cent dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
TOTAL: trois cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

<i>Intervention

Le gérant, Monsieur Carlo SCHEER, prénommé, déclare accepter expressément la prédite cession de parts au nom

et pour compte de la société et dispense le cédant de les faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690
du Code Civil.

DONT ACTE, fait et passé à Beringen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, qualités et demeures,

ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. SCHEER, M. LOUES, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 février 2015. Relation: 2LAC/2015/4268. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR COPIE CONFORME.

Beringen, le 04 mars 2015.

Référence de publication: 2015049360/50.
(150056551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

61373

L

U X E M B O U R G

Meubles Marc Scheer S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7759 Mersch, 35, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 38.678.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 24 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Beringen, le 30 mars 2015.

Maître Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015049361/13.
(150056462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Meubles Marc Scheer S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7759 Mersch, 35, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 38.678.

L'an deux mille quinze, le vingt-quatre février.
Pardevant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Marc SCHEER, commerçant, né à Wiltz le 14 décembre 1956, demeurant à L-9651 Eschweiler/Wiltz, 23,

Kraiz.

2.- Madame Carine EWEN, salariée, épouse de Monsieur Marc Scheer, née à Wiltz le 22 juin 1958, demeurant à L-9651

Eschweiler/Wiltz, 23, Kraiz.

3.- Madame Sandra SCHEER, commerçante, née à Wiltz le 3 novembre 1970, demeurant à L-9651 Eschweiler/Wiltz,

11, Selscheider Paad.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que suivant convention de cession de parts datée du 24 février 2015, Monsieur Carlo SCHEER, commerçant, né à

Wiltz le 2 février 1959, demeurant à L-9540 Wiltz, 22, avenue de la Gare, propriétaire de DIX (10) parts sociales d'une
valeur nominale de DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS (€ 248,00) chacune de la société à responsabilité limités
«MEUBLES MARC SCHEER, S.à r.l.», avec siège social à L-7759 Roost, 35, Route de Mersch et immatriculée au registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro B38.678, constituée suivant acte de Maître Edmond SCHROEDER, notaire
alors  de  résidence  à  Mersch,  en  date  du  28  novembre  1991,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et
Associations, le 5 mai 1992, numéro 182 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte de Maître Henri
HELLINCKX, notaire de alors résidence à Mersch, en date du 24 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, le 3 décembre 2002, numéro 1722, a cédé et transporté avec toutes les garanties de fait et
de droit, avec effet à la date de la prédite convention, DIX (10) parts sociales à Monsieur Marc SCHEER, prénommé.

Que ladite cession de parts est par ailleurs approuvée unanimement par les associés ici réunis, représentant plus de

3/4 du capital social.

Un exemplaire de la dite cession de parts, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire, restera

annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

- Que suite à la prédite cession, la répartition des parts est dorénavant la suivante:

a) Monsieur Marc SCHEER, prénommé,
cent soixante-et-onze parts sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
b) Madame Carine EWEN, prénommée,
cent dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
c) Madame Sandra SCHEER, prénommée,
dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

TOTAL: TROIS CENTS PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

- Que les comparants se sont ensuite réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix,

les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique:

En conséquence de ce qui a été déclaré ci-avant, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

61374

L

U X E M B O U R G

“ Art. 6. Le capital social est fixé à soixante-quatorze mille quatre cents Euros (EUR 74.400,-), représentée par trois

cents (300) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit Euros (EUR 248,-) chacune.”

<i>Intervention

Le gérant, Monsieur Marc SCHEER, prénommé, déclare accepter expressément la prédite cession de parts au nom et

pour compte de la société et dispense le cédant de les faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690
du Code Civil.

DONT ACTE, fait et passé à Beringen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, qualités et demeures,

ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. SCHEER, C. EWEN, S. SCHEER, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 février 2015. Relation: 2LAC/2015/4267. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

POUR COPIE CONFORME

Beringen, le 04 mars 2015.

Référence de publication: 2015049362/59.
(150056463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Mike S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 111.127.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 30 janvier 2015 suivie d'une réunion du

<i>conseil d'administration

L'assemblée générale ainsi que le conseil d'administration ont décidé de de nommer Monsieur Bernard MOXHET,

gestionnaire d'entreprise, demeurant à B-7030 Saint-Symphorien, 19 rue Félix Maigret de Priches en tant que deuxième
administrateur-délégué. Son mandat est pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Administrateur-délégué

Référence de publication: 2015049364/14.
(150056997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Minerals &amp; Resources Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.227.

En date du 4 février 2015, la Société a désigné la société SGG S.A., ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg, comme dépositaire au sens de l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative au dépôt obligatoire et à
l'immobilisation des actions et des parts au porteur.

Certifié sincère et conforme
MINERALS &amp; RESOURCES MANAGEMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015049365/14.
(150056473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Miran S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 149.110.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015

Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-

bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.

61375

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Signature
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2015049366/13.
(150056750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Miso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 186.814.

<i>Extrait de la décision collective du 27 mars 2015

<i>Premier résolution

L'assemblée accepte à l'unanimité les cessions de parts sociales du 3 mars 2015 comme suit:
Monsieur Muping DONG, cuisinier, né à Fujian (République Populaire de Chine), le 25 août 1983 demeurant à L-3260

Bettembourg, 113, route de Mondorf, détenant 80 parts sociales, vend et cède 50 parts sociales à Monsieur Tianming
XU, cuisinier, né à Zheijiang (République Populaire de Chine) le 17 novembre 1972, demeurant à L-1266 Luxembourg,
3, rue Jean-Pierre Beckius et 30 parts sociales à Madame Fung Yee CHAN, serveuse, née à Hong Kong (République
Populaire de Chine) le 10 novembre 1969, demeurant à L-1266 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Beckius.

Monsieur Ka Wing CHEUNG, cuisinier, né à Hong Kong (République Populaire de Chine), le 30 juin 1970, demeurant

à L-1617 Luxembourg, 72, rue de Gasperich, vend et cède ses 20 parts sociales à Madame Fung Yee CHAN, serveuse,
née à Hong Kong (République Populaire de Chine) le 10 novembre 1969, demeurant à L-1266 Luxembourg, 3, rue Jean-
Pierre Beckius.

Suite à cette cession, la nouvelle répartition du capital social est la suivante:
Monsieur Tianming XU, cuisinier, né à Zheijiang (République Populaire de Chine) le 17 novembre 1972, demeurant à

L-1266 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Beckius, détient 50 parts sociales, soit 50% du capital social.

Madame Fung Yee CHAN, serveuse, née à Hong Kong (République Populaire de Chine) le 10 novembre 1969, de-

meurant à L-1266 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Beckius, détient 50 parts sociales, soit 50% du capital social.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Tianming XU, cuisinier, né à Zheijiang (République Populaire

de Chine) le 17 novembre 1972, demeurant à L-1266 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Beckius, gérant technique de la
société en remplacement de Monsieur Ka Wing CHEUNG et de nommer Madame Fung Yee CHAN, serveuse, née à
Hong Kong (République Populaire de Chine) le 10 novembre 1969, demeurant à L-1266 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre
Beckius, gérante administrative de la société en remplacement de Monsieur Muping DONG.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité que la société est dorénavant avec effet immédiat engagée par la signature individuelle

du gérant technique.

Pour extrait conforme
Fidcoserv S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015049367/37.
(150056413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

MMA INT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 117.189.

Par la présente, nous sommes au regret de vous annoncer notre décision de démissionner avec effet immédiat de nos

fonctions de commissaire aux comptes de votre société.

Luxembourg, le 17 mars 2015.

Marc Muller Conseils S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015049368/12.
(150056994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

61376

L

U X E M B O U R G

Moon International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 66.836.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015

Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-

bourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Signature
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2015049370/13.
(150057030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nolan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 188.642.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 mars 2015

En date du 24 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de prendre note du décès de Monsieur Hiroyuki Rex SATO, gérant A de la Société, en date du 7 mars 2015;
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Anne Catherine GRAVE de son mandat de gérant B de la Société

avec effet au 31 mars 2015;

- de nommer Madame Antonella GRAZIANO, née le 20 janvier 1966 à Orvieto, Italie, résidant à l'adresse profes-

sionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 31 mars
2015 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Madame Sonia BALDAN, née le 27 janvier 1960 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant

à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant B de la Société
avec effet au 31 mars 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur John FOSINA, gérant A
- Monsieur Christian REYNTJENS, gérant A
- Monsieur Christophe AURAND, gérant A
- Madame Catherine KOCH, gérant B
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant B
- Madame Sonia BALDAN, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nolan S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015049375/30.
(150056577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 143.334.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 30 Mars 2015

Il résulte dudit procès-verbal que:
1) L'Assemblée prend note de la démission de M. Claus Jørgensen à compter du 27 août 2014.
2) L'Assemblée a décidé de réélire en tant qu'administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir

en 2016:

- Kim Pilgaard résidant à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

61377

L

U X E M B O U R G

- Suzanne Berg résidant à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg
- Jesper Nørgaard résidant à Strandgade 3, DK-0900 Copenhague, Danemark
3) L'Assemblée a décidé d'élire au poste de réviseur d'entreprises pour l'exercice social 2015 et jusqu'à la prochaine

assemblée générale ordinaire à tenir en 2016:

- PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Investment Funds S.A.

Référence de publication: 2015049377/21.
(150056683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 143.334.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Investment Funds S.A.

Référence de publication: 2015049378/12.
(150056687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Multi Label, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 131.121.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 30 Mars 2015

Il résulte dudit procès-verbal que:
1) L'Assemblée prend note de la cooptation en tant qu'administrateur, avec effet au 27 Août 2014 de:
- Mr Nils BOLMSTRAND résidant à Mäster Samuelsgatan 20, SE-10571 Stockholm, Suède
en remplacement de:
- Mr Claus JØRGENSEN résidant à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg
2) L'Assemblée a décidé de réélire en tant qu'administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir

en 2016:

- Suzanne Berg résidant à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
- Kim Pilgaard résidant à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
- Mr Nils Bolmstrand résidant à Mäster Samuelsgatan 20, SE-10571 Stockholm, Suède
3) L'Assemblée a décidé d'élire au poste de réviseur d'entreprises pour l'exercice social 2015 et jusqu'à la prochaine

assemblée générale ordinaire à tenir en 2016:

- PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Investment Funds S.A.

Référence de publication: 2015049380/23.
(150056682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Multi Label, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 131.121.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Investment Funds S.A.

Référence de publication: 2015049381/11.
(150056686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

61378

L

U X E M B O U R G

Nordic Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 669.587,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 187.372.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique datées du 30 mars 2015

En date du 30 mars 2015, l'associé unique de la Société a décidé de révoquer PMI Services S.à r.l. en tant que gérant

de classe A avec effet immédiat et de le nommer en tant que gérant de classe B avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015049383/16.
(150056853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Northland Power Euro Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 183.889.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 30 mars 2015.

Référence de publication: 2015049384/10.
(150056266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

NB Queen S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 116.069.

Les comptes annuels au 26 Juillet 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour NB QUEEN S.à r.l.

Référence de publication: 2015049387/10.
(150056537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Alternative Investment, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 106.173.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 16 Mars 2015

Il résulte dudit procès-verbal que:
1) Le Président de l'Assemblée a fait part de l'indisponibilité des Administrateurs suivants pour un nouveau mandat:
Mr Jhon Mortensen résidant à 20, rue Jean Berteis, L-1230 Luxembourg, Luxembourg
Mrs Eira Palin-Lehtinen résidant à Pohjoinen Hesperiankatu 5 A 24, FI-00260 Helsinki, Finlande
2) L'Assemblée a décidé de réélire en tant qu'administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir

en 2016:

Mr André Roelants résidant à 42, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg
Mr Nils Bolmstrand résidant à Mäster Samuelsgatan 20, SE-10571 Stockholm, Suède
Mr Lars Grønborg Eskesen résidant à Bredgade 77, DK-1260 Copenhague, Danemark
Mr Alex Schmitt résidant à 22-24, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Luxembourg
Mr Snorre Storset résidant à Smålandsgatan 17, SE-10571 Stockholm, Suède

61379

L

U X E M B O U R G

Mr Niels  Thygesen  résidant à  University  of  Copenhagen, Building 26,  Department of Economics,  Farimagsgade 5,

DK-1353 Copenhague, Danemark

3) L'Assemblée a décidé d'élire en tant qu'administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en

2016, sous réserve d'approbation par la CSSF:

Mr Claude Kremer résidant à 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Luxembourg
Mr Thorben Sander résidant à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg
4) L'Assemblée a décidé d'élire au poste de réviseur d'entreprises pour l'exercice social 2015 et jusqu'à la prochaine

assemblée générale ordinaire à tenir en 2016:

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Investment Funds S.A.

Référence de publication: 2015049392/30.
(150056685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Dedicated Investment Fund Sicav-Fis, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 150.516.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nordea Investment Funds S.A.

Référence de publication: 2015049393/12.
(150057008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Nova Marine Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 186.147.

EXTRAIT

Comme décidé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 2015, la Société prend acte de la nomination,

avec effet au 10 mars 2015 et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels au 30 septembre
2036, de:

- Monsieur Giovanni Romeo Di Santillo, Administrateur et Président, né le 26 juillet 1956 à Monte di Procida (Italie)

et demeurant au 40, via Tesserete, CH-6900 Lugano;

- Monsieur Antonio Quaratino, Administrateur, né le 17 février 1982 à Caserta (Italie) et demeurant professionnel-

lement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

La Société prend également acte que Monsieur Paolo Foti, actuel Administrateur, est nommé en tant que Vice-Prési-

dent.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015049396/19.
(150056559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Novellus Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 84.359.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of March.
Before Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- Lombard International Assurance S.A., having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, re-

gistered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 37604,

61380

L

U X E M B O U R G

here represented by Géraldine Nucera, employee, residing professionally in Hesperange,
by virtue of a power of attorney under private seal issued on February 13 

th

 , 2015, Such proxy, after signature “ne

varietur” by the proxyholder and by the undersigned notary will remain attached to the present minutes for the purpose
of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact that:
I.- the appearing party has become the sole owner of the total shares issued of NOVELLUS FUND, société d'inves-

tissement à capital variable, (the «Company»), having its registered office in L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen,
incorporated by deed of notary Gérard LECUIT, then residing in Hesperange, on November 8 

th

 , 2001, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») number 1121 of December 6 

th

 , 2001. The articles of

Association have been modified for the last time by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg
on May 5 

th

 , 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1073 of May 21 

st

 , 2011;

- the Company is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 84.359.
II.- the Company has been incorporated with an initial subscribed share capital of thirty-two thousand Euro (EUR

32,000.-) represented by six thousand eight hundred ninety-six point fifty-five (6.896,55) capitalisation shares of the class
NOVELLUS FUND - LOMBARD EQUITY STRATEGY with no par value, fully paid up.

III.- the appearing party herewith expressly declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect

and to act as liquidator of the Company;

IV.- the appearing party declares having full knowledge of the bylaws of the Company and is perfectly aware of the

financial situation of the Company and that the Company's activities have ceased;

V.- the appearing party, being sole owner of the shares and liquidator of the Company, hereby declares:
i. that all assets have been realised and/or that all assets are to become the property of the sole shareholder;
ii. that all liabilities towards third parties known to the Company shall be taken over by the Shareholder and/or that

all liabilities towards third parties actually known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

iii. regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and outstanding today, that it will irrevocably

assume the obligation to pay for such liabilities, with the result that the liquidation of the Company is to be considered
closed;

iv. that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the exercise of their

mandates;

v. that the corporate books and accounts of the Company shall be kept during a period of five years at the former

registered office.

vi. that the shareholder's register of the Company shall be cancelled.
However, the Company's assets shall not be mixed with the assets of nor attributed to the capital of the sole share-

holder before the expiry of 30 days from the date of publication of the present deed (article 69(2) of the law on commercial
companies) and provided that during this period no person declares himself as creditor of and demands payment of any
outstanding debt due from the Company hereby dissolved.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French Text, the English version will prevail.

Whereof, the present deed is drawn up in Hesperange, in the notary's office, on the day named at the beginning of

this document.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, said person signed together with us, the

Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil quinze, le douze mars.
Pardevant Maître Martine DECKER notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

- Lombard International Assurance S.A., ayant son siège social au 4, rue Lou Hemmer L-1748 Luxembourg, immatri-

culée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37604,

ici représentée par Géraldine Nucera, demeurant professionnellement à Hesperange,
en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée le 13 février 2015,
laquelle procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I.- la comparante est devenue propriétaire de la totalité des actions de NOVELLUS FUND, société d'investissement

à capital variable, (la «Société»), ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen, constituée suivant acte

61381

L

U X E M B O U R G

reçu  par  Maître  Gérard  LECUIT,  notaire  alors  de  résidence  à  Hesperange,  en  date  du  8  novembre  2001,  publié  au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1121 du 6 décembre 2001. Les statuts de la Société ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 mai
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1073 du 21 mai 2011;

- la Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84359.
II.- la Société a été constituée avec un capital social initial souscrit de trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté

par six mille huit cent quatre-vingt-seize virgule cinquante-cinq (6.896,55) actions de capitalisation de la classe d'actions
NOVELLUS FUND - LOMBARD EQUITY STRATEGY sans valeur nominale;

III.- la comparante prononce présentement la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et d'agir en qualité

de liquidateur;

IV.- la comparante déclare avoir pleinement connaissance des statuts de la Société et en connaître la situation financière

et que l'activité de la Société a cessé;

V.- la comparante agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société qu'en tant qu'actionnaire unique déclare:
i. que tous les actifs ont été réalisés et/ou que tous les actifs à devenir la propriété de l'actionnaire unique;
ii. que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été pris en charge par l'actionnaire unique et/ou que

tous les passifs actuellement connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

iii. par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la Société et non payés à l'heure actuelle, assumer

irrévocablement l'obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;

iv. que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société, pour

l'exercice de leurs mandats respectifs;

v. que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à l'ancien siège social;
vi. qu'il sera procédé à l'annulation du registre aux actions de la Société.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à l'action-

naire unique ne pourra se faire avant l'expiration du délai de trente jours à compter de la publication du présent acte
(article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement
dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom et prénom, état et

demeure, il a signé ensemble avec nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Nucera, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8446. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 31 mars 2015.

Référence de publication: 2015049397/106.
(150056364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

NPF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 120.079.

Les comptes consolidés de CBRE Nordic Property Fund au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015049399/13.
(150056842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

61382

L

U X E M B O U R G

NYK Hummingbird S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 195.765.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twelfth of March.
Before Us Maître Kesseler, notary, residing in 5, rue Zenon Bernard, L- 4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Lu-

xembourg.

THERE APPEARED:

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, a company limited by shares (Kabushiki Kaisha) established and existing under the

laws of Japan, having its registered office at 3-2, Marunouchi, 2-Chome, Chiyoda-ku, 100-0005 Tokyo, Japan, and registered
with the Tokyo Legal Affairs Bureau under number 0100-01-023785,

here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, having her professional address at 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given on March 5,2015.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the deed of

establishment of a private limited liability company with the following articles of association:

Art. 1.  There  exists  a  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  under  the  name  of  NYK

Hummingbird S.à r.l., which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and
in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by
the present articles of association (hereinafter, the Articles).

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of
such participating interests, in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio

consisting of any securities and intellectual property rights of whatever origin and participate in the creation, development
and control of any enterprises. It may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to
purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, have them developed and
realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies

or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the
Company belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transac-

tions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly
connected with its purpose or which promote its development.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give
guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries,
affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over all or some of its assets.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the

Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the
general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 5. The subscribed share capital is set at fifteen thousand United States Dollars (USD 15.000,00) represented by

fifteen thousand (15.000) shares with a nominal value of one United States Dollar each (USD 1,00) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.
Any share premium paid on top of the nominal value of any share at issuance shall be allocated to the share premium

account. Any share premium so paid upon subscription for any shares shall be deemed to be automatically attached and
shall always remain attached to the shares in respect of which it has been paid, and shall be reimbursed or otherwise

61383

L

U X E M B O U R G

distributed solely to the owner of such shares at the time of such reimbursement or distribution, who shall have exclusive
rights to such premium.

There shall also be a special equity reserve account (account 115 “apport en capitaux propres non rémunérés par des

titres” of the Luxembourg Chart of Accounts provided for by the Grand Ducal regulation of 10 June 2009), into which
equity contributions may also be made without the issuance of shares. Any amount paid and allocated to the special equity
reserve account by a shareholder shall always remain attached to the shares held by such shareholder on which it has
been allocated, and shall be reimbursed or otherwise distributed solely to the owner of such shares at the time of
reimbursement or distribution, who shall have exclusive rights to such special equity reserve amount.

Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the

shareholders' meeting, in accordance with Article 14.

Art. 7. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the
Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.

Art. 8. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In case of a plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with

article 189 of the Law.

Art. 9. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the sole shareholder or of any of the shareholders.

Art. 10. The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have

been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers). The manager(s) need not be
shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder
or of the shareholders holding more than half of the share capital.

Art. 11. In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the

name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company's purpose, provided that the terms of this Article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within

the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the signature of the Sole Manager or, in case of plurality of

managers, by the joint signature of any two (2) managers.

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the right to grant special proxies for determined matters to

one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

Art. 12. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-today management of the Company to one

or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any),
the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among the managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires. The meetings of the Board of

Managers are convened by the chairman, the secretary or by any manager at the place indicated in the convening notice.
The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to

all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date and time set for such meeting, except in case of
emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of
the Board of Managers.

No such convening notice is required if all members of the Board of Managers are present or represented at the

meeting and if they state to have been duly informed, and agree on the agenda of the meeting. The notice may be waived
by consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several

managers.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or repre-

sented by proxy, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority of the members of the
Board of Managers.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

61384

L

U X E M B O U R G

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a

meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by each of the members of the Board of
Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders on the basis of

a statement of accounts showing that sufficient profits are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward
profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be
established according to the Law or these Articles.

Art. 13. The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commit-

ment validly made by her/him/them in the name of the Company.

Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles and other specific decisions as defined by the Law may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the
provisions of the Law.

Art. 15. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the

same year.

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the Sole Manager or the

Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.
This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share

capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever,
the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their

shareholding in the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the

last paragraph of Article 17.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December of the same year.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, all the shares have been subscribed by Nippon Yusen Kabushiki

Kaisha, prenamed, and fully paid up in nominal value by contribution in cash together with contributions to the legal
reserve and special equity reserve account of the Company (account 115 “apport en capitaux propres non rémunérés
par des titres” of the Luxembourg Chart of Accounts provided for by the Grand Ducal regulation of 10 June 2009) as
follows:

Contribution in cash (USD)

Number

of Shares

Book

value

Aggregate

amount

Shares payment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000

1,00

15.000,00

Legal reserve allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

1.500,00

Account 115 allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

83.500,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000

- 100.000,00

The amount of one hundred thousand United States Dollars (USD 100.000,00) has been fully paid up in cash and is

now available to the Company.

61385

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at 1,700.- euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mr. Hiroaki Nishiyama, Managing Director, born on June 15, 1966 in Tokyo, Japan, residing at 31 Margin Drive,

Wimbledon, London SW19 5HA, UK; and

- Mr. Richard Beyer, Director, born on October 14, 1969 in York, the United-Kingdom, with professional address at

City Point, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9NY, the United-Kingdom.

2. The address of the registered office of the Company is fixed at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, it signed together with Us, notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le douze mars.
Par-devant Nous, Maître Kesseler, notaire de résidence à 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-

Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, une société par actions (Kabushiki Kaisha) établie et existant en vertu des lois du

Japon, ayant son siège social au 3-2, Marunouchi, 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japon, et immatriculée auprès
du Bureau des Affaires Juridiques de Tokyo sous le numéro 0100-01-023785,

ici représenté par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée le 5 mars 2015.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de NYK Hummingbird S.à r.l. qui est régie

par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-

tions  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise,  ainsi  que  l'administration,  la  gestion,  le  contrôle  et  le
développement de ces participations, au Grand Duché de Luxembourg et à l'étranger.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, et participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire
mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou

entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société
(notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-

mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directe-
ment ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, unique-

ment par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts,
convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La

61386

L

U X E M B O U R G

Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respec-

tivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou
par une résolution de l'assemblée générale des associés, suivant les dispositions applicables de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société s'élève à quinze mille Dollars Américains (USD 15.000,00) représenté par quinze

mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.
Toute prime d'émission versée en plus de la valeur nominale de toute part sociale émise sera allouée au compte de

prime d'émission. Toute prime d'émission ainsi versée lors de la souscription de parts sociales sera considérée comme
étant automatiquement attachée et restera toujours attachée aux parts sociales sur lesquelles la dite prime a été payée
et sera remboursable ou distribuable exclusivement au détenteur de ces parts sociales au moment d'un tel rembourse-
ment ou d'une telle distribution, celui-ci disposant de droits exclusifs sur cette prime.

Un compte d'apport en capitaux propres non rémunérés par des titres pourra aussi être créé (compte 115 «apport

en capitaux propres non rémunérés par des titres «du Plan Comptable Luxembourgeois créé par le règlement Grand-
Ducal du 10 juin 2009), au sein duquel des apports en capital pourront être réalisés sans émission de part sociale. Tout
apport payé et versé sur le compte d'apport en capitaux propres non rémunérés par des titres par un associé restera
attachée aux parts sociales sur lesquelles ledit apport a été versé, et sera remboursable ou distribuable exclusivement au
détenteur de ces parts sociales au moment d'un tel remboursement ou d'une telle distribution, celui-ci disposant de droits
exclusifs sur cet apport.

Art. 6. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés, conformément à l'Article 14 des Statuts.

Art. 7. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité
de propriétaires d'une part sociale, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul
propriétaire soit désigné.

Art. 8. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que conformément à l'article 189 de la Loi.

Art. 9. La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 10. La Société est gérée par un gérant unique (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants

sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas
obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une
décision de l'associé unique ou des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Art. 11. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom

de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet
social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent Article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de

la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs

mandataires, gérants ou non, associés ou non.

Art. 12. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs

gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires,
la durée de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant

est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

61387

L

U X E M B O U R G

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Les réunions du Conseil de Gérance

sont convoquées par le président, le secrétaire ou par tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le Conseil
de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par téléfax ou courrier électronique, de toute réunion du

Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date et heure prévues pour la réunion, sauf en cas d'ur-
gence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de
Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont

présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et approuvent
son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit
donné soit en original, soit par téléfax ou courrier électronique.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente

ou représentée par procurations, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple des membres du
Conseil de Gérance.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre

moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement.
Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par chacun les membres du Conseil
de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état

comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des bénéfices suffisants sont
disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ou autres résolutions spécifiques définies par la loi ne peuvent être

adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux pre-
scriptions de la Loi.

Art. 15. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le

Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,

mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la

Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application du dernier alinéa de

l'Article 17.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

61388

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

de la même année.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales ont été souscrites par Nippon Yusen Kabushiki

Kaisha, prénommée, et intégralement libérées en valeur nominale par apport en numéraire, ensemble avec une contri-
bution aux comptes de réserve légale et d'apport en capitaux propres non rémunérés par des titres de la Société (compte
115 «apport en capitaux propres non rémunérés par des titres «du Plan Comptable Luxembourgeois créé par le règlement
Grand-Ducal du 10 juin 2009) comme suit:

Apport en numéraire (USD)

Nombre

de parts

Valeur

nominale

Montant

total

Libération des parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000

1,00

15.000,00

Allocation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

1.500,00

Allocation au compte 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

83.500,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000

- 100.000,00

Le montant de cent mille Dollars Américains (USD 100.000,00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve

dès à présent à la libre disposition de la Société.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.500 euros.

<i>Décisions de l'associé unique

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
-  M.  Hiroaki  Nishiyama,  administrateur  général,  né  le  15  juin  1966  à  Tokyo,  Japon,  résidant  au  31  Margin  Drive,

Wimbledon, London SW19 5HA, Royaume-Uni; et

- M. Richard Beyer administrateur, né le 14 octobre 1969 à York, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au

City Point, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9NY, Royaume-Uni.

2. L'adresse du siège social est fixée au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec Nous,

notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 mars 2015. Relation: EAC/2015/6651. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015049401/369.
(150056813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Optimiz Advices S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, zone d'activité Zare,Ilot Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 195.750.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Monsieur Michael GROSSE, employé privé, né à Metz, (France), le 17 janvier 1982, demeurant à F-57255 Sainte Marie

aux Chênes, 31, rue des d'Ars, (France),

61389

L

U X E M B O U R G

- Madame Michèle SAULNIER, retraitée, née à Saint-Dié-des-Vosges, (France), le 5 août 1958, demeurant à F-57050

Longeville les Metz, 2, rue du Stade, (France)

Tous les deux représentés par Monsieur Henri DA CRUZ, employé privé, demeurant professionnellement à Junglins-

ter, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdite procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y
relatives ainsi que par les présents statuts, lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles
s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes prestations de services dans le domaine de la comptabilité, le conseil économique,

la gestion journalière et l'assistance dans le domaine de la fiscalité, la tenue, le contrôle et la vérification des livres et
pièces comptables. D'une manière générale, la société peut réaliser toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation. La société a également vocation à procurer des services
de conseils généraux et d'intermédiation.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit pas spécialement

réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et im-
mobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, et, en vue de favoriser le développement de sa participation ainsi créée, elle peut apporter tout
soutien financier ou même sa caution.

Art. 3. La société prend la dénomination de «OPTIMIZ ADVICES S.à r.l.»

Art. 4. Le siège social est établi à Ehlerange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-

cinq (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (125,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés en conformité avec l'article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La société ne sera pas dissoute par suite de décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés

par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

En tant que simple mandataire de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables
que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société

61390

L

U X E M B O U R G

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées
par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération des parts sociales

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales comme

suit:

Monsieur GROSSE Michael, prédésigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Madame SAULNIER Michèle, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cent euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent soixante-dix euros.

<i>Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-4384 Ehlerange, Zone d'activité Zare, Ilot Ouest.
2.- Madame Laure RAFFAELLI, épouse GROSSE, employée privée, née à Saint-Dié des Vosges, (France), le 20 mai

1982, demeurant à F-57255 Sainte Marie aux Chênes, 31, rue d'Ars, (France), est nommée gérante de la société pour
une durée indéterminée.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu'il agit, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 mars 2015. Relation GAC/2015/2554. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015049410/113.
(150056641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

61391

L

U X E M B O U R G

Optique New Look, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 55.507.

EXTRAIT

Le mandat de Monsieur Alain SCHRANK au poste de gérant administratif et commercial est révoqué.
La société sera en toutes circonstances valablement engagée par la signature conjointe de la gérante technique et de

la gérante commerciale et administrative.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2015.

OPTIQUE NEW LOOK S.A.R.L.
<i>MAÎTRE OPTICIEN
17-19 avenue de la Libération
L-3850 SCHIFFLANGE
Signature

Référence de publication: 2015049411/18.
(150056334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Freedom Luxembourg Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.508.250,39.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 178.831.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société en date du 30 mars 2015

Il a été décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Diogo Alves en tant que gérant B de la Société avec effet au 4 mars 2015,
- de nommer Monsieur Vito Marinelli, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

en tant que gérant B avec effet immédiat pour une période illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015049147/14.
(150056867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

G-E-O S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6850 Manternach, 1A, Op der Gare.

R.C.S. Luxembourg B 169.061.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 30 mars 2015.

Référence de publication: 2015049173/10.
(150056267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Cooper Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.090.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 180.038.

Le nom du gérant de classe B de la Société est désormais Jennifer Brown Mello.

Luxembourg, le 31 Mars 2015.

Référence de publication: 2015049061/10.
(150056894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

61392


Document Outline

Cooper Holdings S.à r.l.

Digital Services Holding XXI s.à r.l.

F9 B Chateau S. à r. l.

F9 B Chateau S. à r. l.

Falcon Holding S.A.

Fincherry S.A.

Flagssen Invest S.A.

Flex Multimedia Entertainment - EMEA S.à r.l.

FMC Technologies Global Rental Tools S.à.r.l.

FRATELLI International, Société anonyme

FRC Consult S.A.,SPF

Freedom Luxembourg Investor S.à r.l.

FVVP S.A.

G-E-O S.à r.l.

G.N. Research S.A.

G.W.T. S.A.

MEUBLES Carlo SCHEER et Cie s.à r.l.

Meubles Marc Scheer S.àr.l.

Meubles Marc Scheer S.àr.l.

Mike S.A.

Minerals &amp; Resources Management S.A.

Miran S.A.

Miso S.à r.l.

MMA INT S.A.

Moon International Luxembourg S.A.

NB Queen S. à r.l.

Nolan S.à r.l.

Nordea Alternative Investment

Nordea Dedicated Investment Fund Sicav-Fis

Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS

Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FIS

Nordea Multi Label

Nordea Multi Label

Nordic Properties S.à r.l.

Northland Power Euro Wind S.à r.l.

Nova Marine Holding S.A.

Novellus Fund

NPF Soparfi A S.à r.l.

NYK Hummingbird S.à r.l.

Optimiz Advices S.à.r.l.

Optique New Look

ShopWings Global S.à r.l.