logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1228

12 mai 2015

SOMMAIRE

Aerospace Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

58902

Carnegie Fund Management Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58909

Carnegie Fund Services S.A.  . . . . . . . . . . . .

58911

Centaurus C.E.R. (Aviva Investors) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58911

Cite Cube S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58912

CNH Industrial Europe Holding S.A. . . . . .

58912

CNH Industrial Finance Europe S.A.  . . . . .

58912

Cool Runnings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58909

Decodesign S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58904

Devonshire Point Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

58913

Devonshire Point Investment S.à r.l.  . . . . .

58913

Digital Services XVIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

58906

Digital Services XXVII (GP) S.à r.l.  . . . . . .

58906

EnBW Baltic 2 Management S.à r.l.  . . . . . .

58914

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA So-

ciété à responsabilité limitée  . . . . . . . . . . .

58914

Financial Ridge S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58922

Fonds Interculturel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58898

Gemissy SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58903

Globavia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58906

Impact Capital Partners V, LP . . . . . . . . . . .

58907

La Française AM Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58908

La Française LUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58908

Londac No. 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58908

Lux Armature & Construction S.à r.l.  . . . .

58910

Luxembourg Pony Holdings S.à.r.l.  . . . . . .

58923

Lux-Log S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58904

ODIN LuxCo 12 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58899

Orion IV European 32 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

58899

RS Pose d'Armatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58910

Russian Acquisition Company N°2 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58910

Seawind S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58933

SEGRO European Logistics Partnership

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58937

SEGRO Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

58940

SELP (France) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58942

Spain Residential Finance S.à r.l. . . . . . . . . .

58910

SSI Schäfer Shop GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . .

58901

Taurus Euro Logistics Investment Sàrl  . . .

58902

The Building Block Equity Fund S.A., SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58923

Trustconsult Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

58902

X Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58944

58897

L

U X E M B O U R G

Fonds Interculturel, Fondation.

Siège social: L-1922 Luxembourg, 10-12, rue Auguste Laval.

R.C.S. Luxembourg G 159.

<i>Bilan 2014

ACTIF

PASSIF

Actif circulant

Résultat reportés

BGLL LU43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.934,55 Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.161,571

BCEE LU69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.297,40

CCPL LU88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.215,67 Dettes

FORUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.972,70

ASTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.497,72

CLAE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

631,72

Créances

Amit. Port.-Luxbg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.127,00

ALOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

ALOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58,80 KN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313,60

AEHD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

632,10

Résultat de l'exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170,01

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.506,42 TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.506,42

<i>Profit &amp; Perte 2014

Débit

Crédit

Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.376,84 Forum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.376,84

ASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.937,74 ASTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.937,74

CLAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.378,44 CLAE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.378,44

ALOS-LDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.680,00 ALOS-LDH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.680,00

Amitiés Port.-Luxbg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.650,00 Amitiés. Port.-Luxbg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.650,00

AEHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

950,00 AEHD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

950,00

Kannemascht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

820,00 Kannemascht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

820,00

Frais timbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66,60 Recettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

975,85

Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,65 Intérêts créditeurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Indemnités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

610,00

Frais administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108,59 Résultat Fonds Interc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-170,01

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.598,86 TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.598,86

<i>Projet de budget 2015

RECETTES

DEPENSES

Dons pour FORUM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 Dons pour FORUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 000

Dons pour ASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 500 Dons pour ASTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 500
Dons pour CLAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 Dons pour CLAE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000

Dons pour ALOS-LDH . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1600 Dons pour ALOS-LDH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 600

Dons pour APL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 600 Dons poor APL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 600

Dons AEDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Dons AEDH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

Dons KANNERNASCHT . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Dons KANNERNASCHT  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 400 TOTAL:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 400

Luxembourg, le 09 février 2015.

<i>Les membres du conseil d'Administration

Référence de publication: 2015045082/48.

(150051362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

58898

L

U X E M B O U R G

ODIN LuxCo 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Orion IV European 32 S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11/13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 191.662.

In the year two thousand and fifteen, on the twelfth of February,
before us Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Orion IV European 25 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share

capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 11/13, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 189080 (the “Shareholder”),

hereby represented by Mrs Rachel Blaise, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 12 February 2015,
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Orion

IV European 32 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of
twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 11/13, boulevard de la Foire, L-1528 Lu-
xembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  incorporated  following  a  deed  of  Maître  Marc  Loesch,  notary,  residing  in
Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, of 30 October 2014, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations of 3 December 2014 number 3699, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 191662 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not been amended
since its incorporation.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To change the Company's name into "ODIN LuxCo 12 S.à r.l.".
2 To amend the second (2 

nd

 ) paragraph of article one (1) of the Company's articles of association in order to reflect

the resolution to be adopted under item one (1) of the agenda.

3 To amend the third (3 

rd

 ) paragraph and fifth (5 

th

 ) paragraph of article ten (10) of the Company's articles of

association in order to allow the delegation of powers to any appointed manager or other officer.

4 Miscellaneous.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to change the Company's name into "ODIN LuxCo 12 S.à r.l.".

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to amend the second (2 

nd

 ) paragraph of article one (1) of the Company's articles of

incorporation which shall forthwith read as follows:

"The Company will exist under the name of ODIN LuxCo 12 S.à r.l.".

<i>Third resolution

The Shareholder resolves to amend the third (3 

rd

 ) paragraph and fifth (5 

th

 ) paragraph of article ten (10) of the

Company's articles of incorporation which shall forthwith read as follows:

“The board may further delegate specific powers to any manager(s) or other officer(s).”
“Without prejudice to the foregoing powers, all acts binding the Company and all powers and mandates must be signed

by any two managers or by any person(s) to whom signatory authority has been delegated by the managers.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

58899

L

U X E M B O U R G

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by her surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le douze février,
par devant nous Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Orion IV European 25 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital

social de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 11/13, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 189080 (l’«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Madame Rachel Blaise, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 12 février 2015.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L’Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l’Associé est le seul et unique associé de Orion IV European

32 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 11/13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 30 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le
numéro 3699 du 3 décembre 2014 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 191662 (la «Société»). Les statuts n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Modification de la dénomination de la Société en «ODIN LuxCo 12 S.à r.l.».
2 Modification de l'article premier (1 

er

 ), deuxième (2 

e

 ) alinéa, des statuts de la Société de manière à refléter la

résolution à adopter au point un (1) de l'ordre du jour.

3 Modification de l'article dix (10), troisième (3 

e

 ) et cinquième (5 

e

 ) alinéas, des statuts de la Société afin de permettre

la délégation de pouvoirs à tout gérant ou fondé de pouvoir nommé.

4 Divers.
L’Associé a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé décide de modifier la dénomination de la Société en «ODIN LuxCo 12 S.à r.l.».

<i>Deuxième résolution

L'Associé décide de modifier l'article premier (1 

er

 ), deuxième (2 

ème

 ) alinéa des statuts de la Société qui sera

dorénavant rédigé comme suit:

«La Société existe sous la dénomination de ODIN LuxCo 12 S.à r.l.».

<i>Troisième résolution

L'Associé décide de modifier l'article dix (10), troisième (3 

e

 ) et cinquième (5 

e

 ) alinéas des statuts de la Société qui

seront dorénavant rédigés comme suit:

«Il peut aussi déléguer des pouvoirs spécifiques à tout gérant(s) et fondé(s) de pouvoirs.»
«Sans préjudice des pouvoirs de délégation susmentionnés, tous les actes qui engagent la Société, tous les pouvoirs et

toutes les procurations doivent être signés par deux gérants, ou par la/les personne(s) à qui un pouvoir de signature aura
été délégué par les gérants.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

58900

L

U X E M B O U R G

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: R. Blaise, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 février 2015. GAC/2015/1363. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. PIERRET.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 23 mars 2015.

Référence de publication: 2015045300/116.
(150051797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

SSI Schäfer Shop GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, 16, ZI Zare Ilôt Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 191.710.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebzehnten März.
Vor uns Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz zu Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Schäfer Shop Holding International GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Gesell-

schaftssitz in 20 Fritz-Schäfer-Straße, D-57290 Neunkirchen, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
unter Nummer HRB 7767,

hier vertreten durch Herrn Georges THINNES, „conseiller fiscal“, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxemburg, 2,

avenue Charles de Gaulle, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 3. März 2015,

welche nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger

Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die alleinige Gesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung SSI Schäfer Shop GmbH, mit Sitz in L-1852 Luxemburg, 7, rue Kalchesbruck ist,
welche durch notarielle Urkunde vom 29. Oktober 2014 des unterzeichneten Notar gegründet wurde und im „Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 3706 vom 4. Dezember 2014 veröffentlicht wurde,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 191710.
Die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, den Sitz der Gesellschaft von L-1852 Luxemburg, 7, rue Kalchesbruck nach

L-4384 Ehlerange, ZI Zare Ilôt Ouest, 16 zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzungen abzuändern, um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in die Gemeinde Sanem.“

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 900,- EUR geschätzt.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: Georges THINNES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 mars 2015. Relation GAC/2015/2297. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015045419/41.
(150051582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

58901

L

U X E M B O U R G

Taurus Euro Logistics Investment Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 160.972.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015045431/9.
(150051609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Trustconsult Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 46.233.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 28 janvier 2015, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société TRUST-

<i>CONSULT GROUP S.A.

- La démission de M. Michel CAILLARD de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1 

er

 janvier 2015.

- Les mandats des administrateurs:
* M. Christian BÜHLMANN
* M. Alexandre TASKIRAN
* M. Alban CALCAGNO
ont été renouvelés jusqu'au 1 

er

 janvier 2021.

- Le mandat de M. Christian BÜHLMANN, administrateur-délégué, a été renouvelé jusqu'au 1 

er

 janvier 2021.

- Le mandat de Trustconsult Luxembourg S.A. en qualité de commissaire aux comptes a été renouvelé jusqu'au 1 

er

janvier 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TRUSTCONSULT GROUP S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015045458/21.
(150051895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Aerospace Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 73.268.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 mars 2015 que:
- Le siège social de la Société a été transféré du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg, avec effet immédiat.

- L'assemblée a nommé aux postes d'administrateurs de la Société, avec effet à partir du 1 

er

 janvier 2015,

* Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, née le 28 septembre 1962 à Arlon (Belgique), avec

adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,

* Mme Maria Helena GONCALVES, employée privée, née le 20 avril 1976 à Hayange (France), avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, et

* M. Thierry TRIBOULOT, né le 2 avril 1973 à Villers-Semeuse (France), avec adresse professionnelle au 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg,

en remplacement de Mme Kaliroi THOUAS, Mme Laetitia VAUCHEZ et Mme Barbara NEUERBURG, démissionnaires.
Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020.
- Par cette même assemblée, M. Marco RIES, Réviseur d'entreprises, né le 6 janvier 1959 à Esch-sur-Alzette (Luxem-

bourg), avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommé, avec effet immédiat,
au poste de Commissaire aux comptes de la Société, en remplacement de la société Viscomte S.àr.l.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020.
Il résulte également du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue à la même date

que Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, prénommée, a été nommée à la fonction de Présidente du Conseil d'Adminis-
tration de la Société.

58902

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l.

Référence de publication: 2015045552/28.
(150052581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Gemissy SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9373 Gilsdorf, 34, rue de Broderbour.

R.C.S. Luxembourg B 158.621.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le treize mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Sergio GUGLIUZZA, administrateur de sociétés, professionnellement domicilié à L-9373 Gilsdorf, 34, rue

de Broderbour,

ici représentée par Madame Cristiana VALENT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme «GEMISSY S.A.», ayant son siège social à L-9373 Gilsdorf, 34, rue de Broderbour, R.C.S.

Luxembourg numéro B 158621,

a été constituée, suivant acte reçu, par le notaire instrumentant, en date du 10 janvier 2011, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations numéro 855, en date du 29 avril 2011, et dont les statuts n'ont pas été modifiés
depuis.

II.- Que le capital social de la société anonyme «GEMISSY S.A.», prédésignée, s'élève actuellement à 32.000,- EUR

(trente et deux mille euros) représenté par 100 (cent) actions d'une valeur nominale de 320,- EUR (trois cent vingt euros)
chacune.

III.- Que le comparant est propriétaire de toutes les actions de la susdite société «GEMISSY S.A.».
IV.- Que l'activité de la société «GEMISSY S.A.» ayant cessé et que le comparant prononce la dissolution anticipée de

la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que le comparant, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu'en cette qualité, il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la société

dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme «GEMISSY S.A.» est à considérer comme faite et clôturée.
IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs, président du conseil d'administration et au

commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des actionnaires.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social à L-9373 Gilsdorf, 34, rue de Broderbour

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à neuf cent vingt euros (920.- EUR), sont à charge de la

société dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 mars 2015. Relation GAC/2015/2273. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015044450/50.
(150050889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.

58903

L

U X E M B O U R G

Lux-Log S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5444 Schengen, 10, Wengertswee.

R.C.S. Luxembourg B 82.248.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den elften März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr  Rolf  BETTENBURG,  Beamter,  geboren  in  Schwalbach  (Deutschland),  am  20.  Juni  1950,  wohnhaft  in  L-5444

Schengen, 10, Wengertswee;

hier vertreten durch Herrn Romain KETTEL, Buchhalter, beruflich ansässig in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon 1 

er

 , aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung „ne varietur“ durch den Erschienenen und den unterzeichnenden Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt

Der Komparent ersucht, durch seinem Vertreter, den amtierenden Notar ihre Erklärungen und Feststellungen zu

beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Aktiengesellschaft „LUX-LOG S.A.“, mit Sitz in L-5444 Schengen, 10, Wengertswee, eingetragen beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer B 82248, gegründet durch Urkunde
von Notar Jean SECKLER aus Junglinster am 21. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial C No 1133 vom 10. Dezember
2001.

II.- Dass das Stammkapital der Gesellschaft EIN UND DREISSIG TAUSEND EURO (31.000.- EUR) und ist eingeteilt

in DREI HUNDERT ZEHN (310) Aktien von jeweils EIN HUNDERT EURO (100.- EUR).

III.- Dass der Komparent der alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist, und das gesamte Gesellschaftskapital re-

präsentiert.

IV.- Dass der Komparent beschließt die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.
V.- Dass der Komparent die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.
VI.- Dass der Komparent erklärt, alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und dass er persönlich die

Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zurzeit nicht bekannt sind, gewährleistet.

VII.- Dass den Mitgliedern des Verwaltungsrates, Geschäftsführermitglied und dem Kommissar der Gesellschaft, volle

Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag erteilt wird.

VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
IX. Dass sämtliche Aktienzertifikate sowie das Aktienregister annulliert wurden.
X.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren in L-5444

Schengen, 10, Wengertswee, aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen,

unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr neunhundertzwanzig Euro.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zuna-

men, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Romain KETTEL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 mars 2015. Relation GAC/2015/2133. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015043606/47.
(150049778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.

Decodesign S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 32, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 172.472.

Im Jahr zweitausendfünfzehn, den sechzehnten Tag im Monat März.
Vor dem Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitz zu Niederanven.

Ist erschienen:

58904

L

U X E M B O U R G

Herr Joël Norbert TRAMARIN, Privatbeamter, geboren am 07. Oktober 1968 in Dudelange, wohnhaft in L-4710

Pétange, 32, rue d'Athus.

Welcher Komparent den unterzeichnenden Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:
Herr Joël Norbert TRAMARIN, vorbenannt, erklärt in seiner Eigenschaft als alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft

mit beschränkter Haftung DECODESIGN S.à r.l, mit Sitz in L-3316 Bergem, 3B, rue Basse, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 172.472, gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den am-
tierenden  Notar,  am  26.  Oktober  2012,  veröffentlicht  im  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et  Associations,
Nummer 2889 vom 28. November 2012 zu handeln.

Der alleinige Gesellschafter erklärt, eine Hauptversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersucht den amtierenden

Notar, folgende gefassten Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft von L-3316 Bergem, 3B, rue Basse, nach L-4710 Pé-

tange, 32, rue d‘Athus, zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge der obigen Sitzverlegung, erklärt der alleinige Gesellschafter, Artikel 2, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft

abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. (1. Absatz). „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Pétange.“

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, dass das Geschäftsjahr vom 1. Januar eines Jahres bis zum 31. Dezember des-

selben Jahres verläuft.

Aufgrund dieser Änderung beschließt der alleinige Gesellschafter, dass das letzte Geschäftsjahr welches am 1. Sep-

tember 2014 begonnen hat bis zum 31. Dezember 2014 verlaufen ist, und dass, wie oben beschlossen, das derzeitige
Geschäftsjahr am 1. Januar 2015 begonnen hat und bis zum 31. Dezember 2015 verlaufen soll.

<i>Vierter Beschluss

Infolge dessen erklärt der alleinige Gesellschafter, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

„ Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt Frau Rita Fernandes Antunes, geboren am 30. Dezember 1983 in Fafe (Portugal),

wohnhaft in L-4710 Pétange, 32, rue d’Athus, als administrative Geschäftsführerin der Gesellschaft für eine unbestimmte
Dauer, zu ernennen.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers verpflichtet oder durch die

gemeinsame Unterschrift des technischen und administrativen Geschäftsführers.

<i>Sechster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt das Mandat von Herrn Joël Norbert TRAMARIN, als technischen Geschäfts-

führers der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer, zu bestätigen.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers verpflichtet oder durch die

gemeinsame Unterschrift des technischen und administrativen Geschäftsführers.

Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft. Die Kosten werden auf tausendeinhundert

Euro (EUR 1.100,-) abgeschätzt.

<i>Bevollmächtigung

Der Erschienene, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichnenden

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung an alle Erschienenen,  welche  alle  dem  Notar nach  Namen, gebräuchlichen Vornamen,  Stand und

Wohnort bekannt sind, haben alle die gegenwärtige Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: Joël Tamarin, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 18 mars 2015. 1LAC / 2015 / 8416. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

58905

L

U X E M B O U R G

Senningerberg, den 20. März 2015.

Référence de publication: 2015044996/62.
(150051856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Digital Services XVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 186.468.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 23 février 2015

En date du 23 février 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Julien DE MAYER, né le 9 avril 1982 à Etterbeek, Belgique, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Christian SENITZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien DE MAYER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Digital Services XVIII S.à r.l.

Référence de publication: 2015045686/20.
(150052153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Digital Services XXVII (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.568.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 19 février 2015

En date du 19 février 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Julien DE MAYER, né le 9 avril 1982 à Etterbeek, Belgique, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Christian SENITZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien DE MAYER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Digital Services XXVII (GP) S.à r.l.

Référence de publication: 2015045690/20.
(150052357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Globavia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 74.635.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 mars 2015 que:
- Le siège social de la Société a été transféré du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg, avec effet immédiat.

- L'assemblée a nommé aux postes d'administrateurs de la Société, avec effet à partir du 1 

er

 janvier 2015,

* Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, née le 28 septembre 1962 à Arlon (Belgique), avec

adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,

58906

L

U X E M B O U R G

* Mme Maria Helena GONCALVES, employée privée, née le 20 avril 1976 à Hayange (France), avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, et

* M. Thierry TRIBOULOT, né le 2 avril 1973 à Villers-Semeuse (France), avec adresse professionnelle au 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg,

en remplacement de Mme Kaliroi THOUAS, Mme Laetitia VAUCHEZ et Mme Barbara NEUERBURG, démissionnaires.
Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020.
- Par cette même assemblée, M. Marco RIES, Réviseur d'entreprises, né le 6 janvier 1959 à Esch-sur-Alzette (Luxem-

bourg), avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommé, avec effet immédiat,
au poste de Commissaire aux comptes de la Société, en remplacement de la société Viscomte S.àr.l.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020.
Il résulte également du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue à la même date

que Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, prénommée, a été nommée à la fonction de Présidente du Conseil d'Adminis-
tration de la Société.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l.

Référence de publication: 2015045815/28.
(150052632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Impact Capital Partners V, LP, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M.Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 195.539.

<i>Extrait du contrat social de la Société

La dénomination de la société en commandite spéciale est Impact Capital Partners V, LP («la Société»).
La Société a commencé le 20 mars 2015, date à laquelle le contrat social de la Société («le Contrat Social») a été signé

et se poursuivra jusqu’au 20 mars 2020, sauf liquidation anticipée ou extension conformément au Contrat Social.

La Société est constituée exclusivement dans l’objet d’investir dans des titres émis par Luxsit Organic Care AB, et de

gérer cette participation. La Société peut (a) s’engager dans toute autre activité que l’Associé Commandité estime né-
cessaire, utile, opportun ou accessoire à ce qui précède et (b) s’engager dans toute autre acte ou activité légale qui n’est
pas incompatible avec ce qui précède. La Société peut prêter des fonds à ses filiales ainsi qu’à toutes autres sociétés. La
Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des
sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de
manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut
effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise. La Société peut em-
ployer toutes les techniques, moyens légaux et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et
à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêts et autres risques.
La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions con-
cernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

L’Associé Gérant Commandité unique de la Société (responsable indéfiniment et solidairement de tous les engagements

sociaux de la Société conformément à l’article 16 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée) est Twelve Sicamore S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172 242 et dont le siège social se situe au 10A, rue
Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg («Associé Commandité»).

Le siège social de la société se trouve au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

La gestion, le contrôle, le fonctionnement, ainsi que la détermination de la politique concernant la Société, ses inves-

tissements et autres activités sont exclusivement attribués à l’Associé Commandité, lequel est autorisé et habilité, au nom
et pour le compte de la Société et en son propre nom, si nécessaire et approprié, de réaliser tous les objectifs de la
Société et d’accomplir tous les actes ainsi que de conclure et d’exécuter tous les contrats et autres engagements que
l’Associé Commandité, à sa seule discrétion, juge nécessaires, utiles, opportuns ou accessoires.

L’Associé Commandité est autorisé de manière exclusive et unique à représenter la Société et à engager vis-à-vis des

tiers, en toutes circonstances et pour toutes transactions.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015045845/39.
(150051860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

58907

L

U X E M B O U R G

Londac No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 168.146.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 19 mars 2015

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371

Luxembourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015045922/15.
(150052708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

La Française LUX, Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. La Française AM Fund).

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 66.785.

In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of March.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) of LA FRANCAISE AM FUND (the “Company”), a

société d'investissement à capital variable with its registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand
Duchy of Luxembourg, initially incorporated under the name Global Strategy in Luxembourg by a deed of Maître Edmond
Schroeder, then notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg on 28 October 1998, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 26 November 1998, number 859 page 41205. The articles
of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, on 3 October 2012, published in the Mémorial on 20 November 2012, number 2813 page 134978.

The meeting was opened under the chairmanship of Mrs Gwendoline BOONE (the “Chairman”), professionally residing

in Hesperange, who appointed Mrs. Nathalie FINET, professionally residing in Hesperange, as secretary to the Meeting.

The Meeting elected Aline BIEJ, professionally residing in Hesperange as scrutineer.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

A. The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment to article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to change the name of the Company

from currently LA FRANCAISE AM FUND to La Française LUX.

B. The present extraordinary general meeting of shareholders has been duly convened by (i) sending the convening

notice by registered mail on February 26, 2015 to all registered shareholders to their address indicated in the register of
shareholders of the Company and (ii) publishing a convening notice in Le Tijd, L’Echo, Börsen Zeitung, Cinco Dias and
IL Sole 24 Ore on February 26, 2015.

C. That resolutions of the agenda require a quorum of fifty per cent of the share capital of the Company and may only

be validly taken if approved by at least a majority of two thirds of the votes cast at the Meeting.

D. The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list initialled "ne varietur" by the proxyholders, the Chairman, the secretary, the scrutineer, and the under-
signed notary. The said list and proxies will be annexed to this deed, to be registered therewith.

E. It appears from the attendance list that, out of 6,677,648.225700 shares in issue, 3,739,420 shares are present or

duly represented at this meeting, which represent 55% of the share capital.

F. The present Meeting is therefore validly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the Meeting takes the following resolution:

58908

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Meeting unanimously resolved to amend article 1 of the articles of incorporation of the Company, so as to read

as follows:

“ Art. 1. Name. A limited liability company - société anonyme - exists among the subscribers and all those who will

subsequently become shareholders, in the form of a “variable capital investment company” (“société d'investissement à
capital variable”) (SICAV) named La Française LUX (the “Company”). The Company is subject to the provisions of Part
I of the Law of 17 December 2010 on organisations for collective investment.”

<i>Statements

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the bureau, the bureau signed together with the notary the present deed.
Signé: G. BOONE, N. FINET, A. BIEJ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 16 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8096. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 24 mars 2015.

Référence de publication: 2015045929/57.
(150052132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Cool Runnings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 166.542.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015046332/9.
(150053479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Carnegie Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 53.022.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire des actionnaires, tenue au siège social de la société, 5 place de la gare,

<i>L-1616 Luxembourg, le 16 mars 2015 à 9h00

Il résulte dudit procès verbal que:
- Après délibération, l'Assemblée a approuvé la réélection des Administrateurs pour un nouveau mandat d'un an.
A partir de la date de l'Assemblée, le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit et est élu jusqu'à la

date de la prochaine Assemblée Générale:

- Mr. Steinar Lundström, Administrateur,
Fjordalléen 16, N-0015 Oslo, Norvège
- Mr. Mattias Kolm, Administrateur,
Blasieholmsgatan 5, Stockholm S-10 394, Suède.
- Mr. Rolf Dolang, Administrateur,
Dampfaergevej 26, DK-2100 Copenhagen, Danemark.
- Mr. Bruno Vanderschelden, Administrateur,
8, rue Th. Funck-Brentano, L-1544 Luxembourg.
- Après délibération, l'Assemblée a approuvé la réélection de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, comme

Réviseur d'Entreprises, jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

58909

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 24 Mars 2015.

Pour extrait conforme
Jean-Marc Delmotte
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015046309/27.
(150053158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Russian Acquisition Company N°2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 150.846.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 19 mars 2015

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371

Luxembourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015046051/15.
(150052710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

RS Pose d'Armatures, Société à responsabilité limitée,

(anc. Lux Armature &amp; Construction S.à r.l.).

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 164.869.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange.

Carlo GOEDERT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015046061/12.
(150052596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Spain Residential Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 181.576.

II résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 23 mars 2015, que l'associé unique de la Société, BRE/

Europe 7NQ S.à r.l. a transféré 86 des parts sociales qu'il détenait de la manière suivante:

(1) BTO Hercules Holdings L.P., société en commandite, constituée et régie selon les lois des Iles Caïmans, ayant son

siège social au 345 Park Avenue, New York, 10154 NY, États-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Registrar of
Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands sous le numéro IT-75884, 40 parts sociales;

(2) SOF Investments S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché du

Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre
de Commerces et des Sociétés sous le numéro B 186.458 ,40 parts sociales;

(3) BTAS BREP Holdings L.L.C., société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Delaware Limited

Liability Company Act, ayant son siège social au 345 Park Avenue, New York, 10154 NY, États-Unis d'Amérique, et
immatriculée auprès du Intertrust Corporate Services Delaware Ltd. sous le numéro 5500659, 6 parts sociales;

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

58910

L

U X E M B O U R G

1. BRE/Europe 7NQ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 parts sociales
2. BTO Hercules Holdings L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 parts sociales
3. SOF Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 parts sociales
4. BTAS BREP Holdings L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2015.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015046067/28.
(150052400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Carnegie Fund Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 158.409.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire des actionnaires, tenue au siège social de la société, 5, place de la gare,

<i>LU-1616 Luxembourg, le 16 mars 2015 à 14h00

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Après délibération, l'Assemblée Générale a ratifié la décision suivante:
A dater du 16 mars 2015, et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale à tenir le 16 mars 2016, le Conseil d'Adminis-

tration de la société se compose dès lors comme suit: M.

* M. Bruno Frèrejean, Président et Administrateur, 139, Um Trenker, LU-6962 Senningen
* M. Andreas Uller, Administrateur,
14, Idunvägen, SE-133 38 Saltsjöbaden, Suède
* M. Jean-Marc Delmotte, Administrateur,
1, chemin de la Grande Sente, FR-57130 Sainte-Ruffine, France.
- Après délibération, l'Assemblée a approuvé la réélection de PricewaterhouseCoopers, société coopérative, comme

Réviseur d'entreprises agréé, jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Luxembourg, le 24 mars 2015.

Pour extrait conforme
Jean-Marc Delmotte
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015046311/24.
(150053162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Centaurus C.E.R. (Aviva Investors) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 921.600,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 111.774.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 mars 2015:

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Démission de Monsieur Francesco Piantoni en qualité de gérant avec effet au 28 février 2015.
Le conseil de gérance se compose dorénavant comme il suit:
- M. Mark Roland Philips, gérant;
- M. Michael Green, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015046313/16.
(150052843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

58911

L

U X E M B O U R G

Cite Cube S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5942 Itzig, 1, rue Désiré Zahlen.

R.C.S. Luxembourg B 162.042.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2015046323/12.
(150052940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

CNH Industrial Europe Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 71.335.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2015

L'assemblée décide de réélire tous les administrateurs en fonction pour un nouveau mandat qui se terminera à l'issue

de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Le conseil d'administration est composé comme suit:
1. M. Andrea Paulis, administrateur, demeurant professionnellement 6900 Veterans Boulevard, IL 60527 Burr Ridge,

Etats-Unis;

2. M. Nigel Wood, administrateur, demeurant professionnellement Cranes Farm Road, SS14 3AD Basildon, Essex,

Royaume-Uni;

3. M. Paul Hunter, administrateur, demeurant professionnellement Cranes Farm Road, SS14 3AD Basildon, Essex,

Royaume-Uni;

4. Mme Stefania Saini, administrateur, demeurant professionnellement 24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
5. M. Jacques Loesch, avocat, demeurant professionnellement 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et
6. M. Tom Loesch, avocat, demeurant professionnellement 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
A la suite de la réélection de Monsieur Nigel Wood comme administrateur, Monsieur Nigel Wood est reconduit dans

ses fonctions de délégué à la gestion journalière de la Société pour une durée expirant à l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en 2016.

L'assemblée décide de réélire Ernst &amp; Young S.A., Luxembourg, comme réviseurs d'entreprises, pour un nouveau

mandat qui se terminera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 mars 2015

Le conseil nomme président M. Andrea Paulis, administrateur, pour un nouveau mandat qui se terminera à l'issue de

l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CNH Industrial Europe Holding S.A.

Référence de publication: 2015046324/30.
(150052919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

CNH Industrial Finance Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 155.849.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 mars 2015

L'assemblée accepte de réélire tous les administrateurs en fonction pour un nouveau mandat qui se terminera à l'issue

de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Le conseil d'administration est composé comme suit:
1. Mme Stefania Saini, demeurant professionnellement 24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
2. M. Alessandro Meinero, demeurant professionnellement Riva Paradiso 14, 6902 Lugano, Suisse; et
3. M. Tom Loesch, demeurant professionnellement 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

58912

L

U X E M B O U R G

L'assemblée décide de réélire Ernst &amp; Young S.A., Luxembourg, comme réviseurs d'entreprises, pour un nouveau

mandat qui se terminera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 mars 2015

Le conseil nomme président Mme Stefania Saini, administrateur, pour un nouveau mandat qui se terminera à l'issue de

l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CNH Industrial Finance Europe S.A.

Référence de publication: 2015046325/21.
(150052918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Devonshire Point Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 26.958,00.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 185.409.

<i>Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 20 mars 2015

En date du 20 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Myleen Tapawan Basilio de son mandat de Gérant de classe B de la Société avec effet au

20 mars 2015;

- de nommer Dimitri Nys, né le 12 octobre 1984 à Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant comme adresse professionnelle:

4 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec effet au 20 mars 2015
et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de Gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
* Ranesh Ramanathan, gérant de classe A
* Sally Dee Fassler, gérant de classe A
* Grindale Gamboa, gérant de classe B
* Dimitri Nys, gérant de classe B

Luxembourg, le 20 mars 2015.

Référence de publication: 2015046337/21.
(150053232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Devonshire Point Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 26.958,00.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 185.413.

<i>Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 20 mars 2015

En date du 20 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Myleen Tapawan Basilio de son mandat de Gérant de classe B de la Société avec effet au

20 mars 2015;

- de nommer Dimitri Nys, né le 12 octobre 1984 à Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant comme adresse professionnelle:

4 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec effet au 20 mars 2015
et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de Gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
* Ranesh Ramanathan, gérant de classe A
* Sally Dee Fassler, gérant de classe A
* Grindale Gamboa, gérant de classe B
* Dimitri Nys, gérant de classe B

Luxembourg, le 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015046338/21.
(150053233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

58913

L

U X E M B O U R G

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 96.848.

Le 25 mars 2015, ont été opérés les transferts de parts sociales de la Société suivants:
1) Monsieur Patrick Sganzerla a cédé la totalité des parts sociales qu'il détient, soit 64 parts sociales sur un total de

124 à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FPS Audit S.à r.l., ayant son siège social au 19, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.674.

2) Monsieur Steeve Simonetti a cédé la totalité des parts sociales qu'il détient, soit 2 parts sociales sur un total de 124

à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FPS Audit S.à r.l., ayant son siège social au 19, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.674.

3) La société G &amp; P Properties S.à r.l. a cédé la totalité des parts sociales qu'il détient, soit 58 parts sociales sur un

total de 124 à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FPS Audit S.à r.l., ayant son siège social au 19,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 159.674.

De telle sorte que la totalité des parts sociales de Fiduciaire Patrick Sganzerla, Société à responsabilité limitée, soit

124, est désormais détenue par FPS Audit S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 159.674.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
Fiduciaire Patrick Sganzerla
Société à responsabilité limitée
Patrick Sganzerla
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2015046409/29.
(150053337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

EnBW Baltic 2 Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 195.619.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen on the eighteenth day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EnBW Offshore 2 GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Schel-

menwasenstrasse 15, D-70567 Stuttgart, Germany, and registered with the Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart
under number HRB 737005,

here represented by Maître François Felten, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, pursuant to a proxy which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary to draw up the articles of

association of a limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "EnBW Baltic 2 Management
S.à r.l." which is hereby established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "EnBW Baltic 2

Management S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become sha-
reholders  thereafter.  The  Company  will  be  governed  by  these  articles  of  association  and  the  relevant  legislation  of
Luxembourg.

Art. 2. Object.
2.1 The object of the Company is to acquire and hold a participation, in any form whatsoever, and to act as general

partner in the common limited partnership (société en commandite simple) EnBW Baltic 2 S.C.S. ("SCS").

2.2 The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the SCS.

58914

L

U X E M B O U R G

2.3 The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

2.4 In particular, the Company will provide the SCS with the services necessary to its administration, control and

development. As well, the Company undertakes to perform the management of the SCS in the ordinary course, including
the exercise and fulfilment of the contractual rights and obligations of SCS, in particular under any key operating contracts
(as defined in any partnership agreement that may exist from time to time between any partners of SCS). For that purpose,
the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary shareholders'
meeting deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

4.2 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as

the case may be the board of managers.

4.3 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
4.4 In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital.
5.1 The issued share capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) represented

by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each. The share capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for an
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its own shares upon
resolution of its shareholders.

5.2 Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law or

the provisions of any partnership agreement that may exist from time to time between any partners of SCS, the share
transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the issued share capital.

Art. 7. Management of the company.
7.1 The Company is managed by three (3) managers who do not need to be shareholders. The shareholders' meeting

may decide to appoint one manager as chief executive officer ("Chief Executive Officer" or "CEO"), one manager as chief
financial officer ("Chief Financial Officer" or "CFO") and one manager as chief operating officer ("Chief Operating Officer"
or "COO"). Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the
managers be identified with respect to their designation.

7.2 The board of managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise

and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly
reserved by the law or by the articles of association to the shareholders' meeting shall be within the competence of the
board of managers.

7.3 Vis-à-vis third parties the board of managers, has the most extensive powers to act on behalf of the Company in

all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company and not reserved by
law or these articles of association to the shareholders' meeting.

7.4 The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the shareholders' meeting,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

7.5 The managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers

by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear
one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar
means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board of managers
by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

58915

L

U X E M B O U R G

7.6 Written notice of any meeting of the board of managers must be given by any of the managers to the other managers

at least two (2) business days in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which
case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case
of assent of each manager in writing, by mail, email or facsimile or any other similar means of communication. A special
convening notice will not be required for a board of managers' meeting to be held at a time and location determined in
a  prior  resolution  adopted  by  the  board  of  managers.  The  shareholder(s)  shall  give  the  board  of  managers  rules  of
procedure applicable to the board of managers of the Company ("Rules of Procedure") and amend the same, in each case
by shareholders resolution. The Rules of Procedure shall set forth further rules applicable to the board of managers.

7.7 Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the

Company, unless otherwise provided for herein or in the Rules of Procedure.

7.8 No contract or other transaction between the Company and any other company shall be affected or invalidated

by the fact that any one or more of the managers of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate,
member, officer or employee of, such other company or firm. Except as otherwise provided for hereinafter, any manager
or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or employee of any company or firm with which
the Company shall contract or otherwise engage in business activities shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, the affected manager shall make known such personal interest to the board of managers
and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such mangers's interest therein shall be
reported to the partners' meeting of EnBW Baltic 2 SCS.

7.9 The minutes of any meeting of the board of managers shall be in English and signed by all managers.
7.10 The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular

means when expressing its approval in writing, by mail, email or facsimile or any other similar means of communication.
The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions,
including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual
signature of any manager.

7.11 The board of managers shall seek prior consent from the shareholders' meeting on the following matters (the

"Reserved Matters"), such Reserved Matters shall be adopted in a shareholders' meeting by a majority of at least seventy-
five percent (75%) of the issued share capital:

(i) concluding, amending or terminating of affiliation and/or enterprise agreements in the name of the Company.
7.12 The Company will be validly bound by the joint signature of any two managers or by the joint signatures or single

signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits
of such power.

Art. 8. Liability of the managers.
8.1 The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the performance of their duties.

8.2 Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of

the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

8.3 No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the board of managers.

8.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

8.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt

58916

L

U X E M B O U R G

of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings.
10.1 Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Com-

pany law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. The minutes of shareholder(s) meetings and of written
resolutions of the shareholder(s) shall be kept at the registered office of the Company and a copy thereof shall be sent
to the shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution
(as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

10.2 Meetings shall be called by any manager by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their

address appearing in the register of shareholders held by the Company at least ten (10) business days prior to the date
of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without
prior notice. The managers shall be obliged to convene a shareholders' meeting without undue delay upon request of
shareholders holding at least 25% of the issued share capital.

10.3 In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least ten (10) business days before the proposed effective
date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law
for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unani-
mous written resolution may be passed at any time without prior notice.

10.4 Except as otherwise provided by law or the articles of association, decisions of the shareholders' meeting shall

be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the issued share capital. If such majority is
not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second
time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of the
issued share capital represented. However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken
by (i) a majority of the shareholders (ii) representing at least seventy-five percent (75%) of the issued share capital.
Decisions to change the nationality of the Company are to be taken by shareholders representing all of the issued share
capital.

10.5 At no time shall the Company have more than forty (40) shareholders.

Art. 11. Accounting year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year.

Art. 12. Financial statements. Every year as of the accounting year's end, the financial statements are drawn up by the

board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions.
13.1 Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. The balance
may be distributed to the shareholders upon decision of a shareholders' meeting of shareholders.

13.2 The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a shareholders' meeting.

The shareholders' meeting may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the shareholders' meeting who will specify
their powers and remunerations.

Art. 15. Sole shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial com-

panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December 2015.

58917

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, EnBW Offshore 2

GmbH has subscribed and entirely paid-up twelve thousand five hundred (12,500) shares for a total subscription price of
twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500).

All the shares have been entirely paid up by contribution in cash, so that the company has now at its disposal the sum

of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

10 August 1915, as amended, have been fulfilled.

<i>Expenses, valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-

<i>Extraordinary shareholders' meeting

The shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is established at:
7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:

- Dirk Güsewell, born on 30 March 1970 in Radolfzell, Germany, and having his professional address at Eichwiesenring

14, 70567 Stuttgart as CEO;

- Dr. Wolfang Eckert, born on 18 February 1962 in Freiburg, Germany, and having his professional address at Durlacher

Allee 93, 76131 Karlsruhe as CFO; and

- Stefan Kansy, born on 18 Mai 1972 in Sömmerda, Germany, and having his professional address at Fischertwiete 1,

20095 Hamburg as COO.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above

appearing parties the present deed is worded in English followed by and German translation. On request of the same
appearing parties and in case of divergences between the German and the English version, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by its name, first

name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Follows the German translation

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am achtzehnten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

EnBW Offshore 2 GmbH, eine Gesellschaft nach deutschem Recht, mit Geschäftssitz in Schelmenwasenstrasse 15,

D-70567 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter
der Nummer HRB 737005,

hier vertreten durch Maître François Felten, maître en droit, geschäftsansässig in Luxembourg, Großherzogtum Lu-

xemburg, aufgrund einer ihm erteilten privatschriftlichen Vollmacht, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist, um mit
dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat, in ihrer vorgenannten Eigenschaft, den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-

satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Firma "EnBW Baltic 2
Management S.à r.l." wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Firma. Die erschienenen Parteien und alle Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten,

gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Firma "EnBW
Baltic 2 Management S.à r.l." (die "Gesellschaft"). Die Gesellschaft unterliegt den Regelungen der vorliegenden Satzung
und der entsprechenden luxemburgischen Gesetzgebung.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist es, Unternehmensbeteiligungen in jeder beliebigen Form zu erwerben und zu halten

und als unbeschränkt haftender Gesellschafter der Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) EnBW Baltic
2 S.C.S ("SCS") zu handeln.

2.2 Die Gesellschaft kann zugunsten der SCS Bürgschaften stellen, Sicherheiten leisten, Darlehen gewähren oder sie

in anderer Weise unterstützen.

58918

L

U X E M B O U R G

2.3 Die Gesellschaft ist berechtigt, alle geschäftlichen, technischen, finanziellen oder andere Tätigkeiten vorzunehmen,

die damit in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen, welche die Erfüllung ihres Geschäftszwecks fördern.

2.4 Die Gesellschaft wird der SCS insbesondere die Leistungen zur Verfügung stellen, die für ihre Verwaltung, ihre

Kontrolle und ihre Entwicklung notwendig sind. Darüber hinaus verpflichtet sich die Gesellschaft zur ordnungsgemäßen
Geschäftsführung der SCS, einschließlich der Ausübung und Erfüllung der vertraglichen Rechte und Pflichten der SCS,
insbesondere aus jeglichen key operating contracts (wie in jedwedem Gesellschaftsvertrag, der zwischen den Gesell-
schaftern der SCS mitunter besteht, definiert). Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft der Unterstützung anderer
Berater bedienen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 4. Sitz.
4.1 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann durch Beschluss einer

außerordentlichen Gesellschafterversammlung, der nach den Vorschriften für eine Satzungsänderung zu fassen ist, an
jedem Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

4.2 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers beziehungsweise durch die

Geschäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

4.3 Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
4.4  Sollte  der  Geschäftsführer  beziehungsweise  die  Geschäftsführung  feststellen,  dass  außerordentliche  politische,

wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Tätig-
keiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die ungehinderte Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen  im  Ausland  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  vollständigen  Beendigung  dieser
ungewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine
Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzver-
legung  eine  luxemburgische  Gesellschaft  bleibt.  Diese  entsprechenden  vorübergehenden  Maßnahmen  werden  vom
Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführung ergriffen und allen hiervon betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5 Gesellschaftskapital.
5.1 Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euros (EUR 12.500), ein-

geteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1). Das
Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Gesellschafterbeschluss, der nach den Vorschriften für eine Satzungs-
änderung gefasst wurde, erhöht oder herabgesetzt werden und die Gesellschaft kann eigene Gesellschaftsanteile durch
Gesellschafterbeschluss zurückkaufen.

5.2 Jegliche verfügbaren Aufgelder können ausgeschüttet werden.

Art. 6. Übertragung der gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen auf Dritte bedarf, soweit gesetzlich oder jedwedem Gesellschaftsvertrag, der
zwischen den Gesellschaftern der SCS mitunter besteht, nicht anders geregelt, der Zustimmung von Gesellschaftern,
welche zusammen über mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des ausgebebenen Gesellschaftskapitals verfügen.

Art. 7. Geschäftsführung.
7.1 Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch drei (3) Geschäftsführer, die keine Gesellschafter sein müssen.

Die Gesellschafterversammlung kann einen Geschäftsführer zum chief executive officer ("Chief Executive Officer" oder
"CEO"), einen Geschäftsführer zum chief financial officer ("Chief Financial Officer" oder "CFO") und einen Geschäftsführer
zum chief operating officer ("Chief Operating Officer" oder "COO") ernennen. Eine solche Verteilung der Geschäfte und
die Zuordnung zu den jeweiligen Geschäftsführern ist im entsprechenden Gesellschafterbeschluss auszuweisen.

7.2 Die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, die Geschäfte der Gesellschaft zu

führen und ist berechtigt, alle Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen, zu ge-
nehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die vorliegende
Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Geschäftsführung.

7.3 Die Geschäftsführung verfügt gegenüber Dritten über die umfassende Vertretungsmacht, im Namen und Auftrag

der Gesellschaft zu handeln und jederzeit alle Handlungen, welche nicht durch Gesetz oder die vorliegende Satzung der
Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, im Namen der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und zu genehmigen.

7.4 Die Geschäftsführer werden durch ein mit einfacher Mehrheit zu fassenden Beschluss der Gesellschafterversamm-

lung bestellt und abberufen, welche zugleich ihre Befugnisse und ihre Amtszeit bestimmt. Wenn keine Amtszeit bestimmt
ist, sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit bestellt. Die Geschäftsführer können wiederbestellt werden, jedoch
kann ihre Bestellung zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

7.5 Die Geschäftsführer bilden die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung

im Wege einer Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln teilnehmen, sofern
gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren können.
Eine Sitzung kann jederzeit auch ausschließlich im Wege einer Telefonkonferenz oder vergleichbaren Kommunikations-
mitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel gilt als persönliche

58919

L

U X E M B O U R G

Teilnahme an der jeweiligen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Beschränkung der Anzahl
der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

7.6 Die Geschäftsführer sind mindestens zwei (2) Werktage vor einer Sitzung der Geschäftsführung mittels schriftlicher

Einberufung durch einen Geschäftsführer zu benachrichtigen, außer in Notfällen, wobei dann die Art und die Gründe des
Notfalls in der Einberufung dargelegt werden müssen. Eine förmliche Einberufung kann unterbleiben, sofern jeder Ge-
schäftsführer schriftlich per Brief, durch E-Mail oder Telefax oder vergleichbarem Kommunikationsmittel erklärt, darauf
zu verzichten. Zu Sitzungen der Geschäftsführung für welche in einem Geschäftsführungsbeschluss Zeit und Ort künftiger
Sitzungen festgehalten sind, bedarf es keiner besonderen Einberufung. Die Gesellschafterversammlung hat für die Ge-
schäftsführung eine Geschäftsordnung (wie nachfolgend definiert) zu beschließen. Sie kann nur durch einen Beschluss der
Gesellschafterversammlung geändet werden. In der Geschäftsordnung sind weitere Regelungen für die Geschäftsführung
festzulegen.

7.7 Beschlüsse der Geschäftsführung bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft,

sofern nicht in dieser Satzung oder in der Geschäftsordnung etwas anderes bestimmt ist.

7.8 Kein Vertrag oder anderes Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft wird davon

berührt oder dadurch ungültig, dass ein oder mehrere Geschäftsführer ein persönliches Interesse im Zusammenhang mit
der anderen Gesellschaft hat oder Geschäftsführer, Teilhaber, Mitglied, leitender Angestellter oder Arbeitnehmer dieser
anderen Gesellschaft oder Firma ist. Sofern in dieser Satzung nichts anderes hier bestimmt ist, ist jeder Geschäftsführer
oder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Teilhaber, leitender Angestellter oder Arbeitnehmer
in einer anderen Gesellschaft oder Firma tätig ist, mit der die Gesellschaft in Vertragsbeziehung treten will oder auf andere
Weise Geschäftsbeziehungen aufnehmen möchte, nicht aufgrund einer solchen Zugehörigkeit automatisch daran gehin-
dert, solche Vertrags- oder Geschäftsbeziehungen in Betracht zu ziehen und im Zusammenhang damit an Abstimmungen
teilzunehmen oder Handlungen durchzuführen.

Unabhängig von dem Vorstehenden hat ein Geschäftsführer der Gesellschaft, für den Fall, dass er ein persönliches

Interesse im Zusammenhang mit einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, dies gegenüber der Geschäftsführung offen-
zulegen  und  darf  bei  diesem  Rechtsgeschäft  nicht  beraten  oder  sich  an  einer  Abstimmung  hierüber  beteiligen.  Die
betreffenden Rechtsgeschäfte und die Interessen des betreffenden Geschäftsführers sind der Gesellschafterversammlung
der EnBW Baltic 2 SCS offenzulegen.

7.9 Die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung sind in Englisch zu verfassen und von allen Geschäftsführern

zu unterzeichnen.

7.10 Die Geschäftsführung kann auch Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen, wenn alle Mitglieder der Geschäftsführung

schriftlich per Brief, durch E-Mail oder Telefax oder vergleichbarem Kommunikationsmittel zustimmen. Die im Umlauf-
verfahren unterzeichneten Dokumente bilden einen wirksamen schriftlichen Beschluss. Jeder Geschäftsführer kann durch
seine Unterschrift Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich im Umlaufverfahren gefasster Beschlüsse, beglaubigen
oder einen Auszug ausfertigen.

7.11 Die nachfolgenden Angelegenheiten bedürfen eines zustimmenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung

(die "Zustimmungspflichtigen Geschäfte"), der mit einer Mehrheit von mindestens 75 % des ausgegebenen Gesellschafts-
kapitals zu fassen ist:

(iv) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Unternehmensverträgen im Namen der Gesellschaft.
7.12 Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die gemeinsame

oder einzelne Unterschrift von hierzu durch die Geschäftsführung bevollmächtigte(n) Person(en) im Rahmen der erteilten
Vollmacht wirksam verpflichtet.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführer.
8.1 Die Geschäftsführer haften für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht persönlich. Als Vertreter der Gesellschaft

sind sie jedoch für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben verantwortlich.

8.2 Vorbehaltlich der nachstehend aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen stellt die Gesellschaft sämtliche Ge-

schäftsführer oder leitenden Angestellten der Gesellschaft in dem gesetzlich möglichen Umfang von allen Verbindlichkei-
ten und Kosten frei, welche diesen in vertretbaren Maße in Verbindung mit Ansprüchen, Klagen, Prozessen oder Verfahren
entstanden sind, in denen sie als Partei oder anderweitig aufgrund ihrer Tätigkeit als Geschäftsführer oder leitender
Angestellter beteiligt sind. Gleiches gilt für Beträge, die sie zur Beilegung eines Streites aufgewendet haben. Die Begriffe
"Klage", "Streitsache", "Prozess" oder "Verfahren" gelten für alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen,
Prozesse oder Verfahren (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die
Begriffe "Verbindlichkeit" und "Kosten" umfassen auch Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Be-
träge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

8.3 Ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist nicht freigestellt:
(i) von Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihren Gesellschaftern aufgrund von vorsätzlich begangenen

unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung von Pflichten im Rahmen
seiner Amtsführung;

(ii) im Zusammenhang mit Angelegenheiten, in denen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesellschaft

erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

58920

L

U X E M B O U R G

(iii) im Falle der Beilegung eines Streites, es sei denn die Beilegung ist von dem hierfür zuständigen Gericht oder von

der Geschäftsführung gebilligt worden.

8.4  Der  Freistellungsanspruch  ist  unabhängig  und  berührt  nicht  andere  Rechte,  die  Geschäftsführer  oder  leitende

Angestellte zustehen und besteht fort, auch wenn die Person nicht mehr Geschäftsführer oder leitender Angestellter der
Gesellschaft ist. Er steht auch den Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern der Betroffenen zu. Dies gilt
unbeschadet von vertraglichen und gesetzlichen Freistellungsansprüchen, die Mitarbeitern der Gesellschaft, einschließlich
Geschäftsführern und leitenden Angestellten, möglicherweise zustehen.

8.5 Kosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Vertretung im Rahmen der Abwehr eines Anspruchs, der

Verteidigung gegen eine Klage, Streitsache oder Verfahren, wie in dieser Regelung beschrieben, sollen bis zu ihrem end-
gültigen Abschluss von der Gesellschaft ausgelegt werden, so lange bis endgültig feststeht, dass der Geschäftsführer oder
leitende Angestellte keinen Anspruch auf Entschädigung hat. In diesem Fall ist der entsprechende Betrag zurückzuzahlen.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen.

Die Anzahl seiner Stimmen entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Der Gesellschafter kann sich bei jeder
Gesellschafterversammlung durch Erteilung einer entsprechenden Vollmacht vertreten lassen.

Art. 10 Gesellschafterversammlungen.
10.1 Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form

und mit der danach maßgebenden Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich zulässig ist) oder in Gesellschafterver-
sammlungen, gefasst. Die Niederschriften über die Gesellschafterversammlungen und die schriftlichen Gesellschafterbe-
schlüsse  sind  am  Sitz  der  Gesellschaft  aufzubewahren.  Eine  Kopie  ist  an  die  Gesellschafter  zu  übermitteln.  Jede
ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder wirksame schriftliche
Beschluss repräsentiert die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.

10.2 Die Einberufung der Gesellschafterversammlungen kann durch jeden Geschäftsführer mit einer Einberufungsfrist

von mindestens zehn (10) Werktagen vor der Gesellschafterversammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Ge-
sellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene Adresse erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschafts-
kapital der Gesellschaft in einer Gesellschafterversammlung vertreten ist, kann die Sitzung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden. Die Geschäftsführer sind verpflichtet, auf Verlangen von Gesellschaftern, deren Gesellschaftsanteile
zusammen mindestens 25 % des ausgegebenen Gesellschaftskapitals entsprechen, unverzüglich eine Gesellschafterver-
sammlung einzuberufen.

10.3 Sollen Beschlüsse im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens gefasst werden, so sind diese im Entwurf mindes-

tens zehn (10) Werktage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
hinterlegte Adresse zu übermitteln. Die Beschlüsse werden mit Zustimmung der Mehrheit der Stimmen wirksam, die
vom Gesetz für gemeinschaftliche Entscheidungen vorgesehen ist oder sofern das Mehrheitserfordernis erfüllt ist, an dem
Tag der im Beschluss hierfür vorgesehen ist. Beschlüsse können jederzeit ohne vorherige Ankündigung im Umlaufver-
fahren gefasst werden, sofern sie einstimmig gefasst werden.

10.4 Soweit im Gesetz oder in der Satzung nichts anderes geregelt ist, bedürfen die in den Gesellschafterversamm-

lungen  zu  fassenden  Beschlüsse  der  Zustimmung  von  Gesellschaftern,  die  mehr  als  die  Hälfte  des  ausgegebenen
Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung oder im ersten
schriftlichen Umlaufverfahren nicht erreicht, sind die Gesellschafter zu einer zweiten Gesellschafterversammlung per
Einschreiben einzuladen; die Beschlüsse werden sodann mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet
des Anteils des vertretenen Gesellschaftskapitals. Die Satzung kann jedoch nur mit Zustimmung (i) der Mehrheit der
Gesellschafter, welche (ii) mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals vertreten,
geändert werden. Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Einstimmigkeit.

10.5 Die Gesellschaft darf zu keinem Zeitpunkt mehr als vierzig (40) Gesellschafter haben.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Jahresabschluss. Zum Ende eines jeden Geschäftsjahrs stellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss der

Gesellschaft auf.

Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung.
13.1 Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt.

Diese Verpflichtung besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals
beträgt. Ein überschießender Betrag kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung verteilt werden.

13.2 Ein Guthaben auf dem Konto, auf dem Aufgelder gebucht sind kann durch Beschluss der Gesellschafterversamm-

lung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, einen Betrag von
diesem Konto der gesetzlichen Rücklage zuzuführen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist die Gesellschaft von einem oder mehreren Liquidatoren

zu liquidieren, die von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die auch deren Befugnisse und Vergütung be-
stimmt. Die Liquidatoren können, müssen aber nicht Gesellschafter sein.

58921

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Alleingesellschafter. Solange nur ein Gesellschafter alle Gesellschaftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel

179 (2) des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915. In diesem Fall finden u.a. die Artikel 200-1 und
200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 16. Anwendbares recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich

nach den entsprechenden gesetzlichen Regelungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt, endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung und Zahlung

Nachdem die erschienenen Parteien hiermit die Gründungssatzung beschlossen haben, zeichnet und zahlt die EnBW

Offshore 2 GmbH zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile für einen Gesamtzeichungspreis von zwölftau-
sendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500).  Alle  Gesellschaftsanteile  wurden  in  bar  voll  eingezahlt,  so  dass  der  Betrag  von
zwölftausendfünfhundert Euros (EUR 12.500) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich
von dem amtierenden Notar bestätigt wird.

<i>Feststellung

Der amtierende Notar erklärt, dass die Voraussetzungen des Artikels 183 des geänderten Gesetzes über die Han-

delsgesellschaften vom 10. August 1915 erfüllt sind.

<i>Kosten, Wert

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden

Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,-geschätzt.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in:
7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
2. Die folgenden Personen werden für einen unbefristeten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft mit der in

der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Zeichnungsbefugnis ernannt:

- Dirk Güsewell, geboren am 30 März 1970, in Radolfzell, Deutschland, geschäftsansässig in Eichwiesenring 14, 70567

Stuttgart als CEO;

- Dr. Wolfang Eckert, geboren am 18 Februar 1962 in Freiburg, Deutschland, geschäftsansässig in Durlacher Allee 93,

76131 Karlsruhe als CFO; und

- Stefan Kansy, geboren am 18 Mai 1972 in Sömmerda, Deutschland, geschäftsansässig in Fischertwiete 1, 20095 Ham-

burg als COO.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg an dem eingang genannten Datum er-

richtet.

Der unterzeichnende Notar, welcher der deutschen und englischen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf

Wunsch der erschienenen Parteien die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer
deutschen Übersetzung. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung soll die englische
Fassung maßgebend sein.

Nach Verlesung dieser Urkunde vor den erschienenen Vertretern der Parteien, die dem amtierenden Notar durch

Name, Vorname, Anschrift und Wohnort bekannt sind, haben diese und der Notar die Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: F. FELTEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 19 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8551. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 26. März 2015.

Référence de publication: 2015046994/464.
(150054099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Financial Ridge S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 49.401.

Le bilan de la société au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

58922

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015046413/12.
(150052836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

The Building Block Equity Fund S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investisse-

ment en Capital à Risque.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 140.004.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 12 mars 2015

Le mandat de la société Ernst &amp; Young ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, imma-

triculée  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B  88019  en  tant  que  réviseur
d'entreprises est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié conforme

Référence de publication: 2015047426/14.
(150053590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Luxembourg Pony Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 195.604.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of February.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Iconix Luxembourg Holdings S.àr.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 42-44, avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 172.340 and with a share capital of USD 20,000,

here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal,

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Luxembourg Pony Holdings S.à r.l.” (the Company). The Company is a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of
incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

58923

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may buy, sell, exchange, lease, hire, rent and manage any patents, trademarks or other intellectual

property rights of any nature or origin whatsoever which it holds from time to time.

3.5. The Company may license the use and/or the right to exploit any patents, trademarks or other intellectual property

rights of any nature or origin whatsoever which it holds from time to time.

3.6. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five

hundred (12,500) class A shares (the Class A Shares) and zero (0) class B shares (the Class B Shares), in registered form,
having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

The Class A Shares and the Class B Shares are individually referred to as a Share and together as the Shares.
5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on

request.

6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which

sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

58924

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and

any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholders

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted

at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders

may be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-

holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

58925

L

U X E M B O U R G

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and

shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory

stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following

the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders’ Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be

held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice,
on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual
General Meeting shall be held on the following business day.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external

auditors  (réviseurs  d’entreprises  agréés).  The  shareholders  shall  appoint  the  approved  external  auditors,  if  any,  and
determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be

supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of

58926

L

U X E M B O U R G

the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to

claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company’s assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.

<i>Transitional provision

The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December

2015.

<i>Subscription and payment

Iconix Luxembourg Holdings S.àr.l., represented as stated above, subscribes for twelve thousand five hundred (12,500)

Class A Shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a
contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is at the Company’s disposal and evidence of such

amount has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following are appointed as class A managers of the Company for an unlimited period:
- COLE Neil, born on March 17 

th

 1957 in New York, United States of America, with professional address at 1450

Broadway, Building c/o Iconix Brand Group, Inc., 3 

rd

 Floor, New York, NY 10013, United States of America; and

- BURKHARDT William, born on April 08 

th

 , 1963, in Illinois, United States of America, with professional address at

1450 Broadway, New York, NY 10018, United States of America.

2. The following are appointed as class B managers of the Company for an unlimited period:
- TERPSTRA Douwe, born on October 31 

st

 , 1958, in Leeuwarden, The Netherlands, with professional address at 6,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

58927

L

U X E M B O U R G

- FROMENT Hugo, born on February 22 

nd

 , 1974, in Laxou, France, with professional address at 6, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The registered office of the Company is located at 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour de février.
Pardevant le soussigné, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Iconix Luxembourg Holdings S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché

de Luxembourg, dont le siège social est établi au 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.340 et disposant
d’un capital social de USD 20.000,

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.
En vertu d’une procuration sous seing privée.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, la procuration

restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est “Luxembourg Pony Holdings S.à r.l.” (la Société). La Société est

une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans s’y limiter, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l’autorisation requise.

58928

L

U X E M B O U R G

3.3. La Société peut employer toutes les techniques, moyens juridiques et instruments nécessaires à une gestion efficace

de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux
d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut acheter, vendre, échanger, donner en location, exploiter, louer et gérer tout brevet, marque

commerciale ou autre droit de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit qu'elle détient dans le
temps.

3.5. La Société peut permettre l’utilisation et/ou autoriser l’exploitation de tout brevet, marque commerciale ou autre

droit de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit qu'elle détient dans le temps.

3.6. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et zéro (0) parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe
B), sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B sont désignées individuellement comme une Part Sociale

et ensemble comme les Parts Sociales.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à

la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les

associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe
A et un ou plusieurs gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, sera

au Luxembourg.

(ii) Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.

58929

L

U X E M B O U R G

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à condition
que lorsque les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins
un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont
consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous
les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de tout gérant de

classe A et tout gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associés

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont

adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus d’un dixième (1/10) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Lorsque des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés.

Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à  une  seconde  Assemblée  Générale  et  les  décisions  sont  adoptées  par  l’Assemblée  Générale  à  la  majorité  des  voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

58930

L

U X E M B O U R G

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-dessus.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l’expiration du délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés est

considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant

la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice

social en question, soit (a) par l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l’Assemblée Générale annuelle.
13.5. Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse

du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième
lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvré à Luxembourg, l’Assemblée Générale
annuelle se tient le jour ouvré suivant.

Art. 14. Commissaires / réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,

à moins que la loi ne requière la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés. Les commissaires peuvent
être nommés à nouveau par l’Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) Le Conseil établit des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime

d’émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le
montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas
échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes
à affecter à la Réserve Légale;

(iii) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes

intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.

58931

L

U X E M B O U R G

Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s’il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux

réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s’achèvera le trente-et-un (31) décembre

2015.

<i>Souscription et libération

Iconix Luxembourg Holdings S.àr.l., représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit aux douze mille cinq cents (12.500)

Parts Sociales de Classe A sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro chacune, et accepte de les libérer
intégralement par voie d’un apport en numéraire de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au

notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- COLE Neil, né le 17 mars 1957 à New York, Etats-Unis d’Amérique, de résidence professionnelle au 1450 Broadway,

Building c/o Iconix Brand Group, Inc., 3 

ème

 étage, New York, NY 10013, Etats-Unis d’Amérique; et

- BURKHARDT William, né le 8 avril 1963 dans l’Illinois, Etats-Unis d’Amérique, de résidence professionnelle au 1450

Broadway, New York, NY 10018, Etats-Unis d’Amérique.

2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée
- TERPSTRA Douwe, né le 31 octobre, 1958, à Leeuwarden, les Pays-Bas, de résidence professionnelle au 6, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- FROMENT Hugo, né le 22 février 1974, à Laxou, France, de résidence professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi au 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu'en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Dont Acte, le présent acte notarié est passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte, le notaire le signe avec le mandataire autorisé de la partie comparante.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

58932

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 février 2015. Relation: 1LAC/2015/6148. Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 mars 2015.

Référence de publication: 2015047172/531.
(150053084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Seawind S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 157.392.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand fifteen, on the nineteenth day of March.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of SEAWIND S.A., a société anonyme, having its registered office

at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed enacted by Maître Jean-Joseph WA-
GNER, notary then in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on December 7 

th

 , 2010, published in the Mémorial C,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 240 of February 5 

th

 , 2011,

registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 157.392 (the

“Company”).

The meeting is chaired by Mrs. Anaïs DEYGLUN, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange-sur-Attert,

66, Grand-Rue.

The chairman appoints Mrs. Barbara SCHMITT, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange-sur-Attert, 66,

Grand-Rue, as secretary.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange-sur-

Attert, 66, Grand-Rue.

The chairman requests the undersigned notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed “ne varietur” by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the eight thousand one hundred (8,100) shares, representing the whole

capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the shareholders have been beforehand informed.

III.- The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

IV.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Decision to set up on voluntary liquidation the company.
2.- Appointment of the liquidator and definition of its powers
3.- Discharge to the Directors and the statutory auditor.
4.- Decision to immediately hold the second and third General Meetings.
5.- Approval of the report of the liquidator.
6.- Appointment of the commissaire-vérificateur.
7.- Approval of the report of the commissaire-vérificateur and the liquidation accounts.
8.- Discharge to the liquidator and the commissaire-vérificateur.
9.- Closing of the liquidation.
10.- Indication of the place for keeping of the accounts and other documents for a period of five (5) years.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides the anticipated dissolution of the Company and to put it into liquidation with immediate effect.

58933

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The meeting decides to appoint as liquidator Mr. Albert MITJA SARVISE, residing at Calle Sant Magi 11-13, Barcelona

(Spain).

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may

execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for

such period he may determine.

<i>Third resolution

The meeting decides to grant full and complete discharge to the directors and to the statutory auditor for the per-

formance of their mandate.

<i>Fourth resolution

Acting in accordance with article 151 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time

to time, the meeting decides to subsequently hold the second and third General Meetings in connection with the liqui-
dation process.

<i>Fifth resolution

The meeting acknowledges and approves the report of the liquidator regarding the tasks performed according to his

mandate.

The said report, after signature “ne varietur” by the persons attending the meeting and the undersigned notary, will

be attached to the present deed to be registered together with it.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to appoint as commissaire-vérificateur of the liquidation Mrs. Ana DE OLIVEIRA, residing at 8A

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Seventh resolution

The meeting, having taken notice of the report by the Commissaire-Vérificateur, approves the report of the Com-

missaire-Vérificateur and the liquidation accounts.

The said report, after signature “ne varietur” by the persons attending the meeting and the undersigned notary, will

be attached to the present deed to be registered with it.

<i>Eighth resolution

The meeting decides to grant full and complete discharge to the liquidator and to the Commissaire-Vérificateur for

the performance of their mandate.

<i>Ninth resolution

The meeting decides to close the liquidation.

<i>Tenth resolution

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of

five (5) years at the former registered office of the company, and that all the amounts and assets eventually belonging to
shareholders and creditors who do not be present at the end of the liquidation will be deposited at the same former
registered office for the benefit of whom it may concern.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Redange-sur-Attert, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

58934

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le dix-neuf mars.
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

S’est réuni

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SEAWIND S.A., une société anonyme

de droit luxembourgeois ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu  par  Maître  Jean-Joseph WAGNER,  notaire  de  résidence  à Sanem,  Grand-Duché de  Luxembourg, en  date  du  7
décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 240 du 5 février 2011,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 157.392 (la «Société»).
L'assemblée est présidée par Mme Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-

Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.

La présidente désigne comme secrétaire Mme Barbara SCHMITT, clerc de notaire, demeurant professionnellement

au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66,

Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.

La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les huit mille cent (8.100) actions, représentant l'intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux

formalités de convocation, les actionnaires représentés déclarent par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la Société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

4.- Décision de tenir immédiatement les 2 

ème

 et 3 

ème

 assemblées générales.

5.- Approbation du rapport du liquidateur.
6.- Nomination du commissaire-vérificateur.
7.- Approbation du rapport du commissaire-vérificateur; et des comptes de clôture de la liquidation.
8.- Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
9.- Clôture de la liquidation.
10.- Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de cinq

(5) ans.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de la mise en liquidation de la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant que liquidateur M. Albert MITJA SARVISE, demeurant à Calle Sant Magi 11-13,

Barcelone (Espagne).

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Dans l'exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans
limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que
de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée
générale des associés

58935

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour

l’exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

Conformément aux dispositions de l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

l’Assemblée décide de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième assemblées générales de liqui-
dation.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son

mandat.

Ledit rapport après signature «ne varietur» par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant que Commissaire-vérificateur Mme Ana DE OLIVEIRA, demeurant au 8A

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Septième résolution

L'assemblée, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du Commissaire-vérificateur et les comptes de

liquidation.

Ledit rapport, après signature «ne varietur» par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire-vérificateur pour l’exercice

de leur mandat.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de clôturer la liquidation.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans

à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux actionnaires
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui
il appartiendra.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, elles

ont toutes signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. DEYGLUN, B. SCHMITT, V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 23 mars 2015. Relation: DAC/2015/4897. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): J. THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 26 mars 2015.

Référence de publication: 2015047379/193.
(150053952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

58936

L

U X E M B O U R G

SEGRO European Logistics Partnership S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 177.300.

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth of March,
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

1. SEGRO Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.177317 ("SEGRO Luxembourg"), holding 8,350 shares
in the Company,

here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionnally in Junglinster, by virtue of a proxy, given

under private seal; and

2. ESS-LUX, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Lu-

xembourg, having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B.112794 ("ESSLUX") holding 8,350 shares in the Company,

here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionnally in Junglinster, by virtue of a proxy, given

under private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

SEGRO Luxembourg and ESS-LUX are hereinafter referred to as the "Shareholders" and hold together all of the issued

shares of the Company.

Such appearing parties are the shareholders of SEGRO European Logistics Partnership S.à r.l. (hereinafter the "Com-

pany") a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B. 177300, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary
then residing in Luxembourg, dated 8 May 2013, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 6 July 2013, page 77793, number 1621. The
Articles  have  been  amended  for  the  last  time  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Joseph  Elvinger,  notary  then  residing  in
Luxembourg, dated 30 June 2014, published in the Mémorial on 15 September 2014, page 119178, number 2483.

The agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred Euros (EUR 200.-) in order

to raise it from its current amount of sixteen thousand seven hundred Euros (EUR 16,700.-) to sixteen thousand nine
hundred Euros (EUR 16,900.-) by creating and issuing two hundred (200) new shares of one Euro (EUR 1.-) each having
the same features as the existing shares (the "New Shares") to be issued and fully paid up with a share premium of five
million fifty one thousand five hundred ninety six Euros (EUR 5,051,596.-) (the "Share Premium").

Subscription and payment for the New Shares together with the Share Premium.
2. Decision to amend article 5.1 of the Articles of the Company to reflect the capital increase.
3. Miscellaneous.
After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred Euros (EUR

200.-) in order to raise it from its current amount of sixteen thousand seven hundred Euros (EUR 16,700.-) to sixteen
thousand nine hundred Euros (EUR 16,900.-) by creating and issuing two hundred (200) New Shares of one Euro (EUR
1.-) each having the same features as the existing shares to be issued and fully paid up with a share premium of five million
fifty one thousand five hundred ninety six Euros (EUR 5,051,596.-).

<i>Subscriptions and payments

1. SEGRO Luxembourg S.à r.l., aforementioned, declared to subscribe and fully pay in for one hundred (100) New

Shares together with a share premium of two million five hundred twenty five thousand seven hundred ninety eight Euros
(EUR 2,525,798.-) for a total issue price of two million five hundred twenty five thousand eight hundred ninety eight Euros
(EUR 2,525,898.-), through a contribution in kind consisting of a claim which is incontestable, payable and due of an
aggregate amount of two million five hundred twenty five thousand eight hundred ninety eight Euros (EUR 2,525,898.-)
(the "Contribution A"); and

58937

L

U X E M B O U R G

2. ESS-LUX, aforementioned, declared to subscribe and fully pay in for one hundred (100) New Shares together with

a share premium of two million five hundred twenty five thousand seven hundred ninety eight Euros (EUR 2,525,798.-)
for a total issue price of two million five hundred twenty five thousand eight hundred ninety eight Euros (EUR 2,525,898.-),
through a contribution in kind consisting of a claim which is incontestable, payable and due of an aggregate amount of
two million five hundred twenty five thousand eight hundred ninety eight Euros (EUR 2,525,898.-) (the "Contribution B"
and together with the Contribution A, the "Contributions").

As it appeared from the valuation report presented to the undersigned notary, the management of the Company valued

the above-mentioned aggregate Contributions in kind at five million fifty one thousand seven hundred ninety six Euros
(EUR 5,051,796.-), which in the reasonable belief of the management of the Company (i) constitutes a fair and reasonable
valuation of the Contributions and (ii) is at least equal to the New Shares issued in exchange, together with the Share
Premium.

The amount of two hundred Euros (EUR 200.-) was allocated to the share capital of the Company and the amount of

five million fifty one thousand five hundred ninety six Euros (EUR 5,051,596.-) was allocated to the share premium account
of the Company.

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to amend article 5.1 of the Articles of the Company so as to reflect the above decision,

which shall read as follows:

5.1. The share capital of the Company is sixteen thousand nine hundred Euros (EUR 16,900.-) divided into sixteen

thousand nine hundred (16,900) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles,
"Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at three thousand six hundred Euros (EUR 3,600.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the Shareholders and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present deed is drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the Shareholders known to the notary by her name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt mars,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU

1. SEGRO Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.177317 ("SEGRO Luxembourg") détenant 8,350 parts
sociales dans la Société,

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé; et

2. ESS-LUX, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.112794 ("ESS-LUX") détenant 8,350 parts sociales dans la
Société,

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Lesquelles procurations signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

SEGRO Luxembourg et ESS-LUX sont désignées ci-après comme les "Associés" et détiennent ensemble la totalité des

parts émises par la Société.

Lesquelles comparantes sont les associés de SEGRO European Logistics Partnership S.à r.l. (ci-après la "Société"), une

société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B.177300, constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors
de résidence à Luxembourg, en date du 8 mai 2013, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 6 juillet 2013, page 77793, numéro 1621. Les Statuts ont été modifiés pour

58938

L

U X E M B O U R G

la dernière fois par un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin
2014, publié au Mémorial en date du 15 septembre 2014, page 119178, numéro 2483.

L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cents euros (EUR 200,-) afin de le porter

de son montant actuel de seize mille sept cents euros (EUR 16.700,-) à seize mille neuf cents euros (EUR 16.900,-) par
la création et l'émission de deux cents (200) nouvelles parts sociales d'un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes
droits et obligations que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales") devant être émises et intégralement
libérées  avec  une  prime  d'émission  de  cinq  millions  cinquante-et-un  mille  cinq  cent  quatre-vingt-seize  euros  (EUR
5.051.596,-) (la "Prime d'Emission").

Souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission.
2. Décision de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société pour refléter l'augmentation de capital.
3. Divers.
Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cents euros (EUR 200,-) afin

de le porter de son montant actuel de seize mille sept cents euros (EUR 16.700,-) à seize mille neuf cents euros (EUR
16.900,-) par la création et l'émission de deux cents (200) Nouvelles Parts Sociales d'un euro (EUR 1,-) chacune et ayant
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, devant être émises et intégralement libérées avec une
prime d'émission de cinq millions cinquante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (EUR 5.051.596,-).

<i>Souscription et paiement

1. SEGRO Luxembourg, susmentionnée, a déclaré souscrire et entièrement libérer cent (100) Nouvelles Parts Sociales

avec  une  prime  d'émission  de  deux  millions  cinq  cent  vingt-cinq  mille  sept  cent  quatre-vingt-dix-huit  euros  (EUR
2.525.798,-) pour un montant total d'émission de deux millions cinq cent vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-huit
euros (EUR 2.525.898,-), par un apport en nature consistant en une créance liquide, exigible et certaine d'un montant
total de deux millions cinq cent vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 2.525.898,-) (l'"Apport A"); et

2. ESS-LUX, susmentionnée, a déclaré souscrire et entièrement libérer cent (100) Nouvelles Parts Sociales avec une

prime d'émission de deux millions cinq cent vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 2.525.798,-) pour
un  montant  total  d'émission  de  deux  millions  cinq  cent  vingt-cinq  mille  huit  cent  quatre-vingt-dix-huit  euros  (EUR
2.525.898,-), par un apport en nature consistant en une créance liquide, exigible et certaine d'un montant total de deux
millions cinq cent vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 2.525.898,-) (l'"Apport B" et ensemble avec
l'Apport A, les "Apports").

Comme il ressort du rapport d'évaluation présenté au notaire soussigné, la gérance de la Société a évalué les Apports

en nature mentionnés ci-dessus ensemble à cinq millions cinquante-et-un mille sept cent quatre-vingt-seize euros (EUR
5.051.796,-), ce qui selon les gérants de la Société (i) constitue une évaluation juste et raisonnable des Apports et (ii) est
au moins égal aux Nouvelles Actions émises en échange avec la Prime d'Emission.

Le montant de deux cents euros (EUR 200,-) a été alloué au capital social de la Société et le montant de cinq millions

cinquante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (EUR 5.051.596,-) a été alloué au compte de prime d'émission
de la Société.

<i>Deuxième résolution

Les Associés ont décidé de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société, afin de refléter la résolution ci-dessus, qui

aura désormais la teneur suivante:

5.1. Le capital social est fixé à seize mille neuf cents euros (EUR 16.900,-) représenté par seize mille neuf cents

(16.900) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents
Statuts, "Associés" désigne les détenteurs des Parts Sociales à un moment donné et "Associé" doit être interprété con-
formément.".

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement trois mille six cents euros (EUR 3.600,-).

Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version

française, et qu'à la demande des Associés, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais
fera foi.

Cet acte, notarié a été dressé à Junglinster, le jour mentionné au début de ce document.

58939

L

U X E M B O U R G

Ce document ayant été lu au mandataire des Associés, qui est connu par le Notaire par son nom de famille, prénom,

état civil et résidence, le mandataire des Associés et le Notaire ont ensemble signé cet acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 24 mars 2015. Relation GAC/2015/2415. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015047382/170.
(150053808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

SEGRO Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 177.317.

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth of March,
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

SEGRO Overseas Holdings Limited, a private limited company incorporated and existing under the laws of England

and Wales, having its registered office at Cunard House, 15 Regent Street, London SW1Y 4LR and registered in England
and Wales at Companies House under number 01054564 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionnally in Junglinster, by virtue of a proxy, given

under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of SEGRO Luxembourg S.à r.l., (the "Company") a société à responsabilité

limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B.177317, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, dated
8 May 2013, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on 5 July 2013, page 77239, number 1610. The Articles have been amended for the last time pursuant to
a deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, dated 30 June 2014, published in the Mémorial on
16 September 2014, page 120031, number 2500.

The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written

resolutions in accordance with Article 200-2:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred Euros (EUR

100.-) in order to raise it from its current amount of thirteen thousand nine hundred Euros (EUR 13,900.-) to fourteen
thousand Euros (EUR 14,000.-) by creating and issuing one hundred (100) new shares of one Euro (EUR 1.-) each having
the same features as the existing shares (the “New Shares”) to be issued and fully paid up with a share premium of four
million four hundred ninety thousand three hundred eighty five Euros (EUR 4,490,385.-) (the "Share Premium").

<i>Subscriptions and payments

The Sole Shareholder, holding all the shares of the Company, declares to subscribe and fully pay in for the New Shares

together with the Share Premium for a total issue price of four million four hundred ninety thousand four hundred eighty
five Euros (EUR 4,490,485.-) through a contribution in kind consisting of a claim which is incontestable, payable and due
for an aggregate amount of four million four hundred ninety thousand four hundred eighty five Euros (EUR 4,490,485.-)
(the "Contribution").

As it appears from the valuation report presented to the undersigned notary, the management of the Company has

valued the above-mentioned aggregate Contribution in kind at four million four hundred ninety thousand four hundred
eighty five Euros (EUR 4,490,485.-), which in the reasonable belief of the management of the Company (i) constitutes a
fair and reasonable valuation of the Contribution and (ii) is at least equal to the New Shares issued in exchange, together
with the Share Premium.

The amount of one hundred Euros (EUR 100.-) is allocated to the share capital of the Company and the amount of

four million four hundred ninety thousand three hundred eighty five Euros (EUR 4,490,385.-) is allocated to the share
premium account of the Company.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles of the Company so as to reflect the above decision,

which shall read as follows:

58940

L

U X E M B O U R G

5.1. The share capital of the Company is fourteen thousand Euros (EUR 14,000.-) divided into fourteen thousand

(14,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means
the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at three thousand four hundred fifty Euros (EUR 3,450.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the Sole Shareholder and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present deed is drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the Sole Shareholder signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt mars,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

SEGRO Overseas Holdings Limited, une private limited company constituée et existant selon les lois d'Angleterre et

du Pays de Galles, ayant son siège social au Cunard House, 15 Regent Street, Londres SW1Y 4LR et immatriculée en
Angleterre et au Pays de Galles auprès de la Companies House sous le numéro 01054564 (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Laquelle comparante est l'associé unique de SEGRO Luxembourg S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité

limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B.177317, constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg,
en date du 8 mai 2013, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
le 5 juillet 2013, page 77239, numéro 1610. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par
Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 2014, publié au Mémorial le 16
septembre 2014, page 120031, numéro 2500.

L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, adopte par les présentes les résolutions

écrites suivantes conformément à l'Article 200-2:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent euros (EUR 100,-) afin de le

porter de son montant actuel de treize mille neuf cents euros (EUR 13.900,-) à quatorze mille euros (EUR 14.000,-) par
la création et l'émission de cent (100) nouvelles parts sociales d'un euro (EUR 1,-) et ayant les mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales") devant être émises et intégralement libérées avec une
prime d'émission de quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 4.490.385,-)
(la "Prime d'Emission").

<i>Souscription et paiement

L'Associé Unique, détenant toutes les parts sociales de la Société, déclare souscrire et entièrement libérer les Nou-

velles Parts Sociales avec la Prime d'Emission pour un montant total d'émission de quatre millions quatre cent quatre-
vingt-dix mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 4.490.485,-) par un apport en nature consistant en une créance
liquide, exigible et certaine d'un montant total de quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quatre-
vingt-cinq euros (EUR 4.490.485,-) (l'"Apport").

Comme il ressort du rapport d'évaluation présenté au notaire soussigné, la gérance de la Société a évalué l'Apport en

nature mentionné ci-dessus à quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros (EUR
4.490.485,-), ce qui selon les gérants de la Société (i) constitue une évaluation juste et raisonnable de l'Apport et (ii) est
au moins égal aux Nouvelles Parts Sociales émise en échange avec la Prime d'Emission.

Le montant de cent euros (EUR 100,-) est alloué au capital social de la Société et le montant de quatre millions quatre

cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 4.490.385,-) est alloué au compte de prime d'émission.

58941

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter la décision ci-dessus, qui aura

désormais la teneur suivante:

5.1. Le capital social est fixé à quatorze mille euros (EUR 14.000,-) représenté par quatorze mille (14.000) parts

sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés"
désigne les détenteurs des Parts Sociales à un moment donné et "Associé" doit être interprété conformément."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement trois mille quatre cent cinquante euros (EUR 3.450,-).

Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version

française, et qu'à la demande de l'Associé Unique, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte
anglais fera foi.

Cet acte, notarié a été dressé à Junglinster, le jour mentionné au début de ce document.
Ce document ayant été lu au mandataire de l'Associé Unique, qui est connu par le Notaire par son nom de famille,

prénom, état civil et résidence, le mandataire de l'Associé Unique et le Notaire ont ensemble signé cet acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 24 mars 2015. Relation GAC/2015/2414. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015047383/122.
(150053775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

SELP (France) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 177.284.

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth of March,
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

SELP Administration S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.177308 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionnally in Junglinster, by virtue of a proxy, given

under private seal;

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of SELP (France) S.à r.l., (the "Company") a société à responsabilité limitée

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B.177284, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, dated 8 May
2013, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on 4 July 2013, page 76851, number 1602. The Articles have been amended for the last time pursuant to a
deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, dated 30 June 2014, published in the Mémorial on
5 September 2014, page 114454, number 2385.

The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written

resolutions in accordance with Article 200-2:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred Euros (EUR

100.-) in order to raise it from its current amount of twelve thousand eight hundred Euros (EUR 12,800.-) to twelve
thousand nine hundred Euros (EUR 12,900.-) by creating and issuing one hundred (100) new shares of one Euro (EUR
1.-) each having the same features as the existing shares (the “New Shares”) to be issued and fully paid up with a share
premium of seven million six hundred twenty three thousand two hundred twenty seven Euros (EUR 7,623,227.-) (the
"Share Premium").

58942

L

U X E M B O U R G

<i>Subscriptions and payments

The Sole Shareholder, holding all the shares of the Company, declares to subscribe and fully pay in for the New Shares

together with the Share Premium for a total issue price of seven million six hundred twenty three thousand three hundred
twenty seven Euros (EUR 7,623,327.-) through a contribution in kind consisting of claims which are incontestable, payable
and due for an aggregate amount of seven million six hundred twenty three thousand three hundred twenty seven Euros
(EUR 7,623,327.-) (the "Contribution").

As it appears from the valuation report presented to the undersigned notary, the management of the Company has

valued the above-mentioned aggregate Contribution in kind at seven million six hundred twenty three thousand three
hundred twenty seven Euros (EUR 7,623,327.-), which in the reasonable belief of the management of the Company (i)
constitutes a fair and reasonable valuation of the Contribution and (ii) is at least equal to the New Shares issued in
exchange, together with the Share Premium.

The amount of one hundred Euros (EUR 100.-) is allocated to the share capital of the Company and the amount of

seven million six hundred twenty three thousand two hundred twenty seven Euros (EUR 7,623,227.-) is allocated to the
share premium account of the Company.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles of the Company so as to reflect the above decision,

which shall read as follows:

5.1. The share capital of the Company is twelve thousand nine hundred Euros (EUR 12,900.-) divided into twelve

thousand nine hundred (12,900) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles,
"Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at four thousand two hundred Euros (EUR 4.200.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the Sole Shareholder and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the Sole Shareholder signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt mars,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

SELP Administration S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.177308 (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé;

Laquelle procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Laquelle comparante est l'associé unique de SELP (France) S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée

constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.
177284, constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date
du 8 mai 2013, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4
juillet 2013, page 76851, numéro 1602. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par
Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 2014, publié au Mémorial le 5
septembre 2014, page 114454, numéro 2385.

L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, adopte par les présentes les résolutions

écrites suivantes conformément à l'Article 200-2:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent euros (EUR 100,-) afin de le

porter de son montant actuel de douze mille huit cents euros (EUR 12.800,-) à douze mille neuf cents euros (EUR 12.900,-)

58943

L

U X E M B O U R G

par la création et l'émission de cent (100) nouvelles parts sociales d'un euro (EUR 1,-) et ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales") devant être émises et intégralement libérées
avec une prime d'émission de sept millions six cent vingt-trois mille deux cent vingt-sept euros (EUR 7.623.227,-) (la
"Prime d'Emission").

<i>Souscription et paiement

L'Associé Unique, détenant toutes les parts sociales de la Société, déclare souscrire et entièrement libérer les Nou-

velles Parts Sociales avec la Prime d'Emission pour un montant total d'émission de sept millions six cent vingt-trois mille
trois cent vingt-sept euros (EUR 7.623.327,-) par un apport en nature consistant en des créances liquides, exigibles et
certaines  d'un montant total  de sept millions six  cent  vingt-trois mille trois  cent  vingt-sept euros (EUR  7.623.327,-)
(l'"Apport").

Comme il ressort du rapport d'évaluation présenté au notaire soussigné, la gérance de la Société a évalué l'Apport en

nature mentionné ci-dessus à sept millions six cent vingt-trois mille trois cent vingt-sept euros (EUR 7.623.327,-), ce qui
selon les gérants de la Société (i) constitue une évaluation juste et raisonnable de l'Apport et (ii) est au moins égal aux
Nouvelles Parts Sociales émise en échange avec la Prime d'Emission.

Le montant de cent euros (EUR 100,-) est alloué au capital social de la Société et le montant de sept millions six cent

vingt-trois mille deux cent vingt-sept euros (EUR 7.623.227,-) est alloué au compte de prime d'émission.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter la décision ci-dessus, qui aura

désormais la teneur suivante:

5.1. Le capital social est fixé à douze mille neuf cents euros (EUR 12.900,-) représenté par douze mille neuf cents

(12.900) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents
Statuts, "Associés" désigne les détenteurs des Parts Sociales à un moment donné et "Associé" doit être interprété con-
formément."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement quatre mille deux cents euros (EUR 4.200,-).

Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version

française, et qu'à la demande de l'Associé Unique, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte
anglais fera foi.

Cet acte notarié a été dressé à Luxembourg, le jour mentionné au début de ce document.
Ce document ayant été lu au mandataire de l'Associé Unique, qui est connu par le Notaire par son nom de famille,

prénom, état civil et résidence, le mandataire de l'Associé Unique et le Notaire ont ensemble signé cet acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 24 mars 2015. Relation GAC/2015/2419. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015047389/124.
(150053949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

X Communication, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 143.611.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2015.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2015047487/13.
(150053741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

58944


Document Outline

Aerospace Services S.A.

Carnegie Fund Management Company S.A.

Carnegie Fund Services S.A.

Centaurus C.E.R. (Aviva Investors) S.à r.l.

Cite Cube S.à r.l.

CNH Industrial Europe Holding S.A.

CNH Industrial Finance Europe S.A.

Cool Runnings S.A.

Decodesign S.à r.l.

Devonshire Point Holdings S.à r.l.

Devonshire Point Investment S.à r.l.

Digital Services XVIII S.à r.l.

Digital Services XXVII (GP) S.à r.l.

EnBW Baltic 2 Management S.à r.l.

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée

Financial Ridge S.A.

Fonds Interculturel

Gemissy SA

Globavia S.A.

Impact Capital Partners V, LP

La Française AM Fund

La Française LUX

Londac No. 1 S.à r.l.

Lux Armature &amp; Construction S.à r.l.

Luxembourg Pony Holdings S.à.r.l.

Lux-Log S.A.

ODIN LuxCo 12 S.à r.l.

Orion IV European 32 S.à r.l.

RS Pose d'Armatures

Russian Acquisition Company N°2 S.à r.l.

Seawind S.A. SPF

SEGRO European Logistics Partnership S.à r.l.

SEGRO Luxembourg S.à r.l.

SELP (France) S.à r.l.

Spain Residential Finance S.à r.l.

SSI Schäfer Shop GmbH

Taurus Euro Logistics Investment Sàrl

The Building Block Equity Fund S.A., SICAR

Trustconsult Group S.A.

X Communication